logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

22417

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 468

4 mai 2004

S O M M A I R E

Allgemeine  Deutsche  Direktbank  International 

Lan Expert S.A., Foetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22418

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22445

Lucullux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22420

Artista International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

22419

Luxmako, S.à r.l., Roost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22444

AS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

22463

LVS Ulysse Invest S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . 

22460

AS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

22463

Mako S.A., Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22440

AS Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . .

22463

MIV Luxembourg Holding, S.à r.l., Luxembourg. . 

22440

Azur Renting S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

22460

Net Ventures Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

22442

B.F.C.P. S.A., Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22459

P.I.I. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22453

B.F.C.P. S.A., Perlé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22459

Pelias Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

22442

Belgo Metal S.A. Luxembourg, Steinfort. . . . . . . . .

22419

Pelias Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

22442

Biotech Industry S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

22460

Pelias Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

22442

Bram Investment S.A., Larochette  . . . . . . . . . . . . .

22458

Pirelli International Finance S.A., Luxembourg  . . 

22448

Brenntag-Interfer (BC) S.C.A., Munsbach . . . . . . . .

22420

Pirelli International Finance S.A., Luxembourg  . . 

22448

Continental Union Investments S.A., Luxembourg

22418

PJPT S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22464

Continental Union Investments S.A., Luxembourg

22418

Ruala Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22452

Decia Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

22461

Sette S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22453

Diatec, S.à r.l., Berchem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22444

Sette S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22456

Dimini S.A., Larochette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22458

SFDT International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

22441

Euro-Leasing AG, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

22453

SHA Finance S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

22451

Evli Bank Plc, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22464

Sisha S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22419

Farvest, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22452

SOMALUX - Société de Matériel Luxembourgeoise

Fiduciaire  Comptable  et  Fiscale  de  Martelange 

S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22439

S.A., Perlé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22418

Sofirac S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22444

Filimi Investment Holding S.A., Larochette . . . . . .

22457

Sparinvest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22458

Fraser Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

22457

Stemarlu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22457

Fresenius Medical Care MDF S.A., Luxembourg  . .

22453

Stemarlu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22457

Full Computer Services Lux S.A., Rombach-Marte-

Sul Palco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22458

lange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22459

Sul Palco, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

22458

Galey & Lord International, S.à r.l., Luxembourg. .

22447

Sunbow Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

22452

Galey & Lord International, S.à r.l., Luxembourg. .

22447

SVIF S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22420

Gamirco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22445

Svenska Handelsbanken S.A., Luxembourg. . . . . . 

22463

Gamirco S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22445

Topaze Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

22452

Gennaker S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22441

Totem Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

22439

Harmodio S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22451

Totem Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

22439

Harvest CLO I S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

22445

Totem Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

22439

Hefesto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22440

Tregoram Overseas Ltd, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . 

22448

Hefesto S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22440

Trois Soleils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . 

22464

Hestia S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22453

Trois Soleils, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . 

22464

HSBC Dewaay Luxembourg S.A., Luxembourg . . .

22443

Uli, S.à r.l., Hosingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

22419

HSBC Dewaay Luxembourg S.A., Luxembourg . . .

22444

Warm Arisonda S.A., Larochette . . . . . . . . . . . . . . 

22457

Ibiza Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

22459

Welfab Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

22449

Karma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22460

Welfab Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

22451

22418

LAN EXPERT, Société Anonyme.

Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.

R. C. Luxembourg B 88.535. 

<i>Procès-verbal d’Assemblée Générale Extraordinaire du jeudi 13 novembre 2003

L’an deux mille trois, le treize novembre se sont réunis:
1. ZUKUNFT HOLDING AG, société de droit suisse, ayant siège social Bederstrasse 76 CH-8002 Zurich, représen-

tée par son administrateur actuellement en fonction.

2. Monsieur Wenger Stéphane, demeurant 6 rue des Menuisiers F-67290 Weislingen
3. Monsieur Weber Jean Luc, demeurant 30 rue de la Liberté à F-57970 Yutz.

Les trois comparants sub 1 à 3, sont les membres du conseil d’administration actuellement en fonction de LAN EX-

PERT société anonyme constituée suivant acte n° 8864 de Maître Jean Joseph Wagner notaire à Sanem en date du 2
août 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette le 7 août 2002, volume 871, folio 20, case 6, immatriculée au registre de com-
merce de et à Luxembourg sous le numéro B 88.535.

Le conseil d’administration décide à l’unanimité avec l’assentiment des actionnaires de transférer le siège social du 10,

rue de l’Avenir, L-3895 Foetz

au 3, rue des Artisans, L-3895 Foetz avec effet au 12 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03906. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023655.3/000/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

FIDUCIAIRE COMPTABLE ET FISCALE DE MARTELANGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 91.760. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. DSO-AO00277, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901188.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

CONTINENTAL UNION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 65.605. 

Il résulte d’une lettre datée du 11 mars 2004 adressée à la société que Madame Carine Bittler, employée privée, de-

meurant professionnellement à Luxembourg démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet rétroactif au 18
mars 2003.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03421. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023855.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

CONTINENTAL UNION INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 27, rue des Glacis.

R. C. Luxembourg B 65.605. 

Il résulte d’une lettre datée du 11 mars 2004 adressée à la société que Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de so-

ciété, demeurant professionnellement à Luxembourg démissionne de ses fonctions d’administrateur avec effet rétroactif
au 18 mars 2003.

Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03017. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023854.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

ZUKUNFT HOLDING AG / S. Wenger / J. L. Weber
Signature

Diekirch, le 19 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 16 mars 2004.

C. Bittler.

Luxembourg, le 12 mars 2004.

J.-L. Jourdan.

22419

ULI, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-9808 Hosingen, 14, Holzbicht.

H. R. Diekirch B 4.785. 

Der mit Wirkung vom 31. Dezember 2003 erklärte Rücktritt des technischen Geschäftsführers Herrn Bernd Reinert,

wohnhaft im D-54568 Gerolstein, Zum Sandborn 2 wird angenommen. Dem technischen Geschäftsführer wird für seine
Tätigkeit Entlastung erteilt.

Hosingen, den 31. Dezember 2003.

Enregistré à Diekirch, le 19 mars 2004, réf. DSO-AO00356. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Siebenaler.

(901194.2/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

ARTISTA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital: 31.000 EUR.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 89.778. 

Narejos Laurent résidant au 55, Val Sainte Croix au Grand-Duché de Luxembourg, démissionne de son poste d’Ad-

ministrateur-délégué et de Directeur Général de la société ARTISTA INTERNATIONAL S.A.

Il se désengage de toute responsabilité envers ARTISTA INTERNATIONAL S.A.
Cette démission prend effet immédiat le 10 février 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03913. – Reçu 89 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023658.2//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

BELGO METAL S.A. LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Succursale de la société de droit belge BELGO METAL S.A.

Siège social: L-8449 Steinfort, 6, rue des Sports.

R. C. Luxembourg B 60.991. 

Démission de Monsieur Paul Parein de son poste d’administrateur-délégué.
Nomination de Monsieur Luc Branckaerts au poste d’administrateur-délégué, en remplacement de Monsieur Paul Pa-

rein.

Les représentants permanents de la succursale sont donc les suivants:
- Monsieur Thierry Foucart, Administrateur-délégué
- Monsieur Luc Branckaerts, Administrateur-délégué
- Monsieur Fernand Vanderstraeten, Directeur technique.
La succursale est engagée du point de vue technique par la signature du directeur technique.

Fait à Steinfort, le 8 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03723. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023839.3/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

SISHA S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 41.560. 

Par lettre recommandée en date du 11 mars 2004 adressée à SISHA S.A., la société soussignée a dénoncé avec effet

immédiat le siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03788. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(023870.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

B. Reinert / E. Lempges
<i>Geschäftsführer / Geschäftsführer

Luxembourg, le 10 février 2004.

L. Narejos.

T. Foucart / L. Branckaerts / F. Vanderstraeten
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-délégué / Directeur technique

MULTI OFFICE SERVICES S.A.
<i>Le propriétaire des lieux
C. Gretsch
<i>Administrateur-délégué

22420

SVIF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.089. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 3 mars 2004

que:

<i>Délibération

L’Assemblée approuve les comptes annuels au 31 décembre 2002.
Par vote spécial, l’Assemblée accorde décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes

pour l’exécution de leur mandat jusqu’au 31 décembre 2002.

L’Assemblée élit le nouveau Conseil d’administration pour un terme allant jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale sta-

tutaire à tenir en l’an 2004:

Administrateur: Monsieur Jean-Luc Jourdan, directeur de société, demeurant professionnellement à Luxembourg
Administrateur: Maître Christian-Charles Lauer, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
Administrateur: Monsieur Thierry Nowankiewicz, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg
Commissaire aux comptes: FREECAP GLOBAL INC. avec siège social à Tortola (B.V.I.).
Pour extrait conforme, délivré sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

Luxembourg, le 10 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03011. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023856.3/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

LUCULLUX S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 49.357. 

Par lettre recommandée en date du 11 mars 2004 adressée à LUCULLUX S.A., la société soussignée a dénoncé avec

effet immédiat le siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03789. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(023871.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

BRENNTAG-INTERFER (BC), Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.315. 

In the year two thousand and four, on the twenty-fifth of February. 
Before us Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, 
is held an extraordinary general meeting of shareholders of BRENNTAG-INTERFER (BC) (the «Company»), a société

en commandite par actions, having its registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, registered with
the Luxembourg trade and companies’ register under section B number 97.315, incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, on the 25 November 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 7 of 3 January 2004. The articles of incorporation have last been amended pursuant to a deed of the undersigned
notary, on the 26 January 2004, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is opened at 10.50 a.m., with Marc Elvinger, lawyer, residing in Luxembourg, in the chair, who appoints

as secretary Miss Rachel Uhl, jurist, residing in Luxembourg. who was also elected as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist,
residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. - That the agenda of the meeting is the following: 

<i>Agenda:

1) Creation of different classes of shares divided into class A ordinary shares (the «Class A Ordinary Shares») and

management share(s) (the «Management Share(s)»); 

2) Introduction of new provisions into the articles of incorporation providing for the issue of redeemable shares;

<i>Pour la société
Le Conseil d’administration
Signatures

MULTI OFFICE SERVICES S.A.
<i>Le propriétaire des lieux
C. Gretsch
<i>Administrateur-délégué

22421

3) Conversion of the two hundred forty-eight thousand (248,000) existing shares, into two hundred forty-seven thou-

sand nine hundred ninety-nine (247,999) Class A Ordinary Shares and one (1) Management Share;

4) Increase of the share capital from its present amount of three hundred ten thousand euro (EUR 310,000) up to

two million nine hundred eleven thousand eight hundred ten euro (EUR 2,911,810) by the issue of two million eighty-
one thousand four hundred forty-eight (2,081,448) Class A Ordinary Shares having a nominal value of one euro and
twenty-five cent (EUR 1.25) each;

5) Authorisation of the manager to increase the share capital of the Company within the limits of the authorised share

capital without reserving a preferential subscription right to the existing shareholders;

6) Full restatement of the articles of incorporation of the Company; 
7) Miscellaneous
II. - That the shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number

of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities. The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the
appearing parties will also remain annexed to the present deed.

III. - That the entire share capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders

present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.

IV. - That the present meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously takes the following resolutions: 

<i>First resolution

The meeting decides to create shares divided into class A ordinary shares (the «Class A Ordinary Shares») and man-

agement share(s) (the «Management Share(s)») which are more precisely specified below in the new articles 6 and 7 of
the articles of incorporation.

The Class A Ordinary Shares and Management Share(s) are hereinafter collectively referred to as the «Shares».

<i>Second resolution

The general meeting decides that the Company may issue redeemable shares. The redeemable shares bear the same

rights to receive dividends and have the same voting rights as ordinary shares. Subscribed and fully paid in redeemable
shares shall be redeemable upon request of the Company in accordance with the provisions of Article 49-8 of the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. The redemption of the redeemable shares can only be made
by using sums available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. The redeemed shares bear no
voting rights, and have no rights to receive dividends or the liquidation proceeds.

All of the Class A Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provisions of Article 49-8 of the

law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, except for those issued and subscribed for prior to the
insertion of the present article in the articles of incorporation.

The article relation to the redeemable shares to be inserted into the articles of incorporation shall read as follows:
«Art 6.3. Redemption; Convertibility.
(a) Redeemable Shares. The Company may issue redeemable shares in accordance with the terms of these Articles

and the provisions of article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. The Class A
Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the present Article 6.3 and the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended. All redeemable shares shall bear the same rights to receive dividends and other
distributions (including liquidation proceeds) and shall have the same voting rights as the Class A Ordinary Shares. Sub-
scribed and fully paid-in redeemable shares may be redeemed upon a request of the Company made in accordance with
the provisions of these Articles. All redemptions shall be made on a pro rata basis among all holders of each class of
redeemable shares subject to such redemption. The redemption of redeemable shares can only be made by using sums
available for distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (dis-
tributable funds, inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the company as an issue
premium) or the proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Upon redemption, the redeemed
shares shall bear no voting rights and have no rights to receive any dividends, distributions or liquidation proceeds. The
Company may cancel the redeemed shares upon a decision of the Manager.

(b) Special Reserve. In the event of a partial or total redemption of any redeemable shares, an amount equal to the

nominal value, or in the absence thereof, the par value, of all the shares redeemed must be included in a reserve which
cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the
reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalization of reserves.

(c) Redemption Price. Except as otherwise provided in these Articles or by a written agreement which may be en-

tered into among the shareholders, the redemption price applicable to any redemption of the redeemable shares shall
be calculated by the Manager(s) or by such person appointed by the Manager(s) on the basis of the net asset value of all
assets and liabilities of the Company. The net asset value of the Company’s shares shall be expressed as a per share
figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the Company, being the value
of the Company’s assets less its liabilities at close of business on that day, by the number of shares of the Company then
outstanding at such close of business, in accordance with the rules the Manager(s) shall reasonably regard as fair and
equitable. In the absence of bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the Manager(s) with respect

22422

to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and
future shareholders.

(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among

the shareholders of the Company at least ten (10) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by
registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the shares to be re-
deemed, at his or her address last shown in the shareholder’s register of the Company, notifying such holder of the
number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price and the procedures neces-
sary to submit the shares to the Company for redemption. Each holder of shares to be redeemed shall surrender the
certificate or certificates, if any, issued in relation to such shares to the Company. The redemption price of such shares
shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank
account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(e) Management Share(s). The Management Share(s) are not redeemable shares and may not be redeemed by the

Company.»

<i>Third resolution

The meeting decides to convert the two hundred forty-eight thousand (248,000) existing shares, into two hundred

forty-seven thousand nine hundred ninety-nine (247,999) Class A Ordinary Shares and one (1) Management Share, as
follows:

1) the two hundred forty-seven thousand nine hundred ninety-nine (247,999) shares owned by BAIN CAPITAL

FUND VII-E (UK) L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the United States of America,
with registered office at 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, are hereby converted into two hundred for-
ty-seven thousand nine hundred ninety-nine (247,999) Class A Ordinary Shares; and

2) the one (1) share owned by BRENNTAG-INTERFER, a société anonyme incorporated and governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, is hereby con-
verted into one (1) Management Share. 

<i>Fourth resolution

The meeting decides to increase the share capital of an amount of two million six hundred and one thousand eight

hundred ten euro (EUR 2,601,810) in order to increase it from its current amount of three hundred ten thousand euro
(EUR 310,000) up to two million nine hundred eleven thousand eight hundred ten euro (EUR 2,911,810) through the
issue of two million eighty-one thousand four hundred forty-eight (2,081,448) Class A Ordinary Shares having a par value
of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per share.

The two million eighty-one thousand four hundred forty-eight (2,081,448) new Class A Ordinary Shares have been

subscribed as follows:

1) sixty-seven thousand twenty-nine (67,029) Class A Ordinary Shares have been subscribed by BAIN CAPITAL

FUND VII-E (UK) L.P., prenamed, for a total amount, of eighty-three thousand seven hundred eighty-six euro (EUR
83,786);

2) five hundred fifty-three thousand three hundred sixty (553,360) Class A Ordinary Shares have been subscribed by

BAIN CAPITAL VII COINVESTMENT FUND, LP, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cay-
man Islands, with registered office at c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands, for a total amount of six hundred ninety-one thousand seven hundred euro (EUR 691,700);

3) one million seventy-seven thousand six hundred seventy-seven (1,077,677) Class A Ordinary Shares have been

subscribed by BAIN CAPITAL FUND VII, LP, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman
Islands, with registered office at c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands, for a total amount of one million three hundred forty-seven thousand ninety-six euro twenty-five
cent (EUR 1,347,096.25);

4) fifty thousand seven hundred eighty-one (50,781) Class A Ordinary Shares have been subscribed by BCIP ASSO-

CIATES III, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, with registered office at
c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, for a total
amount of sixty-three thousand four hundred seventy-six euro (EUR 63,476);

5) three thousand nine hundred eighty-one (3,981) Class A Ordinary Shares have been subscribed by BCIP ASSOCI-

ATES III-B, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, with registered office at
c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, for a total
amount of four thousand nine hundred seventy-six euro twenty-five cent (EUR 4,976.25);

6) six thousand six hundred seventy-six (6,676) Class A Ordinary Shares have been subscribed by BCIP TRUST AS-

SOCIATES III, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, with registered office
at c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, for a
total amount of eight thousand three hundred forty-five euro (EUR 8,345);

7) two thousand four hundred thirty-seven (2,437) Class A Ordinary Shares have been subscribed by BCIP TRUST

ASSOCIATES III-B, an exempted limited partnership organized under the laws of the Cayman Islands, with registered
office at c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
for a total amount of three thousand forty-six euro twenty-five cent (EUR 3,046.25);

8) twenty-two thousand six hundred eighty-two (22,682) Class A Ordinary Shares have been subscribed by

SANKATY HIGH YIELD PARTNERS II, LP, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
United States of America, with registered office at 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, for a total amount
of twenty-eight thousand three hundred fifty-two euro fifty cent (EUR 28,352.50);

22423

9) twenty-two thousand six hundred eighty-two (22,682) Class A Ordinary Shares have been subscribed by

SANKATY HIGH YIELD PARTNERS III, LP, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware,
United States of America, with registered office at 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, for a total amount
of twenty-eight thousand three hundred fifty-two euro fifty cent (EUR 28,352.50);

10) eleven thousand three hundred forty-one (11,341) Class A Ordinary Shares have been subscribed by SANKATY

CREDIT OPPORTUNITIES, L.P., a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, with registered office at 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, for a total amount of fourteen
thousand one hundred seventy-six euro twenty-five cent (EUR 14,176.25);

11) one hundred twenty-six thousand eleven (126,011) Class A Ordinary Shares have been subscribed by BROOK-

SIDE CAPITAL PARTNERS FUND, LP, a limited partnership organized under the laws of the State of Delaware, United
States of America, with registered office at 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, for a total amount of one
hundred fifty seven thousand five hundred thirteen euros seventy-five cent (EUR 157,513.75);

12) six thousand three hundred and one (6,301) Class A Ordinary Shares have been subscribed by PETER SMEDVIG

CAPITAL, AS, a corporation formed under the laws of Norway, with registered office at Lokkeveien 103B, 4007 Sta-
vanger, Norway, for a total amount of seven thousand eight hundred seventy-six euro twenty-five cent (EUR 7,876.25);

13) ten thousand four hundred ninety (10,490) Class A Ordinary Shares have been subscribed by RANDOLPH

STREET PARTNERS VI, a limited partnership organized under the laws of the State of Illinois, United States of America,
with registered office at 200 E. Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, USA, for a total amount of thirteen thousand
one hundred twelve euro fifty cent (EUR 13,112.50);

14) thirty-six thousand seven hundred and eighty-two (36,782) Class A Ordinary Shares have been subscribed by GS

MEZZANINE PARTNERS II (BRENNTAG) LLC, a limited liability company organized under the laws of the State of
Delaware, United States of America, with registered office at c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilm-
ington, Delaware, USA, for a total amount of forty-five thousand nine hundred and seventy-seven euro and fifty cents
(EUR 45,977.50);

15) fifty-three thousand nine hundred and seventy-three (53,973) Class A Ordinary Shares have been subscribed by

GS MEZZANINE PARTNERS III ONSHORE FUND (BRENNTAG) LLC, a limited liability company organized under the
laws of the State of Delaware, United States of America, with registered office at c/o Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, for a total amount of sixty-seven thousand four hundred and sixty-six euro
and twenty-five cents (EUR 67,466.25);

16) eleven thousand two hundred and eighteen (11,218) Class A Ordinary Shares have been subscribed by GS MEZ-

ZANINE PARTNERS II OFFSHORE (BRENNTAG) LLC, a limited liability company organized under the laws of the State
of Delaware, United States of America, with registered office at c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, USA, for a total amount of fourteen thousand twenty-two euro and fifty cents (EUR 14,022.50);

17) eighteen thousand twenty-seven (18,027) Class A Ordinary Shares have been subscribed by GS MEZZANINE

PARTNERS III OFFSHORE FUND (BRENNTAG) LLC, a limited liability company organized under the laws of the State
of Delaware, United States of America, with registered office at c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, USA, for a total amount of twenty-two thousand five hundred thirty-three euro and seventy-
five cents (EUR 22,533.75).

The shares subscribed have been paid up in cash by the subscribers so that the total sum of two million six hundred

and one thousand eight hundred ten euro (EUR 2,601,810) representing two million six hundred and one thousand eight
hundred ten euro (EUR 2,601,810) for the share capital is at the disposal of the company, as it has been proved to the
undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The meeting decides to renew and approve the authorisation of the manager of the Company to increase the share

capital of the Company up to an amount of five hundred million euro (EUR 500,000,000) for a period ending five years
after the date of publication of the present shareholders’ resolution in the Luxembourg official gazette (Mémorial C Re-
cueil des Sociétés et Associations).

Based on the report provided by the sole manager, the general meeting resolves in accordance with article 32-3 (5)

of the law of 1915 to authorise the manager to suppress the preferential right of subscription of the existing sharehold-
ers within the limits of the authorised share capital.

<i>Sixth resolution

The general meeting decides to fully restate the articles of incorporation of the Company which shall henceforth be

read as follows:

A. Name - Registered Office - Duration - Object

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become shareholders in the future,

a company in the form of a société en commandite par actions under the name of BRENNTAG-INTERFER (BC) (here-
inafter the «Company»).

Art. 2. The registered office of the Company is established in Munsbach-Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.

Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the Manager.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by res-
olution of the Manager. In the event that the Manager determines that extraordinary political or military events have
occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or
with the communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred

22424

abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no effect on
the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg company.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

B. Management - Share Capital

Art. 5. The general partner of the Company (associé commandite) is jointly and severally liable for all liabilities which

cannot be paid out of the assets of the Company. The other shareholders (for the avoidance of doubt, not including the
general partner), being the holder(s) of Class A Ordinary Shares, shall refrain from acting on behalf of the Company in
any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable
to the extent of their contributions to the Company.

Art. 6. Corporate Capital
Art 6.1. Subscribed Capital.
The Company has a subscribed capital of two million nine hundred eleven thousand eight hundred ten euro (EUR

2,911,810) represented by fully paid up shares, consisting of two million three hundred twenty-nine thousand four hun-
dred forty-seven euro (EUR 2,329,447) Class A Ordinary Shares with a par value of one euro twenty-five cents (EUR
1.25) each (herein, the «Class A Ordinary Shares») and by one (1) Management Share with a par value of one euro
twenty-five cents (EUR 1.25) (herein, the «Management Share»).

The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles. The Company may, to the extent and under terms permitted by
law, redeem its own shares.

All shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in these Articles, the holders of any

separate class of shares shall not be entitled to vote separately on any matter. No shares of any class shall be entitled
to any pre emptive rights with respect to any shares of the Company except as may be required by law or as otherwise
provided in any shareholders agreement to be entered into by the Company with the Class A Ordinary Shareholders.

Art. 6.2. Description of the shares.
Art. 6.2.1. The Class A Ordinary Shares.
(a) The Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares shall be identical in all respects. All Class A Ordinary

Shares shall share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends,
which are allocated on an aggregate basis to such Class A Ordinary Shares. All Class A Ordinary Shares purchased or
otherwise acquired by the Company shall, if the Manager so directs, be retired with the effect that the issued number
of Class A Ordinary Shares is reduced. Any redemption, retirement, or other acquisition by the Company of Class A
Ordinary Shares shall be done on a pro rata basis among all holders of Class A Ordinary Shares with the same terms
and conditions (including price per share) applicable to all such holders.

(b) Voting Rights. Each Class A Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

the holders thereof have the right to vote.

Art. 6.2.2. The Management Shares.
(a) The Management Shares. All Management Shares shall be identical in all respects. All Management Shares shall

share ratably in the payment of dividends and in any distribution of assets other than by way of dividends, which are
allocated on an aggregate basis to such Management Shares.

(b) Voting Rights. Each Management Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which the

holders thereof have the right to vote.

Art 6.3. Redemption; Convertibility.
(a) Redeemable Shares. The Company may issue redeemable shares in accordance with the terms of these Articles.

The Class A Ordinary Shares are redeemable shares in accordance with the provision of article 49-8 of the law of 10
August 1915 on commercial companies, as amended. All redeemable shares shall bear the same rights to receive divi-
dends and other distributions (including liquidation proceeds) and shall have the same voting rights as the Class A Or-
dinary Shares. Redeemable shares may be redeemed upon a request of the Company made in accordance with the
provisions of these Articles. All redemptions shall be on a pro rata basis among all holders of each class of redeemable
shares subject to such redemption. The redemption of redeemable shares can only be made by using sums available for
distribution in accordance with article 72-1 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (distributable funds,
inclusive of the extraordinary reserve established with the funds received by the company as an issue premium) or the
proceeds of a new issue made with the purpose of such redemption. Upon redemption, the redeemed shares shall be
cancelled and shall cease to have voting rights and rights to receive any dividends, distributions or liquidation proceeds.

(b) Special Reserve. In the event of a partial or total redemption of any redeemable shares, an amount equal to the

nominal value, or in the absence thereof, the par value, of all the shares redeemed must be included in a reserve which
cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the subscribed share capital; the
reserve may only be used to increase the subscribed share capital by capitalization of reserves.

22425

(c) Redemption Price. Except as otherwise provided in these Articles or by a written agreement which may be en-

tered into among the shareholders, the redemption price applicable to any redemption of the redeemable shares shall
be calculated by the Manager(s) or by such person appointed by the Manager(s) on the basis of the net asset value of all
assets and liabilities of the Company. The net asset value of the Company’s shares shall be expressed as a per share
figure and shall be determined in respect of any valuation day by dividing the net assets of the Company, being the value
of the Company’s assets less its liabilities at close of business on that day, by the number of shares of the Company then
outstanding at such close of business, in accordance with the rules the Manager(s) shall reasonably regard as fair and
equitable. In the absence of bad faith, gross negligence or overt error any decision taken by the Manager(s) with respect
to the calculation of the redemption price shall be conclusive and binding on the Company and on its present, past and
future shareholders.

(d) Redemption Procedure. Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among

the shareholders of the Company at least ten (10) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by
registered mail or internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the shares to be re-
deemed, at his or her address last shown in the shareholder’s register of the Company, notifying such holder of the
number of shares so to be redeemed, specifying the redemption date, the redemption price and the procedures neces-
sary to submit the shares to the Company for redemption. Each holder of shares to be redeemed shall surrender the
certificate or certificates, if any, issued in relation to such shares to the Company. The redemption price of such shares
shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register as the owner thereof on the bank
account provided to the Company by such shareholder before the redemption date.

(e) Management Shares. The Management Shares are not redeemable shares and may not be redeemed by the Com-

pany.

Art 6.4. Distributions to Shareholders.
If any distribution to the shareholders is determined to be made by the Company’s shareholders meeting and/or by

the Manager (whether by interim dividend, redemption or otherwise), the shareholders will be entitled to receive dis-
tributions, when, as, and if declared by the Company’s shareholders meeting and/or by the Manager out of funds legally
available therefor, in accordance with applicable law, in the manner described in the remaining provisions of this Article
6.4. The holders of the Class A Ordinary Shares and the Management Shares shall be entitled to receive all distributions
made by the Company to shareholders, and such distributions shall be made pro rata among the holders of the Class A
Ordinary Shares and the Management Share based on the number of Ordinary Shares held by such holder and should
be made on identical terms and conditions applicable to all holders thereof.

Art 6.5. Liquidation Rights.
In the event of a liquidation, after payment of all debts and liabilities of the Company, the residual assets of the Com-

pany will be distributed to the shareholders in the manner set out in Article 6.4 above. Neither a merger or consolida-
tion of the Company into or with any other entity or entities, nor a merger or consolidation of any other entity or
entities into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration)
of all or any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation within the meaning of this Article 6.5,
unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan
of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.

Art 6.6. Authorised Capital.
In addition to the subscribed capital, the Company has an authorised capital which is fixed at five hundred million

euro (EUR 500,000,000) represented by four hundred million (400,000,000) Class A Ordinary Shares having a par value
of one euro twenty-five cents (EUR 1.25) per share.

During a period ending five (5) years after the date of publication of the shareholders’ resolution to create the au-

thorised capital in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, the Manager is
authorised to increase in one or several times the subscribed capital by causing the Company to issue new shares within
the limits of the authorised capital. Such new shares (Ordinary Shares, preferred shares or shares of any class which
may be issued by the Company) may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the Manager may
determine, more specifically in respect to the subscription and payment of the new shares to be subscribed and issued,
such as to determine the time and the amount of the new shares to be subscribed and issued, to determine if the new
shares are to be subscribed with or without an issue premium, to determine to what an extent the payment of the newly
subscribed shares is acceptable either by cash or by assets other than cash. Any share issuance by the Company shall
comply with the terms and conditions set forth in any shareholders agreement to be entered into between the Company
and the Class A Ordinary Shareholders. Unless the shareholders shall have otherwise agreed, when realising the author-
ised capital in full or in part, the manager is expressly authorised to limit or waive the preferential subscription right
reserved to existing shareholders. The Manager may delegate to any duly authorised director or officer of the Company
or to any other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for the new shares
representing part or all of such increased amounts of capital. After each increase of the subscribed capital performed in
the legally required form and in accordance with these Articles by the Manager, this Article 6.6 shall be adjusted accord-
ingly to reflect such increase.

Art 6.7. Amendment of the subscribed and of the authorised capital.
The subscribed and the authorised capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the present Articles.

Art 6.8. Definitions.
For the purpose of these Articles:
«Affiliate» or «Affiliates» means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, controls,

is controlled by, or is under common control with such first Person or any other Person who holds directly or indirectly

22426

more than a fifty percent (50%) economic interest in such first Person or in whom such first Person holds directly or
indirectly more than a fifty percent (50%) economic interest. For the purpose of this definition, «control» will mean, as
to any Person, the power to direct or cause the direction of the management and policies of such Person, whether
through the ownership of voting securities or membership on the board of managers or directors, by contract (including
without limitation a limited partnership agreement or general partnership agreement) or otherwise. Any trust or nom-
inee directly or indirectly holding securities principally for the benefit of employees of a Holder or the Company, or any
Affiliates thereof, shall be deemed to be an Affiliate of such Person.

«Articles» means these articles of incorporation as amended from time to time.
«Class A Ordinary Shares» has the meaning provided in Article 6.1.
«Company» has the meaning provided in Article 1.
«Investor Securities» means, with respect to an Investor, such Investor’s Ordinary Shares together with any other

Securities of the Company subscribed for by such Investor.

«Management Share» has the meaning provided in Article 6.1.
«Manager» has the meaning provided in Article 8.
«Ordinary Shares» means the ordinary shares of the Company.
«Person» means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock

company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency
or political subdivision thereof.

«Securities» means any duly authorized securities of the Company, including but not limited to, any Series 1 PECs,

Series 2 PECs, Series 1 CPECs, or Ordinary Shares issued by the Company.

«Securityholder» means any holder of Securities.
«Series 1 CPECs» means the Series 1 convertible preferred equity certificates which may be issued by the Company

from time to time and, if applicable, any additional series of convertible preferred equity certificates duly authorized and
issued by the Company from time to time.

«Series 1 PECs» means the Series 1 preferred equity certificates which may be issued by the Company from time to

time and, if applicable, any additional series of preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company
from time to time.

«Series 2 PECs» means the Series 2 preferred equity certificates which may be issued by the Company from time to

time and, if applicable, any additional series of preferred equity certificates duly authorized and issued by the Company
from time to time. 

«Transfer» or «transfer» has the meaning provided in Article 73(c).

C. Shares - Shareholders Register - Share Transfers

Art. 7. Shares
Art. 7.1. Shareholders Register.
All the shares will be and remain in the form of registered shares. A shareholders register which may be examined

by any shareholder will be kept at the registered office. The register will contain the precise designation of each share-
holder and the indication of the number of shares held, the indication of the payments made on the shares as well as
the transfers of shares and the dates thereof. Each shareholder will notify to the Company by registered letter its ad-
dress and any change thereof. The Company will be entitled, to rely on the last address thus communicated. Certificates
of these recordings shall be issued and signed by the Manager upon request of the relevant shareholder.

Art. 7.2. Share Ownership.
Ownership of the registered shares will result from the recordings in the shareholders register. The Company rec-

ognizes only one owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the ownership of such share(s) is dis-
puted, all persons claiming a right to such share(s) must appoint one single representative to represent such share(s)
towards the Company. The failure to appoint such representative shall imply a suspension of all rights attached to such
shares.

Art. 7.3. Share Transfer.
(a) Declaration of Transfer. The transfers of shares will be carried by a declaration of transfer registered into the

shareholders’ register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their representative(s). The transfers
of shares may also be carried out in accordance with the rules on the transfer of claims laid down in article 1690 of the
Luxembourg Civil Code. Furthermore, the Company may accept and register into the shareholders’ register any trans-
fer referred to in any correspondence or other document showing the consent of the transferor and the transferee.

(b) Limitations on transfer. Prior to 25 February 2014 or during such shorter period as may be consistent with ap-

plicable law, except as otherwise provided in any shareholders agreement to be entered into between the Company
and the Class A Ordinary Shareholders, the shareholders of the Company may not validly transfer the shares issued by
the Company, other than to Affiliates or pursuant to Article 7.5(e) below, without the prior written approval of the
Company’s Manager.

(c) Transfer. For the purposes of this article, «Transfer» or «transfer» shall mean any transaction, whether voluntary

or involuntary or by operation of law, resulting in a transfer of the ownership, «nue propriété» «usufruit» or any rights
of the shares issued by the Company (including any voting rights or dividend rights) to any person other than the Com-
pany itself, whether a shareholder of the Company or not, by any means whatsoever (including, without limitation, gifts,
partial contributions of assets («apports partiels d’actifs»), mergers, splits («scissions»), sales, assignments, pledges or
any other for of transfer, conveyance or disposition of any legal or beneficial interest in the shares, as well as any com-
bination of such methods of transfer of ownership.

(d) Transfer of Management Share. e Management Share(s) held by the Manager is (are) not transferable except to a

successor manager to be appointed in accordance with Article 8 of these Articles.

22427

(e) Transfers to Affiliates. The restrictions set out in this Article 7.3 shall not apply with respect to any transfer of

Investor Securities by a holder of Investor Securities to Affiliates after delivering written notice of such transfer to the
Manager.

(f) Transfers in Violation of the Articles. Any Transfer or attempted Transfer of any Securities in violation of any pro-

vision of these Articles shall be void and of no effect, and the Company shall not give effect to such Transfer nor record
such Transfer on its books or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any
purpose.

D. Manager

Art. 8. The Company shall be managed by BRENNTAG-INTERFER S.A., a joint stock company (société anonyme)

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in its capacity as sole general partner (associé commandité)
and manager of the Company (herein referred to as the «Manager»). The other shareholders shall neither participate
in nor interfer with the management of the Company. In the event of legal incapacity, liquidation or other permanent
situation preventing the Manager from acting as manager of the Company, the Company shall not immediately be dis-
solved and liquidated, provided the Supervisory Board, as provided for in Article 11 hereof, appoints an administrator,
who need not be a shareholder, in order that he effect urgent management acts, until a general meeting of shareholders
is held, which such administrator shall convene within 15 days of his appointment At such general meeting, the share-
holders may appoint a successor manager, in accordance with the quorum and majority requirements for amendment
of the Articles. Failing such appointment, the Company shall be dissolved and liquidated. The appointment of a successor
manager shall not be subject to the approval of the Manager.

Art. 9. The Manager is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposal within the

Company’ stated object. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of share-
holders or to the Supervisory Board are within the powers of the Manager.

Art. 10. The Company is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the Manager which itself is bound

vis-à-vis third parties by the joint signatures of any duly appointed representatives, or by the signature(s) of any other
person(s) to whom authority has been delegated by the Manager at its sole discretion, save that the Manager may not
delegate any authority to any limited shareholder.

E. Supervision

Art. 11. The business of the Company and its financial situation, in particular its books and accounts shall be super-

vised by a Conseil de Surveillance (the «Supervisory Board») comprising at least three members, who need not be share-
holders. For the carrying out of its supervisory duties, the Supervisory Board shall have the powers of a statutory
auditor, as provided for by article 62 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to
time. The Supervisory Board may be consulted by the Manager on such matters as he may determine and may authorise
any actions taken by the Manager that may, pursuant to law or regulation or under the Articles, exceed the powers of
the Manager. The members of the Supervisory Board shall be elected by the annual general meeting of shareholders for
a period of one (1) year and shall hold office until their successors are elected. The members of the Supervisory Board
are re-eligible for election and may be removed at any time, with or without cause, by a resolution adopted by the gen-
eral meeting of shareholders. The Supervisory Board may elect one of its members as chairman.

The Supervisory Board shall be convened by its chairman or by the Manager. A meeting of the Supervisory Board

must be convened if any of its members so requests.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all its members at least three (3) days prior

to the date set for such meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature of such emergency shall
be detailed in the notice of meeting. The notice will indicate the place of the meeting and it will contain the agenda there-
of. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, telex, telefax or any other similar means of commu-
nication, a copy being sufficient. Special notices shall not be required for meetings held at times and places fixed in a
calendar previously adopted by the Supervisory Board.

The chairman of the Supervisory Board will preside at all meetings of such board, but in his absence the Supervisory

Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore by vote of the majority present
at such meeting. Any member may act at any meeting by appointing another member as his proxy in writing, by telegram,
telex or telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. A member may represent several
of his colleagues.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or rep-

resented. Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

Resolutions of the Supervisory Board are to be recorded in minutes and signed by the chairman of the meeting. Cop-

ies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere shall be validly signed by the chair-
man of the meeting or any two (2) members.

Written resolutions, approved and signed by all the members of the Supervisory Board, shall have the same effect as

resolutions voted at the Supervisory Boards’ meetings; each member shall approve such resolution in writing, by tele-
gram, telex, telefax or any other similar means of communication, a copy being sufficient. All such documents shall to-
gether form the document which proves that such resolution has been taken.

Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call

or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another.
The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

22428

The member(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commitments reg-

ularly made by them in the name of the Company. They are authorised agents only and are therefore merely responsible
for the execution of their mandate.

The Company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the Supervisory Board and his

heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or
proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the Supervisory Board
of the Company and from which he shall not be entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he
shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct; in the event of set-
tlement, indemnification shall only be provided in connection with such matters covered by the settlement as to which
the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit a breach of duty. The foregoing
right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

The Company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any pro-

ceeding in advance of the final disposition, so long as the Company receives a written and legally binding undertaking by
such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to in-
demnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea
of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy
the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The Company shall make a cash payment to
such indemnifiable person equal to the full amount to be indemnified promptly upon notification of an obligation to in-
demnify from the indemnifiable person supported by such information as the Company shall reasonably require.

Art. 12. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected

or invalidated by the fact that the Manager or any one or more of the directors or officers of the Manager, or any Affiliate
thereof, has any interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm; provided,
however, that any such transaction shall be at arm’s length on commercially reasonable and customary terms. Any di-
rector or officer of the Manager who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the
Company contracts or otherwise engages in business shall not, by reason of such affiliation with such other company
or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other
business.

F. General Meeting of Shareholders

Art. 13. The general meeting of shareholders represents all the shareholders of the Company. It has the broadest

powers to order, proceed with or ratify any acts relating to the operations of the Company, under the reservation that,
unless otherwise provided by the present Articles, a resolution shall be validly adopted only if approved by the Manager.
The general meeting of the shareholders of the Company shall meet when convened by the Manager or the Supervisory
Board.

The annual general meeting shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other

place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of meeting, on the third Friday of May at 11.00 a.m. If
such day is a legal or a bank holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following busi-
ness day in Luxembourg. Other general meetings of shareholders may be held at such places and times specified in the
respective convening notices. The general meetings of the shareholders are convened by a notice indicating the agenda
and sent by the Manager by registered mail at least eight (8) days preceding the general meeting to each shareholder of
the Company at the address indicated in the share register.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The Manager
may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any meeting of share-
holders. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

G. Accounting Year - Balance Sheet

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first (1) of January and shall terminate on the thirty-

first (31

st

) of December of the same year.

Art. 15. From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the reserve required by

law. This allocation shall cease to be required when the amount of the statutory reserve shall have reached ten percent
(10%) of the subscribed share capital. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Manager, shall
determine how the remainder of the annual net profit will be disposed of and interim dividends may be distributed by
observing the terms and conditions provided for by law; provided, however, that any such disposal of profits or distri-
butions shall be in compliance with any shareholders agreement to be entered into between the Company and the Class
A Ordinary Shareholders.

H. Liquidation - Amendment of the Articles

Art. 16. These Articles may be amended, subject to the approval of the Manager, by a general meeting of sharehold-

ers under the quorum and majority requirements provided for by the law of 10 August 1915 on commercial companies
as amended, unless otherwise provided herein. Notwithstanding anything to the contrary in these Articles (i) any
amendment of any provision of these Articles that affects a holder of Class A Ordinary Shares in a manner more adverse
than such amendment affects the other holders of Class A Ordinary Shares shall require the unanimous consent of the
more adversely affected holders of Class A Ordinary Shares and (ii) any amendment of any provision of these Articles
that affects the economic rights of the Management Shares (including by way of issuance of additional Management

22429

Shares or by affecting the rights of the Management Shares to receive distributions on a share by share basis with the
Class A Ordinary Shares) shall require the unanimous consent of all holders of the Class A Ordinary Shares.

Art. 17. In case of dissolution of the Company, one or more liquidators (individuals or legal entities) shall carry out

the liquidation. The liquidator(s) shall be appointed by the general meeting which decided the dissolution and which shall
determine their powers and compensation.

I. Final Dispositions - Applicable Law

Art. 18. For all matters not governed by these Articles, the parties shall refer to the Luxembourg Law of 10 August

1915 on commercial companies, as amended.

J. Miscellaneous

Art. 19. The Company intends timely to elect to be classified as a fiscally transparent (i.e., pass-through) entity for

U.S. tax purposes effective for its first taxable year. In this connection, the Manager, and each other person so authorized
by action of the Shareholders, shall have the authority to execute and file such an election on behalf of the Company.
The Shareholders shall cooperate to effect such election.

There being no further business, the meeting is closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing per-

sons, this deed is worded in English followed by a German translation. On request of the same appearing persons and
in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their first and surnames,

civil status and residences, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

 Im Jahre zweitausendvier, den fünfundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar M

e

 Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

sind die Aktionäre der Kommanditgesellschaft auf Aktien BRENNTAG-INTERFER (BC) (die «Gesellschaft»), mit Ge-

sellschaftssitz in 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, eingetragen im Luxemburg Gesellschafts- und Handelsre-
gister unter Sektion B Nummer 97.315, zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengetreten. Die
Gesellschaft wurde am 25. November 2003 gegründet, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde
am 3. Januar 2004 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 7 veröffentlicht wurde. Die Satzung
der Gesellschaft wurde am 26. Januar 2004 abgeändert, gemäß Urkunde des unterzeichneten Notars, welche Urkunde
noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Die Versammlung wurde um 10.50 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Marc Elvinger, Jurist, wohnhaft in Luxemburg,

eröffnet,

welche zum Schriftführerin in Rachel Uhl, Juristin, wohnhaft, in Luxembourg. bestellt.
Die Hauptversammlung wählt zum Stimmzählerin Fräulein Rachel Uhl, vorgenannt.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den amtierenden Notar folgen-

des zu beurkunden:

I. - Dass die gegenwärtige Hauptversammlung über folgende Tagesordnung zu befinden hat:

<i>Tagesordnung:

1. Schaffung von verschiedenen Klassen von Aktien in Form von Stammaktien der Klasse A (die «Stammaktien der

Klasse A») und Komplementärsaktien (die «Komplementärsaktien»);

2. Einführung neuer Bestimmungen in die Satzung der Gesellschaft über die Ausgabe von Rückkaufsaktien;
3. Umwandlung der zweihundertachtundvierzigtausend (248.000) bestehenden Aktien in zweihundertsiebenundvier-

zigtausendneunhundertneunundneunzig (247.999) Stammaktien der Klasse A und eine (1) Komplementärsaktie;

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals von seinem jetzigen Betrag von dreihundertzehntausend Euro (EUR 310.000)

auf zwei Millionen neunhundertelftausendachthundertzehn Euro (EUR 2.911.810) durch die Schaffung von zwei Millionen
einundachzigtausendvierhundertachtundvierzig (2.081.448) Aktien mit einem Nennwert von je ein Euro fünfundzwanzig
Cent (EUR 1,25);

5. Genehmigung an den Geschäftsführer das Gesellschaftskapital innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals zu

erhöhen ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugszeichungsrecht einzuräumen;

6. Vollständige Abänderung der Satzung. 
7. Verschiedenes.
II. - Dass die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, sowie die

Anzahl der von ihnen besessenen Aktien in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird von
den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und dem Versammlungsvorstand unter-
zeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben eingetragen zu werden. Die Vollmachten der
vertretenen Aktionäre, nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen bleibt auch gegenwärtiger Urkunde als
Anlage beigefügt.

III. - Dass das gesamte Gesellschaftskapital auf gegenwärtiger außerordentlichen Hauptversammlung anwesend oder

gültig vertreten ist und die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sich als ordnungsgemäß einberufen erkennen und
erklären vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt zu haben, so dass die förmliche Einberufung unterlassen werden
konnte.

IV. - Dass die gegenwärtige Versammlung sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt, ordnungsgemäß einberufen ist

und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.

Nach Beratung fasst die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse: 

22430

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die Schaffung von verschiedenen Klassen von Aktien in Form von Stammaktien der

Klasse A (die «Stammaktien der Klasse A») und Komplementärsaktien (die «Komplementärsaktien»), welche in Artikel
6 und 7 der untenstehenden neuen Satzung genauer beschrieben sind.

Die Stammaktien der Klasse A und die Komplementärsaktien werden hier unten zusammen als die «Aktien» bezeich-

net.

<i>Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt dass die Gesellschaft Rückkaufsaktien ausgeben kann. Mit sämtlichen rückkaufba-

ren Aktien sind die gleichen Rechte in Bezug auf den Erhalt von Dividenden und sonstigen Ausschüttungen (einschließlich
Abwicklungserlösen) verbunden, und sie sind mit den gleichen Stimmrechten wie die Stammaktien der Klasse A verse-
hen. Gezeichnet und vollständig eingezahlte rückkaufbare Aktien können bei entsprechender Aufforderung der Gesell-
schaft, die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung erfolgen muss, rückgekauft werden. Der Rückkauf rückkaufbarer
Aktien kann nur unter Einsatz von Beträgen erfolgen, die für eine Ausschüttung gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaft in der letzten Fassung zur Verfügung stehen oder aber unter Einsatz der Erlöse
aus einer neuen Ausgabe, die zum Zwecke einem solchen Rückkauf vorgenommen wird. Nach ihrem Rückkauf verfallen
die mit den rückgekauften Aktien verbundenen Stimmrechte; weiterhin besteht auch kein Recht mehr auf Bezug von
Dividendenausschüttungen oder Abwicklungserlösen.

Alle Stammaktien der Klasse A sind rückkaufbare Aktien gemäß den Bestimmungen des Artikels 49-8 des Gesetzes

vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzter Fassung, mit Ausnahme der Aktien die vor der Ein-
führung dieser Bestimmungen in die Satzung gezeichnet wurden.

Die Bestimmungen über die Rückkaufsaktien in der Satzung lauten wie folgt: 

Art. 6.3 - Rückkauf; Konvertibilität.
(a) Rückkaufbare Aktien. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der Bedingungen dieser Satzung rückkaufbare Aktien

ausgeben. Die Stammaktien der Klasse A sind rückkaufbare Aktien gemäß Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzten Fassung. Mit sämtlichen rückkaufbaren Aktien sind die gleichen Rech-
te in bezug auf den Erhalt von Dividenden und sonstigen Ausschüttungen (einschließlich Abwicklungserlösen) verbun-
den, und sie sind mit den gleichen Stimmrechten wie die Stammaktien der Klasse A versehen. Rückkaufbare Aktien
können bei entsprechender Aufforderung der Gesellschaft, die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung erfolgen muss,
rückgekauft werden. Sämtliche Rückkäufe erfolgen anteilmäßig bezogen auf sämtliche Inhaber jeder Klasse rückkaufba-
rer Aktien, die den Rückkäufen unterworfen werden. Der Rückkauf rückkaufbarer Aktien kann nur unter Einsatz von
Beträgen erfolgen, die für eine Ausschüttung gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaft in der letzten Fassung zur Verfügung stehen (ausschüttungsfähige Gelder, einschließlich der außergewöhnli-
chen Rücklage, die mit den Geldern eingerichtet wurde, die die Gesellschaft als Emissionsagio eingenommen hat), oder
aber unter Einsatz der Erlöse aus einer neuen Ausgabe, die zum Zwecke einem solchen Rückkauf vorgenommen wird.
Nach ihrem Rückkauf werden die rückgekauften Aktien für ungültig erklärt und ihre verbundenen Stimmrechte, Rechte
auf Dividendenausschüttungen oder auf Abwicklungserlöse verfallen.

(b) Sonderrücklage. Im Falle eines teilweisen oder vollständigen Rückkaufs der rückkaufbaren Aktien ist ein Betrag in

Höhe des Nominalwerts oder - liegt ein solcher Wert nicht vor - in Höhe des Pari-Wertes aller rückgekauften Aktien
in eine Rücklage zu geben, die nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet werden darf, außer im Falle einer Senkung des
gezeichneten Aktienkapitals; diese Rücklage darf nur für eine Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals durch Umwand-
lung der Rücklage verwendet werden. 

(c) Rückkaufspreis. Soweit in dieser Satzung oder in einer schriftlichen Vereinbarung, die zwischen den Gesellschaf-

tern abgeschlossen werden kann, nicht anderweitig vorgesehen, ist der auf einen Rückkauf aller rückkaufbaren Aktien
anwendbare Rückkaufspreis vom/von den Geschäftsführer/n oder einer von ihm/ihnen bestellten Person auf der Grund-
lage des Nettovermögenswertes aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu bestimmen. Der Net-
tovermögenswert der Aktien der Gesellschaft ist als Ziffer pro Aktie auszudrücken und ist in bezug auf jeden
Bewertungstag durch Dividieren der Nettovermögenswerte der Gesellschaft - der Wert der Vermögenswerte der Ge-
sellschaft abzüglich ihrer Verbindlichkeiten bei Geschäftsschluss an einem solchen Tag - durch die Anzahl der Aktien der
Gesellschaft, die bei Geschäftsschluss an einem solchen Tag ausstehen, nach Maßgabe der Regeln festzustellen, die der/
die Geschäftsführer zumutbarerweise als fair und billig betrachten. Soweit kein böser Glaube, keine grobe Fahrlässigkeit
und kein manifester Fehler vorliegen, ist jede vom/von den Geschäftsführer/n getroffene Entscheidung über die Berech-
nung des Rückkaufspreises für die Gesellschaft und ihre derzeitigen, vergangenen und zukünftigen Gesellschafter end-
gültig und verbindlich.

(d) Rückkaufsverfahren. Soweit nicht in einer schriftlichen Vereinbarung, die mindestens zehn (10) Tage vor dem

Rückkaufsdatum zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft abgeschlossen werden kann, anderweitig vereinbart, er-
hält jeder eingetragene Inhaber von einzuziehenden Aktien per Einschreiben oder durch einen international anerkannten
Nachtcourier eine schriftliche Mitteilung an die im Aktionärsregister zuletzt eingetragene Anschrift, mit der er unter
Angabe des Rückkaufsdatums, des Rückkaufspreises und des erforderlichen Verfahrens zur Vorlage der Aktien bei der
Gesellschaft zum Rückkauf über die Anzahl der zurückzukaufenden Aktien in Kenntnis gesetzt wird. Jeder Inhaber zu-
rückzukaufenden Aktien hat der Gesellschaft in diesem Zusammenhang seine/n etwaige/n Aktienschein/e, die für die Ak-
tien ausgestellt worden waren, auszuhändigen. Der Rückkaufspreis für diese Aktien ist an die Order der Person, deren
Name im Aktienregister als Inhaber erscheint, auf das Bankkonto zu zahlen, das der betreffende Gesellschafter der Ge-
sellschaft vor dem Rückkaufsdatum mitgeteilt hat.

(e) Komplementärsaktie/n. Die Komplementärsaktie/n ist/sind keine rückkaufbare/n Aktie/n und kann von der Ge-

sellschaft nicht zurückgekauft werden.»

22431

<i>Dritter Beschluss 

Die Hauptversammlung beschließt die Umwandlung der zweihundertachtundvierzigtausend (248.000) bestehenden

Aktien in zweihundertsiebenundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig (247.999) Stammaktien der Klasse A und
eine (1) Komplementärsaktie, wie folgt:

1) die zweihundertsiebenundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig (247.999) Aktien die von BAIN CAPITAL

FUND VII-E (UK) L.P., eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von den USA, mit Sitz in 111 Huntington Avenue,
Boston, MA 02199, USA, sind hiermit in zweihundertsiebenundvierzigtausendneunhundertneunundneunzig (247.999)
Stammaktien der Klasse A umgewandelt; und

2) die eine Aktie die von BRENNTAG-INTERFER, eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem Luxemburger Recht,

mit Sitz in 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach ist hiermit in eine Komplementärsaktie umgewandelt.

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um zwei Millionen sechshunderteintau-

sendachthundertzehn Euro (EUR 2.601.810) von seinem jetzigen Betrag von dreihundertzehntausend Euro (EUR
310.000) auf zwei Millionen neunhundertelftausendachthundertzehn Euro (EUR 2.911.810), durch die Schaffung von
zwei Millionen einundachzigtausendvierhundertachtundvierzig (2.081.448) neuen Stammaktien der Klasse A mit einem
Nennwert von je ein Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 1,25) zu erhöhen.

Die zwei Millionen einundachtzigtausendvierhundertachtundvierzig (2.081.448) neuen Stammaktien der Klasse A

wurden wie folgt gezeichnet

1) siebenundsechzigtausendneunundzwanzig (67.029) Stammaktien der Klasse A wurden durch BAIN CAPITAL

FUND VII-E (UK) L.P., vorgenannt, für einen Betrag von dreiundachtzigtausendsiebenhundertsetzhundachtzig Euro fünf-
undzwanzig Cent (EUR 83.786) gezeichnet;

2) fünfhundertdreiundfünfzigtausenddreihundertsechzig (553.360) Stammaktien der Klasse A wurden durch BAIN

CAPITAL VII COINVESTMENT FUND, LP, ein exempted limited partnership gegründet nach dem Recht von Cayman
Islands, mit Sitz in c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman
Islands für einen Betrag von sechshunderteinundneunzigtausendsiebenhundert Euro (EUR 691.700) gezeichnet;

3) eine Million siebenundsiebzigtausendsechshundertsiebenundsiebzig (1.077.677) Stammaktien der Klasse A wurden

durch BAIN CAPITAL FUND VII, LP, ein exempted limited partnership gegründet nach dem Recht von Cayman Islands,
mit Sitz in c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands
für einen Betrag von eine Million dreihundertsiebenundvierzigtausendsechsundneunzig Euro (EUR 1.347.096,25) ge-
zeichnet;

4) fünfzigtausendsiebenhunderteinundachtzig (50.781) Stammaktien der Klasse A wurden durch BCIP ASSOCIATES

III, ein exempted limited partnership gegründet nach dem Recht von Cayman Islands, mit Sitz in c/o Walkers SPV Li-
mited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands für einen Betrag von dreiund-
sechzigtausendvierhundertsechsundsiebzig Euro (EUR 63.476) gezeichnet;

5) dreitausendneunhunderteinundachtzig (3.981) Stammaktien der Klasse A wurden durch BCIP ASSOCIATES III-B,

ein exempted limited partnership gegründet nach dem Recht von Cayman Islands, mit Sitz in c/o Walkers SPV Limited,
P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, für einen Betrag von viertausend-
neunhundertsechsundsiebzig Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 4.976,25) gezeichnet;

6) sechstausendsechshundertsechsundsiebzig (6.676) Stammaktien der Klasse A wurden durch BCIP TRUST ASSO-

CIATES III, ein exempted limited partnership gegründet nach dem Recht von Cayman Islands, mit Sitz in c/o Walkers
SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, für einen Betrag von
achttausenddreihundertfünfundvierzig Euro (EUR 8.345) gezeichnet;

7) zweitausendvierhundertsiebenunddreißig (2.437) Stammaktien der Klasse A wurden durch BCIP TRUST ASSO-

CIATES III-B, ein exempted limited partnership gegründet nach dem Recht von Cayman Islands, mit Sitz in c/o Walkers
SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, für einen Betrag von
dreitausendsechsundvierzig Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 3.046,25) gezeichnet;

8) zweiundzwanzigtausendsechshundertzweiundachtzig (22.682) Stammaktien der Klasse A wurden durch SANKATY

HIGH YIELD PARTNERS II, LP, ein limited partnership gegründet nach dem Recht vom Staate Delaware aus den Ver-
einigten Staaten von Amerika, mit Sitz in 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, für einen Betrag von acht-
undzwanzigtausenddreihundertzweiundfünfzig Euro fünfzig Cent (EUR 28.352,50) gezeichnet;

9) zweiundzwanzigtausendsechshundertzweiundachtzig (22.682) Stammaktien der Klasse A wurden durch SANKATY

HIGH YIELD PARTNERS III, LP, ein limited partnership gegründet nach dem Recht vom Staate Delaware aus den Ver-
einigten Staaten von Amerika, mit Sitz in 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, für einen Betrag von
achtundzwanzigtausenddreihundertzweiundfünfzig Euro fünfzig Cent (EUR 28.352,50) gezeichnet;

10) elftausenddreihunderteinundvierzig (11.341) Stammaktien der Klasse A wurden durch SANKATY CREDIT OP-

PORTUNITIES, L.P., ein limited partnership gegründet nach dem Recht vom Staate Delaware aus den Vereinigten Staa-
ten von Amerika, mit Sitz in 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, für einen Betrag von
vierzehntausendeinhundertsechsundsiebzig Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 14.176,25) gezeichnet;

11) hundertsechsundzwanzigtausendelf (126.011) Stammaktien der Klasse A wurden durch BROOKSIDE CAPITAL

PARTNERS FUND, LP, ein limited partnership gegründet nach dem Recht vom Staate Delaware aus den Vereinigten
Staaten von Amerika, mit Sitz in 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, für einen Betrag von einhundert-
siebenundfünfzigtausendfünfhundertdreizehn Euro fünfundsiebzig Cent (EUR 157.513,75) gezeichnet;

12) sechstausenddreihundertein (6.301) Stammaktien der Klasse A wurden durch PETER SMEDVIG CAPITAL, AS,

eine Gesellschaft gegründet nach dem Recht von Norwegen, mit Sitz in Lokkeveien 103B, 4007 Stavanger, Norwegen,
für einen Betrag von siebentausendachthundertsechsundsiebzig Euro fünfundzwanzig Cent (EUR 7.876,25) gezeichnet;

22432

13) zehntausendvierhundertneunzig (10.490) Stammaktien der Klasse A wurden durch RANDOLPH STREET PART-

NERS VI, ein limited partnership gegründet nach dem Recht vom Staate Illinois aus den Vereinigten Staaten von Amerika,
mit Sitz in 200 E. Randolph Drive, Chicago, Illinois 60601, USA, für einen Betrag von dreizehntausendeinhundertzwölf
Euro fünfzig Cent (EUR 13.112,50) gezeichnet;

14) sechsunddreissigtausendsiebenhundertzweiundachtzig (36.782) Stammaktien der Klasse A wurden durch GS

MEZZANINE PARTNERS II (BRENNTAG) LLC, eine limited liability company gegründet nach dem Recht vom Staate
Delaware aus den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Sitz in c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wil-
mington, Delaware, USA, für einen Betrag von fünfundvierzigtausendneunhundertsiebenundsiebzig Euro fünfzig Cent
(EUR 45.977,50) gezeichnet;

15) dreiundfünfzigtausendneunhundertdreiundsiebzig (53.973) Stammaktien der Klasse A wurden durch GS MEZ-

ZANINE PARTNERS III ONSHORE FUND (BRENNTAG) LLC, eine limited liability company gegründet nach dem
Recht vom Staate Delaware aus den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Sitz in c/o Corporation Trust Center, 1209
Orange Street, Wilmington, Delaware, USA, für einen Betrag von siebenundsechzigtausendvierhundertsechsundsechzig
Euro fünfundzwanzig Cent EUR 67.466,25) gezeichnet;

16) elftausendzweihundertachtzehn (11.218) Stammaktien der Klasse A wurden durch GS MEZZANINE PARTNERS

II OFFSHORE (BRENNTAG) LLC, eine limited liability company gegründet nach dem Recht vom Staate Delaware aus
den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Sitz in c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, De-
laware, USA, für einen Betrag von vierzehntausendzweiundzwanzig Euro fünfzig Cent (EUR 14.022,50) gezeichnet; und

17) achtzehntausendsiebenundzwanzig (18.027) Stammaktien der Klasse A wurden durch GS MEZZANINE PART-

NERS III OFFSHORE FUND (BRENNTAG) LLC, eine limited liability company gegründet nach dem Recht vom Staate
Delaware aus den Vereinigten Staaten von Amerika, mit Sitz in c/o Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wil-
mington, Delaware, USA, für einen Betrag von zweiundzwanzigtausendfünfhundertdreiunddreißig Euro fünfundsiebzig
Cent (EUR 22.533,75) gezeichnet.

Frau Doris Engel hält diese Stammaktien der Klasse A, für Zwecke der Satzung der Gesellschaft und eines Executive

Equity Subscription Agreement welcher zwischen ihr, der Gesellschaft, BRENNTAG-INTERFER (BC) S.C.A. und ande-
ren leitenden Angestellten die darin aufgeführt sind abgeschlossen werden könnte, als zulässiger Übertragungsempfänger
von Herrn Klaus Engel

Die so gezeichneten Aktien wurden voll durch Geldeinlage eingezahlt, so dass die Gesamtsumme von zwei Millionen

sechshunderteintausendachthundertzehn Euro (EUR 2.601.810) bestehend aus einer Kapitaleinlage von zwei Millionen
sechshunderteintausendachthundertzehn Euro (EUR 2.601.810) der Gesellschaft zur Verfügung stehen, wie es dem un-
terzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt den Geschäftsführer weiterhin zu genehmigen das Gesellschaftskapital bis zu ei-

nem Betrag von fünfhundert Millionen Euro (EUR 500.000.000) für eine Zeit von fünf Jahren ab der Veröffentlichung
dieses Beschlusses der Hauptversammlung im Luxemburger Amtsblatt zu erhöhen.

Auf Grund des Berichts des Geschäftsführers der Gesellschaft, beschließt die Hauptversammlung einstimmig, gemäß

den Bestimmungen von Artikel 32-3 (5) des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften, den Geschäftsführer zu ge-
nehmigen das Vorzugszeichungsrechte der bestehenden Aktionären innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals
einzuschränken oder wegfallenzulassen.

<i>Sechster Beschluss

Die Hauptversammlung beschließt die völlige Abänderung der Satzung die fortan wie folgt lautet:

A. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Es besteht eine zwischen den Zeichnern sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung ausgestellten

Aktien eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die die Bezeichnung BRENNTAG INTERFER (BC) führt (die «Gesell-
schaft»).

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach-Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg. Die Verlegung

des Sitzes der Gesellschaft innerhalb der gleichen Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers.
Durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Groß-
herzogtum Luxemburg als auch im Ausland, gegründet werden. Aufgrund eines bestehenden oder unmittelbar drohen-
den politischen, militärischen oder anderen Notfalls von höherer Gewalt außerhalb der Kontrolle, Verantwortlichkeit
und Einflussmöglichkeit der Gesellschaft, der die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungs-
losen Verkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland beeinträchtigt, kann der Geschäftsführer durch einen einfachen
Beschluss den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur Wiederherstellung von normalen Verhältnissen ins Ausland ver-
legen. In diesem Falle wird jedoch die Gesellschaft die luxemburgische Nationalität beibehalten.

Art. 3. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur
betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind.

22433

B. Geschäftsführung - Aktienkapital

Art. 5. Der Komplementär (associé commandité) haftet gesamtverbindlich für alle Schulden, die nicht aus den Gü-

tern der Gesellschaft beglichen werden können. Die anderen Aktionäre (zum Ausschluss jedes Zweifels, ausschließlich
des Komplementärs), der/die Eigentümer von Aktien der Klasse A, sollen jede Handlung im Namen der Gesellschaft, in
jeder Art und Funktion unterlassen, außer die Ausübung Ihrer Rechte als Aktionäre bei Hauptversammlungen. Die Kom-
manditäre haften nur mit ihrer Kapitaleinlage.

Art. 6. Gesellschaftskapital
Art. 6.1. Gezeichnetes Kapital. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwei Millionen neunhunder-

telftausendachthundertzehn Euro (EUR 2.911.810) und setzt sich zusammen aus vollständig eingezahlten Aktien, beste-
hend aus zwei Millionen dreihundertneunundzwanzigtausendvierhundertsiebenundvierzig (2.329.447) Stammaktien der
Klasse A im Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25) (nachstehend «Stammaktien der Klasse
A» genannt) sowie einer (1) Komplementärsaktie im Pari-Wert von einem Euro fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25)
(nachstehend «Komplementärsaktie» genannt).

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft kann anhand eines Beschlusses der Gesellschafter, der genauso anzunehmen

ist wie ein Beschluss über eine Satzungsänderung, erhöht oder gesenkt werden. Die Gesellschaft ist in dem gesetzlich
zulässigen Ausmaß sowie unter den gesetzlich zulässigen Bedingungen berechtigt, ihre eigenen Aktien zurückzukaufen.

Abstimmungen der Inhaber sämtlicher Aktien sind gemeinsam vorzunehmen, und die Inhaber separater Klassen von

Aktien sind nicht befugt, separat über Angelegenheiten abzustimmen, es sei denn, dies ist kraft Gesetz erforderlich oder
in dieser Satzung festgelegt. In Verbindung mit keiner Aktienklasse bestehen in bezug auf Aktien der Gesellschaft Vor-
kaufsrechte, es sei denn, dies ist kraft Gesetz erforderlich oder in einer sonstigen Aktionärsvereinbarung, die zwischen
der Gesellschaft und den Inhabern der Stammaktien der Klasse A abgeschlossen werden kann, vorgesehen.

Art. 6.2. Beschreibung der Aktien 
Art. 6.2.1. Stammaktien der Klasse A 
(a) Die Stammaktien der Klasse A. Die Stammaktien der Klasse A sind in jeder Hinsicht identisch. Sämtliche Stamm-

aktien der Klasse A nehmen anteilmäßig an der Ausschüttung von Dividenden sowie an jeglichen Verteilungen von Ver-
mögenswerten auf anderem Wege als durch Dividenden teil, die insgesamt diesen Stammaktien der Klasse A zugewiesen
werden. Sämtliche Stammaktien der Klasse A, die von der Gesellschaft gekauft oder anderweitig erworben werden,
werden - soweit der Geschäftsführer entsprechendes anweist - mit der Wirkung zurückgekauft, daß die ausgegebene
Anzahl der Stammaktien der Klasse A gesenkt wird. Rückkäufe, Rückkäufe oder sonstige Erwerbungen von Stammaktien
der Klasse A durch die Gesellschaft finden anteilmäßig auf sämtliche Inhaber der Stammaktien der Klasse A unter Be-
dingungen und Konditionen (inklusive Preis pro Aktie) Anwendung, die gleichermaßen für sämtliche Inhaber gelten. 

(b) Stimmrechte. Eine Stammaktie der Klasse A erteilt dem Inhaber eine Stimme in Zusammenhang mit sämtlichen

Angelegenheiten, über die diese Inhaber abstimmen dürfen.

Art. 6.2.2. Die Komplementärsaktien.
(a) Die Komplementärsaktie(n). Sämtliche Komplementärsaktie(n) sind in jeder Hinsicht identisch. Sämtliche Kom-

plementärsaktie(n) nehmen anteilmäßig an der Ausschüttung von Dividenden sowie jeglichen Verteilungen von Vermö-
genswerten auf anderem Wege als durch Dividenden teil, die insgesamt dieser/diesen Komplementärsaktie(n)
zugewiesen werden.

(b) Stimmrechte. Eine Komplementärsaktie erteilt dem Inhaber eine Stimme in Zusammenhang mit sämtlichen Ange-

legenheiten, über die diese Inhaber abstimmen dürfen.

Art. 6.3. Rückkauf; Konvertibilität.
(a) Rückkaufbare Aktien. Die Gesellschaft kann nach Maßgabe der Bedingungen dieser Satzung rückkaufbare Aktien

ausgeben. Die Stammaktien der Klasse A sind rückkaufbare Aktien gemäß Artikel 49-8 des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in dessen letzten Fassung. Mit sämtlichen rückkaufbaren Aktien sind die gleichen Rech-
te in bezug auf den Erhalt von Dividenden und sonstigen Ausschüttungen (einschließlich Abwicklungserlösen) verbun-
den, und sie sind mit den gleichen Stimmrechten wie die Stammaktien der Klasse A versehen. Rückkaufbare Aktien
können bei entsprechender Aufforderung der Gesellschaft, die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung erfolgen muss,
rückgekauft werden. Sämtliche Rückkäufe erfolgen anteilmäßig bezogen auf sämtliche Inhaber jeder Klasse rückkaufba-
rer Aktien, die den Rückkäufen unterworfen werden. Der Rückkauf rückkaufbarer Aktien kann nur unter Einsatz von
Beträgen erfolgen, die für eine Ausschüttung gemäß Artikel 72-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsge-
sellschaft in der letzten Fassung zur Verfügung stehen (ausschüttungsfähige Gelder, einschließlich der außergewöhnli-
chen Rücklage, die mit den Geldern eingerichtet wurde, die die Gesellschaft als Emissionsagio eingenommen hat), oder
aber unter Einsatz der Erlöse aus einer neuen Ausgabe, die zum Zwecke einem solchen Rückkauf vorgenommen wird.
Nach ihrem Rückkauf werden die rückgekauften Aktien für ungültig erklärt und ihre verbundenen Stimmrechte, Rechte
auf Dividendenausschüttungen oder auf Abwicklungserlöse verfallen.

(b) Sonderrücklage. Im Falle eines teilweisen oder vollständigen Rückkaufs der rückkaufbaren Aktien ist ein Betrag in

Höhe des Nominalwerts oder - liegt ein solcher Wert nicht vor - in Höhe des Pari-Werte aller rückgekauften Aktien
in eine Rücklage zu geben, die nicht an die Gesellschafter ausgeschüttet werden darf, außer im Falle einer Senkung des
gezeichneten Aktienkapitals; diese Rücklage darf nur für eine Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals durch Umwand-
lung der Rücklage verwendet werden. 

(c) Rückkaufspreis. Soweit in dieser Satzung oder in einer schriftlichen Vereinbarung, die zwischen den Gesellschaf-

tern abgeschlossen werden kann, nicht anderweitig vorgesehen, ist der auf einen Rückkauf aller rückkaufbaren Aktien
anwendbare Rückkaufspreis vom/von den Geschäftsführer/n oder einer von ihm/ihnen bestellten Person auf der Grund-
lage des Nettovermögenswertes aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu bestimmen. Der Net-
tovermögenswert der Aktien der Gesellschaft ist als Ziffer pro Aktie auszudrücken und ist in bezug auf jeden
Bewertungstag durch Dividieren der Nettovermögenswerte der Gesellschaft - der Wert der Vermögenswerte der Ge-

22434

sellschaft abzüglich ihrer Verbindlichkeiten bei Geschäftsschluss an einem solchen Tag - durch die Anzahl der Aktien der
Gesellschaft, die bei Geschäftsschluss an einem solchen Tag ausstehen, nach Maßgabe der Regeln festzustellen, die der/
die Geschäftsführer zumutbarerweise als fair und billig betrachten. Soweit kein böser Glaube, keine grobe Fahrlässigkeit
und kein manifester Fehler vorliegen, ist jede vom/von den Geschäftsführer/n getroffene Entscheidung über die Berech-
nung des Rückkaufspreises für die Gesellschaft und ihre derzeitigen, vergangenen und zukünftigen Gesellschafter end-
gültig und verbindlich.

(d) Rückkaufsverfahren. Soweit nicht in einer schriftlichen Vereinbarung, die mindestens zehn (10) Tage vor dem

Rückkaufsdatum zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft abgeschlossen werden kann, anderweitig vereinbart, er-
hält jeder eingetragene Inhaber von einzuziehenden Aktien per Einschreiben oder durch einen international anerkannten
Nachtcourier eine schriftliche Mitteilung an die im Aktionärsregister zuletzt eingetragene Anschrift, mit der er unter
Angabe des Rückkaufsdatums, des Rückkaufspreises und des erforderlichen Verfahrens zur Vorlage der Aktien bei der
Gesellschaft zum Rückkauf über die Anzahl der zurückzukaufenden Aktien in Kenntnis gesetzt wird. Jeder Inhaber zu-
rückzukaufenden Aktien hat der Gesellschaft in diesem Zusammenhang seine/n etwaige/n Aktienschein/e, die für die Ak-
tien ausgestellt worden waren, auszuhändigen. Der Rückkaufspreis für diese Aktien ist an die Order der Person, deren
Name im Aktienregister als Inhaber erscheint, auf das Bankkonto zu zahlen, das der betreffende Gesellschafter der Ge-
sellschaft vor dem Rückkaufsdatum mitgeteilt hat.

(e) Komplementärsaktie/n. Die Komplementärsaktie/n ist/sind keine rückkaufbare/n Aktie/n und kann von der Ge-

sellschaft nicht zurückgekauft werden.

Art. 6.4. Ausschüttungen an die Gesellschafter
Wenn die Gesellschafterversammlung und/oder der Geschäftsführer der Gesellschaft die Vornahme einer Ausschüt-

tung an die Gesellschafter beschließt (sei es durch Zwischendividende, Rückkauf oder anderweitig), haben die Gesell-
schafter ein Recht auf Erhalt der Ausschüttungen, wenn, so wie und soweit von der Gesellschafterversammlung und/
oder dem Geschäftsführer erklärt, aus den dafür rechtmäßig zur Verfügung stehenden Geldern gemäß geltendem Recht
und in der Art und Weise, die in den restlichen Bestimmungen dieses Artikels 6.4 dargelegt ist. Die Inhaber von Stamm-
aktien der Klasse A und der Komplementärsaktie/n haben Anspruch auf Erhalt aller Ausschüttungen, die die Gesellschaft
an die Gesellschafter vornimmt, und diese Ausschüttungen werden pro rata unter den Inhabern der Stammaktien der
Klasse A und der Komplementärsaktie/n auf der Grundlage der vom jeweiligen Inhaber gehaltenen Anzahl an Stammak-
tien vorgenommen; darüber hinaus sollten dabei für alle Inhaber die gleichen Bedingungen und Konditionen gelten.

Art. 6.5. Rechte bei Liquidation
Im Falle einer Liquidation werden die nach Zahlung aller Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleiben-

den Vermögenswerte der Gesellschaft auf die im Artikel 6.4 oben genannte Art und Weise zwischen den Gesellschaf-
tern verteilt. Eine Fusion oder Verschmelzung der Gesellschaft in oder mit einer anderen oder mehreren anderen
Körperschaften oder eine Fusion oder Verschmelzung einer oder mehrerer anderer Körperschaften in bzw. mit der
Gesellschaft oder ein Verkauf, eine Übertragung, eine Verpachtung oder die Vornahme eines Tauschgeschäfts (gegen
Bargeld, Wertpapiere oder sonstige Gegenleistungen) von allen oder einigen Teilen der Vermögenswerte der Gesell-
schaft gilt im Sinne dieses Artikels 6.5 nicht als Liquidation, es sei denn, eine solche Fusion, Verschmelzung, ein solcher
Verkauf, eine solche Übertragung, Verpachtung oder ein solches Tauschgeschäft wird in Zusammenhang mit einer voll-
ständigen Auflösung, Liquidation oder Abwicklung der Gesellschaft vorgenommen oder ist in einem solchen Rahmen
geplant.

Art. 6.6. Genehmigtes Kapital
Zusätzlich zu dem gezeichneten Kapital verfügt die Gesellschaft über ein genehmigtes Kapital in Höhe von fünf hun-

dert Millionen Euro (EUR 500.000.000), bestehend aus vierhundert Millionen (400.000.000) Stammaktien der Klasse A
mit einem Pari-Wert von je einem Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR 1,25).

In einem Zeitraum, der fünf (5) Jahre nach dem Datum der Bekanntgabe des Gesellschafterbeschlusses über die Ein-

richtung des genehmigten Kapitals im Luxemburger Amtsblatt, Mémorial C, Recueil et Associations, endet, ist der Ge-
schäftsführer befugt, das gezeichnete Kapital in einem oder mehreren Schritten zu erhöhen, indem er die Gesellschaft
zur Ausgabe neuer Aktien innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals veranlasst. Diese neuen Aktien (Stammak-
tien, Vorzugsaktien oder Aktien einer beliebigen Klasse, die von der Gesellschaft ausgegeben werden dürfen) können
unter den Bedingungen und Konditionen gezeichnet und ausgegeben werden, die der Geschäftsführer bestimmt, genau-
er gesagt, die er in bezug auf die Zeichnung und die Einzahlung der auszugebenden und zu zeichnenden neuen Aktien
bestimmt; Entscheidung über den Zeitpunkt und Menge der zu zeichnenden und auszugebenden neuen Aktien; Entschei-
dung darüber, ob die neuen Aktien mit oder ohne Emissionsagio gezeichnet werden sollen; Entscheidung darüber, in
welchem Ausmaß die Zahlung der neu gezeichneten Aktien in bar oder anhand anderer Vermögenswerte als Bargeld
erfolgen soll. Jede Aktienausgabe der Gesellschaft muss nach Maßgabe der Bedingungen und Konditionen erfolgen, die
in Aktionärsverträgen niedergelegt sind, welche zwischen der Gesellschaft und den Inhabern der Stammaktien der Klas-
se A abgeschlossen werden können. Soweit die Gesellschafter keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen haben, gilt
bei der vollständigen oder teilweisen Umwandlung des genehmigten Kapitals, dass der Geschäftsführer ausdrücklich be-
fugt ist, die Vorzugszeichnungsrechte, die den bestehenden Aktionären vorbehalten sind, einzuschränken oder wegfallen
zu lassen. Der Geschäftsführer kann die Pflichten zur Annahme von Zeichnungen und Entgegennahme von Zahlungen
für neue Aktien, die den gesamten Betrag der Kapitalerhöhung oder einen Teil davon ausmachen, an ordnungsgemäß
bevollmächtige Verwaltungsräte oder leitende Angestellte der Gesellschaft oder anderweitig ordnungsgemäß bevoll-
mächtige Personen delegieren. Nach jeder Erhöhung des gezeichneten Kapitals durch den Geschäftsführer in der recht-
lich vorgeschriebenen Form und gemäß dieser Satzung ist dieser Artikel 6.6 im Sinne der Berücksichtigung dieser
Erhöhung entsprechend abzuändern.

Art. 6.7. Änderungen des gezeichneten und des genehmigten Kapitals

22435

Erhöhungen oder Senkungen des gezeichneten und genehmigten Kapitals der Gesellschaft unterliegen der Entschei-

dung der Gesellschafterversammlung, die darüber mit der gleichen beschlussfähigen Anzahl abzustimmen hat wie die die
für Änderungen der vorliegenden Satzung erforderlich ist.

Art. 6.8. Definitionen
Für die Zwecke dieser Satzung gilt wie folgt:
«Zweiggesellschaft» oder «Zweiggesellschaften» bezeichnet, in Bezug auf jede Person, jede andere Person die, direkt

oder indirekt, kontrolliert, kontrolliert wird durch, oder unter der gemeinsamen Kontrolle mit dieser ersten Person
oder einer anderen Person die direkt oder indirekt fünfzig (50) Prozent der wirtschaftlichen Interessen in dieser ersten
Person oder in der diese erste Person direkt oder indirekt mehr als fünfzig (50) Prozent der wirtschaftlichen Interessen
hält, ist. Zum Zweck dieser Definition, «Kontrolle» bezeichnet, in Bezug auf jede Person, die Macht zu kontrollieren
oder die Kontrolle über die Gesellschaftsführung und die Orientierungen dieser Person zu veranlassen, ob durch Besitz
der wahlberechtigten Wertpapiere oder durch Mitgliedschaft im Verwaltungsrat der Geschäftsführerrat, durch Vertrag
(einbegriffen aber nicht eingeschränkt auf einen «limited partnership agreement» oder einen «general partnership agree-
ment») oder anderweitig. Ein trust oder ein nominee der direkt oder indirekt Wertpapiere zum hauptsächlichen Profit
von Angestellten des Inhabers oder der Gesellschaft, oder einer deren Zweiggesellschaft hält, wird als Zweiggesellschaft
dieser Person angesehen.

«Satzung» ist die vorliegende Satzung in ihrer jeweils letzten Fassung. 
«Stammaktien der Klasse A» hat die im Artikel 6.1 genannte Bedeutung. 
«Gesellschaft» hat die im Artikel 1 genannte Bedeutung. 
«Komplementärsaktie» hat die im Artikel 6.1 genannte Bedeutung. 
«Geschäftsführer» hat die im Artikel 8 genannte Bedeutung. 
«Stammaktien» bezeichnet die Stammaktien der Gesellschaft (außer der/den Komplementärsaktie/n).
«Person» bezeichnet eine Privatperson, eine Personengesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, eine Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung, eine Vereinigung, eine Aktiengesellschaft, einen Trust, ein Joint Venture, eine nicht eingetragene
Organisation, eine Regierungskörperschaft oder eine Abteilung, Agentur oder politische Unterabteilung davon.

«Wertpapiere» sind sämtliche ordnungsgemäß genehmigten Wertpapiere der Gesellschaft, einschließlich aber nicht

beschränkt auf jegliche Serien1 PECs, Serien 2 PECs, Serien 1 CPECs oder die Stammaktien, die von der Gesellschaft
ausgegeben wurden. 

«Wertpapierinhaber» bezeichnet einen Inhaber von Wertpapieren.
«Serie 1 CPECs» bezeichnet die Serie 1 von umwandelbaren, bevorzugten Eigenkapitalscheinen, die von Zeit zu Zeit

von der Gesellschaft ausgegeben werden können, und, soweit anwendbar, alle weiteren Serien umwandelbarer, bevor-
zugter Eigenkapitalscheine, die von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft ordnungsgemäß genehmigt und ausgegeben wer-
den.

«Serie 1 PECs» bezeichnet die Serie 1 von bevorzugten Eigenkapitalscheinen, die von Zeit zu Zeit von der Gesell-

schaft ausgegeben werden können, und, soweit anwendbar, alle weiteren Serien bevorzugter Eigenkapitalscheine, die
von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft ordnungsgemäß genehmigt und ausgegeben werden.

«Serie 2 CPECs» bezeichnet die Serie 2 von umwandelbaren, bevorzugten Eigenkapitalscheinen, die von Zeit zu Zeit

von der Gesellschaft ausgegeben werden können, und, soweit anwendbar, alle weiteren Serien umwandelbarer, bevor-
zugter Eigenkapitalscheine, die von Zeit zu Zeit von der Gesellschaft ordnungsgemäß genehmigt und ausgegeben wer-
den.

«Übertragung» hat die im Artikel 7.3(c) genannte Bedeutung.

C. Aktien - Aktienregister - Aktienübertragungen

Art. 7. Aktien
Art. 7.1. Aktienregister
Sämtliche Aktien weisen jetzt und in Zukunft die Form eingetragener Aktien auf. Ein Aktienregister, das von jedem

Aktionär eingesehen werden kann, wird am eingetragenen Geschäftssitz gehalten. Dieses Register enthält die genauen
Bezeichnungen aller Aktionäre sowie Angaben über die Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Aktien, über die auf die
Aktien erfolgten Einzahlungen sowie über die Aktienübertragungen und die Übertragungsdaten. Jeder Aktionär hat die
Gesellschaft per Einschreiben über seine Anschrift und jegliche Anschriftenänderungen zu informieren. Die Gesellschaft
ist befugt, sich auf die zuletzt mitgeteilte Anschrift zu berufen. Zertifikate über diese Eintragungen werden auf Wunsch
der jeweiligen Aktionäre vom Geschäftsführer ausgegeben und unterzeichnet.

Art. 7.2. Aktieneigentum
Das Eigentumsrecht an den eingetragenen Aktien geht aus den Eintragungen im Aktienregister hervor. Die Gesell-

schaft erkennt pro Aktie nur einen Eigentümer an. Wenn eine oder mehrere Aktien in einem Gemeinschaftseigentum
stehen oder wenn das Eigentumsrecht an einer oder mehreren Aktien strittig ist, müssen sämtliche Personen, die ein
Recht auf eine oder mehrere Aktien anmelden, einen einzigen Vertreter zwecks Vertretung dieser Aktie/n gegenüber
der Gesellschaft bestellen. Wird ein solcher Vertreter nicht bestellt, führt dies zu einer Aufhebung sämtlicher mit sol-
chen Aktien verbundenen Rechte.

Art. 7.3. Aktienübertragung
(a) Erklärung einer Übertragung. Die Übertragung, von Aktien wird von einer Erklärung einer im Aktienregister ein-

getragenen Übertragung begleitet, die von der übertragenden Person und von dem Übertragungsempfänger oder dessen
Vertreter/n datiert und unterzeichnet wird. Weiterhin unterliegen Aktienübertragungen den Bestimmungen über die
Übertragung von Forderungen gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuchs von Luxemburg. Die Gesellschaft
kann außerdem jegliche Übertragungen annehmen und im Aktionärsregister eintragen, die in schriftlichen Mitteilungen
oder sonstigen Dokumenten niedergelegt sind, in denen die Zustimmung der übertragenden Person und des Übertra-
gungsempfängers enthalten ist.

22436

(b) Übertragungsauflagen. Vor dem 25. Februar 2014 oder während eines kürzeren Zeitraums, der dem maßgeblichen

Recht entsprechen mag, es sei denn, ein Aktionärsvertrag zwischen der Gesellschaft und den Inhabern von Stammaktien
der Klasse A enthält anderweitige Vorkehrungen, ist es den Gesellschaftern der Gesellschafter nicht erlaubt, die von
der Gesellschaft ausgegebenen Aktien an andere Personen als an Zweiggesellschaften oder auf anderem Wege als gemäß
Artikel 7.5(e) unten rechtswirksam zu übertragen, soweit nicht die vorherige schriftliche Zustimmung des Geschäfts-
führers der Gesellschaft vorliegt.

(c) Übertragung. Für die Zwecke dieses Artikels bezeichnet der Begriff «Übertragung» jede freiwillig oder zwangsläu-

fig oder kraft Gesetz vonstatten gehende Transaktion, die zu einer Übertragung des Eigentumsrechts, «nue propriété»,
«usufruit» oder anderer Rechte an den von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien (einschließlich Stimmrechten oder
Rechten auf Dividenden) an andere Personen als an die Gesellschaft führt, unabhängig davon, ob es sich dabei um einen
Gesellschafter dieser Gesellschaft oder nicht handelt; die dazu führenden Maßnahmen spielen dabei keine Rolle (und
umfassen, sind aber nicht beschränkt auf Schenkungen, Teileinlagen auf Vermögenswerte («apports partiels d’actifs»),
Fusionen, Spaltungen («scissions»), Verkäufe, Abtretungen, Pfändungen oder sonstige Formen von Übertragungen,
Übereignungen oder Veräußerungen rechtmäßiger oder wirtschaftlicher Anteile an Aktien sowie Kombinationen dieser
Eigentumsübertragungsmaßnahmen.

(d) Übertragung einer oder mehrerer Komplementärsaktie/n. Die vom Geschäftsführer gehaltene/ Komplementärs-

aktie/n ist/sind nicht übertragbar, außer an einen Nachfolgegeschäftsführer, der gemäß Artikel 8 dieser Satzung zu er-
nennen ist.

(e) Übertragungen an Zweiggesellschaften. Die in diesem Artikel 7.3 niedergelegten Auflagen finden keine Anwendung

auf die Übertragung von Wertpapieren von Investoren durch den Inhaber solcher Wertpapiere an Zweiggesellschaften
nach Zustellung einer schriftlichen Mitteilung einer solchen Übertragung an den Geschäftsführer.

(f) Übertragunungen bei Verletzung dieser Satzung. Jegliche Übertragungen oder versuchten Übertragungen von

Wertpapieren bei Verletzung von Bestimmungen dieser Satzung sind nichtig und wirkungslos, und die Gesellschaft ver-
leiht solchen Übertragungen weder Wirkung noch trägt sie diese Übertragungen in ihre Bücher ein oder behandelt einen
vermeintlichen Übertragungsempfänger solcher Wertpapiere für irgendwelche Zwecke als den Eigentümer solcher
Wertpapiere.

D. Geschäftsführer

Art. 8. Die Gesellschaft wird durch BRENNTAG-INTERFER A.G., eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem Recht

des Großherzogtums Luxemburg, in ihrer Eigenschaft als Komplementär (associé commandité) und Geschäftsführer der
Gesellschaft verwaltet («der Geschäftsführer»). Die anderen Aktionäre dürfen an dieser Verwaltung der Gesellschaft
weder teilnehmen noch sich darin einmischen. Im Falle einer rechtlichen Geschäftsunfähigkeit, einer Liquidation, oder
einer anderen endgültigen Lage welche den Geschäftsführer verhindert als Geschäftsführer der Gesellschaft zu fungie-
ren, wird die Gesellschaft nicht unmittelbar aufgelöst und liquidiert, sofern der Aufsichtsrat gemäß Artikel 11 dieser Sat-
zung, einen Geschäftsführer ernennt, welcher nicht Aktionär sein muss, damit dieser die dringende Geschäftsführung
übernimmt, bis eine Hauptversammlung der Aktionäre stattgefunden hat, die der Geschäftsführer innerhalb von 15 Ta-
gen nach seiner Ernennung, einberuft. Auf dieser Hauptversammlung können die Aktionäre, den gesetzlich erforderli-
chen Anwesenheitsquoten und Fristen folgend, einen Nachfolger des Geschäftsführers ernennen. Sollte diese Ernennung
nicht geschehen, wird die Gesellschaft aufgelöst und liquidiert. Die Ernennung des Nachfolgers des Geschäftsführers be-
nötigt nicht die Zusage des Geschäftsführers.

Art. 9. Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Geschäftsführer hat sämtliche Befug-
nisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung der Aktionäre oder
dem Aufsichtsrat vorbehalten sind.

Art. 10. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet, der selbst

gegenüber Dritten durch die gemeinsame Unterschrift von zwei bevollmächtigten Vertretern des Geschäftsführers ver-
pflichtet wird, oder durch die Unterschrift jeder vom Geschäftsführer bevollmächtigten Person(en), nach seinem eige-
nem Ermessen, außer jede Übertragung einer Befugnis an einen Kommanditisten.

E. Aufsichtsrat

Art. 11. Die Geschäfte sowie die finanzielle Situation der Gesellschaft, insbesondere ihre Bilanzen und Konten, un-

terliegen der Überwachung des Conseil de Surveillance (der «Aufsichtsrat»), der aus mindestens drei Mitgliedern be-
steht, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Der Aufsichtsrat hat für seine Überwachungsfunktion die in
Artikel 62 des Gesetzes des 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert, vorgesehene
Befugnisse eines Rechnungsprüfers. Der Aufsichtsrat wird befragt über spezielle Fragen vom Komplementär und geneh-
migt jede Handlung die, durch Anwendung des Gesetzes oder durch gegenwärtige Satzung, die Befugnisse des Komple-
mentärs überschreiten. Die jährliche Hauptversammlung der Aktionäre wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats für eine
Dauer von einem Jahr. Die Mitglieder behalten ihr Mandat bis zur Ernennung eines Nachfolgers. Die Mitglieder des Auf-
sichtsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden und können jederzeit und unbegründet durch Beschluss
der Hauptversammlung abberufen werden. Der Aufsichtsrat kann aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden
wählen.

Der Aufsichtsrat wird von seinem Vorsitzenden oder von dem Geschäftsführer einberufen. Der Aufsichtsrat muss

auf Anfrage einer seiner Mitglieder einberufen werden.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates erhält mindestens drei (3) Tage vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der Sitzung, ein

Einberufungsschreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlich-
keit im Einberufungsschreiben angegeben werden müssen. Das Einberufungsschreiben enthält den Ort und die Tages-

22437

ordnung der Sitzung. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel
(eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitglieds der Aufsichtsrates, kann auf die Einberufungs-
schreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sitzungen des Aufsichtsrates,
die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen Beschluss des Aufsichtsrates auf
dem Kalender festgesetzt wurden.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Aufsichtsrates; in seiner Abwesenheit kann der Aufsichtsrat mit

Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates ernennen, um den Vorsitz dieser Sitzungen zeitweilig
zu führen. Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann sich in der Sitzung aufgrund einer schriftlich, durch Faksimileübertra-
gung oder durch andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht durch ein anderes Mit-
glied des Aufsichtsrats vertreten lassen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats kann mehrere andere Mitglieder vertreten.

Der Aufsichtsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten

sind. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.

Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in Protokollen festgehalten und von dem Vorsitzenden unterzeichnet. Die Ver-

tretungsvollmächte werden an dieser angeheftet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder ander-
weitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Mitgliedern unterzeichnet.

Einstimmige Beschlüsse des Aufsichtsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schriftli-

cher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll, das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrates kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommu-

nikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.
Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung..

Die Mitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche sie im Namen der Ge-

sellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft und sind daher aus-
schließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt auf die im weitest möglichen Sinne nach Recht zulässige Art und Weise jedes Mitglied

des Aufsichtsrates, seine Erben, Testamenvollstrecker oder Geschäftsführer für angemessene Kosten die im Zusam-
menhang mit jeder Handlung, jedem Prozess oder Verfahren in denen er wegen seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat als
Partei beteiligt ist oder war, entstanden sind. Das Mitglied hat kein Recht auf Entschädigung, wenn im Zusammenhang
mit jeder diesbezüglichen Handlung, jedem Prozess oder jedem Verfahren gerichtlich festgestellt wurde, dass es wegen
Fahrlässigkeit oder schlechter Geschäftsführung haftbar ist. Im Falle eines Vergleiches wird Entschädigung nur in Bezug
auf die im Vergleich einbegriffenen Angelegenheiten gezahlt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtbeistand Bestä-
tigung erhält, dass das betroffene Mitglied seine Pflichten nicht verletzt hat. Das hiervor aufgeführte Recht auf Entschä-
digung schließt andere Rechte die dem Mitglied zustehen sollten nicht aus.

Die Gesellschaft übernimmt die Kosten jeder Person, die hierdurch Recht auf Entschädigung hat in Verbindung mit

jedem Verfahren, vor dem endgültigen Urteil, insofern die Gesellschaft eine schriftliche und rechtskräftige Verpflichtung
dieser Person erhält, den Vorschussbetrag zurückzuerstatten, im Fall einer endgültigen Feststellung, dass kein Recht auf
Entschädigung von der Gesellschaft besteht. Alleine durch die Beendigung einer Handlung, eines Prozesses oder eines
Verfahrens durch ein Urteil, eine Anweisung, Beilegung, Verurteilung oder nolo contendere oder gleichwertige Vertei-
digung, entsteht nicht die Vermutung, dass die Person, welche Recht auf Entschädigung hat, den Benehmensstandart,
durch den das Entschädigungsrecht entsteht, nicht eingehalten hat. Die Gesellschaft wird eine Barzahlung an den Ent-
schädigungsberechtigten machen, in gleicher Höhe wie die von ihm eingegangene entschädigungsberechtigte Verpflich-
tungen, sofort nach Erhalt der Mitteilung einer Entschädigungspflicht von dem Entschädigungsberechtigten, unterstützt
von den Informationen welche die Gesellschaft vernünftigerweise fordern kann.

Art. 12. Kein Vertrag oder andere Transaktion zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma

soll dadurch beeinträchtigt oder für ungültig erklärt werden, dass der Geschäftsführer, oder ein oder mehrere Verwal-
tungsratsmitglieder oder leitende Angestellte dieses Geschäftsführers, oder einer Zweig/Tochtergesellschaft davon, ein
Interesse darin hat, oder ein Verwaltungsratsmitglied, ein leitender Angestellter oder ein Angestellter dieser anderen
Gesellschaft oder Firma ist; jedoch, vorausgesetzt, dass eine solche Transaktion auf gutgläubiger und auf rein geschäftli-
cher Basis an eine unabhängige dritte Partei erfolgt. Jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeder leitende Angestellte dieses
Geschäftsführers, der als Verwaltungsratsmitglied, leitender Angestellter oder Angestellter einer Gesellschaft oder Fir-
ma handelt, mit der die Gesellschaft handelt oder in anderer Weise Geschäfte macht, soll nicht wegen dieser Bindung
an diese andere Gesellschaft oder Firma, von der Betrachtung, vom Wählen oder Handeln betreffend einer Angelegen-
heit im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder Geschäft ausgeschlossen werden.

F. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 13. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft, mit Vorbehalten, dass ein Beschluss nur fähig ist wenn dieser vom Geschäftsführer genehmigt wird, insofern
diese Satzung keine anderweitigen Bestimmungen trifft. Die Hauptversammlung wird durch den Geschäftsführer oder
den Aufsichtsrat einberufen.

Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der Einla-

dung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 11.00 Uhr morgens am dritten Freitag vom Mo-
nat Mai oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt. Andere
Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einberufen wer-
den. Die Hauptversammlungen werden durch Einberufungsschreiben welche die Tagesordnung beinhalten einberufen.

22438

Die Einberufungsschreiben werden vom Geschäftsführer wenigsten acht (8) Tage vor der Hauptversammlung per Ein-
schreiben an jeden Aktionär der Gesellschaft an die in dem Aktienregister eingetragene Adresse geschickt.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Fak-

simileübertragung oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten
vertreten lassen. Der Geschäftsführer kann all die anderen Bedingungen festlegen die durch Aktionäre erfüllt werden
müssen um an den Gesellschafterversammlungen teilzunehmen. Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwe-
send oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu kennen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberu-
fung abgehalten werden.

G. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember eines jeden

Jahres.

Art. 15. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen

Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen. Die Hauptversamm-
lung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Geschäftsführers über die Verwendung des restlichen Betrages des Rein-
gewinns und im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen über die Ausschüttung von Vorschussdividenden; jedoch
vorausgesetzt dass solche Gewinn- oder Ausschüttungsverfügungen mit jedem Aktionärsvertrag der von der Gesell-
schaft mit Inhabern der Stammaktien der Klasse A von Zeit zu Zeit abgeschlossen werden würde übereinstimmen.

H. Auflöung der Gesellschaft - Satzungsänderung

Art. 16. Die gegenwärtige Satzung kann, mit Zustimmung des Geschäftsführers, von einer Hauptversammlung der

Aktionäre abgeändert werden, vorausgesetzt die Anwesenheits- und Mehrheitsquoten gemäß des Gesetzes vom 10. Au-
gust 1915 über Handelsgesellschaften, in dessen letzten Fassung, werden beachtet, insofern keine anderweitigen Bestim-
mungen in der Satzung vorgesehen sind.

Ungeachtet anderwärtiger Bestimmungen in dieser Satzung, erfordert (i) eine Abänderung von Bestimmungen der

Satzung, die einige Inhaber von Stammaktien der Klasse A mehr als andere Inhaber von Stammaktien der Klasse A be-
einträchtigt, das Einverständnis all der Inhaber von Stammaktien der Klasse A deren Aktien die mehr beeinträchtigt wor-
den sind (ii) eine Abänderung von Bestimmungen der Satzung, die die wirtschaftlichen Rechte der Komplementärsaktien
beeinträchtigen (die Ausgabe von zusätzlichen Komplementärsaktien oder die Beeinträchtigung der Rechte der Kom-
plementärsaktien auf Ausschüttungen auf einer Aktie per Aktie Basis mit den Stammaktien der Klasse A, einbegriffen)
das Einverständnis aller Inhaber von Stammaktien der Klasse A.

Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt diese(n) Liquidator(en) und setzt seine/ihre Befugnisse und Vergütung fest.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 18. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, ist das Gesetz vom 10. August 1915,

über Handelsgesellschaften bestimmend, in dessen letzten Fassung.

J. Verschiedenes

Art. 19. Die Gesellschaft beabsichtigt sich wegen U.S. Steuergründen rechtzeitig anzumelden um, mit Wirksamkeit

ab ihrem ersten Steuerjahr, als steuerlich transparente Körperschaft eingestuft zu werden (d.h. pass-through). In diesem
Zusammenhang, hat der Geschäftsführer, und jede andere durch die Aktionäre bevollmächtigte Person, die Befugnis die-
se Anmeldung im Namen der Gesellschaft durchzuführen und einzuregistrieren. Die Aktionäre sollen kooperieren um
diese Anmeldung durchzuführen.

Da keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Debatte stehen, wird die Versammlung geschlossen.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-

bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: M. Elvinger, R. Uhl, J. Elvinger.

Enregistré à Luxembourg, le1

er

 mars 2004, vol. 20CS, fol. 48, case 12. – Reçu 26.018,10 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022890.3/211/1172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2004.

Luxembourg, le 4 mars 2004.

J. Elvinger.

22439

TOTEM HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 14.560. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02789, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2004.

(023889.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

TOTEM HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 14.560. 

Les statuts coordonnés, enregistrés le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02754, ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2004.

(023917.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

TOTEM HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 14.560. 

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 17 avril 2001 et avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social

de la société a été converti de BEF 1.250.000,- en EUR 30.986.69. Le capital social est dorénavant fixé à trente mille neuf
cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (EUR 30.986,69), représenté par mille deux cent cinquante (1.250)
actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02715. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023919.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

SOMALUX-SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 4.523. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03173, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2004.

(024181.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

<i>Pour TOTEM HOLDINGS S.A.
société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société anonyme
A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans

<i>Pour TOTEM HOLDINGS S.A.
société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
société anonyme
A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans

<i>Pour TOTEM HOLDINGS S.A.
société anonyme holding
EXPERTA LUXEMBOURG
société anonyme
A. Garcia-Hengel / S. Wallers

SOMALUX-SOCIETE DE MATERIEL LUXEMBOURGEOISE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

22440

HEFESTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 69.952. 

Les statuts coordonnés, enregistrés le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02760, ont été déposés au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2004.

(023926.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

HEFESTO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 69.952. 

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 15 mars 2001, et avec effet au 1

er

 janvier 2001 le capital souscrit

de la société a été converti de ITL 150.000.000,- en EUR 77.468,53. Le capital souscrit est dorénavant fixé à soixante-
dix-sept mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-trois cents (EUR 77.468,53) représenté par cent cinquante
(150) actions sans désignation de valeur nominale. Le capital autorisé a été converti de ITL 480.000.000,- en EUR
247.899,31. Le capital autorisé est fixé à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et trente
et un cents (EUR 247.899,31).

Luxembourg, le 11 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 2004, réf. LSO-AO02739. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023928.2//18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

MIV LUXEMBOURG HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 99.331. 

Suite à la cession de parts intervenue en date du 17 février 2004 entre MARK IV HOLDINGS, S.à r.l. et MARK IV

HOLDINGS BV, les 5.330.299 parts sociales de «la Société» sont réparties comme suit:

- MARK IV HOLDINGS, S.à r.l., 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 à Luxembourg: 
5.330.246 parts sociales d’une valeur nominale de 100 euros.
- MARK IV HOLDINGS BV, Naritaweg 165 1043BW à Amsterdam Pays-Bas: 
53 parts sociales d’une valeur nominale de 100 euros
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024010.3/683/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

MAKO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3225 Bettembourg, Z.I. Schéleck.

R. C. Luxembourg B 22.208. 

Les bilans aux 31 décembre, 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 29 janvier

2004 resp. 4 mars 2004, réf. LSO-AO00811, AO00813, AM07418, ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024220.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

<i>Pour HEFESTO S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans

<i>Pour HEFESTO S.A., société anonyme
EXPERTA LUXEMBOURG, société anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>MIV LUXEMBOURG HOLDINGS, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Signatures

22441

GENNAKER S.A., Société Anonyme,

(anc. GENNAKER HOLDING S.A.).

Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 40.815. 

EXTRAIT

L’assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 17 février 2004 a renouvelé les mandats des administrateurs

et du commissaire aux comptes pour un terme de six ans.

Le Conseil d’Administration se compose comme suit:
- Monsieur Massimo Colomban, président, demeurant au 15, Via Mangesa, Conegliano, Italie.
- Monsieur Jean Hoffmann, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
- Monsieur Marc Koeune, domicilié professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
- Madame Nicole Thommes, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
- Madame Andrea Dany, domiciliée professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg
Le commissaire aux comptes est CeDerLux-Services, S.à r.l., avec siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxem-

bourg.

Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2009.
Décharge pleine et entière leur a été accordée.

Enregistré à Luxembourg, le 19 février 2004, réf. LSO-AN04223. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023974.3/693/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

SFDT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 82.108. 

<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue en date du 17 mars 2004

Sont présents:
Monsieur Guy Feite, Administrateur
COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL, Administrateur
Est absente et excusée:
Madame Céline Boussebassi, Administrateur
Le conseil d’administration réunissant ainsi la présence effective de deux des trois administrateurs en fonction peut

valablement délibérer.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Feite pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:
- Cooptation d’un Administrateur
Monsieur le Président donne lecture d’une lettre émanant de Madame Céline Boussebassi par laquelle elle se démet

de ses fonctions d’Administrateur de la société.

Afin de combler la vacance ainsi créée, Monsieur le Président propose d’appeler au poste d’Administrateur, la société

de droit luxembourgeois ASSCO EUROPE, S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 38, avenue
du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Le conseil d’administration après avoir délibéré, décide à l’unanimité des voix:
- de coopter la société de droit luxembourgeois ASSCO EUROPE, S.à r.l., constituée le 4 mai 2001 par acte portant

le numéro 349/2001 passé devant Maître Jean-Paul Hencks, Notaire de résidence à Luxembourg, société à responsabilité
limitée au capital social de quinze mille Euros (15.000 Euros) ayant son siège social au 38, avenue du X Septembre, L-
2550 Luxembourg, prénommée, au poste d’administrateur. La société terminera le mandat de Madame Céline Bousse-
bassi, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2007. La coopta-
tion de la société de droit luxembourgeois ASSCO EUROPE, S.à r.l. sera ratifiée à la prochaine Assemblée.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04051. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024088.3/850/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

<i>Le Conseil d’Administration
G. Feite 
<i>Administrateur 
 COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL
Signature
<i>Administrateur

22442

NET VENTURES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 40.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 72.605. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 15 mars 2004 que la

démission de M. Dirk C. Oppelaar en tant qu’administrateur avec effet au 25 novembre 2003 est acceptée et décharge
lui est accordée pour l’exécution de son mandat.

Madame Anne Compère, avec adresse professionnelle au 12, rue Léon Thyes, L-2636 Luxembourg, a été nommée

nouvel administrateur avec effet au 25 novembre 2003. Elle terminera le mandat de son prédécesseur qui prendra fin
lors de l’assemblée générale de l’année 2005.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03986. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024097.3/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

PELIAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 77.545. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02664, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023941.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

PELIAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 77.545. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 2004, réf. LSO-AO02658, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023943.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

PELIAS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 77.545. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 30 janvier 2004

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à

Luxembourg et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Guy Hornick, expert-compta-

ble, demeurant à Bertrange qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2006.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée accepte la démission de l’administrateur Monsieur Edmond Ries, expert-comptable, demeurant à Ber-

trange et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

Le Conseil d’Administration désigne en remplacement de l’administrateur démissionnaire, Monsieur Thierry Fleming,

expert-comptable, demeurant à Mamer qui achèvera son mandat prenant fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
qui se tiendra en 2006.

Luxembourg, le 15 mars 2004.

R. P. Pels.

PELIAS HOLDING S.A.
Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

PELIAS HOLDING S.A.
Société Anonyme
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Administrateur / Administrateur

22443

<i>Sixième résolution

L’Assemblée accepte la démission de MONTBRUN FIDUCIAIRE, S.à r.l. de son poste de commissaire de surveillance

et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de son mandat.

L’Assemblée désigne en remplacement du commissaire démissionnaire, la société AUDIEX S.A. avec siège social à

57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg, en remplacement du commissaire de surveillance démissionnaire, et
ce, pour la fin de son mandat échéant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023937.3/045/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

HSBC DEWAAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme,

(anc. DEWAAY LUXEMBOURG S.A.).

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.966. 

 L’an deux mille quatre, le treize février.
 Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

 L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme DEWAAY LUXEMBOURG S.A., ayant

son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B
62.966, constituée suivant acte notarié du 2 janvier 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 133 du 3 mars 1998 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte du notaire soussigné, en date
du 25 septembre 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1127 du 29 octobre 2003.

 L’Assemblée est ouverte à dix heures sous la présidence de Monsieur Alain Weicker, employé privé, demeurant à

Niederdonven,

 qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Marina Muller, employée privée, demeurant à Athus (Belgique),
 L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sandra Schenk, employée privée, demeurant à Arlon (Belgi-

que).

 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

 1. Changement de la dénomination de la société
 2. Modification subséquente de l’article 1

er

 des statuts.

 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera an-
nexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

 Les procurations des actionnaires représentés, jointes en copie aux présentes, sont annexées à un procès-verbal

d’assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire soussigné en date du 25 septembre 2003, enregistré à Luxem-
bourg A.C., le 29 septembre 2003.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut déli-

bérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’Assemblée décide de modifier la dénomination de la société en HSBC DEWAAY LUXEMBOURG S.A.

<i>Deuxième résolution

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination sociale HSBC DEWAAY LUXEMBOURG S.A.»

 Ce changement de dénomination a fait l’objet d’un agrément octroyé par le Monsieur le Ministre des Finances en

date du 27 janvier 2004 suivant lettre ci-annexée en copie.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

 Signé: A. Weicker, S. Schenk, M. Muller, F. Baden.

PELIAS HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
G. Hornick / C. Schmitz
<i>Deux Administrateurs

22444

Enregistré à Luxembourg, le 18 février 2004, vol. 142S, fol. 57, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(024110.3/200/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

HSBC DEWAAY LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 62.966. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024115.3/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

SOFIRAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 13, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 98.882. 

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration tenu le 17 mars 2004

<i>Première résolution

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Frédéric Adam de sa fonction d’administrateur, décide

d’accepter cette démission. Le conseil le remercie pour l’activité déployée jusqu’à ce jour.

<i>Deuxième résolution

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet à partir du 17 mars 2004 Monsieur Andrew Simms, de-

meurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Ces résolutions, adoptées à l’unanimité, seront ratifiées par la prochaine assemblée générale de la société, conformé-

ment à la loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04018. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024175.3/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

DIATEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3321 Berchem, 29, rue de la Montée.

R. C. Luxembourg B 31.090. 

Les bilans aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2004

resp. 29 janvier 2004, réf. LSO-AO00814, AO00815, AM07411, ont été déposés au registre de commerce et des socié-
tés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024223.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

LUXMAKO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7759 Roost, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 75.764. 

Les bilans aux 31 décembre 2000, 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 4 mars 2004, réf. LSO-AO00818

et AO00816, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024227.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Luxembourg, le 15 mars 2004.

F. Baden.

Signature.

Pour extrait conforme
SOFIRAC S.A.
Société Anonyme
Signatures

22445

GAMIRCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.492. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04007, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024167.3//14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

GAMIRCO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 19.492. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 4 mars 2004

<i>Résolution

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004:

<i>Conseil d’administration  

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04006. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024169.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

ALLGEMEINE DEUTSCHE DIREKTBANK INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 28.907. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03171, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024272.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

HARVEST CLO I S.A., Société Anonyme,

(anc. HARVEST CDO S.A.).

Registered office: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 93.786. 

In the year two thousand and four, on the twenty-seventh of February.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of HARVEST CDO S.A., a public limited liability

company, having its registered office at 33, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 93.786 and incorpo-
rated under the Luxembourg law pursuant to a deed of the Luxembourg notary Joseph Elvinger dated 1 April 2003 and
published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 672 dated 26 June 2003 (page 32.236).

The articles of incorporation of the Company (the «Articles») have not been amended since its incorporation.

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Claude Deschenaux, président de banque, demeurant à Luxembourg, président;

Bernard Huppert, dirigeant d’entreprises, demeurant à Reinach (Suisse), administrateur;
Pierluigi Zanaboni, dirigeant d’entreprises, demeurant à Saronno (Italie), administrateur;

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 18 mars 2004.

A. Schwachtgen.

22446

The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), who appoints as secretary Rachel Uhl,

jurist, residing in Kédange (France).

The meeting elects as scrutineer Rachel Uhl, prenamed.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
 I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.

 II. It appears from the attendance list, that the thirty-one (31) registered shares, representing the entirety of the

statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. All the shareholders declare
having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements and formalities.
The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting.

 III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1) To change the name of the Company from HARVEST CDO S.A. into HARVEST CLO I S.A. and subsequent to

amend the article 1.2 of the Articles so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

«The Company exists under the firm name of HARVEST CLO I S.A.»
2) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolution was taken, unanimously, in compliance with article 16 clauses 2 and 4 of

the Articles:

<i>Sole resolution

The shareholders resolve to change the name of the Company from HARVEST CDO S.A. into HARVEST CLO I S.A.

and subsequent to amend the article 1.2 of the Articles so as to reflect the taken decision, which shall read as follows:

«The Company exists under the firm name of HARVEST CLO I S.A.»
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.

Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-

ument.

The document having been read to the persons appearing, known to the notary by their names, first names, civil status

and residence, said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, HARVEST CDO S.A., ayant

son siège social au 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 93.786 et constituée sous la loi luxembour-
geoise en vertu d’un acte reçu le 1

er

 avril 2003 par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger et publié au Mémorial C,

Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 672 du 26 juin 2003 (page 32.236) (la «Société»).

Les statuts de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis sa constitution.
L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), lequel désigne comme secré-

taire, Rachel Uhl, juriste, demeurant à Kédange (France).

L’assemblée choisit comme scrutateur Rachel Uhl, prénommé. 
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions détenues par chacun d’eux sont renseignés sur

une liste de présence signée par les actionnaires ou leur représentant, le bureau et le notaire. Cette liste et les procu-
rations ne varietur, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II. Il ressort de la liste de présence que les trente et une (31) actions nominatives, représentant l’intégralité du capital

social de la société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire. Tous les actionnaires ayant été
préalablement informé de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l’assemblée peut dé-
libérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.

III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changer le nom de la Société HARVEST CDO S.A. en HARVEST CLO I S.A. et modifier en conséquence l’article

1.2 des Statuts afin de refléter la présente décision, lequel sera dorénavant libellé comme suit:

«La Société adopte la dénomination HARVEST CLO I S.A.»
2. Divers.
Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité en application de l’article 16 alinéas 2 et 4 des

Statuts:

<i>Résolution unique

Les actionnaires décident de changer le nom de la Société HARVEST CDO S.A. en HARVEST CLO I S.A. et de mo-

difier en conséquence l’article 1.2 des Statuts afin de réfléter la présente décision, lequel sera dorénavant libellé comme
suit:

22447

«La Société adopte la dénomination HARVEST CLO I S.A.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est

établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 2004, vol. 142S, fol. 73, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024036.3/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

GALEY &amp; LORD INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 68.050. 

<i>Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle tenue au siège social en date du 10 juillet 2001, du rapport des Gérants

de la société GALEY &amp; LORD INTERNAITONAL, S.à r.l., que l’actionnaire unique a pris les décisions suivantes pour
les comptes annuels de 1999/2000:

1) Les comptes annuels au 30 septembre 2000 sont approuvés et la perte qui s’élève à LUF 378.098.045 est reportée.
2) Décharge est accordée aux Gérants pour l’année 2000:
M. C.H. Hürlimann
M. M. Reeves Harmon
Décharge avait été accordée au troisième gérant MANACOR (LUXEMBOURG) lors de l’assemblée du 19 décembre

2000.

3) Décharge est accordée au commissaire aux comptes ERNST &amp; YOUNG S.A. pour l’année 1999/2000.
4) Réélection des Gérants:
M. Claus H. Hürlimann
M. Leonard F. Ferro
HRT REVISION, S.à r.l.
5) Réélection de ERNST &amp; YOUNG S.A. en tant que Commissaire aux Comptes.
6) Les mandats des Gérants et du commissaire aux comptes expireront à la suite de l’Assemblée Générale annuelle

appelée à s’exprimer sur les comptes au 30 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03970. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024204.3/565/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

GALEY &amp; LORD INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 32, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 68.050. 

<i>Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle

Il résulte de l’Assemblée Générale Annuelle de GALEY &amp; LORD INTERNATIONAL, S.à r.l., tenue au siège social en

date du 9 juillet 2002, et du rapport des Gérants, que l’actionnaire unique a pris les décisions qui suivent.

1) Les comptes pour l’exercice fiscal clos le 30 septembre 2001 sont approuvés et le bénéfice qui s’élève au montant

de LUF 581.708.175 est reporté au prochain exercice.

2) Décharge est accordée aux Gérants pour l’année 2000/2001 et jusqu’à la date de cette Assemblée Générale:
- M. Claus Hürlimann
- M. Leonard F. Ferro
- HRT REVISION, S.à r.l.
Décharge avait été accordée à MANACOR (LUXEMBOURG) lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 19 décem-

bre 2000.

Décharge avait été accordée à M. Michael Reeves Harmon lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 dé-

cembre 2000.

3) Décharge est accordée au Commissaire aux Comptes ERNST &amp; YOUNG S.A. pour l’année 2000/2001.

Luxembourg, le 17 mars 2004.

J. Elvinger.

HRT REVISION, S.à r.l.
<i>Administrateur
Signatures

22448

4) Pour l’exercice fiscal 2001/2002 les Gérants sont réélus comme suit:
- M. Claus Hürlimann
- M. Leonard F. Ferro
- HRT REVISION, S.à r.l.
5) Comme Commissaire aux Comptes est réélu le cabinet ERNST &amp; YOUNG.
6) Les mandats des Gérants et du Commissaire aux Comptes viendront à expiration à la suite de l’Assemblée Géné-

rale Annuelle appelée à s’exprimer sur les comptes au 30 septembre 2002.

Luxembourg, le 11 juillet 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03967. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024201.3/565/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

TREGORAM OVERSEAS LTD, Société à responsabilité limitée.

R. C. Luxembourg B 56.966. 

Par lettre recommandée en date du 11 mars 2004 adressée à TREGORAM OVERSEAS LTD, la société soussignée a

dénoncé avec effet immédiat le siège social à Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.

Enregistré à Luxembourg, le 19 mars 2004, réf. LSO-AO04182. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024185.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

PIRELLI INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.459. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04009, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024171.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

PIRELLI INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 90.459. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue de manière anticipée le 4 mars 2004

<i>Résolutions

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide de les réélire

pour la période expirant à l’assemblée générale statuant sur l’exercice 2004:

<i>Conseil d’administration 

<i>Commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

HRT REVISION, S.à r.l. / C. Hürlimann
<i>Gérant / <i>Gérant
Signatures

MULTI OFFICE SERVICES S.A.
<i>Le propriétaire des lieux
C. Gretsch
<i>Administrateur-Délégué

SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

MM. Pierluigi Zanaboni, dirigeant, demeurant à Milan (Italie) administrateur;

Dario Andrea Taglioretti dirigeant, demeurant à Milan (Italie) administrateur;
Patrick Ehrhardt, employé privé, demeurant à Luxembourg, administrateur.

Pour extrait conforme
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

22449

Enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04008. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024174.3/024/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

WELFAB INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 97.341. 

In the year two thousand four, on the twenty-fifth day of February.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of WELFAB INVESTMENTS S.A., a société anonyme,

having its registered office at L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, trade register Luxembourg section B number
97.341, incorporated by deed enacted on November 28, 2003, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 5 of January 3, 2004; and whose Articles of Association never have been amended.

The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist at L-1450 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Miss Rachel Uhl, jurist at L-1450 Luxembourg
The chairman requests the notary to act that:
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-

ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.

II.- Closed, the attendance list let appear that the 20,000 (twenty thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one

hundred Euros) each, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly
decide on all the items of the agenda of which the shareholders have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Amendment of the articles of incorporation in order to render the shares exclusively under nominative form, to es-

tablish a preferential subscription right for any issue of new shares and, consequently to restate title II, articles 5 and 6.

After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders unanimously decide what follows: 

<i>Sole resolution

The meeting decides to amend the articles of incorporation in order to render the shares exclusively under nomina-

tive form, to establish a preferential subscription right for any issue of new shares and, consequently to restate title II,
articles 5 and 6 to read as follows:

Chapter II.- Capital

Art. 5. Corporate Capital
5.1. The subscribed corporate capital is set at EUR 2,000,000,- (two million Euros), divided into 20,000 (twenty thou-

sand) nominative shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each. 

5.2. The shares are and will remain on registered form.
5.3. A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth

the name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid
in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

5.4. The Corporation may issue registered certificates representing shares of the Corporation or share confirma-

tions.

5.5. The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer registered on the register of share-

holders, such declaration or transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding
suitable powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instru-
ments of transfer satisfactory to the Corporation.

5.6. Each share is entitled to one vote.

Art. 6. Modification of Corporate Capital
6.1. The authorized and the subscribed capital of the Corporation may be increased or reduced by resolutions of the

shareholders adopted in the manner required for amending these Articles of Incorporation.

6.2. The new shares to be subscribed shall be anyway offered in preference to shareholders, in the proportion of the

part of the corporate capital which is represented by their shares. The general meeting of shareholders shall fix the delay
during which the right of preference shall be exercised. It shall confer to the Board of Directors any powers in order
to execute the decision taken by it and it shall fix the conditions of the exercise of the right of preference. 

6.3. The board authorized capital is set at EUR 10,000,000.- (ten million Euros) which shall be, if any, represented by

100,000 (one hundred thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.

6.4. Furthermore the Board of Directors is authorized, from the incorporation’s day dated November 28, 2003 and

until November 28, 2008, to increase from time to time the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
This increase of capital may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution
in kind or cash, by incorporation of claims in any other way to be determined by the Board of Directors. The Board of
Directors may delegate to any duly authorized Director or officer of the Corporation, or to any other duly authorized
person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such increased
amounts of capital.

22450

6.5. Each time the Board of Directors shall act to render effective an increase of the subscribed capital, the present

article shall be considered as automatically amended in order to reflect the result of such action.

6.6. The Corporation can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by law.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail. 

Suit la traduction française:

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq février. 
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme WELFAB INVESTMENTS

S.A., ayant son siège social à L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine, R.C. Luxembourg section B numéro 97.341, cons-
tituée suivant acte reçu le 28 novembre 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 5 du
3 janvier 2004 et dont les statuts n’ont jamais été modifiés.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste à L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Rachel Uhl, juriste à

L-1450 Luxembourg.

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Clôturée, cette liste de présence fait apparaître que les 20.000 (vingt mille) actions d’une valeur nominale de EUR

100,- (cent euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée géné-
rale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont
les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

Modification des statuts aux fins de rendre les actions exclusivement nominatives, d’instaurer un droit préférentiel

pour toute émission d’actions nouvelles et refonte des articles 5 et 6 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Résolution unique

L’assemblée décide de modifier les statuts aux fins de rendre les actions exclusivement nominatives, d’instaurer un

droit préférentiel pour toute émission d’actions nouvelles et, en conséquence, de procéder à une refonte du titre II,
articles 5 et 6 des statuts pour leur donner la teneur suivante;

Titre II.- Capital

Art. 5. Capital social
5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 2.000.000,- (deux millions de Euros), divisé en 20.000 (vingt mille) actions

nominatives d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

5.2. Les actions sont et resteront exclusivement sous la forme nominatives. 
5.3. Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la société. Ce registre contiendra le nom de chaque

actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, la somme libérée pour chacune de ces
actions ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.

5.4. La société pourra émettre des certificats nominatifs représentant les actions de la société ou des confirmations

d’actions.

5.5. Le transfert d’une action se fera par une déclaration écrite de transfert portée au registre des actionnaires, cette

déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les
pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La société pourra également accepter en guise de preuve
du transfert d’autres instruments de transfert juges suffisants par la société.

5.6. Chaque action donne droit à un vote.

Art. 6. Modification du capital social
6.1. Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décisions de l’as-

semblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

6.2. Les nouvelles actions à souscrire en numéraire sont en toutes circonstances offertes par préférence aux action-

naires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. L’assemblée générale fixe le délai de
l’exercice du droit de préférence. Elle confère au conseil d’administration tous pouvoirs aux fins d’exécuter les décisions
prises et de fixer les conditions de l’exercice du droit de préférence. 

6.3. Le capital autorisé est fixé à EUR 10.000.000,- (dix millions de Euros), représenté le cas échéant par 100.000 (cent

mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.

22451

6.4. En outre le conseil d’administration est, à partir du jour de la constitution en date du 28 novembre 2003 et jus-

qu’au 28 novembre 2008 inclus, autorisé à augmenter en temps utile qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur
des limites du capital autorisé. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec
ou sans prime d’émission et libérées par apport en nature ou en numéraire, par compensation avec des créances ou de
toute autre manière à déterminer par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout admi-
nistrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions et
recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

6.5. Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital

souscrit, le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

6.6. La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, R. Uhl, J. Elvinger
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 mars 2004, vol. 20CS, fol. 49, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024044.2/211/144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

WELFAB INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2418 Luxembourg, 5, rue de la Reine.

R. C. Luxembourg B 97.341. 

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024047.3/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

HARMODIO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 38.394. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03176, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2004.

(024182.2//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

SHA FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 32.639. 

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03177, a été déposé au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2004.

(024183.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Luxembourg, le 15 mars 2004.

J. Elvinger.

HARMODIO S.A.
Signature
<i>Administrateur-Délégué

SHA FINANCE S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

22452

RUALA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.

R. C. Luxembourg B 84.773. 

<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Statutaire tenue à Luxembourg

<i>en date du 15 mars 2004 à 10.00 heures

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs démissionnaires BRY-

CE INVEST S.A. et KEVIN MANAGEMENT S.A. de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leurs fonc-
tions pendant la durée de leur mandat.

Les sociétés CRITERIA, S.à r.l. et PROCEDIA, S.à r.l., avec siège social au 3, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

ont été nommées comme nouveaux administrateurs et termineront le mandat de leurs prédécesseurs

Luxembourg, le 15 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03653. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(023866.3/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2004.

FARVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 73, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 76.419. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03512, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(023991.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

TOPAZE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.602. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03962, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

(024018.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

SUNBOW GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 58.445. 

EXTRAIT

Il résulte d’un extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale des actionnaires sous seing privé tenue en date du

16 février 2004, enregistrée à Luxembourg, le 8 mars 2004, référence LSO-AO01690, que:

- Madame Alicja Wegrzyn-Grzeskowiak, demeurant à UI. Zygmunta Glogera, 40, 71-792 Szczecin/Pologne, a démis-

sionné de sa fonction d’administrateur avec effet au 23 septembre 1999.

- Monsieur Slawomir Balazy, né le 18 août 1957 à Szczecin/Pologne, demeurant à UI. Szeligowskiego, 75/3, 71-051

Szczecin/Pologne, est nommé en tant qu’administrateur avec effet au 23 septembre 1999 et pour une période de six ans.

Le mandat des administrateurs suivants a été confirmé avec effet au 16 février 2004 et pour une nouvelle période de

six ans:

- Monsieur Tadeusz Niszczota, né le 1

er

 février 1956 à Szczecin/Pologne, demeurant UI. Macierzanki, 39, 71-499, Szc-

zecin/Pologne.

- Madame Grazyna Janaszek-Rygielska, née le 22 août 1948 à Sierakow/Pologne, demeurant à 4, rue des Girondins,

L-1626 Luxembourg.

- Monsieur Marek Prowans, né le 19 mars 1941 à Lublin/Pologne, demeurant à 10, rue E. Oster, L-2272 Howald/

Luxembourg.

(024268.3/230/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour RUALA INVEST S.A.
Signature

Strassen, le 18 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 18 mars 2004.

A. Schwachtgen.

22453

P.I.I. S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 260.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 72.883. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03959, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

(024020.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

HESTIA S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 87.089. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO03957, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

B. Zech.

(024023.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

FRESENIUS MEDICAL CARE MDF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 56.027. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04144, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024148.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

EURO-LEASING AG, Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 11.250. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04136, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024149.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

SETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.605. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le vingt-cinq février,
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.
A été tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires d’une société constituée selon le droit italien,

sous le nom de SETTE S.p.A., ayant son siège social à Via Monte Mascheda 37, Brescia (BS), avec un capital souscrit et
entièrement libéré de cent vingt mille euros (120.000,- EUR). La société a été constituée suivant acte du 16 novembre
1995 et elle est inscrite au Registre des Entreprises de Brescia sous le numéro 03339400172 R.E.A. 361236.

La séance a été ouverte sous la présidence de Madame Sabrina Lepomme, employée privée, demeurant à Virton (Bel-

gique).

Le président a désigné comme secrétaire Mademoiselle Nadine Thoma, employée privée, demeurant à Oetrange.
L’assemblée a choisi comme scrutateur Mademoiselle Laurence Dony, employée privée, demeurant à Colmar-Berg.
Les actionnaires représentés à cette assemblée, qui représentent tout le capital social et qui détiennent toutes les

actions de la société figurent sur une liste de présence signée par le représentant des actionnaires représentés. Cette
liste de présence et les procurations, après avoir été signées ne varietur par le bureau de l’assemblée et par le notaire
soussigné resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Luxembourg, le 17 mars 2004.

Signature.

Luxembourg, le 12 mars 2004.

Signature.

22454

Le Président déclare et l’assemblée reconnaît que l’ensemble du capital souscrit est représenté à l’assemblée, qui est

ainsi valablement constituée pour décider sur les différents points à l’ordre du jour. Le représentant des actionnaires
représentés déclare en outre expressément renoncer à toutes les formalités relatives à la convocation des assemblées
générales et déclare avoir une connaissance complète de l’ordre du jour de l’assemblée ainsi que du texte des nouveaux
statuts en vigueur après le transfert du siège à Luxembourg, y inclus le texte exact du nouvel objet social après le trans-
fert du siège.

 L’assemblée reconnaît en outre que les documents suivants lui ont été soumis: 
 - une expédition du procès-verbal d’une assemblée du 13 janvier 2004 reçu par Maître Francesco Cavallone, notaire

de résidence à Milan, décidant du transfert et de la continuation de la société au Luxembourg et de mettre un terme à
la soumission de la société au droit italien,

 - une copie de la dernière version des statuts de la société; 
 - une copie de l’extrait de la Chambre de Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et de l’Agriculture de Brescia du

22 décembre 2003;

 - un extrait du registre des actionnaires de la société.
 Les documents prémentionnés, après avoir été signés ne varietur par le bureau de l’assemblée et le notaire soussigné,

resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci.

 Le Président déclare que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant: 
 1. Transfert du siège social de la société à Luxembourg.
 2. Adoption de la forme d’une société anonyme régie par le droit luxembourgeois.
 3. Refonte des statuts de la société afin de les mettre en concordance avec le droit luxembourgeois, et notamment

la modification de la dénomination sociale en SETTE S.A. et de l’objet social, l’augmentation de la valeur nominale des
actions de 1,- EUR à 2,- EUR et la réduction du nombre des actions de 120.000 à 60.000, ainsi que toute autre modifi-
cation.

4. Approbation du rapport établi par Monsieur Stéphane Weyders, réviseur d’entreprises, conformément à l’article

26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en date du 19 février 2004.

5. Nomination des membres du Conseil d’Administration et du commissaire aux comptes et détermination de la du-

rée de leur mandat.

6. Fixation du siège social réel et statutaire.
Le Président déclare que: 
La société souhaite établir son siège social statutaire à Luxembourg. 
Ainsi qu’il ressort de la résolution des actionnaires ci-avant, datée du 13 janvier 2004, l’assemblée générale des ac-

tionnaires a déjà décidé à l’unanimité de transférer le siège social statutaire de la société à Luxembourg, cette assemblée
étant convoquée afin de voter une seconde fois sur le transfert du siège social statutaire d’Italie à Luxembourg et
d’authentifier cette résolution conformément aux formalités du droit luxembourgeois.

De plus, il a été décidé de confier à cette assemblée générale la modification de la dénomination sociale et de l’objet

social de la société, les autres modifications mentionnées ci-dessous et les modifications nécessaires pour conformer
les statuts avec les prescriptions légales luxembourgeoises ainsi que la nomination des membres du Conseil d’Adminis-
tration et du commissaire aux comptes.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci passe à l’ordre du jour.
Après délibération, le président met aux voix les résolutions suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’assemblée générale approuve et confirme la décision de transférer le siège social statutaire et le principal établisse-

ment de la société SETTE S.p.A. de Via Monte Mascheda 37, Brescia (BS) à 167, route de Longwy, L-1941 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et déclare que la société a par conséquent adopté la nationalité luxembourgeoise.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’adopter la forme d’une société anonyme qui sera régie par le droit luxembourgeois. Par con-

séquent, les décisions suivantes sont prises conformément au droit luxembourgeois.

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier la dénomination sociale en SETTE S.A., de modifier l’objet social, d’augmen-

ter la valeur nominale des actions de un euro (1,- EUR) à deux euros (2,- EUR), de réduire le nombre des actions de
cent vingt mille (120.000) à soixante mille (60.000), de restructurer les statuts de la société pour les rendre conformes
au droit luxembourgeois et de procéder à une refonte complète des statuts qui auront dorénavant la teneur suivante:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de SETTE S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Toutefois, cette mesure ne pourra avoir d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège

sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de telles circons-
tances.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée.

22455

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille. 

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, garanties ou de toute autre manière à des sociétés
filiales ou affiliées. La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d’obligations.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations fi-

nancières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet.

Titre II.- Capital, actions

Art. 5. Le capital social s’élève à cent vingt mille euros (120.000,- EUR) représenté par soixante mille (60.000) actions

d’une valeur nominale de deux euros (2,- EUR) chacune.

Les actions de la société peuvent être créées, au choix de l’actionnaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de deux ou de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les termes et conditions prévues par la loi.
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Conseil d’Administration

Art. 6. La société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les révoquer à tout mo-
ment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle seront fixés par l’assemblée

générale des actionnaires.

Art. 7. Le Conseil d’Administration élira parmi ses membres un Président.
Le Conseil d’Administration sera convoqué par le Président, aussi souvent que les intérêts de la société le requièrent.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, sans pré-

judice des décisions à prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le
Conseil d’Administration en vertu de l’article 10.- des présents statuts.

Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs

directeurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi
ses propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-

nérale.

Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société

par le Conseil d’Administration, représenté par son Président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixera leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 1

er

mardi du mois de mai à 11.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, affectation des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commencera le 1

er

 janvier et finira le 31 décembre de chaque année. 

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été en-
tamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

22456

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution

de la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommées par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération. 

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commencera ce jour et finira le 31 décembre 2004.
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale approuve le rapport établi en date du 19 février 2004 par Monsieur Stéphane Weyders, réviseur

d’entreprises, conformément à l’article 26-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Le rapport prémentionné sera signé ne varietur par le bureau de l’assemblée et par le notaire soussigné et restera

annexé au présent acte aux fins de l’enregistrement.

Le rapport contient la conclusion suivante:
 «Conclusion
Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la

valeur de l’apport qui correspond au moins au nombre et à la valeur comptable des actions à émettre en contrepartie.»

<i>Cinquième résolution

 L’assemblée générale prend les décisions et nominations suivantes:
 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
 2. Sont nommés administrateurs:
 a) Monsieur Herbert Grossmann, docteur en droit, demeurant 75, rue des Romains, L-2443 Senningerberg;
 b) Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, demeurant 17, rue du Château, B-6747 Saint-Léger, 
 c) Monsieur Claude Schroeder, médecin dentiste, demeurant 498, route de Thionville, L-5886 Alzingen.
 3. Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
 STRATEGO INTERNATIONAL, société à responsabilité limitée avec siège social à L-1941 Luxembourg, 167, route

de Longwy.

 4. Le mandat des administrateurs et commissaires prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui statuera

sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2008.

<i>Sixième résolution

 L’assemblée décide de fixer le siège social à L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s’élève à approximativement 5.100,- EUR.

Pour les besoins de l’enregistrement, il est indiqué que le présent transfert du siège social à Luxembourg est exempt

du droit d’apport conformément à l’Article 3 paragraphe 2 de la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant
les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.

Signé: S. Lepomme, N. Thoma, L. Dony, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 2 mars 2004, vol. 142S, fol. 68, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(024366.3/212/192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

SETTE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 99.605. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024367.3/212/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Luxembourg, le 18 mars 2004.

P. Frieders.

Luxembourg, le 18 mars 2004.

P. Frieders.

22457

STEMARLU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 68.994. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03750, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024291.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

STEMARLU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 68.994. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03747, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024288.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

FRASER HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 44.565. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03178, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mars 2004.

(024184.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

WARM ARISONDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 59.827. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04034, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024230.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

FILIMI INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 44.541. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04032, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024231.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

FRASER HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

22458

SUL PALCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 2, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 53.851. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03491, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024345.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

SUL PALCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 2, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 53.851. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03493, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024346.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

BRAM INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 52.028. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04024, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024233.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

SPARINVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 2, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 81.400. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04133, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024150.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

DIMINI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 32.197. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04030, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024232.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

Luxembourg, le 17 mars 2004.

Signature.

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

22459

B.F.C.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 3.345. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. DSO-AO00279, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901186.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

B.F.C.P. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8824 Perlé, 4, rue de la Poste.

R. C. Diekirch B 3.345. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. DSO-AO00280, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901185.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

FULL COMPUTER SERVICES LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 7, rue des Tilleuls.

R. C. Diekirch B 95.711. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. DSO-AO00278, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(901187.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 19 mars 2004.

IBIZA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 42.087. 

DISSOLUTION

L’an deux mille quatre, le douze janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Mersch (Luxembourg).

A comparu:

LATINO COMMERCE S.A., une société du droit de Bélize, ayant son siège à Jasmine Court, 35A, Regent Street, PO

Box 1 777 Bélize,

ici représentée par Monsieur Joë Lemmer, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Bélize, le 10 août 2003.
Laquelle procuration restera, après avoir été paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès qualité qu’il agit, a prié le notaire instrumentaire de documenter les déclarations suivantes:
- La société anonyme IBIZA HOLDING S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue, fut constituée

suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, alors notaire de résidence à Mersch, en date du 7 décembre 1992,
publié au Mémorial, Recueil C numéro 73 du 15 février 1993.

- La société a actuellement un capital social d’un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois (LUF

1.250.000,-), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-) cha-
cune, entièrement libérées.

- Le comparant déclare que toutes les actions ont été réunies entre les mains d’un seul actionnaire, savoir la société

LATINO COMMERCE S.A., prédésignée.

- L’actionnaire unique déclare procéder à la dissolution de la société IBIZA HOLDING S.A., prédésignée.
- Il a pleine connaissance des statuts de la société et connaît parfaitement la situation financière de la société IBIZA

HOLDING S.A.

- Il donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leur mandat jusqu’à ce jour, ainsi

qu’à Monsieur Joë Lemmer, prénommé, pour tous les travaux effectués par ce dernier pour le compte de la société.

- Il reprend à sa charge en tant que liquidateur tout l’actif ainsi que le cas échéant l’apurement du passif connu ou

inconnu de la société qui devra être terminé avant toute affectation quelconque de l’actif à sa personne en tant qu’ac-
tionnaire unique.

Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la société IBIZA HOLDING S.A., prédésignée.

Le 19 mars 2004.

Signature.

Le 19 mars 2004.

Signature.

Le 19 mars 2004.

Signature.

22460

Les livres et documents comptables de la société IBIZA HOLDING S.A., prédésignée demeureront conservés pen-

dant cinq ans à L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-

re, le comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. Lemmer, H. Hellinckx.
Enregistré à Mersch, le 19 janvier 2004, vol. 426, fol. 61, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(022171.3/242/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2004.

LVS ULYSSE INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7619 Larochette, 10-12, rue de Medernach.

R. C. Luxembourg B 59.711. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04028, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024236.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

AZUR RENTING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 68.831. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04047, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024248.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

KARMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 42, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 73.101. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 mars 2004, réf. LSO-AO04042, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(024249.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

BIOTECH INDUSTRY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1711 Luxembourg, 21, rue Bernard Haal.

R. C. Luxembourg B 56.902. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03485, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024331.4//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Mersch, le 1

er

 mars 2004.

H. Hellinckx.

<i>Pour la société
R. Gokke
<i>Le domiciliataire

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

22461

DECIA INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 38, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 99.624. 

STATUTS

L’an deux mille quatre, le dix février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Ont comparu:

1) FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., société de droit luxembourgeoise ayant son siè-

ge à Luxembourg.

2) MARBURY INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LLC., société de droit du Wyoming ayant son siège à Cheyenne

dans l’Etat du Wyoming, Etats-Unis.

3) FRUCTILUX BUSINESS LTD, société de droit des Iles Vierges Britanniques ayant son siège à P.O. Box 3152, Road

Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques.

Tous trois sont ici représentés par Mademoiselle Rachel Uhl, juriste, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une pro-

curation sous seing privé, laquelle, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée
au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lequel comparant, agissant ès- dites qualités, a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une so-

ciété anonyme que les fondateurs ont déclaré constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I.- Dénomination - Siège - Objet - Durée

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci- après créées une société anonyme luxembourgeoise, dénommée DECIA INVEST S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par une décision

des actionnaires délibérant dans les conditions requises pour un changement des statuts.

Art. 3. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Lorsque des évènements extraordinaires d’ordre militaire, politique, économique ou social feraient obstacle à l’acti-

vité normale de la société à son siège ou seraient imminents, le siège social pourra être transféré par simple décision
du conseil d’administration dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg et même à l’étranger, et ce jusqu’à
la disparition desdits évènements.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-

merciales, industrielles, financières, ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, la prestation de services à filiales, l’ac-
quisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat,
de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en
valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute
activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans
vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte

avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.

La société a également pour objet l’exécution de toutes opérations immobilières, la gestion et l’administration de

biens immobiliers.

Titre II.- Capital social - Actions

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 31.000,- (trente et un mille euros), représenté par 3.100 (trois mille cent)

actions de EUR 10,- (dix euros) chacune, disposant chacune d’une voix aux assemblées générales.

Toutes les actions sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Titre III.- Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et qui élit un président dans

son sein. Ils sont nommés pour un terme n’excédant pas six années.

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les présents statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment accepter des compro-
mis, transiger, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder au versement d’acomptes sur dividendes aux conditions et suivant

les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La première personne à qui sera déléguée la gestion journalière et le premier président du conseil d’administration

peuvent être nommés par la première assemblée générale des actionnaires.

22462

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires. Ils sont nommés pour un terme n’ex-

cédant pas six années. 

Titre IV.- Année sociale - Assemblées Générales

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième mardi du mois de mai à 18.00 heures au

siège social ou à tout autre endroit à désigner par les avis de convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée
se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent le

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

Titre V.- Généralités

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Dispositions transitoires

Exceptionnellement, le premier exercice social commencera ce jour et se terminera le 31 décembre 2004.

<i>Souscription - Libération

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraire à concurrence de 100 % (cent

pour cent), de sorte que la somme de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition
de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Déclaration

Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents Euros. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès-qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
Sont nommés aux fonctions d’administrateurs pour la durée de six ans:
1) COMPAGNIE D’ETUDE ET DE CONSEIL LUXEMBOURG S.A., société de droit luxembourgeois ayant son siège

à Luxembourg.

2) M. Pierre Schwartz, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
3) M. Sébastien Vachon, employé privé, demeurant à Auxonne, France, 18, rue du 19 mars 1962, né à Dijon, France,

le 27 janvier 1976.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée nomme comme commissaire pour la durée de six ans: La société EUROPEAN MANAGEMENT FIDU-

CIARY S.A., 38, avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L’adresse de la société est fixée au 38, avenue du X septembre, L-2550 Luxembourg.
Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

1. FINANCIAL PLANNING AND DEVELOPMENT HOLDING S.A., prédésignée, mille cinq cent cinquante ac-

tions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.550

2. MARBURY INTERNATIONAL BUSINESS GROUP LLC., prédésignée, mille cinq cent quarante neuf actions 1.549
3. FRUCTILUX BUSINESS LTD, prédésignée, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois mille cent actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.100

22463

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société à

un ou plusieurs de ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente mi-

nute.

Signé: R. Uhl, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 2004, vol. 142S, fol. 55, case 8. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024634.3/211/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2004.

AS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 77.131. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03481, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024323.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

AS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 77.131. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03482, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024327.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

AS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2560 Luxembourg, 12, rue de Strasbourg.

R. C. Luxembourg B 77.131. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03484, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024329.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

SVENSKA HANDELSBANKEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 15.992. 

Le bilan au 31 décembre 2003, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03661, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024257.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Luxembourg, le 17 mars 2004.

J. Elvinger.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 19 mars 2004.

Signature.

22464

TROIS SOLEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 61, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 54.572. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03518, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024359.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

TROIS SOLEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 61, rue Zénon Bernard.

R. C. Luxembourg B 54.572. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 17 mars 2004, réf. LSO-AO03519, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mars 2004.

(024360.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

PJPT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 90.937. 

Lors de la réunion du conseil d’administration du 9 mars 2004, Monsieur Peter Vansant, gérant de société, avec adres-

se professionnelle au 28, côte d’Eich, L-1450 Luxembourg a été nommé aux fonctions d’administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2004.

Enregistré à Luxembourg, le 15 mars 2004, réf. LSO-AO03063. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(024254.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

EVLI BANK PLC

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 82.970. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 16 mars 2004, réf. LSO-AO03215, a été déposé au re-

gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(024259.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2004.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour PJPT S.A.
P. Vansant
<i>Administrateur-délégué

Luxembourg, le 19 mars 2004.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Lan Expert

Fiduciaire Comptable et Fiscale de Martelange S.A.

Continental Union Investments S.A.

Continental Union Investments S.A.

Uli, S.à r.l.

Artista International S.A.

Belgo Metal S.A. Luxembourg

Sisha S.A.

SVIF S.A.

Lucullux S.A.

Brenntag-Interfer (BC)

Totem Holdings S.A.

Totem Holdings S.A.

Totem Holdings S.A.

SOMALUX, Société de Matériel Luxembourgeoise S.A.

Hefesto S.A.

Hefesto S.A.

MIV Luxembourg Holding, S.à r.l.

Mako S.A.

Gennaker S.A.

SFDT International S.A.

Net Ventures Holding S.A.

Pelias Holding S.A.

Pelias Holding S.A.

Pelias Holding S.A.

HSBC Dewaay Luxembourg S.A.

HSBC Dewaay Luxembourg S.A.

Sofirac S.A.

Diatec, S.à r.l.

Luxmako, S.à r.l.

Gamirco S.A.

Gamirco S.A.

Allgemeine Deutsche Direktbank International S.A.

Harvest CLO I S.A.

Galey &amp; Lord International, S.à r.l.

Galey &amp; Lord International, S.à r.l.

Tregoran Overseas LTD

Pirelli International Finance S.A.

Pirelli International Finance S.A.

Welfab Investments S.A.

Welfab Investments S.A.

Harmodio S.A.

SHA Finance S.A.

Ruala Invest S.A.

Farvest, S.à r.l.

Topaze Finance, S.à r.l.

Sunbow Group S.A.

P.I.I. S.A.

Hestia S.A.

Fresenius Medical Care MDF S.A.

Euro-Leasing AG

Sette S.A.

Sette S.A.

Stemarlu S.A.

Stemarlu S.A.

Fraser Holding S.A.

Warm Arisonda S.A.

Filimi Investment Holding S.A.

Sul Palco, S.à r.l.

Sul Palco, S.à r.l.

Bram Investment S.A.

Sparinvest S.A.

Dimini S.A.

B.F.C.P. S.A.

B.F.C.P. S.A.

Full Computer Services Lux S.A.

Ibiza Holding S.A.

LVS Ulysse Invest S.A.

Azur Renting S.A.

Karma S.A.

Biotech Industry S.A.

Decia Invest S.A.

AS Luxembourg, S.à r.l.

AS Luxembourg, S.à r.l.

AS Luxembourg, S.à r.l.

Svenska Handelsbanken S.A.

Trois Soleils, S.à r.l.

Trois Soleils, S.à r.l.

PJPT S.A.

Evli Bank Plc