This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
5233
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 110
28 janvier 2004
S O M M A I R E
Abba Taxis, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . .
5234
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5261
AGSI, Agence Générale et Service d’Investisse-
GSC European Mezzanine Luxembourg III, S.à r.l.,
ment S.A., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5267
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5268
AGSI, Agence Générale et Service d’Investisse-
Health Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5245
ment S.A., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5268
Health Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5245
Alimar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5259
Health Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5246
Alimar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5259
Health Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5246
Alpenrose Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5236
ILS Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
5267
Alpenrose Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
5236
Kass Immobilière S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
5279
APA Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5244
Kass Immobilière S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
5279
APA Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5244
Kass Immobilière S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
5279
Avafin Ré S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . .
5278
Kass Immobilière S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . .
5279
Avroy S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5278
KS Knitting Solution S.A.H., Luxembourg. . . . . . .
5236
Bukkuram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5261
Laria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5242
Bukkuram S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5261
Laria S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5242
Cannel S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5280
LME Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
5244
Cofima Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5280
LME Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
5244
Compagnie des Grands Lacs S.A., Luxembourg . . .
5262
Lux-Avantage Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5246
EHI Fund (France Number 1), S.à r.l., Luxem-
Lux-Avantage Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5248
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5237
M.E.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5259
Euroinvest (Czech 3), S.à r.l., Luxembourg. . . . . . .
5235
M.E.M. S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5259
Euroinvest (Hungary 1), S.à r.l., Luxembourg. . . . .
5242
Margin Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
5266
Euroinvest (Hungary 2), S.à r.l., Luxembourg. . . . .
5242
Marstrand, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5269
Euroinvest (Hungary 3), S.à r.l., Luxembourg. . . . .
5260
Movi Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5245
Euroinvest (Poland 1), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
5260
Movi Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
5245
F.M. Auto, S.à r.l., Bivange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5268
Riva Financial Systems Limited, Luxembourg
F.M. Auto, S.à r.l., Bivange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5269
Branch, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5248
Felton S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5266
Riva Financial Systems Limited, Luxembourg
Fiduciaire Grand-Ducale S.A., Luxembourg . . . . . .
5277
Branch, Senningerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5248
Fiduciaire Grand-Ducale S.A., Luxembourg . . . . . .
5277
S.K. Trans, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5236
Fiduciaire Grand-Ducale S.A., Luxembourg . . . . . .
5278
S.K. Trans, S.à r.l., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5237
Financière de l’Avenir S.A., Luxembourg . . . . . . . .
5266
Sport Team S.A., Schifflange . . . . . . . . . . . . . . . . .
5279
Fingroup S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5277
Tertia Holding S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . .
5243
Fingroup S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5277
Tertia Holding S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . .
5243
Fingroup S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5277
Tertia Holding S.A., Hesperange . . . . . . . . . . . . . .
5243
Fondation Ste-Gertrude, Luxembourg . . . . . . . . . .
5260
Timedi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5243
Fregaton S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5280
Timedi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5243
Giar S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5280
World Energy Program S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5262
GSC European Mezzanine Luxembourg I, S.à r.l.,
World Tour Invest Ltd. S.A.H., Luxembourg . . . .
5280
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5260
Zippy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5263
GSC European Mezzanine Luxembourg II, S.à r.l.,
Zippy S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5266
5234
ABBA TAXIS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 123, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 97.829.
—
STATUTS
L’an deux mille trois, le douze décembre.
Par-devant Maître Anja Holtz, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1.- Monsieur Antonio Staltari, électro-mécanicien, demeurant à L-4222 Esch-sur-Alzette, 186, rue de Luxembourg,
2.- Monsieur Saverio Papagni, gérant, demeurant à L-4053 Esch-sur-Alzette, 5, rue des Charbons.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d’une société à responsabilité limitée,
qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après
créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de ABBA TAXIS, S.à r.l.
Art. 2. Le siège social de la société est établi à Esch-sur-Alzette. Il pourra être transféré en toute autre lieu du Grand-
Duché de Luxembourg par décision des associés.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise de transports de personnes et loueur de taxis et am-
bulances.
En général, la société pourra faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobi-
lières qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social et qui seraient de nature à en faciliter la réali-
sation et le développement.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) divisé en deux cent cinquante (250)
parts sociales de cinquante euros (50,- EUR) chacune, réparties comme suit:
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,-) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
La propriété des parts sociales résulte des présentes statuts ou des actes de cession de parts régulièrement consen-
tis, sans qu’il y ait lieu à délivrance d’aucun titre.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l’accord
du ou des associés représentant l’intégralité des parts sociales.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.
En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés survivants.
En cas de refus d’agrément il est procédé comme prévu à l’article 6.
Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu’il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s’en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Gérance - Assemblée générale
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à
tout moment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pou-
voirs sont définis dans l’acte de nomination.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement
aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 11. Pour engager valablement la société, la signature du ou des gérants est requise.
Art. 12. Chaque associé peut particper aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartien-
nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
1.- Monsieur Antonio Staltari, prénommé, deux cent quarante-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
2.- Monsieur Saverio Papagni, prénommée, une part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total des parts: deux cent cinquante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
5235
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représen-
tant les trois quarts du capital social.
Année sociale - Bilan
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtes et la gérance dresse un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à
ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.
Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve,
pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.
Dissolution - Liquidation
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d’arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Disposition générale
Art. 17. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas
été dérogé par les présents statuts.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 950,- EUR
<i>Assemblée Générale extraordinairei>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale, et, à l’una-
nimité des voix, ont pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la société est établi à L-4011 Esch-sur-Alzette, 123, rue de l’Alzette.
2.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
3.- L’assemblée générale désigne pour une durée indéterminée:
- gérant technique Monsieur Saverio Papagni, gérant, né à Montemilone (Italie), le 24 mars 1947, demeurant à L-4053
Esch-sur-Alzette, 5, rue des Charbons
- gérant administratif Monsieur Antonio Staltari, électro-mécanicien, né à Canalo (Italie), le 10 juin 1961, demeurant
à L-4222 Esch-sur-Alzette, 186, rue de Luxembourg.
La société sera valablement engagée par la signature conjointe du gérant technique et administratif.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: A. Staltari, S. Papagni, A. Holtz.
Enregistré à Wiltz, le 16 décembre 2003, vol. 317, fol. 85, case 1. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Biver.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(001710.3/2724/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2004.
EUROINVEST (CZECH 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.883.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01651, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002496.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Wiltz, le 18 décembre 2003.
A. Holtz.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signatures.
5236
ALPENROSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.029.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01355, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002424.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
ALPENROSE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 50.029.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2003i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01353.– Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002426.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
KS KNITTING SOLUTION S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 67.271.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01343, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002434.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
S.K. TRANS, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
(anc. V & A, S.à r.l.).
Gesellschaftssitz: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.
H. R. Luxemburg B 88.476.
—
Im Jahre zweitausendunddrei, am siebenundzwanzigsten November.
Vor dem unterschriebenen Notar Alphonse Lentz, im Amtssitze zu Remich.
Ist erschienen:
Herr Wilhelm Dickler, Kaufmann, geboren in Stolberg (Deutschland) am 24. Dezember 1950, wohnhaft in D-93149
Nittenau, Am Rücken 20.
Dieser Komparent erklärt, dass er alleiniger Inhaber ist sämtlicher Anteile des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung V & A, S.à r.l., mit Sitz in L-6793 Grevenmacher, 20, route de Trèves, gegründet gemäss Ur-
kunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. Juli 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Nummer 1431 vom 3. Oktober 2002.
Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in einhundert (100)
Anteile zu je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR).
Der alleinige Gesellschafter, Herr Wilhelm Dickler ersucht den unterzeichneten Notar folgende Beschlüsse zu beur-
kunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst die Änderung der Firmenbezeichnung von V & A, S.à r.l. in S. K. TRANS, S.à r.l. und
dementsprechend Artikel 3 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 3. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung S. K. TRANS, S.à r.l.»
Extrait sincère et conforme
ALPENROSE HOLDING S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
ALPENROSE HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Extrait sincère et conforme
KS KNITTING SOLUTION S.A.
Signature
5237
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Gesellschaftssitz von L-6793 Grevenmacher, 20, route de Trèves nach L-5540 Re-
mich, 36, rue de la Gare zu verlegen und dementsprechend Artikel 4, erster Satz der Statuten abzuändern und ihm fol-
genden Wortlaut zu geben:
«Art. 4. Erster Satz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Remich.»
<i>Dritter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst den Gegenstand der Gesellschaft abzuändern um Artikel 2 folgenden Wortlaut zu ge-
ben:
«Art. 2. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind die Eiltransporte bis zu 7,5 Tonnen und Kurierfahrten, sowie
alle kaufmännischen Operationen und Geschäfte, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammen-
hängen oder diese fördern.
Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen, die einen ähnlichen Zweck
verfolgen; sie kann weiterhin sämtliche handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche di-
rekt oder indirekt auf den Hauptzweck Bezug haben.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.»
<i>Vierter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschliesst, mit Wirkung zum heutigen Tage, Herrn Peter Goretzky, Ausbeiner, wohnhaft in D-
71696 Möglingen, Im Heuleger 28, als Geschäftsführer abzuberufen.
Der Erschienene erteilt ihm Entlast für seine Tätigkeit.
Zum neuen Geschäftsführer wird Herr Wilhelm Dickler, Kaufmann, geboren in Stolberg (Deutschland) am 24. De-
zember 1950, wohnhaft in D-93149 Nittenau, am Rücken 20, ernannt.
Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift des Geschäftsführers.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vorna-
men, Stand und Wohnort bekannt, haben derselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: W. Dickler, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 2 décembre 2003, vol. 467, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Molling.
Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
(002321.3/221/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
S.K. TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 88.476.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9
janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002323.3/221/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
EHI FUND (FRANCE NUMBER 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 97.908.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the seventeenth of December.
Before Us, Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-sur-Alzette.
There appeared:
EHIF NOMINEES LIMITED, a company incorporated under the laws of Great Britain, having its registered office at
c/o Ashurst Morris Crisp, Broadwalk House, 5 Appold Street, London EC2A 2HA, Great Britain, duly represented by
Marc Meyers, avocat, residing at 2, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, by virtue of a proxy given in London (Great Britain),
on December 10, 2003.
The said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary,
shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the officiating notary to enact the following articles
of association (hereafter the «Articles») of a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which is
hereby incorporated.
Remich, le 8 janvier 2004.
A. Lentz.
Remich, le 8 janvier 2004.
A. Lentz.
5238
Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-
come shareholders in the future, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be gov-
erned by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August,
1915 on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the present Articles, which specify in
the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to a one shareholder company.
Art. 2. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of participating
interests in any enterprise in whatever form and the administration, management, control and development of those
participating interests.
The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed
from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the cre-
ation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or op-
tion, securities and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, to
receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies in which the
Company has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial assistance,
loans, advances or guarantees.
The Company may also use its funds to invest in real estate and to carry out any commercial, industrial or financial
operation which the Company may deem directly or indirectly useful to the accomplishment of its purposes.
The Company may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures and
certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name EHI FUND (FRANCE NUMBER 1), S.à r.l.
Art. 5. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. It may be transferred to any
other place within the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the extraordinary general meeting of sharehold-
ers deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 6. The Company’s share capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR), represented by
five hundred (500) shares having a nominal value of twenty-five euro (25.- EUR) each, all fully subscribed and fully paid up.
The Company may redeem its own shares.
However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable reserves are available as regards the excess purchase
price. The shareholders’ decision to redeem its own shares shall be taken by an unanimous vote of the shareholders
representing one hundred per cent (100%) of the share capital, in an extraordinary general meeting and will entail a
reduction of the share capital by cancellation of all the redeemed shares.
Art. 7. Without prejudice to the provisions of article 6, the capital may be changed at any time by decision of the
single shareholder or by decision of the shareholders’ meeting deliberating in the same manner provided for amend-
ments to the Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible and only one owner is admitted per share. Joint
co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in accordance with
the requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealings with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
sole signature of any member of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
5239
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders’ meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights in proportion to his shareholding. Collective de-
cisions are validly taken insofar as they are adopted by shareholders representing more than half of the share capital.
Notwithstanding the above, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of
the shareholders owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December. The
first financial year starts today and ends on 31st December, 2003.
Art. 16. Each financial year, the Company’s accounts are established and the manager or, in case of plurality of man-
agers, the board of managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and
liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allo-
cated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) in proportion to his/their share holding in the
Company.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the manager or the board of managers;
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve;
3. The decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or, as the case may be, by an extraordinary
general meeting of the shareholders; and
4. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Com-
pany are not threatened.
Art. 18. In case of winding up the Company, liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders
or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Subscription and paymenti>
All the shares have been subscribed by EHIF NOMINEES LIMITED, as aforementioned.
All these shares are fully paid up by payments in cash such that the sum of twelve thousand five hundred euro
(12,500.- EUR) is from now on at the free disposal of the Company, proof thereof having been given to the officiating
notary who expressly bears witness to it.
<i> Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at about one thousand two hundred euro (1,200.- EUR).
<i> Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder, representing the entirety of the sub-
scribed capital has passed the following resolutions:
1) The following persons are appointed for an undetermined period of time as managers of the Company:
- Jan Rottiers, company director, born in Naples (Italy), on October 31, 1964, residing professionally at 291, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg;
- Alain Lam, company director, born in Rose Hill (Mauritius), on February 28, 1969, residing professionally at 291,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
2) The address of the registered office is established at 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the years and day first above written.
The document having been read to the appearing party’s proxy holder known to the notary by its name, first name,
civil status and residence, the appearing party’s proxy holder signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,
A comparu:
EHIF NOMINEES LIMITED, une société constituée sous les lois de la Grande-Bretagne, ayant son siège social à c/o
Ashurst Morris Crisp, Broadwalk House, 5 Appold Street, Londres EC2A 2HA, Grande-Bretagne, ici représentée par
5240
Marc Meyers, avocat, demeurant à 2, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé don-
née à Londres (Grande-Bretagne), le 10 décembre 2003.
Laquelle procuration, après avoir été paraphée et signée ne varietur par le mandataire ainsi que par le notaire sous-
signé, restera annexée au présent acte pour être soumise ensemble à la formalité de l’enregistrement.
Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire de dresser les statuts (ci-après les «Sta-
tuts») d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer comme suit:
Art. 1. Il est formé par les présentes, entre la comparante et toutes les personnes qui pourraient devenir associés
par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et notamment
celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les présents
Statuts, lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à respon-
sabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La Société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
La Société pourra notamment employer ses fonds pour établir, gérer, développer et céder ses actifs se composant
ponctuellement de manière non limitative à son portefeuille de titres de toute origine, de participer à la création, au
développement et au contrôle de toute entreprise, d’acquérir par voie d’apport, souscription, prix ferme ou option
d’achat, et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les réaliser par voie de vente, cession,
échange ou autrement, recevoir ou accorder des licences sur des droits de propriété intellectuelle et accorder à ou
pour le bénéfice de sociétés dans lesquelles la Société a une participation directe ou indirecte ou à des sociétés du grou-
pe, toute assistance, prêts, avances ou garanties.
La Société pourra également employer ses fonds pour investir dans des biens immobiliers et pour accomplir toutes
opérations commerciales, industrielles ou financières qu’elle estimera utile à l’accomplissement de son objet.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission privée d’obligations de toute nature, à con-
dition qu’elles ne soient pas librement négociables et émises sous forme nominative.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination EHI FUND (FRANCE NUMBER 1), S.à r.l.
Art. 5. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville. Il peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l’assemblée générale extraordinaire des associés statuant comme
en matière de changement des Statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée dans les limites de la commune par simple décision du gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cent euros (12.500,- EUR), représenté
par cinq cent (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, toutes intégralement
souscrites et entièrement libérées.
La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d’achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent
pour cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social
par annulation des parts sociales rachetées.
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant
décision de l’associé unique sinon de l’assemblée des associés délibérant comme en matière de modifications des Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif
social ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-
cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.
Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition de remplir les exigences de l’article
189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de la faillite ou de la déconfiture de
l’associé unique, sinon d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un con-
seil de gérance. Le ou les gérants n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont révocables ad nutum.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-
constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblé générale des associés
sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.
En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par
la seule signature de n’importe quel membre du conseil de gérance.
5241
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des
opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.
Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire
et sa rémunération (si tel est les cas), la durée de la période de représentation et n’importe quelles autres conditions
pertinentes de ce mandat.
En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants
présents ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Cependant, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année. Par exception, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2003.
Art. 16. Chaque année les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un in-
ventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Art. 17. Les produits de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortis-
sements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la
libre disposition de l’assemblée générale.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivan-
tes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance;
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice;
3. L’associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d’acomptes sur dividendes; et
4. Le paiement n’est effectué par la Société qu’après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont
pas menacés.
Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions de la loi
du 10 août 1915, telle que modifiée.
<i> Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été toutes souscrites par EHIF NOMINEES LIMITED, susmentionnée.
Toutes ces parts sociales ont été libérées entièrement par paiement en numéraire, de sorte que le montant de douze
mille cinq cent euros (12.500,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumen-
taire qui le constate expressément.
<i> Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille deux cents euros (1.200,-
EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, l’associé unique, représentant la totalité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
1.- Les personnes suivantes sont nommées pour une durée indéterminée en tant que gérants de la Société:
Monsieur Jan Rottiers, administrateur de société, né à Naples (Italie), le 31 octobre 1964, demeurant professionnel-
lement à 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg,
Monsieur Alain Lam, administrateur de société, né à Rose Hill (Ile Maurice), le 28 février 1969, demeurant profes-
sionnellement à 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
2.- L’adresse du siège social de la Société est établi à 291, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
5242
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,
la présente minute.
Signé: M. Meyers, B. Moutrier.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2003, vol. 894, fol. 25, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002549.3/272/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
LARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.949.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01345, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002431.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
LARIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 81.949.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2003i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01344. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002433.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
EUROINVEST (HUNGARY 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.927.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01653, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002498.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
EUROINVEST (HUNGARY 2), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.928.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01657, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002499.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2003.
B. Moutrier.
Extrait sincère et conforme
LARIA S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
LARIA S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signatures.
5243
TIMEDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.766.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01349, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002427.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
TIMEDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.766.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 23 décembre 2003i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01346. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002428.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
TERTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 59.457.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05699, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002500.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
TERTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 59.457.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05701, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002501.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
TERTIA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 59.457.
—
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 22 décembre 2003, réf. LSO-AL05704, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002504.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Extrait sincère et conforme
TIMEDI S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
TIMEDI S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 17 décembre 2003.
Signature.
5244
APA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R.C. Luxembourg B 63.007.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01415, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002440.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
APA GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 63.007.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 24 octobre 2003i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Les mandats d’administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer, EDIFAC S.A., viennent à échéance lors de cette
assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Jean Lambert, Caroline Folmer,
EDIFAC S.A., sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.
Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01391.– Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002443.3//24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
LME INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.860.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01390, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002445.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
LME INVEST S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 74.860.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 30 décembre 2003i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, Cristian Pescatori, Jean Lambert viennent à échéance lors de cette
assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, Cristian Pes-
catori, Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.
Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Extrait sincère et conforme
APA GROUP S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
APA GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Extrait sincère et conforme
LME INVEST S.A.
Signature
5245
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01387. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002446.3/1022/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
MOVI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.365.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01341, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002438.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
MOVI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 52.365.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2003i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01340. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002439.2//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
HEALTH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 78.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06323, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(002411.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
HEALTH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 78.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06328, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(002412.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Extrait sincère et conforme
LME INVEST S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Extrait sincère et conforme
MOVI FINANCE S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
MOVI FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour HEALTH HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour HEALTH HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
5246
HEALTH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 78.082.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06332, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(002413.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
HEALTH HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R. C. Luxembourg B 78.082.
—
L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 27 juin 2003 a élu comme administrateurs: Monsieur Eggert J.
Hilmarsson, KAUPTHING BUNADARBANKI HF ICELAND and KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A., et comme
commissaire aux comptes LUX-AUDIT REVISION, S.à r.l.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, réf. LSO-AL06317. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002410.3/1021/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
LUX-AVANTAGE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.041.
—
L’an deux mille trois, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de la société établie à Luxembourg sous la dénomination de LUX-AVAN-
TAGE R.C. Numéro B 46.041, ayant son siège social à Luxembourg, constituée sous la forme d’une société d’investis-
sement à capital variable suivant acte reçu par le notaire instrumentaire, en date du 28 décembre 1993.
Les statuts de la société ont été publiés au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Numéro 54 du 8 février
1994.
Les statuts de la société ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Martine Weinandy, notaire de résidence à Cler-
vaux, en remplacement du notaire instrumentaire, en date du 24 octobre 2000, publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations numéro 868 du 30 novembre 2000.
L’Assemblée est ouverte à onze heures sous la présidence de Monsieur Patrick Schu, Employé de Banque à la BAN-
QUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, Luxembourg, demeurant à Echternach.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Jeff Schmit, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAIS-
SE D’EPARGNE DE L’ETAT, demeurant à Itzig.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Claude Ewen, Attaché de Direction à la BANQUE ET CAISSE D’EPAR-
GNE DE L’ETAT, demeurant à Leudelange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Que la présente Assemblée Générale a été dûment convoquée par des annonces parues au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations Numéro 1304 du 8 décembre 2003 et Numéro 1256 du 27 novembre 2003, et au Luxem-
burger Wort des 27 novembre 2003 et 8 décembre 2003.
Les numéros justificatifs de ces publications ont été déposés au bureau de l’Assemblée.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Recevoir le rapport du Conseil d’Administration et le rapport du Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au
30 septembre 2003.
2) Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2003; affectation des résultats.
3) Donner quitus aux Administrateurs.
4) Nominations statutaires.
5) Nomination du Réviseur d’Entreprises.
6) Divers.
<i>Pour HEALTH HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Pour HEALTH HOLDING S.A.
i>KAUPTHING BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
5247
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l’Assemblée, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur 4.160.729 actions sans désignation de valeur nominale en circu-
lation à la date du 18 décembre 2003, 61.429 actions sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en consé-
quence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du
jour, ci-avant reproduit.
L’Assemblée a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après avoir reconnu qu’elle était régulièrement cons-
tituée, a pris, après délibération, les résolutions suivantes à l’unanimité des voix.
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale constate qu’elle a pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport du
Réviseur d’Entreprises pour l’exercice clos au 30 septembre 2003.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2003 tels qu’ils ont été présentés
ainsi que l’affectation du résultat proposée par le Conseil d’Administration.
Compartiment LUX-AVANTAGE I:
Adoptant la décision du Conseil d’Administration, l’Assemblée donne son accord sur:
- la part du montant distribuable du compartiment revenant aux actions de capitalisation (actions de classe A) qui
sera réinvestie dans ce compartiment au profit des actionnaires de la classe A;
- la part du montant distribuable du compartiment revenant aux actions de distribution (actions de classe B) étant
zéro, aucun dividende ne sera payé.
Ainsi, le coupon numéro 22 reste attaché à la feuille des coupons.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale approuve la gestion du Conseil d’Administration et donne décharge pleine et entière aux Ad-
ministrateurs pour l’exercice de leur mandat jusqu’au 30 septembre 2003.
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée constate que lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 décembre 2002, le terme du mandat des
Administrateurs a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente Assemblée Générale.
Le mandat des Administrateurs venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination des membres suivants
au Conseil d’Administration pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en
décembre 2004:
Monsieur Raymond Kirsch, président;
Monsieur Armand Weis, vice-président;
Monsieur Michel Birel, administrateur
Monsieur Gilbert Ernst, administrateur;
Monsieur Jean-Claude Finck, administrateur;
Monsieur Jean-Paul Kraus, administrateur;
Monsieur Jacques Mangen, administrateur;
Monsieur Nicolas Rollinger, administrateur;
Monsieur Paul Waringo, administrateur.
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée constate que le mandat du Réviseur d’Entreprises a été fixé à un an, c’est-à-dire jusqu’à la présente As-
semblée Générale.
Le mandat venant ainsi à échéance, l’Assemblée procède à la nomination du Réviseur d’Entreprises Pricewaterhouse-
Coopers pour un nouveau terme d’un an jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2004.
<i>Diversi>
L’Assemblée décide d’allouer aux membres du Conseil d’Administration des rémunérations pour l’exercice en cours
s’élevant à un montant total maximum de 30.840,- EUR.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: P. Schu, J. Schmit, C. Ewen, A. Schwachtgen.
- Actif net au 30.09.2003: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
174.233.538,85 EUR
- Résultat net réalisé au 30.09.2003: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 8.942.758,95 EUR
- Résultat des opérations au 30.09.2003: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34.621.148,30 EUR
5248
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 62, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002642.3/230/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
LUX-AVANTAGE SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R. C. Luxembourg B 46.041.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 2003, enregistrés à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00756, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002645.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
RIVA FINANCIAL SYSTEMS LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 97.915.
—
It results from a decision of the Board of directors RIVA FINANCAL SYSTEMS LIMITED that:
1. RIVA FINANCIAL SYSTEMS LIMITED will establish a Luxembourg branch office situated at the European Bank and
Business Centre, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg.
2. The capital allocated to the branch will be GBP 100.-.
3. Paul Reilly, living at Enner Der Haerdchen 4, L-6170 Godbrange, Luxembourg will be nominated technical manager
(director) of RIVA FINANCIAL SYSTEMS LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH.
4. Anthony John Parker, living at 47 Cité Waertzgaertchen, L-5693 Elvange, Luxembourg, Laurence Anthony New,
living at Enner Der Haerdchen 4, L-6170 Godbrange and Timothy Paul Leeming living at Calderville, Selborne Drive,
Douglas, Isle of Man IM2 3NH, will be nominated administrative managers (directors) of RIVA FINANCIAL SYSTEMS
LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH.
5. The Branch will be bound by the signature of the technical manager together with one of the administrative man-
agers.
Braddan, Isle of Man the 17th December 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2003, réf. LSO-AM00888. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002583.3/607/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
RIVA FINANCIAL SYSTEMS LIMITED, LUXEMBOURG BRANCH.
Registered office: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 97.915.
—
<i>Memorandum of Association of RIVA FINANCIAL SYSTEMS LIMITEDi>
1. The name of the Company is RIVA FINANCIAL SYSTEMS LIMITED.
2. The Company is a Private Company.
3. The liability is limited to the members.
4. The share capital of the Company is £ 10,000.- divided into 10,000 shares of £ 1.- each.
We the subscribers to this Memorandum of Association:
a) wish to form a Company pursuant to this Memorandum;
b) agree to take the number of shares shown opposite our respective names;
c) declare that all the requirements of the Companies Acts 1931-1993 in respect of matters relating to the registra-
tion and of matters precedent and incidental thereto have been complied with.
Dated this 15th day of October 2002.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 6 janvier 2004.
A. Schwachtgen.
For approval
Signature / Signature
<i>Director / Directori>
Name and Address of Subscribers
Signature
No. of shares taken
Timothy Peter Leeming, 38 Selborne Drive, Douglas, Isle of Man, IM2 3NH . . . . . . Signature
100
Laurence Anthony New, Enner Der Haerdchen, L-6170 Godbrange, Luxembourg . Signature
100
Paul Reilly, Enner Der Haerdchen, L-6170 Godbrange, Luxembourg . . . . . . . . . . . . Signature
100
J. Newman
<i>Witness to the above signaturesi>
5249
ARTICLES OF ASSOCIATION
<i>Interpretationi>
1 (1) In these Articles
«the Act» means the Companies Acts 1931 to 1993 including any statutory modification or re-enactment thereof for
the time being in force;
«the Articles» means the Articles of Association of the Company;
«clear days» in relation to the period of a notice means that period excluding the day when the notice is given or
deemed to be given and the day for which it is given or on which it is to take effect;
«executed» includes any mode of execution;
«office» means the registered office of the company;
«the holder» in relation to shares means the member whose name is entered in the register of members as the hold-
ers of the shares;
«the seal» means the common seal of the Company and, where the context so admits, shall include an official seal as
authorised under Article 112 hereof,
«secretary» means the secretary of the Company or any other person appointed to perform the duties of the sec-
retary of the Company, including a joint assistant or deputy secretary.
(2) Unless the context otherwise requires, words or expressions contained in these Articles bear the same meaning
as in the Act but excluding any statutory modification thereof not in force when these Articles become binding on the
Company.
2. Table A in the Schedule to the Companies (Memorandum and Articles of Association) Regulation 1988 shall not
apply to the Company.
<i>Private Companyi>
3. The Company is a «Private Company» within the meaning of Section 26 of the Act and accordingly no invitation
shall be issued to the public to subscribe for any shares or debentures of the Company.
<i>Sharesi>
4. (1) Subject to the provisions of the Act and without prejudice to any rights attached to any existing shares, any
share may be issued with such rights or restrictions as the Company may by ordinary resolution determine.
(2) Subject to the provisions of the Act, shares may be issued in fractional denomination to the same extent as whole
shares.
5. Subject to the provisions of the Act and the Articles, redeemable preference shares may be issued on such terms
and in such manner as may be provided by the Articles.
6. The shares shall be under the control of the Directors, and (save as otherwise directed by the Company in General
Meeting) they may allot or otherwise dispose of them to such persons at such times and generally on such terms and
conditions as they think proper.
7. Any preference shares may be issued on the terms that they are, or at the option of the Company or the holder
are, liable to be redeemed and such redemption may, subject to the provisions of Section 46 and 46A of the Act, be
effected on such terms and in such manner as the Company before the issue of such Shares may by Special Resolution
determine.
8. The Company may issue share warrants to the Bearer in respect of any fully paid up shares of the Company stating
that the Bearer of the warrant is entitled to the shares therein specified. Such warrants shall be issued on such terms
and subject to such conditions as may be resolved by the Directors and shall be transferable by delivery. The Bearer of
the warrant shall be deemed for all purposes to be the shareholder and member of the Company.
9. The shares comprised in a warrant shall be transferred by the delivery of the warrant and the provisions of the
Articles with respect to the transfer and transmission of shares shall not apply thereto.
10. The Bearer for the time being of any warrant shall be subject to the Articles of the Company and shall be deemed
to be a member of the Company to the full extent (subject as hereinafter mentioned in respect of the shares represent-
ed by such warrant).
11. The Company notwithstanding any notice or knowledge it may have shall not be bound by or be required to rec-
ognise any legal or equitable right, title or interest whatever in respect of any shares represented by any warrant except
the rights of the Bearer of such warrant as a member of the Company to the shares specified therein.
12. Until otherwise resolved by resolution of a general meeting the exercise of all the powers of the Company with
reference to warrants to Bearer and the issue of the same shall be entrusted to the Directors. The Directors shall not
be bound to exercise the power of issuing warrants to Bearer, either generally or in any particular case, but it shall be
in their absolute discretion to exercise such power or not as the interests of the Company may seem to require.
13. The Company may pay a commission to any person in consideration of his subscribing or agreeing to subscribe,
whether absolutely or conditionally, for any shares in the Company, or procuring or agreeing to procure subscription,
whether absolute or conditional, for any shares, debentures or debenture stock in the Company, provided that the com-
mission does not exceed 10 per cent of the price at which such shares are issued, or an amount equivalent thereto, and
such commission may be paid in whole or in part, in cash or fully or partly paid shares, debentures or debenture stock
of the Company, as may be arranged. The statement required by Section 43 of the Act shall be duly delivered to the
Registrar of Companies for registration, and Sections 42 of the same Act shall where necessary be duly complied with,
and the amount of any such commission shall be stated in the balance sheets and annual return of the Company as re-
quired by Section 44 and 107 of the Act.
5250
14. Except as required by law, no person shall be recognised by the Company as holding any shares upon any trust
and (except as otherwise provided by the Articles or by the law) the Company shall not be bound by or recognise any
interest in any share except an absolute right to the entirety thereof in the holder.
<i>Share certificatesi>
15. (1) Every member, upon becoming the holder of any shares, shall be entitled
(a) without payment, to one certificate for all the shares of each class held by him (and, upon transferring a part of
his holding of shares of any class, to a certificate for the balance of such holding); or
(b) to several certificates each for one or more of his shares upon payment, for every certificate after the first, of
such reasonable sum as the Directors may determine.
(2) Every certificate shall be sealed with the seal and shall specify the number, class and distinguishing numbers (if any)
of the shares to which it relates and the amount or respective amounts paid up thereon.
(3) The Company shall not be bound to issue more that one certificate for shares held jointly by several persons and
delivery of the certificate to one joint holder shall be a sufficient delivery to all of them.
16. If a share certificate is defaced, worn out, lost or destroyed. It may be renewed on such items (if any) to evidence
and indemnity and payment of the expenses reasonably incurred by the Company in investigating evidence as the Di-
rectors may determine, but otherwise free of charge, and (in the case of defacement or wearing out) on delivery up of
the old certificate.
<i>Lieni>
17. The Company shall have a first and paramount lien on every share (whether partly or fully paid up) for all monies
(whether presently payable or not) payable at a fixed time or called in respect of that share. The Directors may at any
time declare any share to be wholly or in part exempt from the provision of this regulation. The Company’s lien on a
share shall extend to any amount payable in respect of it.
18. The Company may sell in such manner as the Directors determine any shares on which the Company has a lien
if a sum in respect of which the lien exists is presently payable and is not paid within fourteen days after notice has been
given to the holder of the share or to the person entitled to it in consequence of the death or bankruptcy of the holder,
demanding payment and stating that of the notice is not complied with the shares may be sold.
19. To give effect to the sale the Directors may authorise some persons to execute an instrument of transfer of the
shares sold to, and in accordance with the directors of, the purchaser. The title of the transferee to the shares shall not
be affected by any irregularities in or invalidity of the proceedings in reference to the sale.
20. The net proceeds of the sale, after payment of the costs, shall be applied in payment of so much of the sum for
which the lien exists as is presently payable, and any residue shall (upon surrender to the Company for cancellation of
the certificate for the shares sold and subject to the like lien for any monies not presently payable as existing upon the
shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of the sale.
<i>Calls on shares and forfeiturei>
21. Subject to the terms of allotment, the Directors may make calls upon the members in respect of any monies un-
paid on their shares (whether in respect of nominal value or premium) and each member shall (subject to receiving at
least fourteen clear days’ notice specifying when and where payment is to be made) pay the Company as required by
the notice the amount called on his shares. A call may be required to be paid by instalments. A call may, before receipt
by the Company of any sum due thereunder, be revoked in whole or part and payment of a call may be postponed in
whole or part. A person upon whom a call is made shall remain liable for calls made upon him notwithstanding the sub-
sequent transfer of the shares in respect whereof the call was made.
22. A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising the call
was passed.
23. The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect hereof.
24. If a call remains unpaid after it has become due and payable the person from whom it is due and payable shall pay
interest on the amount unpaid from the day it became due and payable until it is paid at the rate fixed by the terms of
allotment of the shares or in the notice of the call or, if no rate is fixed, at the rate of 5 per cent per annum but the
Directors may waive payment of the interest wholly or in part.
25. An amount payable in respect of a share on allotment or at any fixed date, whether in respect of nominal value
or premium or as an instalment of a call, shall be deemed to be a call and if it is not paid the provisions of the Articles
shall apply as if that amount has become due and payable by virtue of a call.
26. Subject to the terms of the allotment, the Directors may make arrangements on the issue of shares for a differ-
ence between the holders in the amounts and times of payment of calls on their shares.
27. If a call remains unpaid after it has become due and payable the Directors may give to the person from whom it
is due not less than fourteen clear days’ notice requiring payment of the amount unpaid together with any interest which
may have accrued. The notice shall name the place where payment is to be made and shall state that if the notice is not
complied with the shares in respect of which the call was made will be liable to be forfeited.
28. The liability of any members in default in respect of a call or instalment of a call shall include all expenses that may
have been incurred by the Company by reason of such non-payment,
29. If the notice is not complied with any shares in respect of which it was given may, before the payment required
by the notice has been made, be forfeited by a resolution of the Directors and the forfeiture shall include all dividends
or other monies payable in respect of the forfeited shares and not paid before the forfeiture.
30. Subject to the provisions of the Act, a forfeited share may be sold, re-allotted or otherwise disposes of on such
terms and in such manner as the Directors determine either to the person who was, before the forfeiture, the holder
or to any other person and at any time before sale, re-allotment or other disposition, the forfeiture may be cancelled
5251
on such terms as the Directors may think fit. When for the purposes of its disposal a forfeited share is to be transferred
to any person the Directors may authorise some person to execute an instrument of transfer of the share to that per-
son.
31. A person any of whose shares have been forfeited shall cease to be a member in respect of them and shall sur-
render to the Company for cancellation the certificate for the shares forfeited but shall remain liable to the Company
for all monies which at the date of forfeiture were presently payable to him to the Company in respect of those shares
with interest at the rate which interest was payable on those monies before the forfeiture or, if no interest was payable,
at the rate of 5 per cent per annum from the date of forfeiture until payment without any allowance for the value of the
shares at the time of forfeiture or for any consideration received on their disposal.
32. A statutory declaration by a Director of the Secretary that a share has been forfeited on a specified date shall be
conclusive evidence of the facts stated in it as against all persons claiming to be entitled o the share and the declaration
shall (subject to the execution of any instrument of transfer if necessary) constitute a good title to the share and the
person to whom the share is disposed of shall not be bound to see the application of the consideration, if any, nor shall
his title to the share be affected by any irregularity in or invalidity of the proceedings in reference to the forfeiture or
disposal of the share.
<i>Transfer of sharesi>
33. The instrument of transfer of a share may be in any usual form or in any other form which the Directors may
approve and shall be executed by or on behalf of the transferor and, unless the share is fully paid, by or on behalf of the
transferee.
34. No transfer of any share in the capital of the Company to any person not already a member of the Company shall
be made or registered without the previous sanction of the Directors, who may without assigning any reason, decline
to give any such sanction.
35. The Directors may also refuse to register a transfer unless
(a) it is lodged at the office or at such other place as the Director may appoint and is accompanied by the certificate
for the shares to which it related and such other evidence as the Directors may reasonably require to show the right
of the transferor to make the transfer.
(b) it is in respect of only one class of share; and
(c) it is in favour of not more that four transferees.
36. If the Directors refuse to register a transfer of a share, they shall within two months after the date on which the
transfer was lodged with the Company send to the transferee notice of the refusal.
37. The registration of transfers of shares or of transfers of any class of shares may be suspended at such times and
for such periods (not exceeding thirty days in any year) as the Directors may determine.
38. No fee shall be charged for the registration of any instrument of transfer or other document relating to or affect-
ing the title of any share.
39. The Company shall be entitled to retain any instrument of transfer which is registered, but any instrument of
transfer which the Directors refuse to register shall be returned to the person lodging it when notice of the refusal is
given.
<i>Transmission of sharesi>
40. If a member dies the survivor or survivors where he was a joint holder, and his personal representative where
he was a sole holder or the only survivor of joint holders, shall be the only persons recognised by the Company as having
any title to his interest; but nothing herein contained shall release the estate of a deceased member from any liability in
respect of any share which had been jointly held by him.
41. A person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member may, upon such
evidence being produced as the Directors may properly require, elect either to become the holder of the share or to
have some person nominated by him registered as the transferee. If he elects to become the holder he shall give notice
to the Company to that effect. If he elects to have another person registered he shall execute an instrument of transfer
of the share to that person. All Articles relating to the transfer of shares shall apply to the notice or instrument of trans-
fer as if it were an instrument of transfer executed by the member and the death or bankruptcy of the member had no
occurred. Provided always that the Directors may at any time give notice requiring any such person to elect either to
be registered himself or to transfer the share, and if the notice is not complied with within ninety days the Directors
may thereafter withhold payment of dividends, bonuses or other monies payable in respect of the Shares until the re-
quirements of the notice have been complied with.
42. A person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member shall have the
rights to which he would be entitled if he were the holder of the share, except that he shall not, before being registered
as the holder of the share, be entitled in respect of it to attend or vote at any meeting of the Company or at any separate
meeting of the holders of any class of shares in the Company.
<i>Alteration of share capitali>
43. The Company may by ordinary resolution
(a) increase its share capital by new shares of such amount as the resolution prescribes;
(b) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amounts than existing shares;
(c) subject to the provisions of the Act, sub-divide its shares, or any of them, into shares of smaller amount and the
resolution may determine that, as between the shares resulting from the sub-division, any of them may have any pref-
erence or advantages as compared with the other; and
(d) cancel shares which, at the date of the passing of the resolution, have not been taken or agreed to be taken by
any person and diminish the amount of its share capital by the amount of the shares so cancelled.
5252
44. Whenever as a result of a consolidation of shares any members would become entitled to fractions of a share,
the Directors may, instead of issuing the fractions of a share, on behalf of those members, sell the shares representing
the fractions for the best price reasonably obtainable to any person (including, subject to the provisions of the Act, the
Company) and distribute the net proceeds of sale in due proportion among those members, and the Directors may
authorise some person to execute an instrument of transfer of the shares to, or in accordance with the directions of,
the purchaser. The transferee shall not be bound to see to the application of the purchase money nor shall his title to
the shares be affected by any irregularity in or invalidity of the proceedings in reference to the sale.
45. Subject to the provisions of the Act, the Company may by special resolution reduce its share capital, any capital
redemption reserve and any share premium account in any way.
<i>General meetingi>
46. All general meetings other than annual general meetings shall be called extraordinary general meetings.
47. The Directors shall call general meetings and, on the requisition of members pursuant to the provisions of the
Act, shall forthwith proceed to convene an extraordinary meeting for a date not later than eight weeks after receipt of
the requisition.
<i>Notice of general meetingsi>
48. An annual general meeting and an extraordinary general meeting called for the passing of a special resolution or
a resolution appointing a person as a Director shall be called by at least twenty-one clear days’ notice. All other extraor-
dinary general meetings shall be called by at least fourteen clear days’ notice but a general meeting may be called by
shorter notice if it is so agreed
(a) in the case of an annual general meeting, by all the members entitled to attend and vote thereat, and
(b) in the case of any other meeting by a majority in number of the members having a right to attend and vote being
a majority together holding not less than ninety-five per cent in nominal value of the shares giving that right.
The notice shall specify the time and place of the meeting and the general nature of the business to be transacted and,
in the case of the annual general meeting, shall specify the meeting as such.
Subject to the provisions of the Articles and to any restrictions imposed on any shares, the notice shall be given to
all the members, to all persons entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy of a member and to the
Directors and Auditors.
49. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by, any person
entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.
<i>Proceedings at general meetingi>
50. No business shall be transacted at any meeting unless a quorum is present. Two persons entitled to vote upon
the business to be transacted, each being a member or a proxy for a member or a duly authorised representative of a
corporation, shall be a quorum.
51. If such a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting, or if during a meeting
a quorum ceases to be present, the meeting shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time
and place or to such time and place as the Directors may determine.
52. The chairman, if any, of the Board of Directors or in his absence some other Director nominated by the Directors
shall preside as chairman of the meeting, but if neither the chairman nor such other Director (if any) be present within
fifteen minutes after the time appointed to holding the meeting and willing to act, the Directors present shall elect one
of their number to be chairman and, if there is only one Director present and willing to act, he shall be chairman.
53. If no Director is willing to act as chairman, or if no Director is present within fifteen minutes after the time ap-
pointed for holding the meeting, the members present and entitled to vote shall choose one of their number to be chair-
man.
54. A Director shall, notwithstanding that he is not a member, be entitled to attend and speak at any general meeting
and at any separate meeting of the holders of any class of shares in the Company.
55. The chairman may, with the consent of a meeting at which a quorum is present (and shall if so directed by the
meeting), adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at an ad-
journed meeting other than business which might properly have been transacted at the meeting had the adjournment
not taken place. When a meeting is adjourned for fourteen days or more, at least seven clear days’ notice shall be given
specifying the time and place of the adjourned meeting and the general nature of the business to be transacted. Other-
wise it shall not be necessary to give any such notice.
56. A resolution put to the vote of a meeting shall be decided on a show of hands unless before, or on the declaration
of the results of, the show of hands a poll is duly demanded. Subject to the provisions of the Act, a poll may be demanded
(a) by the chairman; or
(b) by at least two members having the right to vote at the meeting; or
(c) by a member or members representing not less than one tenth of the total voting rights of all the members having
the right to vote at the meeting; or
(d) by a member or members holding shares conferring to a right to vote at the meeting being shares on which an
aggregate sum has been paid up equal to not less than one tenth of the total sum paid up on all the shares conferring
that right;
and a demand by a person as proxy for a member shall be the same as a demand by the member.
57. Unless a poll is duly demanded a declaration by the chairman that a resolution had been carried unanimously, or
by a particular majority, or lost, or not carried by a particular majority and an entry to that effect in the minutes of the
meeting shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in
favour of or against the resolution.
5253
58. The demand for a poll may, before the poll is taken, be withdrawn but only with the consent of the chairman and
a demand so withdrawn shall not be taken to have invalidated the result of a show of hands declared before the demand
was made.
59. A poll shall be taken as the chairman directs and he may appoint scrutineers (who need not be members) and fix
a time and place for declaring the result of the poll. The result of the poll shall be deemed to be the resolution of the
meeting at which the poll was demanded.
60. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the chairman shall be entitled to a
casting vote in addition to any other vote he may have.
61. A poll demanded on the election of a chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll
demanded on any other question shall be taken either forthwith or at such time and place as the chairman directs not
being more than thirty days after the poll is demanded. The demand for a poll shall not prevent the continuance of a
meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll was demanded. If a poll is de-
manded before the declaration of the result of a show of hands and the demand is duly withdrawn, the meeting shall
continue as if the demand had not been made.
62. No notice need be given of a poll not taken forthwith if the time and place at which it is to be taken are announced
at the meeting at which it is demanded. In any other case at least seven clear days’ notice shall be given specifying the
time and place at which the poll is to be taken.
63. A resolution in writing executed by or on behalf of each member who would have been present shall be as effec-
tual as if it had been passed at a general meeting duly convened and held and may consist of several instruments in the
like form each executed by or on behalf of one or more members.
<i>Votes of membersi>
64. Subject to any right or restrictions attached to any shares, on a show of hands every member who (being an in-
dividual) is present in person (being a corporation) is present by a duly authorised representative, not being himself a
member entitled to vote, shall have one vote and on a poll every member shall have one vote for every share of which
he is the holder.
65. In the case of joint holders the vote of the senior who tenders a vote, whether a person or by proxy, shall be
accepted to the exclusion of the votes of other joint holders; and seniority shall be determined by the order in which
the names of the holders stand in the register of members.
66. A member in respect of whom an order has been made by any court having jurisdiction (whether in the Isle of
Man or elsewhere) in matters concerning mental disorder may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his
receiver, curator bonis or other person authorised in that behalf appointed by that court, and any such receiver, curator
bonis or other person may, on a poll, vote by proxy.
Evidence to the satisfaction of the Directors of the authority of the persons claiming to exercise the right to vote
shall be deposited at the office, or at such place as is specified in accordance with the Articles for the deposit of instru-
ments of proxy, not less than 48 hours before the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting at which
the right to vote is to be exercised and in default the right to vote shall not be exerciseable.
67. No member shall vote at any general meeting or at any separate meeting of the holders of any class of shares in
the Company, either in person or by proxy, in respect of any shares held by him unless all monies presently payable by
him in respect of that share have been paid.
68. No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the meeting or adjourned meeting at which
the vote objected to is tendered, and every vote not disallowed at the meeting shall be valid. Any objection made in due
time shall be referred to the chairman whose decision shall be final and conclusive.
69. On a poll votes may be given either personally or by proxy. A member may appoint more than one proxy to
attend on the same occasion.
70. An instrument appointing a proxy shall be in writing, executed by or on behalf of the appointed and shall be in
whatever form the Directors may approve.
71. The instrument appointing a proxy and any authority under which it is executed or a copy of such authority cer-
tified notarially or in some other way approved by the Directors may
(a) be deposited at the office or at such other place as is specified in the notice convening the meeting or in any in-
strument of proxy sent out by the Company in relation to the meeting not less than 48 hours before the time for holding
the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote; or
(b) in the case of a poll taken more than 48 hours after it is demanded, be deposited as aforesaid after the poll had
been demanded and not less than 24 hours before the time appointed for taking the poll; or
(c) where the poll is not taken forthwith but it is taken not more than 48 hours after it was demanded, be delivered
at the meeting at which the poll was demanded to the chairman of to the Secretary or to any Director;
and an instrument of proxy which is not deposited or delivered in a manner so permitted shall be invalid.
72. A vote given or poll demanded by proxy or by the duly authorised representative of the corporation shall be valid
notwithstanding the previous determination of the authority of the person voting or demanding a poll unless notice of
the determination was received by the Company at the office or at such other place at which the instrument of proxy
was duly deposited before the commencement of the meeting or adjourned meeting at which the vote is given or the
poll demanded or (in the case of a poll taken otherwise than on the same day as the meeting or adjourned meeting) the
time appointed for taking the poll.
73. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous
death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed,
or the transfer of the Shares in respect of which the proxy was given, provided that no intimation in writing of such
5254
death, insanity, revocation or transfer, as aforesaid shall have been received by the Company at the registered office
before the commencement of the Meeting or adjourned Meeting at which the proxy is used.
<i>Directorsi>
74. The names of the first Directors shall be determined in writing by a majority of the subscribers of the Memoran-
dum of Association. Unless and until otherwise determined by ordinary resolution, the number of Directors (other than
Alternate Directors) shall not be less than two and shall not be subject to any maximum.
<i>Alternate Directorsi>
75. Any Director (other than an Alternate Director) may appoint any other Director, or any person approved by
resolution of the Directors and willing to act, to be an Alternate Director and may remove from office an Alternate
Director so appointed by him.
76. An Alternate Director shall be entitled to receive notice of all meetings of Directors and of all meetings of com-
mittees of Directors of which his appointer is a member, to attend and vote at any such meeting at which the Director
appointing him is not personally present, and generally to perform all the functions of his appointor as a Director in his
absence but shall not be entitled to receive any remuneration from the Company for his services as an Alternate Direc-
tor. But it shall not be necessary to give notice of such a meeting to an Alternate Director who is absent from the Isle
of Man.
77. An Alternate Director shall cease to be an Alternate Director if his appointer ceases to be a Director; but, if a
Director retires by rotation or otherwise but is reappointed or deemed to have been reappointed at the meeting at
which he retires, any appointment of an Alternate Director made by him which was in force immediately prior to his
retirement shall continue after his reappointment.
78. Any appointment or removal of an Alternate Director shall be by notice to the Company signed by the Director
making or revoking the appointment or in any other manner approved by the Directors.
79. Save as otherwise approved in the Articles, an Alternate Director shall be deemed for all purposes to be a Di-
rector and shall alone be responsible for his own acts and defaults and he shall not be deemed to be the agent of the
Director appointing him.
<i>Powers of Directorsi>
80. Subject to the provisions of the Act, the Memorandum and the Articles and to any directions given by special
resolution, the business of the Company shall be managed by the Directors who may exercise all the powers of the
Company. No alteration of the Memorandum and Articles and no such director shall invalidate any prior act of the Di-
rectors which would have been valid if that alteration had not been made or that direction had not been given. The
powers given by this regulation shall not be limited by any special powers given to the Directors by the Articles and a
meeting of Directors at which a quorum is present may exercise all powers exerciseable by the Directors.
81. The Directors may from time to time at their discretion, raise or borrow, without the consent of the members
in General Meeting, such sum or sums of money for the purposes of the Company’s business as they may think fit and
may secure the repayment of or raise any such sum or sums as aforesaid in such manner and upon such terms and con-
ditions and in all other respects as they may think fit, and in particular by mortgages, deeds of bond and security, or
other charges upon the whole or any part of the property and assets of the Company present or future, including un-
called capital, or by issue, at such price as they may think fit, of bonds or debentures or debenture stock of the Company,
either charged upon the whole of any part of the property and assets of the Company, or not so charged, or in any
other way that the Directors may think expedient, and the Directors may issue debentures, or debenture stock or paid-
up shares to any person or persons as consideration for the purchase of any goodwill, business or property purchases
by the Company.
<i>Delegation of Directors’ powersi>
82. The Director may from time to time, and at any time.
(a) by power of attorney or otherwise, appoint any person to be the agent of the Company for such purposes and
on such conditions as they determine, including authority for the agent to delegate all or any of his powers;
(b) delegate any of their powers to any committee consisting of one or more Directors;
(c) provide through Local Boards, Attorneys or Agencies for the management of the affairs of the Company abroad,
and may appoint any persons to be members of such Local Boards or as Attorneys or Agents, and may remove any
persons so appointed and appoint others in their place, and may fix their remuneration.
(d) Delegate to any such Local Board, Attorney or Agent any of the powers authorities and discretions for the time
being vested in the Directors, and any such delegation may be made on such terms and subject to such conditions as
the Directors may think fit, and may include a power to subdelegate, and the Directors may at any time annul or vary
any such delegation, but no person dealing in good faith and without notice of such annulment or variation shall be ef-
fected thereby;
(e) Delegate to any Managing Director or any Director holding any other executive office such of their powers as
they consider desirable to be exercised by him.
Any such delegation may be subject to any conditions the Directors may impose, and either collaterally with or to
the exclusion of their own powers and may be revoked or altered. Subject to any such conditions, the proceedings of
a Local Board committee with two or more members shall be governed by the Articles regulating the proceedings of
Directors so far as they are capable of applying.
<i>Appointment and retirement of Directorsi>
83. No person shall be appointed a Director at any general meeting unless.
(a) he is recommended by the Directors; and
5255
(b) not less than fourteen nor more that thirty-five clear days before the date appointed for the meeting, notice ex-
ecuted by a member qualified to vote at the meeting has been given to the Company of the intention to propose that
person for appointment stating the particulars which would, if he were so appointed, be required to be included in the
Company’s register of Directors together with notice executed by that person of his willingness to be appointed.
84. Not less than seven nor more that twenty-eight clear days before the date appointed for holding a general meeting
notice shall be given to all who are entitled to receive notice of the meeting of any person who is recommended by the
Directors for appointment as a Director at the meeting or in respect of whom notice has been duly given to the Com-
pany of the intention to propose him at the meeting for appointment as a Director. The notice shall give the particulars
of that person which would, if he were so appointed, be required to be included in the Company’s register of Directors.
85. Subject to aforesaid, the Company may by ordinary resolution appoint a person who is willing to act to be a Di-
rector either to fill a vacancy or as an additional Director.
86. The Director may appoint a person who is willing to act to be a Director, either to fill a vacancy or as an additional
Director, provided that the appointment does not cause the number of Directors to exceed any number fixed by or in
accordance with the Articles as the maximum number of Directors. A Director so appointed shall hold office only until
the next following annual general meeting and shall be deemed to have been re-elected at that meeting unless at that
meeting it is expressly resolved that he should not be re-elected.
<i>Disqualification and removal of Directorsi>
87. The office of a Director shall be vacated if
(a) he ceases to be a Director by virtue of any provisions of the Act or he becomes prohibited by law from being a
Director; or
(b) he becomes bankrupt or makes any arrangements or composition with his creditors generally; or
(c) he is, or may be, suffering from mental disorder and either
(i) he is admitted to hospital pursuant of an application for admission for treatment under the Mental Health Act 1974,
or
(ii) an order is made by a court having jurisdiction (whether in the Isle of Man or elsewhere) in matters concerning
mental disorder for his detention or for the appointment of a receiver, curator bonis or other person to exercise pow-
ers with respect to his property or affairs; or
(d) he resigns his office by notice to the Company; or
(e) he shall for more than six consecutive months have been absent without permission of the Directors from meet-
ings of Directors held during that period and the Directors resolve that his office is vacated.
88. The Company may by Extraordinary Resolution remove any Director before the expiration of his period of office
notwithstanding anything in these regulations or in any agreement between the Company and such Director. Such re-
moval shall be without prejudice to any claim such Director may have for damages for breach of any contract of service
between him and the Company.
<i>Remuneration of Directorsi>
89. The Directors shall be entitled to such remuneration as the Company may by ordinary resolution determine and,
unless the resolution provides otherwise, the remuneration shall be deemed to accrue from day to day.
<i>Directors’ Expensesi>
90. The Directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by the in connection with
their attendance at meetings of the Directors or committees of Directors or general meetings or separate meetings of
the holders of any class of shares or of debentures of the Company or otherwise in connection with the discharge of
their duties.
91. Subject to the provisions of the Act, the Directors may appoint one or more of their number to the office of
Managing Director or to any other executive office under the Company and may enter into an agreement or arrange-
ment with any Director for his employment by the Company of for the provision by him of any services outside the
scope of the ordinary duties of Director. Any such appointment, agreement or arrangement may be made upon such
terms as the Directors may determine and they may remunerate such Director for his services as they think fit. Any
appointment of a Director to an executive office shall terminate if he ceases to be a Director but without prejudice to
any claim to damages for breach of contract of service between the Director and the Company.
92. Subject to the provisions of the Act, and provided that he had disclosed to the Directors the nature of any ma-
terial interest of his, a Director notwithstanding his office
(a) may be a party to, or otherwise interested in, any transaction or arrangement with the Company or in which the
Company is otherwise interested;
(b) may be a Director or other officer of, or employed by, or a party to any transaction or arrangement which, or
otherwise interested in, any body corporate promoted by the Company or in which the Company is otherwise inter-
ested; and
(c) shall not, by reason of his office, be accountable to the Company for any benefit which he derives from any such
office or employment or from any such transaction or arrangement or from any interest in any such body corporate
and no such transaction or arrangement shall be liable to be avoided on the ground of any such interest or benefit.
93. For the purposes of Article 93
(a) a general notice given to the Directors that a Director is to be regarded as having an interest of the nature and
extent specified in the notice in any transaction or arrangement in which a specified person or class of persons is inter-
ested shall be deemed to be a disclosure that the Director has an interest in any such transaction of the nature and
extent so specified; and
5256
(b) an interest of which a Director has no knowledge and of which it is unreasonable to expect him to have knowledge
shall not be treated as an interest of his.
<i>Directors’ gratuities and pensionsi>
94. Subject to the provisions of the Act, the Directors may provide benefits, whether by the payment of gratuities or
pensions or by insurance or otherwise, for any Director who has held but no longer holds executive office or employ-
ment with the Company or with any body corporate which is or has been a subsidiary of the Company or a predecessor
in business of the Company or of any such subsidiary, and for any member of his family (including a spouse and a former
partner) or any person who is or was dependent on him, and may (as well before as after he ceases to hold such office
or employment) contribute to any fund and pay premiums for the purchase or provision of any such benefit.
<i>Proceedings of Directorsi>
95. Subject to the provisions of the Articles, the Directors may regulate their proceedings as they think fit. A Director
may, and the Secretary at the request of a Director shall, call a meeting of the Directors. Questions arising at a meeting
shall be decided by a majority of votes. In the case of an equality of votes, the chairman shall have a second or casting
vote. A Director who is also an Alternative Director shall be entitled in the absence of his appointor to a separate vote
on behalf of his appointor in addition to his own vote.
96. Any Director or Member of a Committee of the Directors may participate in a Meeting of the Directors or such
Committee by means of conference telephone or similar telecommunications equipment whereby all persons partici-
pating can hear each other and participation in a Meeting in this manner shall be deemed to constitute presence in per-
son at such Meeting.
97. The quorum for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors and unless so fixed
at any other number shall be two. A person who holds office only as an Alternate Director shall, if his appointor is not
present, be counted in the quorum.
98. The continuing Directors or a sole continuing Director may act notwithstanding any vacancies in their number,
but, if the number of Directors is less than the number fixed as the quorum, the continuing Directors or Director may
act only for the purpose of filling the vacancies or of calling a general meeting.
99. The Directors may appoint one of their number to be the chairman of the Board of Directors and may at any
time remove him from that office. Unless he is willing to do so, the Director so appointed shall preside at every meeting
of Directors at which he is present. But if there is no Director holding that office, or if the Director holding it is unwilling
to preside or is not present within five minutes after the time appointed for the meeting, the Directors present may
appoint one of their number to be chairman of the meeting.
100. All acts done by a meeting of Directors, or of a committee of Directors, or by a person acting as a Director
shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was a defect in the appointment of any Director or
that any of them were disqualified from holding office, or had vacated office, or were not entitled to vote, be valid as if
every such person had been duly appointed and was qualified and had continued to be a Director and had been entitled
to vote.
101. A resolution in writing signed by all the Directors entitled to receive notice of a meeting of Directors or of a
committee of Directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of Directors or (as the case
may be) a committee of Directors duly convened and held and may consist of several documents in the like form each
signed by one or more Directors; but a resolution signed by an Alternate need not also be signed by his appointor and,
if it is signed by a Director who has appointed an Alternate Director, it need not be signed by the Alternate Director
in that capacity.
102. Save as otherwise provided by the Articles, a Director shall not vote at a meeting of Directors or of a committee
of Directors on any resolution concerning a matter in which he had, directly or indirectly, an interest or duty which is
material and which conflicts or may conflict with the interests of the Company unless he had declared the nature of his
interest in the manner required by Section 148 of the Act.
103. A Director shall not be counted in the quorum present at a meeting in relation to a resolution in which he is
not entitled to vote.
104. The Company may by ordinary resolution suspend or relax to any extent, either generally or in respect of any
particular matter, any provision of the Articles prohibiting a Director from voting at a meeting of Directors or of a com-
mittee of Directors.
105. Where proposals are under consideration concerning the appointment of two or more Directors to offices or
employments with the Company or any body corporate in which the Company is interested the proposals may be di-
vided and considered in relation to each Director separately and (provided he is not for another reason precluded from
voting) each of the Directors concerned shall be entitled to vote and be counted in the quorum in respect of each res-
olution except that concerning his own appointment.
106. If a question arises at a meeting of Directors or of committee of Directors as to the right of a Director to vote,
the question may, before the conclusion of the meeting, be referred to the chairman of the meeting and his ruling in
relation to any Director other than himself shall be final and conclusive.
<i>Management and controli>
107. The place of management and control of the businesses of the Company shall be determined by the Directors.
All meetings of Directors or any Local Boards, Attorneys, Agents or Agencies appointed under Article 82 hereof shall
be held accordingly.
5257
<i>Secretaryi>
108. Subject to the provisions of the Act, the Secretary shall be appointed by the Directors for such term, at such
remuneration and upon such conditions as they may think fit; and any Secretary so appointed may be removed by them.
<i>Minutesi>
109. The Directors shall cause minutes to be made in books kept for the purpose
(a) of all appointments of officers made by the Directors; and
(b) of all proceedings at meetings of the Company, of all holders of any class of shares in the Company, and of the
Directors, and of the committees of Directors, including the names of the Directors present at such meetings.
<i>The seali>
110. The seal shall only be used by the authority of the Directors or of a committee of Directors authorised by the
Directors. The Directors may determine who shall sign any instrument to which the seal is affixed and unless otherwise
so determined it shall be signed by a Director and by the Secretary or by a second Director.
<i>Facsimile sealsi>
111. The Company may have official seals for use under Section 32 of the Act and Section 2 of the Stock Exchange
(Completion of Bargains) (Isle of Man) Act 1979, where and as the Directors shall determine.
<i>Dividendsi>
112. Subject to the provision of the Act, the Company may be ordinary resolution declare dividends in accordance
with the respective rights of the members, but no dividend shall exceed the amount recommended by the Directors.
113. Subject to the provision of the Act, the Directors may pay interim dividends if it appears to them that they are
justified by the profits of the Company available for distribution. If the share capital is divided into different classes, the
Directors may pay interim dividends on shares which confer deferred or non-preferred rights with regard to dividend
as well as on shares which confer preferential rights with regards to dividends, but no interim dividend shall be paid on
shares carrying deferred or non-preferred rights if, at the time of payment, any preferential dividend is in arrears. The
Directors may also pay at intervals settled by them any dividend payable at a fixed rate if it appears to them that the
profits available for distribution justify the payment. Provided that the Directors act in good faith they shall not incur
any liability to the holders of the shares conferring preferred rights for any loss they may suffer by the lawful payment
of an interim dividend on any shares having deferred or non-preferred rights.
114. Except as otherwise provided by the rights attached to shares, all dividends shall be declared and paid according
to the amounts paid up on the shares on which the dividend is paid. All dividends shall be apportioned and paid propor-
tionately to the amount paid up on the shares during any portion or portions of the period in respect of which the
dividend is paid; but, if any share is issued on terms providing that it shall rank dividend as from a particular date, the
share shall rank for dividend accordingly.
115. A general meeting declaring a dividend may, upon recommendation of the Directors, direct that it shall be sat-
isfied wholly or partly by the distribution of assets and, where any difficulty arises in regard to the distribution, the Di-
rectors may settle the same and in particular may issue fractional certificates and fix the value for distribution of any
assets and may determine that cash shall be paid to any member upon the footing value so fixed in order to adjust the
rights of members and may vest any assets in trustees.
116. Any dividend or other monies payable in respect of a share may be paid by cheque sent by post to the registered
address of the person entitled or if two or more persons are the holders of the share or are jointly entitled to it by
reason of death or bankruptcy of the holder, to the registered address of one of those persons who is first named in
the register of members or to such person and to such address as the person or persons entitled may in writing direct.
Every cheque shall be made payable to the order of the person or persons entitled or to such other person as the person
or persons entitled may in writing direct and payment of the cheque shall be in good discharge of the Company. Any
joint holder or other person jointly entitled to a share as aforesaid may give receipts for any dividend or other monies
payable in respect of the share.
117. No dividend or other monies payable in respect of a share shall bear interest against the Company unless oth-
erwise provided by the rights attached to the share.
118. Any dividend which has remained unclaimed for twelve years from the date when it became due for payment
shall, if the Directors so resolve, be forfeited and cease to remain owing by the Company.
<i>Accountsi>
119. No member shall (as such) have any right of inspecting any accounting records or other books or document of
the Company except as conferred by statute or authorised by the Directors or by ordinary resolution of the Company.
120. For so long as the Company is a Private Company and fulfils the requirements of the Companies (Exempt and
Non Resident Private Companies) (Audit Exemption) Regulations 1993 or the Companies (Exempt and Non-Resident
Private Companies) (Audit Exemption) (Amendment) Regulations 1994 the company shall be exempt from the require-
ments of the Companies Acts 1931 to 1993 which relate to the audit of accounts of the companies to the extent per-
mitted by those Regulations and as they may be amended from time to time.
<i>Capitalisation of profitsi>
121. The Directors may with the authority of an ordinary resolution of the Company
(a) subject as hereinafter provided, resolve to capitalise any undivided profits of the Company not required for paying
any preferential dividend (whether or not they are available for distribution) or any sum standing to the credit of the
Company’s share premium account or capital redemption reserve;
5258
(b) appropriate the sum resolved to be capitalised to the members who would have been entitled to it if it were
distributed by way of dividend and in the same proportions and apply such sums on their behalf either in or towards
paying up the amounts, if any, for the time being unpaid on any shares held by them respectively, or on paying up in full
unissued shares or debentures of the Company of a nominal amount, equal to that sum, and allot the shares or deben-
tures credited as fully paid to those members, or as they may direct, in those proportions, or partly in one way and
partly in the other, but the share premium account, the capital redemption reserve, and any profits which are not avail-
able for distribution may, for the purposes of this regulation, only be applied in paying up unissued shares to be allotted
to members credited as fully paid;
(c) make such provision by the issue of fractional certificates or by payment in cash or otherwise as they determine
in the case of shares or debentures becoming distributable under this regulation in factions; and
(d) authorise any person to enter on behalf of all the members concerned into an agreement with the Company pro-
viding for the allotment to them respectively, credited as fully paid, of any share or debentures to which they are entitled
upon such capitalisation, any agreement made under such authority being binding on all such members.
<i>Noticesi>
122. Any notice to be given to or by any person pursuant to the Articles shall be in writing except that a notice calling
a meeting of the Directors need not be in writing.
123. The Company may give any notice to a member either personally or by sending it by post in a prepaid envelope
addressed to the member at his registered address or by leaving it at that address. In the case of joint holders of a share,
all notices shall be given to the joint holder whose name stands first in the register of members in respect of the joint
holding and notice so given shall be sufficient notice to all the joint holders. A member whose registered address is not
within the British Islands and who gives to the Company an address within the British Islands at which notice may be
given to him shall be entitled to have notices given to him at that address, but otherwise no such member shall be en-
titled to receive any notice from the Company.
124. A member present, either in person or by proxy, at any meeting of the Company or of the holders of any class
of shares in the Company shall be deemed to have received notice of the meeting and, where requisite, of the purposes
for which it was called.
125. Every person who becomes entitled to a share shall be bound by any notice in respect of that share which, before
his name is entered in the register of members, has been duly given to a person from whom he derives his title.
126. Proof that an envelope containing a notice was properly addressed, prepaid and posted shall be conclusive evi-
dence that the notice was given. A notice shall be deemed to be given at the expiration of 48 hours after the envelope
containing it was posted.
127. A notice may be given by the Company to the persons entitled to a share in consequence of the death or bank-
ruptcy of a member by sending or delivering it, in any manner authorised by the Articles for the giving of notice to a
member, addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or trustee of the bankrupt or
by any like description at the address, if any, within the British Islands supplied for that purpose by the persons claiming
to be so entitled. Until such an address has been supplied, a notice may be given in any manner in which it might have
been given if the death or bankruptcy had not occurred.
128. If the Company is wound up, the liquidator may, with the sanction of an extraordinary resolution of the Com-
pany and any other sanction required by the Act, divide among the members in specie the whole or any part of the
assets of the Company and may, for that purpose, value any assets and determine how the division shall be carried out
as between the members of different classes of members. The liquidator may, with the like sanction, vest the whole or
part of the assets in trustees upon such trusts for the benefit of the members as he with the like sanction determines,
but no member shall be compelled to accept any assets upon which there is a liability.
<i>Indemnityi>
129. Subject to the provisions of the Act but without prejudice to any indemnity to which a Director may otherwise
be entitled, every Director or other officer or auditor of the Company shall be indemnified out of assets of the Company
against any liability incurred by him in defending any proceedings, whether civil or criminal, in which judgement is given
in his favour or in which he is acquitted or in connection with any application in which relief is granted to him by the
court from liability for negligence, default, breach of duty or breach of trust in relation to the affairs of the Company.
Dated this 15th day of October 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00891. – Reçu 66 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002584.2//656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Name and Address of Subscribers
Signature
Timothy Peter Leeming, 38 Selborne Drive, Douglas, Isle of Man, IM2 3NH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature
Laurence Anthony New, Enner Der Haerdchen, L-6170 Godbrange, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature
Paul Reilly, Enner Der Haerdchen, L-6170 Godbrange, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signature
J. Newman
<i>Witness to the above signaturesi>
5259
ALIMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.022.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01386, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002447.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
ALIMAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.022.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2003i>
Les comptes clôturés au 31 décembre 2002 ont été approuvés.
Décharge a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’au
31 décembre 2002.
Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A., Jean Lambert viennent à échéance lors de cette
assemblée générale annuelle.
Tous les titulaires se représentent à vos suffrages. Les mandats d’administrateurs de Caroline Folmer, EDIFAC S.A.,
Jean Lambert sont reconduits jusqu’à l’Assemblée Générale qui se tiendra en l’année 2005.
Le mandat de commissaire aux comptes de TRUSTAUDIT S.A. vient à échéance lors de cette assemblée générale
annuelle.
Le titulaire se représente à vos suffrages. Le mandat de TRUSTAUDIT S.A., commissaire aux comptes est reconduit
jusqu’à l’assemblée générale qui se tiendra en l’année 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01384. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002452.3/1022/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
M.E.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 28, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 81.457.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01202, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
(002515.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
M.E.M. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 28, rue de Bragance.
R. C. Luxembourg B 81.457.
—
<i>Extrait sincère et conforme du procès-verbal de l’assemblée générale tenue à Luxembourg, le 24 décembre 2003i>
<i>Résolutionsi>
<i>Première résolutioni>
L’assemblée des actionnaires prend note de la démission de la société GOLDEN SCREEN, S.à r.l. de ses mandats
d’administrateur et d’administrateur-délégué, et lui donne décharge pleine et entière pour l’exercice de ses mandats de
la date de sa nomination à ce jour.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Extrait sincère et conforme
ALIMAR S.A.
Signature
Extrait sincère et conforme
ALIMAR S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS
Signature
5260
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée des actionnaires nomme Monsieur Daniel Schwall comme administrateur et administrateur-délégué.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01208. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002503.3/592/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
EUROINVEST (HUNGARY 3), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.929.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01662, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002502.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
EUROINVEST (POLAND 1), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.930.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01666, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002505.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG I, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.784.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01673, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 6 janvier 2004.
(002508.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
FONDATION STE-GERTRUDE
Siège social: L-2449 Luxembourg, 11, boulevard Royal.
—
<i>Compte financier au 31 decembre 2001 (euros)i>
BILAN
<i>Actifi>
<i>Passifi>
<i>Pour la société
i>Signature
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signatures.
Luxembourg, le 5 janvier 2004.
Signatures.
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
Obligations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429.306,69
Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
656.991,44
Fonds de Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.544,42
Alternatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112.239,49
Liquidités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
615,15
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.237.697,10
Réserve au 31 décembre 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.429.645,30
Résultat négatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191.957,20
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.237.697,10
5261
RESULTATS
BUDGET 2002
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01596. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002509.2//35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.786.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01678, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 6 janvier 2004.
(002511.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
BUKKURAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 74.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00925, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002620.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
BUKKURAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 74.892.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00930, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
(002616.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
<i>Créditi>
<i>Débiti>
1) Pertes sur portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110.239,83
2) Dividendes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.947,31
3) Frais banque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.601,52
4) Subsides hopital Kapolowé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.123,55
5) Retraits de titres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46.441,48
6) Frais domiciliation et publication. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.516,04
7) Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.017,91
8) Résultat négatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.957,20
Totaux: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239.922,42 239.922,42
Actif: Revenu du portefeuille (3%) 1.237.697,10 x 3% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37.130,91
Passif: Mensualités hopital Kapolowé: 12 x 5.701,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68.418,60
Déficit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.287,69
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
<i>Pour BUKKURAM S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia-Hengel / C. Day-Royemans
<i>Pour BUKKURAM S.A., Société Anonyme
i>EXPERTA LUXEMBOURG, Société Anonyme
A. Garcia Hengel / C. Day-Royemans
5262
WORLD ENERGY PROGRAM S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 95.084.
—
Conformément à la législation régissant la domiciliation des sociétés, la dénonciation, avec effet immédiat, de la con-
vention de domiciliation entre les sociétés:
FIDUCIAIRE LATITUDES, S.à r.l., 37, Val St. André, L-1128 Luxembourg, et
WORLD ENERGY PROGRAM S.A., 37, Val St. André, L-1128 Luxembourg est décidée.
La dénonciation du contrat de domiciliation a été notifiée en date du 31 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00711. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002216.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
COMPAGNIE DES GRANDS LACS, Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 79.060.
—
DISSOLUTION
L’an deux mille trois, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
La société COMPAGNIE INTERNATIONALE D’OUTREMER S.A. en abrégé INTEROUTREMER, ayant son siège so-
cial à L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen, R. C. S. Luxembourg n° B 20.702, ci-après «la Comparante»,
ici représentée par Madame Cécile Gadisseur, employée privée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxem-
bourg, 59, boulevard Royal,
en vertu d’une procuration sous seing privé, datée du 18 décembre 2003.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la représentante de la Comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle Comparante, représentée ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
1.- Que la société anonyme COMPAGNIE DES GRANDS LACS, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B,
boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le
numéro 79.060, ci-après «la Société», a été constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à
Junglinster, en date du 17 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 436 du
13 juin 2001.
2.- Que le capital social de la Société s’élève actuellement à EUR 50.000,- (cinquante mille euros) représenté par 100
(cent) actions d’une valeur nominale de EUR 500,- (cinq cents euros) chacune, entièrement libérées.
3.- Que la Comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la Société.
4.- Qu’en tant que seule actionnaire la Comparante déclare expressément vouloir dissoudre et liquider la Société,
celle-ci ayant cessé toute activité.
5.- Que la Comparante connaît parfaitement la situation financière et les statuts de la Société.
6.- Que la Comparante donne décharge expresse aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour leur man-
dat jusqu’à ce jour.
7.- Que la Comparante, actionnaire unique, se considérant comme liquidateur déclare avoir réglé ou provisionné tout
le passif de la Société et répondra personnellement de tout le passif social et de tous les engagements de la Société,
même inconnus à ce jour.
8.- Que partant, la dissolution et la liquidation de la Société sont achevées.
9.- Qu’il y a lieu de procéder à l’annulation des actions émises.
10.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la So-
ciété.
Pour les publications et dépôts à faire tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée en une langue d’elle connue à la représentante de la Comparante, con-
nue du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Gadisseur, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 83, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(002404.3/222/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
<i>Pour le domiciliataire
i>J.-M. Wohl
<i>Géranti>
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 janvier 2004.
T. Metzler.
5263
ZIPPY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.219.
—
L’an deux mille trois, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding ZIPPY S.A., avec siège
social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 12 février 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 285 du 9 juin 1997, dont les
statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 1
er
avril 1999, publié au Mémorial C,
numéro 488 du 25 juin 1999, et modifiés suivant assemblée générale extraordinaire sous seing privé portant notamment
conversion du capital en euros, du 6 mai 2002, publiée par extrait au Mémorial C, numéro 1383 du 24 septembre 2002,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 58.219.
<i>Bureaui>
La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Sandro Capuzzo, employé privé, demeurant
professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Nathalie Schroeder, employée privée, demeurant
professionnellement à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Isabelle Bressan, employée privée, demeurant professionnelle-
ment à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
<i>Composition de l’assembléei>
Il existe actuellement 800 (huit cents) actions, d’une valeur nominale de EUR 512,- (cinq cent douze euros) chacune,
entièrement souscrites et libérées et représentant l’intégralité du capital social de EUR 409.600,- (quatre cent neuf mille
six cents euros).
Les noms des actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun
d’eux ont été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux re-
présentés, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se
référer.
Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des
actionnaires représentés à la présente assemblée, signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instru-
mentant.
<i>Exposé de Monsieur le Présidenti>
Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Suppression de la valeur nominale des actions.
2. Augmentation du capital social de la société à concurrence de EUR 340.400,- pour le porter de son montant actuel
de EUR 409.600,- à EUR 750.000,- par la création de 664 actions nouvelles.
3. Souscription et libération par la société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. des 664 (six cent soixante-qua-
tre) nouvelles actions ainsi créées par incorporation d’une créance certaine, liquide et exigible de EUR 340.400,- (trois
cent quarante mille quatre cents euros).
4. Renonciation par LOUV, S.à r.l. à utiliser son droit préférentiel de souscription conformément à l’article 3 des sta-
tuts.
5. Remplacement des 1.464 (mille quatre cent soixante-quatre) actions sans mention de valeur nominale représenta-
tives du capital de la société par 7.500 (sept mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros)
chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 750.000,- (sept cent cinquante mille euros) représenté par 7.500 (sept mille
cinq cents) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.
6. Autorisation au Conseil d’Administration d’accomplir les modalités en rapport avec l’augmentation de capital, an-
nuler les anciennes actions et les remplacer par les nouvelles actions.
7. Annulation du capital autorisé existant et fixation d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 7.500.000,-
(sept millions cinq cent mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 750.000,- (sept cent
cinquante mille euros) à EUR 8.250.000,- (huit millions deux cent cinquante mille euros) et modification subséquente de
l’article 3 des statuts.
8. Autorisation au Conseil d’Administration de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription lors des
augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.
9. Divers.
II.- L’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée générale, il a pu être fait abs-
traction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et dé-
clarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
5264
<i>Constatation de la validité de l’assembléei>
L’exposé de Monsieur le Président, après vérification par le scrutateur, est reconnu exact par l’assemblée. Celle-ci se
considère comme valablement constituée et apte à délibérer sur les points à l’ordre du jour.
Monsieur le Président expose les raisons qui ont motivé les points à l’ordre du jour.
<i>Résolutionsi>
L’assemblée aborde l’ordre du jour et, après avoir délibéré, elle prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 340.400,- (trois cent quarante mille
quatre cents euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 409.600,- (quatre cent neuf mille six cents euros) à
EUR 750.000,- (sept cent cinquante mille euros) représenté par les 800 (huit cents) actions existantes et par l’émission
de 664 (six cent soixante-quatre) nouvelles actions sans valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.
<i>Souscription et libérationi>
Le Président rappelle que les sociétés SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A. et LOUV, S.à r.l., sont les deux seu-
les actionnaires de la Société.
1.- Est à l’instant intervenue:
- La société SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 23, avenue Mon-
terey (R. C. S. Luxembourg B 65.906),
dûment représentée par Mademoiselle Isabelle Bressan, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 3 décembre 2003.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
Mademoiselle Isabelle Bressan, prénommée, déclare souscrire au nom et pour le compte de la prénommée société
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A., aux 664 (six cent soixante-quatre) actions nouvellement émises de la So-
ciété, et libérer entièrement ces actions nouvelles par un apport à hauteur de EUR 340.400,- (trois cent quarante mille
quatre cents euros) de partie d’une créance certaine, liquide et exigible due par la Société à la société SERVICES GE-
NERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée, et consistant en une partie de l’avance accordée par l’actionnaire, SERVICES
GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée, figurant au passif des comptes provisoires de la société au 31 octobre
2003, ce qui entraîne l’annulation de la créance à concurrence du montant apporté.
Une copie du bilan provisoire au 31 octobre 2003 ainsi qu’une attestation datée du 15 décembre 2003, attestant que
le montant du compte actionnaire n’a pas diminué depuis le 31 octobre 2003, après avoir été signées ne varietur par les
membres du bureau et par le notaire resteront annexées au présent acte et seront soumises avec lui aux formalités
d’enregistrement.
La mandataire a exposé que conformément aux dispositions des articles 26-1 et 32-1 (5) de la Loi Luxembourgeoise
sur les Sociétés Commerciales, un rapport d’évaluation a été établi le 9 décembre 2003 par Monsieur Jean Bernard Zei-
met, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, dans lequel
la créance ainsi apportée a été décrite et évaluée.
La mandataire a produit le rapport dont la conclusion est la suivante:
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la
valeur de l’apport qui correspond au moins à la valeur nominale de l’augmentation de capital de 340.400 EUR et aux 664
actions nouvelles à émettre.»
Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par les membres du bureau et par le notaire restera annexé au présent
acte et sera soumis avec lui aux formalités d’enregistrement.
En contrepartie de cet apport, la Société émettra 664 (six cent soixante-quatre) nouvelles actions sans mention de
valeur nominale.
2.- Intervient maintenant la société à responsabilité limitée LOUV, S.à r.l., ayant son siège social à L-2086 Luxembourg,
23, avenue Monterey (R. C. S. Luxembourg B 89.272),
dûment représentée par Mademoiselle Isabelle Bressan, prénommée,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 3 décembre 2003.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
Mademoiselle Isabelle Bressan, prénommée, déclare renoncer au nom de la société LOUV, S.à r.l., préqualifiée, à
l’exercice du droit de souscription préférentiel relatif à la souscription des 664 (six cent soixante-quatre) actions nou-
vellement émises.
Sur quoi l’assemblée générale décide d’accepter lesdits souscription et paiement et d’émettre et d’attribuer les 664
(six cent soixante-quatre) nouvelles actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées à la société SERVI-
CES GENERAUX DE GESTION S.A., préqualifiée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée générale décide de remplacer les 1.464 (mille quatre cent soixante-quatre) actions sans mention de va-
leur nominale représentatives du capital de la société par 7.500 (sept mille cinq cents) actions d’une valeur nominale de
5265
EUR 100,- (cent euros) chacune. Le capital est désormais fixé à EUR 750.000,- (sept cent cinquante mille euros) repré-
senté par 7.500 (sept mille cinq cents) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune.
L’assemblée générale décide d’autoriser le Conseil d’Administration à accomplir toutes les modalités en rapport avec
l’augmentation du capital social, à annuler les anciennes actions et à les remplacer par de nouvelles actions.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale prend acte de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 28 novembre 2003, pro-
posant la création d’un capital autorisé à concurrence de EUR 7.500.000,- (sept millions cinq cent mille euros) pour
porter le capital social de son montant actuel de EUR 750.000,- (sept cent cinquante mille euros) à EUR 8.250.000,- (huit
millions deux cent cinquante mille euros) par la création de 75.000 (soixante-quinze mille) actions d’une valeur nominale
de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes, et d’autoriser le
Conseil d’Administration à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants dans
le cadre dudit capital autorisé.
Une copie dudit procès-verbal après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumen-
tant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale constate que le capital autorisé existant n’est plus valable.
L’assemblée générale approuve la création d’un nouveau capital autorisé à concurrence de EUR 7.500.000,- (sept mil-
lions cinq cent mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 750.000,- (sept cent cinquante
mille euros) à EUR 8.250.000,- (huit millions deux cent cinquante mille euros) par la création de 75.000 (soixante-quinze
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes, et décide de déléguer au Conseil d’Administration de la Société le pouvoir d’augmenter le capital
social de la Société dans les limites dudit capital autorisé.
<i>Sixième résolutioni>
L’assemblée générale autorise le Conseil d’Administration à limiter ou à supprimer le droit préférentiel de souscrip-
tion lors des augmentations de capital réalisées dans le cadre du capital autorisé.
<i>Septième résolutioni>
Suite aux résolutions qui précèdent l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts, pour lui donner la
teneur suivante:
«Le capital social est fixé à EUR 750.000,- (sept cent cinquante mille euros) représenté par 7.500 (sept mille cinq
cents) actions de EUR 100,- (cent euros) chacune, toutes intégralement libérées. Ces actions sont rachetables selon les
dispositions de l’article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales.
Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social initial à concurrence de EUR 7.500.000,- (sept
millions cinq cent mille euros) pour porter le capital social de son montant actuel de EUR 750.000,- (sept cent cinquante
mille euros) à EUR 8.250.000,- (huit millions deux cent cinquante mille euros) par la création de 75.000 (soixante-quinze
mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes, pour une période de cinq ans prenant cours à la date de publication au Mémorial de l’acte insérant
le capital autorisé.
En conséquence, il est autorisé à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles
éventuelles en une ou plusieurs fois et par tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions
partielles éventuelles, à déterminer les conditions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de
nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même
non spécialement prévues en la présente résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions
nouvelles, la libération et les augmentations effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les
modifications dérivant de l’augmentation de capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée
du 10 août 1915, notamment avec la condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
Sous respect des conditions ci-avant stipulées et par dérogation à l’article 12 ci-après, le Conseil d’Administration est
autorisé à augmenter le capital social, même par incorporation des réserves libres.
De même, le Conseil d’Administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles ou non sous
forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que
ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital auto-
risé.
Le Conseil d’Administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Le Conseil d’Administration a l’autorisation de supprimer ou de limiter le droit de souscription préférentiel lors d’une
augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé. Le capital autorisé et le capital souscrit pourront
être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires statuant comme en ma-
tière de modifications des statuts.»
<i>Clôturei>
Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
5266
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul
préjudice à la somme de EUR 5.100,- (cinq mille cent euros).
Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous
connus du notaire instrumentant par noms, prénoms usuels, états et demeures, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous Notaire, aucun actionnaire n’ayant demandé à signer.
Signé: Capuzzo, Schroeder, Bressan, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 2003, vol. 141S, fol. 83, case 5. – Reçu 3.404 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(002451.3/222/199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
ZIPPY S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 58.219.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002454.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
FINANCIERE DE L’AVENIR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R. C. Luxembourg B 51.388.
—
Messieurs Jean-Louis Prevost et Jean-Louis Olivaux démissionnent de leur mandat d’administrateur avec effet immé-
diat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 janvier 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01206. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002506.3/592/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
MARGIN FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 67, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 15.294.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00354, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002513.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
FELTON S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 38.354.
—
Le siège de la société FELTON S.A. a été dénoncé avec effet immédiat.
Luxembourg, le 18 novembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05165. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(002518.2//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 janvier 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 janvier 2004.
T. Metzler.
<i>Pour la société
i>FIDUCIAIRE WEBER ET BONTEMPS, S.à r.l.
Signature
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
Signature.
FELTON S.A.
M
e
R. Reichling
5267
ILS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 19.079.
—
<i>Extrait des principales résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale Ordinairei>
<i>tenue de manière Extraordinaire au siège social, le 18 novembre 2003 à 17.00 heuresi>
A l’unanimité, il a été décidé de transférer le siège social du 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg au 11B,
boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg avec effet au 1
er
décembre 2003.
Les lettres de démission des administrateurs ont été acceptées et bonne et valable décharge pour l’exercice de leur
mandat jusqu’à ce jour est donnée.
Ces administrateurs sont:
- Michèle Eisenhuth,
- Guy Harles,
- Paul Mousel.
En remplacement des administrateurs démissionnaires sont nommés:
- Claude Alvisse,
- Patrick Sganzerla,
- Steeve Simonetti.
A l’unanimité, il a été décidé de révoquer le commissaire aux comptes en place, à savoir Monsieur Michel Federspiel,
et de nommer en son remplacement, Monsieur Christian Billon, FIDUCIAIRE BILLON, S.à r.l.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 2003, réf. LSO-AL06016. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002461.3/850/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
AGSI, AGENCE GENERALE ET SERVICE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3316 Bergem, 3, rue de Schifflange.
R. C. Luxembourg B 63.005.
—
L’an deux mille trois, le cinq décembre.
Par-devant Maître Urbain Tholl, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme AGSI, AGENCE GENERALE ET SERVICE
D’INVESTISSEMENT S.A., ayant son siège social à L-8077 Bertrange, 83A, rue de Luxembourg,
Constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Norbert Muller, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date
du 3 février 1998, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C page 15604 de 1998 et dont les statuts
ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois aux termes d’un acte reçu par le notaire soussigné en date
du 15 septembre 2003, en cours de publication au Mémorial,
Inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro L B 63.005.
L’assemblée est présidée par Monsieur Ernest Krier, employé privé, demeurant à L-5671 Altwies, 12, route de Fils-
dorf,
qui désigne comme secrétaire Madame Christine Noël, clerc de notaire, demeurant à B-Morhet.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Ernest Saksida, employé privé, demeurant à L-5653 Mondorf, 1, rue des
Rosiers.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents et/ou représentés ainsi que le nombre des actions qu’ils détiennent sont renseignés sur
une liste de présence, signée par le bureau de l’assemblée et le notaire instrumentant.
La liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
II.- Il résulte de la liste de présence que cinquante (50) actions représentant la moitié du capital social sont présentes
ou représentées à l’assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur l’ordre
du jour, objet des présentes.
III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
Transfert du siège social
L’assemblée, ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Unique résolution i>
L’assemblée décide de transférer le siège de Bertrange à L-3316 Bergem, 3, rue de Schifflange. En conséquence, la
première phrase de l’article 4 des statuts est supprimée et remplacée par la suivante:
«Le siège social est établi à Bergem.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.
Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour ILS HOLDING S.A.
i>P. Sganzerla
<i>Expert-Comptablei>
5268
<i>Frais i>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef des présentes à environ huit cent vingt (
€ 820,-) euros.
Dont acte, fait et passé à Mersch, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et de-
meures ils ont signé les présentes avec le notaire.
Signé: Krier, Noël, Saksida, U. Tholl.
Enregistré à Mersch, le 9 décembre 2003, vol. 426, fol. 11, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002336.3/232/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
AGSI, AGENCE GENERALE ET SERVICE D’INVESTISSEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3316 Bergem, 3, rue de Schifflange.
R. C. Luxembourg B 63.005.
—
Statuts coordonnés suivant acte du 5 décembre 2003, reçu par M
e
Urbain Tholl, de résidence à Mersch, déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002338.3/232/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
GSC EUROPEAN MEZZANINE LUXEMBOURG III, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 86.739.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01679, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 6 janvier 2004.
(002514.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
F.M. AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3324 Bivange, 2, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 67.807.
—
L’an deux mille trois, le dix-sept décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur José Miguel Ferreira Borges Pedroso, employé privé, demeurant à L-3324 Bivange, 2, rue Edward Steichen.
Ce comparant a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:
I.- Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée F.M. AUTO, S.à r.l., ayant son siège social à
L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 23 décembre 1998,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 175 du 17 mars 1999, dont les statuts ont été mo-
difiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 31 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 395 du 12 mars
2002,
immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 67.807.
II.- Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400,-) représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-quatre euros (EUR 124,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant à l’associé unique
Monsieur José Miguel Ferreira Borges Pedroso, préqualifié.
III.- Monsieur José Miguel Ferreira Borges Pedroso, représentant comme seul et unique associé l’intégralité du capital
social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale extraordinaire, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège de la société de L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener à L-3324 Bivange,
2, rue Edward Steichen.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier le premier alinéa de l’article 2 des statuts de la
société pour lui donner la teneur suivante:
«Le siège de la société est établi à Bivange.»
Mersch, le 7 janvier 2004.
U. Tholl.
U. Tholl.
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
Signatures
5269
IV.- Le montant des frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimé sans nul préjudice à la somme de
six cents euros (EUR 600,-), est à charge de la société qui s’y oblige, l’associé unique en étant solidairement tenu envers
le notaire.
V.- Le comparant élit domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie, en l’Etude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant, connu du notaire instru-
mentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le Notaire.
Signé: Ferreira Borges Pedroso, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 décembre 2003, vol. 141S, fol. 72, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(002456.3/222/42) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
F.M. AUTO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3324 Bivange, 2, rue Edward Steichen.
R. C. Luxembourg B 67.807.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002458.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
MARSTRAND, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R. C. Luxembourg B 97.946.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the eighteen of December
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appears:
Mr Robert Andreen, company director, born in Gamlestad on February 5, 1943, residing at Strandvägen 37, SE-114
56 Stockholm, Sweden.
The founder is here represented by Mr Patrick Van Hees, residing at Luxembourg, by virtue of a proxy given under
private seal.
The beforesaid proxy, being initialled ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a «société à responsabilité limitée» which
its declares to incorporate.
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, including its article 209, of September 18th, 1933 and of December 28th, 1992 on «sociétés à
responsabilité limitée», as amended, and the present articles of incorporation.
At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following
shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercices the powers devolved to the General Meeting of sharehold-
ers.
Art. 2. The Company’s name is MARSTRAND, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,
industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participa-
tion, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents
and licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold,
manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit,
and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in fi-
nancial, commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any
other company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary,
in which the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow
and raise money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation
which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929, on
Holding Companies.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 janvier 2004.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 7 janvier 2004.
T. Metzler.
5270
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments
have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.
Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any shareholder.
Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
Capital - Shares
Art. 8. The Company’s capital is set at EUR 32,500.- (thirty-two thousand five hundred euro), represented by 650
(six hundred fifty) shares of EUR 50.- (fifty euro) each, distributed amongst the types and classes of shares as set out
below:
- 250 (two hundred fifty) ordinary shares, each of EUR 50.- (fifty euro), hereafter altogether referred to as the «Or-
dinary Shares»;
- 400 (four hundred) redeemable shares, each of EUR 50.- (fifty euro), hereafter altogether referred to as the «Pre-
ferred Shares», which are divided into 4 (four) classes of 100.- (one hundred) shares each.
Art. 9. Each share, either Ordinary Share or Preferred Share, confers an identical voting right and each shareholder
has voting rights commensurate to his shareholding. Each share shall rank pari passu with every other share and shall
entitle its owner to equal rights to any distribution of dividends.
Art. 10. The rights and preferences of the shares issued by the Company shall be the following:
The Ordinary Shares are non-redeemable shares.
The Preferred Shares are redeemable shares, at the option of the Company only under the terms and conditions
stipulated in the present clause, such as follows.
a) In the event the Company decides to exercise its option of redemption, it may not redeem part only of a specific
class of shares, but may only redeem all of the shares comprised into a class of shares, in their entirety.
b) The Company may only exercise the option to redeem a class of shares under the condition that at the time of
the redemption such as described below, the Company has made profits or holds reserves available for distribution ac-
cording to the approved annual accounts of the last closed financial year of the Company, or as the case may be accord-
ing to an interim balance-sheet of the Company drawn up on the date of the redemption.
c) Any class of redeemable shares may only be redeemed at the time and during the period, such as described below:
- The Class A Shares relates to the financial year ending on 31 December 2004 (hereafter referred to as «FY 1») and
may only be redeemed during a period starting on 1 July 2004 and ending on 31 December 2005;
- The Class B Shares relates to the financial year ending on 31 December 2005 (hereafter referred to as «FY 2»), and
may only be redeemed during a period starting on 1 July 2005 and ending on 31 December 2006;
- The Class C Shares relates to the financial year ending on 31 December 2006 (hereafter referred to as «FY 3»), and
may only be redeemed during a period starting on 1 July 2006 and ending on 31 December 2007;
- The Class D Shares relates to the financial year ending on 31 December 2007 (hereafter referred to as «FY 4»),
and may only be redeemed during a period starting on 1 July 2007 and ending on 31 December 2008;
d) In the case where a class of shares has not been redeemed for any reason, then the Company may opt for the
redemption of the same class of shares during the financial years subsequent to FY 5, and, in case of numerous classes
of shares not redeemed after FY 5, pursuant to the increasing order of the number of the classes of shares. Any class
of shares that has not been redeemed may, pursuant to this increasing order, be indefinitely redeemed, without any
limitation of time, until the option to redeem is finally exercised by the Company. Such second round redemption shall
occur pursuant to the same terms and conditions as the first round redemption, such as described in the present article
10, to the exception of sub-paragraph c) above.
e) The redemption shall be carried out by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders adopted at an
extraordinary general meeting at the unanimity of the shareholders as the case may be, upon proposal by the manager,
or in case of plurality of managers, by the board of managers.
5271
f) The redemption price per share (the «Share Redemption Price») shall be calculated as follows:
Where:
- The Share Nominal Value is the nominal value of each share of the Class of Shares redeemed at the time where the
option of redemption is exercised by the Company;
- The Distributable Sums are all distributable sums pursuant to the approved annual accounts of the financial year to
which the Class of Shares concerned relates, in the meaning of article 72-1 of the Law.
g) The interim redemption price per share (the «Interim Share Redemption Price») shall be calculated as follows:
Where:
- The Interim Share Nominal Value is the nominal value of each share of the Class of Shares redeemed at the time
where the option of redemption is exercised by the Company;
- The Interim Distributable Sums are the realised profits since the end of the last financial year preceding the one to
which the Class of Shares concerned is related to, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
the Articles, as resulting from the Interim Accounts.
h) Any redeemed shares shall be cancelled immediately as soon as they are received and owned by the Company,
and therefore the Company’s share capital shall be decreased accordingly.
i) Any amendment of any stipulations of the present article 10 as well as any amendment relating to articles 17 and
18 shall be carried out by a resolution of the sole shareholder or of the shareholders, adopted at the extraordinary
general meeting of the shareholders at the unanimity of all the shareholders.
Art. 11. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-members unless members representing at least three quarter of
the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.
Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 to the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Management
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any
time, with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be
present.
In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or
represented.
The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of
the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 13. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 14. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex an-
other manager as his proxy.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the
managers’ meeting.
In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, trans-
mitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications me-
dia.
Shareholders decisions
Art. 15. Shareholders decisions are taken by shareholder’s meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
Share Redemption Price = Share Nominal Value +
Distributable sums
Number of the shares in the Class of shares redeemed
Interim Share Redemption Price = Interim Share Nominal Value + Interim Distributable sums
Number of the shares in the Class of shares
redeemed
5272
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or
decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.
Art. 16. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to
a second meeting.
At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be
represented.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of share-
holders representing the three quarters of the capital.
Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section
XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.
Financial year - Balance sheet
Art. 17. The Company’s financial year begins on January 1st and closes on December 31st.
Art. 18. Each year, within 4 (four) months as from the 31st of December, the management will draw up the balance
sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accom-
panied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.
At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of shareholders together with the balance sheet.
Art. 19. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss
account.
Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charg-
es and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The balance is at the disposal of the shareholders.
The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-
termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred
to an extraordinary reserve.
Winding-up - Liquidation
Art. 21. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the
general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at
the pro-rata of their participation in the share capital of the company.
A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Applicable law
Art. 22. The laws here above mentioned in article 1st shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not
provide for the contrary.
<i>Transitory measuresi>
Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2004.
<i>Subscription - Paymenti>
All the 650 (six hundred fifty) shares representing the capital have been entirely subscribed by Mr Robert Andreen,
prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of EUR 32,500.- (thirty-two thousand five hundred euro) is
as now at the disposal of the Company MARSTRAND, S.à r.l., proof of which has been duly given to the notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- EUR.
<i>General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as manager for an undetermined duration
Mr Godfrey Abel, Private Employee, born in Brixworth on July 2, 1960, residing at 46A, avenue John f. Kennedy, L-
1855 Luxembourg;
In accordance with article twelve of the by-laws, the company shall be bound the sole signature of its single manager.
2) The Company shall have its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg
5273
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing
person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original
deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le dix-huit décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Comparaît:
Monsieur Robert Andreen, associé, né à Gamlestad, le 5 février 1943, résidant à Standvägen 37, SE-114 56 Stockholm,
Suède
Fondateur ici représenté par Monsieur Patrick Van Hees en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité limitée qu’il déclare
constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:
Dénomination - Siège - Objet - Durée
Art. 1
er
. Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois
luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, en ce
compris l’article 209, du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les
sociétés unipersonnelles, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.
A tout moment, un associé unique peut s’associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés
ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l’Assemblée Générale
des associés.
Art. 2. La dénomination de la société sera MARSTRAND, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans
toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d’acquérir par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d’actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d’assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d’octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d’une manière ou
d’une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt finan-
cier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d’emprunter et de lever des fonds de quelque manière
que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations gé-
néralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir toutefois bénéficier de la
loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le
siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.
La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l’étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de na-
ture à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec
l’étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration
de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
5274
Capital - parts sociales
Art. 8. Le capital social est fixé à EUR 32,500.- (trente-deux mille cinq cent euro), représenté par 650 (six cent cin-
quante) parts sociales entièrement souscrites, d’une valeur de EUR 50,- (cinquante euro) chacune, réparties en types et
classes de parts comme suit:
- 250 (deux cent cinquante) parts sociales ordinaires chacune de EUR 50.- (cinquante euro) ci-après mentionné com-
me les «Parts Sociales Ordinaires»;
- 400 (quatre cent) parts sociales rachetables, chacune de EUR 50,- (cinquante euro) ci-après mentionné comme les
«Parts Sociales Préférentielles», qui sont divisées en 4 (quatre) catégories de 100 (cent) parts sociales chacune.
Art. 9. Chaque part sociale, qu’elle soit Part Sociale Ordinaire ou Part Sociale Préférentielle, confère un droit de
vote identique lors des prise de décisions et chaque associé dispose d’un droit de vote proportionnel à sa participation
dans le capital. Chaque part sociale est de même rang que toute autre et conférera à son propriétaire des droits égaux
dans toute distribution de dividendes.
Art. 10. Les droits et les préférences des parts sociales souscrites par la Société seront établit comme suit:
Les Parts Sociales Ordinaires sont des parts non rachetables.
Les Parts Sociales Préférentielles sont des parts sociales rachetables à l’option de la Société, et seulement sous les
conditions générales stipulées dans la présente clause, à savoir.
a) Dans le cas où la Société décide d’exercer son option de rachat, elle ne peut pas racheter seulement une partie
spécifique d’une classe de parts sociales, mais peut seulement racheter toutes les parts sociales comprises dans une clas-
se de parts sociales, dans leur intégralité.
b) La Société ne peut exercer l’option de rachat d’une classe de parts sociales que si et seulement si, au moment du
rachat comme décrit ci-dessous, les comptes annuels approuvés du dernier exercice financier de la Société, ou, le cas
échéant, un bilan intérimaire de la Société établi à la date du rachat, établissent que la Société a fait des profits ou dispose
de réserves disponibles pour la distribution, d’un montant suffisant.
c) Quelle que soit la classe de Parts Sociales Préférentielles, elle ne peut être rachetée qu’au moment et durant les
périodes ci-après définies:
- Les Parts Sociales de classe A se rapportent à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2004 (ci-après men-
tionné comme «FY 1») et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1
er
juillet 2004 et se
terminant le 31 décembre 2005;
- Les Parts Sociales de classe B se rapportent à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2005 (ci-après men-
tionné comme «FY 2») et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1
er
juillet 2005 et se
terminant le 31 décembre 2006;
- Les Parts Sociales de classe C se rapportent à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2006 (ci-après men-
tionné comme «FY 3») et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1
er
juillet 2006 et se
terminant le 31 décembre 2007;
- Les Parts Sociales de classe D se rapportent à l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2007 (ci-après men-
tionné comme «FY 4») et peuvent seulement être rachetées pendant la période commençant le 1
er
juillet 2007 et se
terminant le 31 décembre 2008;
d) Au cas où, pour quelque raison que ce soit, une classe de parts sociales n’a pas été rachetée, la Société peut opter
pour le rachat de cette même classe de parts sociales pendant les exercices financiers ultérieurs à FY 5 et, en cas de
nombreuses classes de parts sociales non rachetées après FY 5, par ordre croissant des numéros des classes de parts
sociales. N’importe quelle classe de parts sociales qui n’a pas été rachetée peut, en respectant cet ordre croissant, être
indéfiniment rachetable, sans aucune limitation de temps, jusqu’à ce que l’option d’achat soit finalement exercée par la
Société. Un tel deuxième tour de rachat se déroulera conformément aux mêmes conditions générales que le premier
tour de rachat, comme décrit dans l’article présent 10, à l’exception de sous-paragraphe c) ci-dessus.
e) Le rachat sera effectué par une décision de l’associé unique ou à l’unanimité des associés adoptée lors d’une as-
semblée générale extraordinaire des associés suivant le cas, sur proposition du gérant, ou, en cas de pluralité de gérants,
par le conseil de gérance.
f) Le prix de rachat des parts sociales (le «Prix de rachat des Parts») sera calculé de la manière suivante:
Où:
- La Valeur nominale de la part correspond à la valeur nominale de chaque part de classe rachetable au moment de
l’exercice de l’option de rachat par la Société;
- Les sommes distribuables correspondent aux sommes distribuables sur base des comptes annuels approuvés de
l’exercice financier auquel se rapporte la classe d’action dans le sens de l’article 72-1 de la Loi.
g) Le prix intérimaire de rachat des parts sociales (le «Prix intérimaire de rachat des Parts») sera calculé de la manière
suivante:
- La valeur nominale intérimaire de rachat de part correspond à la valeur nominale de chaque part de classe rachetable
au moment de l’exercice de l’option de rachat par la Société;
Prix de rachat des Parts = valeur nominale de la part +
Sommes distribuables.
Nombre de parts dans la Classe de parts rachetée
Prix intérimaire de rachat des Parts = valeur nominale Intérimaire de la part + Sommes distribuables.
Nombre de parts dans la Classe
de parts rachetée
5275
- Les sommes intérimaires distribuables correspondent aux profits réalisés à compter de la clôture du dernier exer-
cice financier précédent celui auquel la classe d’action rachetable se rapporte, augmenté des profits à terme et réserves
distribuables, mais diminué des pertes à terme et sommes devant être allouées à une réserve devant être établi en con-
formité avec la Loi et les Articles comme résultant de comptes intérimaires.
h) Toute part rachetée sera immédiatement annulée aussitôt qu’elle aura été reçue et acquise par la Société, et dès
lors le capital social de la Société sera réduit d’autant.
i) Toute modification d’une quelconque stipulation du présent article 10 ainsi que toute modification relative aux ar-
ticles 17 et 18 sera décidée par résolution de l’associé unique ou adoptée lors d’une assemblée générale des associés à
l’unanimité de tous les associés.
Art. 11. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément donné
en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Gérance
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment,
avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de
la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La société sera engagée par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération
(s’il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants
sont présents.
Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 13. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, câble,
télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil de gérance.
Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie
circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.
Décisions des associés
Art. 15. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d’assemblées générales n’est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-
cinq.
Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément for-
mulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.
Art. 16. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés repré-
sentant plus de la moitié du capital social.
Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée
par lettre recommandée.
Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit
la portion du capital représenté.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des
associés représentant les trois quarts du capital social.
Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.
Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la section
XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
5276
Exercice social - Comptes annuels
Art. 17. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 18. Chaque année, endéans les 4 (quatre) mois suivant le 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra
l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé
tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 19. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 20. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le
bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.
Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans
le capital de la Société.
Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement
à sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.
Loi applicable
Art. 22. Les lois mentionnées à l’article 1
er
, ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application par-
tout où il n’est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2004.
<i>Souscription - Libérationi>
Les 650 (six cent cinquante) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites par
Monsieur Robert Andreen, prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte
que la somme de EUR 32.500,- (trente-deux mille cinq cent euro) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société,
ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ 1.500 EUR.
<i>Assemblée Généralei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée
Monsieur Godfrey Abel, employé privé, né le 2 juillet 1960 à Brixworth, résidant au 46A, avenue John f. Kennedy, L-
1855 Luxembourg;
Conformément à l’article 12 des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature de son gérant unique.
2) Le siège social de la Société est établi au 5, rue Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête de la personne compa-
rante les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête de la même personne et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2003, vol. 141S, fol. 90, case 11. – Reçu 325 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(003148.3/211/462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 janvier 2004.
Luxembourg, le 7 janvier 2004.
J. Elvinger.
5277
FINGROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2019 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 24.860.
—
Les bilan et annexes au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01246, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002544.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
FINGROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2019 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 24.860.
—
Les bilan et annexes au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01243, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002542.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
FINGROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Adames.
R. C. Luxembourg B 24.860.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 décembre 2003 que:
- le siège social de la société est transféré au 10, rue Adames L-1114 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01242. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002539.3/317/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 56.682.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01240, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002533.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 56.682.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 29 décembre
2003 que:
- a été reconduit dans ses fonctions d’administrateur:
Monsieur Jean-Marie Boden, réviseur d’entreprises, demeurant professionnellement à L-1140 Luxembourg, 45-47,
route d’Arlon;
- a été reconduit dans ses fonctions de commissaire aux comptes:
Monsieur François Thill, demeurant à L-8041 Strassen, 196, rue des Romains.
Le mandat d’administrateur de Monsieur Jean-Marie Boden et de commissaire aux comptes de Monsieur François
Thill prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31 décembre
2003.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
5278
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01237. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002535.3/317/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 56.682.
—
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par le conseil d’administration lors d’une réunion tenue en date du 30 décembre 2003
que:
- Monsieur Jean-Marie Boden a été réélu administrateur-délégué de la société pour la durée de son mandat d’admi-
nistrateur qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires qui statuera sur les comptes annuels au 31
décembre 2003. Il disposera d’un pouvoir de signature individuelle dans les limites de l’article 60 de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales (telle qu’elle a été modifiée).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01236. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002537.3/317/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
AVROY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R. C. Luxembourg B 89.598.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2004, réf. LSO-AM00633, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002548.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
AVAFIN RE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.
R. C. Luxembourg B 39.181.
—
<i>Procès-Verbal du Conseil d’Administration par vote circulaire de décembre 2003i>
<i>Première résolution: Nomination d’un nouvel Administrateuri>
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission de M. Alain Dieryck de son poste d’Administrateur.
Le Conseil le remercie chaleureusement pour sa participation au développement de la société.
Il est décidé à l’unanimité de coopter au poste d’Administrateur vacant, M. Tom Bamelis jusqu’à la prochaine Assem-
blée Générale.
<i>Deuxième résolution: Nomination du Président du Conseil d’Administrationi>
Conformément au 1
er
alinéa de l’article 8 des statuts, le Conseil nomme à l’unanimité M. Tom Bamelis, en qualité de
Président du Conseil d’Administration.
Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2004, réf. LSO-AM01672. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002572.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
<i>Pour la société
i>Signature
5279
KASS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,
(anc. VAIL S.A.).
Siège social: L-3521 Dudelange, 19, rue Karl Marx.
R. C. Luxembourg B 53.880.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01308, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002574.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
KASS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,
(anc. VAIL S.A.).
Siège social: L-3521 Dudelange, 19, rue Karl Marx.
R. C. Luxembourg B 53.880.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01311, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002575.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
KASS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme,
(anc. VAIL S.A.).
Siège social: L-3521 Dudelange, 19, rue Karl Marx.
R. C. Luxembourg B 53.880.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 9 janvier 2004, réf. LSO-AM01312, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002573.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
KASS IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3521 Dudelange, 19, rue Karl Marx.
R. C. Luxembourg B 53.880.
—
<i>Extraiti>
Conformément à l’article 100 de la Loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société KASS IMMOBI-
LIERE S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 10 décembre 2003, ont pris unanimement la décision
de maintenir l’activité sociale de la société.
Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01314. – Reçu 14 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): D. Hartmann.
(002568.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
SPORT TEAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3850 Schifflange, 33, avenue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 64.302.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 6 janvier 2004, réf. LSO-AM00718, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 décembre 2003.
(002524.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
Signature
<i>Le mandatairei>
<i>Pour la société
i>Signature
5280
COFIMA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 56.922.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM00995, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002525.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
WORLD TOUR INVEST LTD., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 22.101.
—
Le bilan au 30 juin 2003, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01028, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002527.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
GIAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 74.634.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01233, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002528.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
CANNEL S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 39.791.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01037, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002529.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
FREGATON S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.
R. C. Luxembourg B 72.427.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 7 janvier 2004, réf. LSO-AM01235, a été déposé au re-
gistre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(002530.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 8 janvier 2004.
Signature.
Luxembourg, le 9 janvier 2004.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Abba Taxis, S.à r.l.
Euroinvest (Czech 3), S.à r.l.
Alpenrose Holding S.A.
Alpenrose Holding S.A.
KS Knitting Solution S.A.
S.K. Trans, S.à r.l.
S.K. Trans, S.à r.l.
EHI Fund (France Number 1), S.à r.l.
Laria S.A.
Laria S.A.
Euroinvest (Hungary 1), S.à r.l.
Euroinvest (Hungary 2), S.à r.l.
Timedi S.A.
Timedi S.A.
Tertia Holding S.A.
Tertia Holding S.A.
Tertia Holding S.A.
APA Group S.A.
APA Group S.A.
LME Invest S.A.
LME Invest S.A.
Movi Finance S.A.
Movi Finance S.A.
Health Holding S.A.
Health Holding S.A.
Health Holding S.A.
Health Holding S.A.
Lux-Avantage Sicav
Lux-Avantage Sicav
Riva Financial Systems Limited, Luxembourg Branch
Riva Financial Systems Limited, Luxembourg Branch
Alimar S.A.
Alimar S.A.
M.E.M. S.A.
M.E.M. S.A.
Euroinvest (Hungary 3), S.à r.l.
Euroinvest (Poland 1), S.à r.l.
GSC European Mezzanine Luxembourg I, S.à r.l.
Fondation Ste-Gertrude
GSC European Mezzanine Luxembourg II, S.à r.l.
Bukkuram S.A.
Bukkuram S.A.
World Energy Program S.A.
Compagnie des Grands Lacs
Zippy S.A.
Zippy S.A.
Financière de l’Avenir S.A.
Margin Finance S.A.
Felton S.A.
ILS Holding S.A.
AGSI, Agence Générale et Service d’Investissement S.A.
AGSI, Agence Générale et Service d’Investissement S.A.
GSC European Mezzanine Luxembourg III, S.à r.l.
F.M. Auto, S.à r.l.
F.M. Auto, S.à r.l.
Marstrand, S.à r.l.
Fingroup S.A.
Fingroup S.A.
Fingroup S.A.
Fiduciaire Grand-Ducale S.A.
Fiduciaire Grand-Ducale S.A.
Fiduciaire Grand-Ducale S.A.
Avroy S.A.
Avafin Ré S.A.
Kass Immobilière S.A.
Kass Immobilière S.A.
Kass Immobilière S.A.
Kass Immobilière S.A.
Sport Team S.A.
Cofima Holding S.A.
World Tour Invest Ltd.
Giar S.A.
Cannel S.A.H.
Fregaton S.A.