logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

65281

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1361

22 décembre 2003

S O M M A I R E

IMAGINE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1329 Luxembourg, 34, rue de Cessange.

R. C. Luxembourg B 58.181. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00256, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082004.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

A.2.Z S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65299

O.A.C.C., S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65293

Adam’s Art, S.à r.l., Dudelange  . . . . . . . . . . . . . . . .

65328

O.A.C.C., S.à r.l., Frisange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65293

Ami Consult, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

65321

Panna-Com Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

65296

Baltic Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

65326

Panna-Com Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

65296

Baltic Assets S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

65328

Panna-Com Invest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

65296

Brenntag-Interfer S.A., Munsbach  . . . . . . . . . . . . . .

65308

Parsiflor S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65318

Bullstrode Continental, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

65284

Paupinal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

65321

Bullstrode Continental, S.à r.l., Luxembourg . . . . .

65284

Paupinal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

65321

Callaway Invest S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . .

65320

Paupinal Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . 

65321

CWE Property Investments, S.à r.l., Luxembourg .

65320

Pindella Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

65318

G.T. Bijoux, S.à r.l., Dudelange. . . . . . . . . . . . . . . . .

65328

Prada Participation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

65316

IGNI, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65318

Prada Participation, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . 

65317

Imagine, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . .

65281

Prada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65297

Immobilière Hortense, S.à r.l., Luxembourg  . . . . .

65320

Prada S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65297

Infralux Real Estate Company, S.à r.l., Strassen . . .

65307

SangStat Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

65282

Infralux Real Estate Company, S.à r.l., Strassen . . .

65308

SangStat Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . 

65282

Interfer S.A., Munsbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65284

Semerca Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

65294

Käfer Gesellschaft S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

65325

Semerca Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . 

65296

Käfer Gesellschaft S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

65326

Shelton Properties, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

65322

Keepint International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

65291

Topaze Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

65283

Keepint International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

65292

Topaze Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

65283

Lallemang, S.à r.l., Esch-sur-Alzette  . . . . . . . . . . . .

65319

Topaze Finance, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

65283

Larchmont Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

65282

Transcom WorldWide S.A., Bertrange . . . . . . . . . 

65322

Larchmont Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

65282

Transcom WorldWide S.A., Bertrange . . . . . . . . . 

65324

Larchmont Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .

65282

Transmex S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

65304

Levlux S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65293

Valley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65283

Nouvelle Hostellerie de la Gare S.A., Bascharage  .

65298

Yule  Catto Pharma  Holdings,  S.à r.l.,  Luxem-  

O.A.C.C., S.à r.l., Frisange  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65293

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65305

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2003.

Signature.

65282

SangStat LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.980,-.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.390. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf.

LSO-AL00934, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080552.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

SangStat LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.980,-.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.390. 

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf.

LSO-AL00931, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 décembre 2003.

(080555.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

LARCHMONT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.973. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01406, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080974.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

LARCHMONT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.973. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01407, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080976.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

LARCHMONT HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.973. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01412, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080977.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG)
<i>Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

65283

TOPAZE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.602. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01874, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. C. Oppelaar.

(080826.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

TOPAZE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.602. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01872, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

D. C. Oppelaar.

(080835.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

TOPAZE FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,-.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 76.602. 

EXTRAIT

Après avoir pris connaissance du bilan au 31 décembre 2001 adopté par l’assemblée générale des actionnaires en date

du 5 novembre 2003 et en se référant à l’article 100 de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, l’assemblée
générale décide de ne pas procéder à une dissolution de la Société, mais de continuer les opérations nonobstant la si-
tuation économique et financière de la société et la perte dépassant la moitié du capital social.

D. C. Oppelaar.

Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, réf. LSO-AL01871. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(080634.2//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

VALLEY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 77.636. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 4 novembre 2003 a ratifié la décision du Con-

seil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l. en
remplacement de Monsieur Edward Bruin.

Puis cette Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE S.A.,

6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- Madame Marie-José Reyter, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Madame Sabine Plattner, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00947. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081158.3/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour VALLEY S.A.
S. Plattner
<i>Administrateur

65284

BULLSTRODE CONTINENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.496. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01391, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080947.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

BULLSTRODE CONTINENTAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 18.496. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01388, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(080949.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

INTERFER, Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.257. 

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fifth day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. BRENNTAG-INTERFER (BC), a société en commandite par actions incorporated and governed by the laws of Lux-

embourg, having its registered address at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

duly represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 No-

vember 2003.

2. BRENNTAG-INTERFER, a société anonyme incorporated and governed by the laws of Luxembourg, having its reg-

istered address at 5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

duly represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 No-

vember 2003.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain at-

tached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their here-above stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société anonyme, which they declare organised as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of INTERFER.

Art. 2. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 4. The registered office of the company is established in Münsbach-Schuttrange. Within the same municipality,

the registered office of the company may be transferred by resolution of the board of directors. Branches or other of-
fices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

B. Share Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of twenty-four thousand

eight hundred (24,800) shares with a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each. 

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at six hundred thousand euro (EUR 600,000.-) con-

sisting of four hundred eighty thousand (480,000) shares with a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per
share. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of association, the directors be

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Signature.

65285

and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such
terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a
preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the

general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The
company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the company are in registered form.
A shareholders’ register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any share-

holder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register.
Certificates of these recordings shall be issued and signed by two directors upon request of the relevant shareholder. 

The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company.
The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been desig-
nated as the sole owner in relation to the company.

C. General Meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company.

The general meeting is convened by the board of directors or by the company’s auditor.
It may also be convened by request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the company’s

share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the thirtieth day of June of
each year at 12.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following busi-
ness day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective no-
tices of meeting.

The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Resolutions at
a meeting of shareholders duly convened will be passed with the unanimous consent of the shareholders.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

D. Board of Directors

Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the company. The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall de-
termine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected for successive terms.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. 

Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except
in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This
notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile or by any other means of communication,
a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,

by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may represent one or more
of his colleagues.

65286

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting
of shareholders fall within the powers of the board of directors.

In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the daily

management of the company, as well as the representation of the company in relation with this management may be
delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their
appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a
member of the board of directors is subject to prior general authorisation of the general meeting of shareholders.

The company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 13. The company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signature of two directors of the company or

by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. 

Art. 14. The director(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate. 

The company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the board of directors and his

heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit, or
proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the board of directors
of the company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

The company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any pro-

ceeding in advance of the final disposition, so long as the company receives a written and legally binding undertaking by
such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to in-
demnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea
of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy
the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The company shall make a cash payment to
such indemnifiable person equal to the full amount incurred by such person and to be indemnified promptly upon noti-
fication of an obligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the company shall
reasonably require.

E. Supervision of the Company

Art. 15. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. The statutory auditor(s) may be re-appointed
for successive terms. 

F. Financial Year - Profits

Art. 16. The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on Decem-

ber thirty-first of the same year.

Art. 17. From the annual net profits of the company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by the board of directors by
observing the terms and conditions provided for by law.

G. Liquidation

Art. 18. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 19. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted under the conditions of quorum provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial
companies, as amended, and with the unanimous consent of the shareholders.

65287

I. Final Clause - Applicable Law

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended. 

<i>Transitional Provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 De-

cember 2004.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2005. 

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) BRENNTAG-INTERFER (BC), prenamed,
paid EUR 7,750.- in subscription for 24,799 shares;
2) BRENNTAG-INTERFER, prenamed,
paid EUR 1.25 in subscription for 1 share;
Total: EUR 7,750.- paid for 24,800 shares.
All the shares have been paid-up for the quarter of their subscription price, so that the amount of seven thousand

seven hundred fifty euro (EUR 7,750.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been ful-
filled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately thousand five hundred euro.

<i>General Meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at four (4) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed as directors of the Company:
a) Paul Edgerley, managing director, residing in 119 Hyslop Road, Brookline, MA 02146, U.S.A., born on 12 December

1955 in the U.S.A.

b) Steve Barnes, managing director, residing in One Old Colony drive, Dover, MA 02030, U.S.A., born on 6 April

1960 in the U.S.A.

c) Michel Plantevin, managing director, residing in 16 Belsize Crescent, London MW3 5QU, United Kingdom, born

on 24 October 1956 in Marseilles, France. 

d) Ailbhe Jennings, director, residing in 17 rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxembourg, born on 27 March 1963

in Dublin, Ireland.

3. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company: 
PricewaterhouseCoopers with address at L-1471 Luxemburg, 400, route d’Esch. 
4. The registered address of the company is set at L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts as of 31 December 2004 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.

6. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as

amended, hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the company and the repre-
sentation of the company in relation with this management to any of its members.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den fünfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg. 

Sind erschienen:

1. BRENNTAG-INTERFER (BC), eine Kommanditgesellschaft gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in

5, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

rechtmäßig vertreten durch Herrn Marc Elvinger, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher

Vollmacht, ausgestellt am 20. November 2003.

65288

2. BRENNTAG-INTERFER, eine Aktiengesellschaft gegründet nach dem Recht von Luxemburg, mit Sitz in 5, Parc

d’Activité Syrdall, L-5365 Münsbach,

rechtmäßig vertreten durch Herrn Marc Elvinger, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher

Vollmacht, ausgestellt am 20. November 2003.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden.

A. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Es besteht hiermit eine zwischen den Zeichnern, sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung aus-

gestellten Aktien eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung INTERFER führt. 

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach-Schuttrange. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft

innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluss des Ver-
waltungsrates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland, gegründet werden.

B. Kapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in vierundzwanzig-

tausendachthundert (24.800) Aktien mit einem Nennwert von ein Euro fünfundzwanzig (EUR 1,25) eingeteilt.

Das genehmigte Aktienkapital, inklusive das gezeichnete Kapital, beträgt sechshunderttausend Euro (EUR 600.000,-)

und ist in vierhundertachtzigtausend (480.000) Aktien mit einem Nennwert von ein Euro fünfundzwanzig (EUR 1,25)
pro Aktie eingeteilt. Während einer Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung, ist der Verwaltungsrat
ermächtigt Aktien auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien zu erteilen, zugunsten solcher Personen und
zu solchen Bedingungen wie dies der Verwaltungsrat für geeignet hält. Der Verwaltungsrat ist in diesem Zusammenhang
insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorzugsrechte einzuräumen.

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Hauptversammlung

der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt wer-
den. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-
ben. 

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses

Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Re-
gister festgestellt.

Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register

bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen

diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 7. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder den Rechnungsprüfer einberufen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals vertreten, einberu-

fen werden.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der

Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 12.00 Uhr morgens am Dreißigsten des Mo-
nats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag statt.
Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten einbe-
rufen werden.

65289

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den

gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestim-
mungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Fak-

simileübertragung, oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten
vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden mit Einstimmigkeit der
anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,

um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können. 

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-

nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

D. Verwaltungsrat

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern beste-

hen muss, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der
Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Haupt-
versammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre
nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet. Die Mitglieder des Ver-
waltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien ge-

wählt.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen jedes Mitglied des Verwal-

tungsrates abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so

kann das freigewordene Amt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung be-
setzt werden.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-

keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungs-

rat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen
zeitweilig zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungs-
schreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einbe-
rufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates,
kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sit-
zungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden. 

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksi-

mileübertragung oder durch vergleichbare Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht
durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere
Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommuni-

kationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.
Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder ver-

tretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das
Protokoll das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 11. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-

heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befug-
nisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können ge-

mäß Artikel sechzig des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder meh-
rere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte,

65290

welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden.
Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt. Die
Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Hauptversammlung vorab genehmigt werden. 

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-

macht übertragen.

Art. 13. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch

Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

Art. 14. Die Verwaltungsratsmitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche

sie im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft
und sind daher ausschließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich. 

Die Gesellschaft entschädigt auf die im weitest möglichen Sinne nach Luxemburger Recht zulässige Art und Weise

jedes Mitglied des Verwaltungsrates, seine Erben, Testamenvollstrecker oder Verwalter für angemessene Kosten die im
Zusammenhang mit jeder Handlung, jedem Prozess oder Verfahren in denen er wegen seiner Mitgliedschaft im Verwal-
tungsrat als Partei beteiligt ist oder war, entstanden sind. Das hiervor aufgeführte Recht auf Entschädigung schließt an-
dere Rechte die dem Verwaltungsratsmitglieder zustehen sollten nicht aus.

Die Gesellschaft übernimmt die Kosten jeder Person, die hierdurch Recht auf Entschädigung hat in Verbindung mit

jedem Verfahren, vor dem endgültigen Urteil, insofern die Gesellschaft eine schriftliche und rechtskräftige Verpflichtung
dieser Person erhält, den Vorschussbetrag zurückzuerstatten, im Fall einer endgültigen Feststellung, dass kein Recht auf
Entschädigung von der Gesellschaft besteht. Alleine durch die Beendigung einer Handlung, eines Prozesses oder eines
Verfahrens durch ein Urteil, eine Anweisung, Beilegung, Verurteilung oder nolo contendere oder gleichwertige Vertei-
digung, entsteht nicht die Vermutung, dass die Person, welche Recht auf Entschädigung hat, den Benehmensstandart,
durch den das Entschädigungsrecht entsteht, nicht eingehalten hat. Die Gesellschaft wird eine Barzahlung an den Ent-
schädigungsberechtigten machen, in gleicher Höhe wie die von ihm eingegangene entschädigungsberechtigte Verpflich-
tungen, sofort nach Erhalt der Mitteilung einer Entschädigungspflicht von dem Entschädigungsberechtigten, unterstützt
von den Informationen welche die Gesellschaft vernünftigerweise fordern kann.

E. Überwachung der Gesellschaft

Art. 15. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktio-

näre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und
setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer
können mehrmals hintereinander ernannt werden.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen

Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals,
wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen. 

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des rest-

lichen Betrages des Reingewinns. Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdi-
videnden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch eine

oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest. 

H. Satzungsänderung

Art. 19. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beach-

tung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesell-
schaften, wie abgeändert, und der einstimmigen Zustimmung der Aktionäre.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 20. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

bestimmend über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

<i>Übergansbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2005 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Gründer haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:
1) BRENNTAG-INTERFER (BC) K.G., vorgenannt,
hat 24.799 Aktien für EUR 7.750,00 gezeichnet;
2) BRENNTAG-INTERFER A.G., vorgenannt,
hat 1 Aktie für EUR 1,25 gezeichnet;
Insgesamt: EUR 7.750,- eingezahlt für 24.800 Aktien.

65291

Alle Aktien wurden für ein Viertel in bar einbezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt

über einen Betrag von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 7.750) wie dies dem unterzeichneten Notar nach-
gewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr tausend fünf hundert Euro.

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen

(1) festgelegt.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Paul Edgerley, managing director, wohnhaft in 119 Hyslop Road, Brookline, MA 02146, U.S.A., geboren am 12. De-

zember 1955 in den U.S.A.

b) Steve Barnes, managing director, wohnhaft in One Old Colony drive, Dover, MA 02030, U.S.A., geboren am 6.

April 1960 in den U.S.A.

c) Michel Plantevin, managing director, wohnhaft in 16 Belsize Crescent, London MW3 5QU, Groß-Britannien, gebo-

ren am 24. Oktober 1956 in Marseilles, Frankreich.

d) Ailbhe Jennings, director, wohnhaft in 17 rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxemburg, geboren am 27. März

1963 in Dublin, Irland.

3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt: PricewaterhouseCoopers mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d’Esch.
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung die über

die jährliche Konten im 31. Dezember 2004 entscheidet oder zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeit-
punkt.

6. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert,

ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäfts-
führung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, vol. 141S, fol. 50, case 3.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081948.3/211/458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

KEEPINT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.428. 

L’an deux mille trois, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître André Jean Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg

sous la dénomination de KEEPINT INTERNATIONAL S.A., R. C. numéro B 70.428 ayant son siège social à Luxembourg
au 18, rue de l’Eau, transférée au Grand-Duché de Luxembourg par acte de Maître Georges d’Huart, notaire de rési-
dence à Pétange, en date du 31 mai 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 679 du
10 septembre 1999.

Les statuts ont depuis été modifiés par acte reçu du notaire instrumentaire, en date du 20 février 2003, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 679 du 10 septembre 1999.

La séance est ouverte à dix-sept heures quinze sous la présidence de Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié

professionnellement au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

J. Elvinger.

65292

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, domicilié professionnel-

lement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cinq mille (5.000) ac-

tions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cinq cent
mille euros (EUR 500.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social à concurrence de quatre cent soixante-cinq mille euros (EUR 465.000,-), pour le porter

de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une valeur
nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), par remboursement aux action-
naires et avec annulation correspondante de quatre mille six cent cinquante (4.650) actions.

2. Modifications afférentes de l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts.

3. Divers.

L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social de la Société est réduit à concurrence de quatre cent soixante-cinq mille euros (EUR 465.000,-), pour

le porter de son montant actuel de cinq cent mille euros (EUR 500.000,-), représenté par cinq mille (5.000) actions d’une
valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-), par remboursement à l’ac-
tionnaire TRUMACO INTERNATIONAL INC avec siège social à Panama, République de Panama et avec annulation cor-
respondante de quatre mille six cent cinquante (4.650) actions lui appartenant.

Le conseil d’administration est chargé de procéder à l’annulation des quatre mille six cent cinquante (4.650) actions

ainsi qu’au remboursement subséquent.

Cette réduction de capital social est régie par l’article 69 (2) de la Loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

telle que modifiée.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’article 3 alinéa 1

er

 des statuts est modifié pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Alinéa 1

er

. Le capital social est fixé à trente-cinq mille euros (EUR 35.000,-) divisé en trois cent cinquante

(350) actions de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s’est terminée à dix-sept heu-

res trente.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-

nute.

Signé: M. Koeune, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081758.3/230/62) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

KEEPINT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 70.428. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1605 du 27 novembre 2003, déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081761.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

65293

O.A.C.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.524. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00623, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081026.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

O.A.C.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.524. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00626, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081020.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

O.A.C.C., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5752 Frisange, 33A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.524. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf. LSO-AL00627, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081016.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 décembre 2003.

LEVLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 28.478. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 3 novembre 2003, les mandats des

administrateurs:

- Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
- UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg;
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg;
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2004.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00960. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081161.3/029/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour FIDCOSERV, S.à r.l.
Signature

<i>Pour LEVLUX S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

65294

SEMERCA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 64.444. 

In the year two thousand three, on the twenty-eight of November.
Before Us, Maître Joseph Gloden, notary residing in Grevenmacher (Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the Luxembourg société anonyme SEMERCA IN-

VESTMENTS S.A., having its registered office in L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, registered at the R.C.S.
Luxembourg Number B 64.444,

incorporated in Luxembourg by a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, on the 30th of April

1998, published in the Mémorial C number 560 on the 31st of July 1998, modified for the latest time by a deed of the
undersigned notary, on the 29th of June 1999, published in the Mémorial C number 707 on the 23rd of September 1999.

The extraordinary general meeting is opened at 12.15 p.m.
by Mr Eric Leclerc, employé privé, with professional address in Luxembourg City, acting as Chairman of the meeting.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Martine Kapp, employée privée, with professional address in

Luxembourg City.

The meeting elects as scrutineer Mr Jos Hemmer, employé privé, with professional address in Luxembourg City.
The bureau of the meeting having thus been constituted the Chairman declares and requests the notary to state that:

I) The agenda of the meeting is the following: 
1. Modification of the financial year to be closed on December 31, instead of June 30 and for the first time on De-

cember 31, 2003.

2. Amendment of the first paragraph of article 18 of the by-laws, which henceforth will read as follows: 

Art. 18. First paragraph. The business year begins on January 1st and ends on December 31st.

French version 

Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale comme le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

3. Amendment of the annual general meeting from the last Friday in September to the first Friday in June and for the

first time in 2004.

4. Amendment of the first paragraph of article 15 of the by-laws, which henceforth will read as follows:

Art. 15. First paragraph. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the

place specified in the convening notice on the first Friday of the month of June at 2.00 p.m.

French version 

Art. 15. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit in-

diqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin à quatorze (14.00) heures.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of shares

owned by the shareholders are shown on an attendance -list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III) It appears from the attendance-list that all the shares are present or represented at the meeting, which conse-

quently is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

After deliberation, the meeting adopts, each time unanimously, the following resolutions: 

<i>First resolution

The extraordinary general meeting resolves to modify the financial year to be closed on December 31st instead of

June 30 and for the first time on December 31st, 2003.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of article 18 of the by-laws, which hence-

forth will read as follows:

«Art. 18. First paragraph. The business year begins on January 1st and ends on December 31st.»

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the annual general meeting from the last Friday in September

to the first Friday in June and for the first time in 2004.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting resolves to amend the first paragraph of article 15 of the by-laws, which hence-

forth will read as follows:

«Art. 15. First paragraph. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at

the place specified in the convening notice on the first Friday of the month of June at 2.00 p.m.»

65295

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which fall to be paid by the company are estimated at

approximately one thousand six hundred euro (1,600.- EUR).

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 12.30 p.m.

The undersigned notary, who knows English, states herewith that, on request of the above persons, the present deed

is worded in English, followed by a French version; on request of the same persons and in case of any differences be-
tween the English and the French texts, the English text will prevail.

In faith of which, we the undersigned notary have set our hand and seal on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, the original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-huit novembre,
Par-devant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher (Luxembourg).

S’est tenue l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme luxembourgeoise SEMERCA

INVESTMENTS S.A., ayant son siège social à L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer, inscrite au R.C. S. Luxembourg
sous le numéro B 64.444,

constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg en date du 30 avril 1998,

publié au Mémorial C numéro 560 du 31 juillet 1998, modifiée pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentaire en date du 29 juin 1999, publié au Mémorial C, numéro 707 du 23 septembre 1999, 

La séance est ouverte à 12.15 heures,
sous la présidence de Monsieur Eric Leclerc, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg,
Le président désigne comme secrétaire Madame Martine Kapp, employée privée, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Jos Hemmer, employé privé, demeurant professionnellement à

Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:

I) L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
1. Modification de l’année sociale pour finir le 31 décembre au lieu du 30 juin, et ce pour la première fois le 31 dé-

cembre 2003.

2. Modification du premier alinéa de l’article 18 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.»

3. Modification de la date de l’assemblée générale annuelle du dernier vendredi du mois de septembre au premier

vendredi du mois de juin, et ce pour la première fois en 2004.

4. Modification du premier alinéa de l’article 15 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante: 
«Art. 15. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit in-

diqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin à quatorze (14.00) heures.»

II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent, laquelle après avoir été signé par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumise à l’enregistrement en même temps.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentaire,

resteront également annexées au présent acte.

III) Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée, laquelle est

dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Après délibération, l’assemblée générale prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de clôture de l’exercice social pour finir le 31 décem-

bre au lieu du 30 juin, et ce pour la première fois le 31 décembre 2003.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’article 18 des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

«Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier la date de l’assemblée générale annuelle du dernier vendredi

du mois de septembre au premier vendredi du mois de juin, et ce pour la première fois en 2004.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale extraordinaire décide de modifier le premier alinéa de l’article 15 des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

65296

«Art. 15. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit in-

diqué dans la convocation, le premier vendredi du mois de juin à quatorze (14.00) heures.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis

à sa charge, sont estimés à environ mille six cents euros (1.600,- EUR).

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.30 heures.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants le présent

acte a été rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes compa-
rants, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétations donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: E. Leclerc, M. Kapp, J. Hemmer, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 1

er

 décembre 2003, vol. 523, fol. 58, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(081767.3/213/138) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

SEMERCA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 64.444. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

J. Gloden.

(081769.3/213/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

PANNA-COM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.407. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf.

LSO-AL00746, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(081392.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

PANNA-COM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.407. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf.

LSO-AL00749, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(081393.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

PANNA-COM INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 79.407. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 2 décembre 2003, réf.

LSO-AL00751, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(081394.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Grevenmacher, le 8 décembre 2003.

J. Gloden.

65297

PRADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.328. 

 L’an deux mille trois, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme PRADA S.A. ayant son siège

social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 48.328, constituée sous la dénomination PREFEL S.A. suivant acte du notaire Maître Gérard Lecuit,
de résidence à Luxembourg, en date du 29 juillet 1994 publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations
C sous le numéro 469 du 19 novembre 1994, dont les statuts ont été modifiés une dernière fois suivant acte, reçu par
le notaire Roger Arrensdorff de Mondorf-les-Bains en date du 30 septembre 2003, publié au susdit Mémorial C, numéro
1162 du 6 novembre 2003.

L’Assemblée est ouverte sous la présidence de Maître Vivian Walry, avocat demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Denise Risch, employée privée, demeurant à Mondorf-les-Bains.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Demichelet Christelle, employée privée, demeurant à Algrange (France).

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I.- La présente Assemblée générale a pour ordre du jour les points suivants:
1) Modification de l’année sociale de la société pour faire débuter celle-ci le 1

er

 janvier et la faire terminer le 31 dé-

cembre de chaque année;

2) Modification subséquente de l’article 15 des statuts de la société.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’ac-

tions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence, cette liste de présence, après avoir été signée ne varietur
par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregis-
trement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Il résulte de la liste de présence que l’assemblée, représentant l’ensemble du capital souscrit, est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur tous les points à l’ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’année sociale afin que celle-ci débute le 1

er

 janvier et se termine le 31 dé-

cembre de chaque année.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la première résolution, l’assemblée générale décide de modifier l’article 15 des statuts de la so-

ciété, qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leur nom, prénom usuel,

état et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: V. Walry, D. Risch, C. Demichelet, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 1

er

 décembre 2003, vol. 467, fol. 35, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081853.3/218/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

PRADA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.328. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081855.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Mondorf-les-Bains, le 3 décembre 2003.

R. Arrensdorff.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

R. Arrensdorff.

65298

NOUVELLE HOSTELLERIE DE LA GARE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 92.531. 

L’an deux mille trois, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. Monsieur Fabrice Digne, chef de cuisine, demeurant à L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale.
2. Madame Fabienne Ledanois, maître d’hôtel, épouse de Monsieur Fabrice Digne, demeurant à L-4917 Bascharage,

1, rue de la Continentale.

Lesquels comparants déclarent être actionnaires nominatifs Monsieur Fabrice Digne, prénommé, de cinq cent une

actions nominatives (501) et Madame Fabienne Ledanois, prénommée, de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions no-
minatives (499), ainsi que le constate le registre des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois dé-
nommée NOUVELLE HOSTELLERIE DE LA GARE S.A., avec siège social à L-4917 Bascharage, 1, rue de la Continentale,
au capital social de trente et un mille euros intégralement souscrites et libérées et représentées par mille actions nomi-
natives (1.000) de trente et un euros (EUR 31,-) chacune,

constituée (originairement sous la dénomination de HOSTELLERIE DE LA GARE S.A.) suivant acte reçu par le notaire

instrumentant, en date du 4 mars 2003, numéro 2675 de son répertoire, en cours de publication au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations; et

modifiée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 3 avril 2003, numéro 2953 de son répertoire, en

cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Cession d’actions nominatives:

1.- Monsieur Fabrice Digne, prénommé, déclare céder et transporter sous les garanties ordinaires de fait et de droit,

à compter rétroactivement du 4 mars 2003, les cinq cent une actions nominatives (501) lui appartenant dans la prédite
société à Monsieur Etienne Ledanois, rentier, demeurant à F-50190 Periers/France, non présent, ici représenté par Mon-
sieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu d’une procuration sous seing privé,
donnée à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2003, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et
le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

<i>Prix de cession:

Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de quinze mille cinq cent trente et un euros (EUR 15.531,-), somme

que le cédant déclare avoir reçue du cessionnaire, avant la passation des présentes et en dehors de la présence du no-
taire soussigné, dont bonne et valable quittance.

2.- Madame Fabienne Ledanois, prénommée, déclare céder et transporter sous les garanties ordinaires de fait et de

droit, à compter rétroactivement du 4 mars 2003, les quatre cent quatre-vingt-dix-neuf actions nominatives (499) lui
appartenant dans la prédite société à Madame Eliane Martin, sans état, demeurant à F-50190 Periers/France, non pré-
sente, ici représentée par Monsieur Jean-Pascal Cambier, employé privé, demeurant à Esch-sur-Alzette, en vertu d’une
procuration sous seing privé, donnée à Esch-sur-Alzette, le 27 juin 2003, laquelle procuration, après avoir été signée ne
varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, avec lequel elle sera formalisée.

<i>Prix de cession:

Cette cession a eu lieu pour et moyennant le prix de quinze mille quatre cent soixante-neuf euros (EUR 15.469,-),

somme que la cédante déclare avoir reçue de la cessionnaire, avant la passation des présentes et en dehors de la pré-
sence du notaire soussigné, dont bonne et valable quittance.

<i>Mention

Mention des présentes cessions d’actions nominatives seront faites à la diligence du conseil d’administration sur le

registre des actionnaires tenu au siège social de la société.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre cents euros
(EUR 400,-).

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, pré-

nom usuel, état et demeure, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Digne, F. Ledanois, J.-P. Cambier, A. Biel.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 27 novembre 2003, vol. 892, fol. 95, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(081847.3/203/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2003.

A. Biel.

65299

A.2.Z, Société Anonyme.

Registered office: L-1734 Luxembourg, 2, rue Carlo Hemmer.

R. C. Luxembourg B 97.249. 

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh day of November.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

1.- The company GALVEN INVESTORS S.A., a company governed by the laws of the British Virgin Islands, established

and having its registered office in Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (British
Virgin Islands),

here represented by:
Mr Jos Hemmer, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on November 26, 2003. 
2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, acting in his own name.
3.- Mr Eric Leclerc, employee, with a professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
The prenamed proxy, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing persons, acting in their above stated capacities, have requested the undersigned notary to draw up

the following Articles of Incorporation of a joint stock company (société anonyme) which the prenamed parties intend
to organize among themselves.

Name - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is herewith formed a Luxembourg joint stock company («société anonyme») under the name of A.2.Z. 

Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-

bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office

of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the sharehold-
ers’ meeting.

If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered

office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,

shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The company’s object is to take participation, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign en-

terprises; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting firm purchase or option,
negotiation or in any other way and namely to acquire patents and licences, to manage and develop them; to grant to
enterprises in which the company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, to perform any opera-
tion which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31, 1929,
on Holding Companies.

The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to fa-

cilitate the accomplishment of its purpose in all areas as described above.

Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at thirty-one thousand EURO (31,000.- EUR) divided into one

hundred (100) shares, without a par value.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders, subject to the restriction foreseen by

law. 

The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders voting with the same quorum as for the amendment of the articles of incorporation.

Board of directors and statutory Auditors

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the general meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time by the general meeting.

If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may

provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his

place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.

65300

The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions if the majority of its members is present or represented, proxies

between directors being permitted with the restriction that a director can only represent one of his colleagues.

The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter. 
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the direc-

tors’ meetings.

Art. 8. Decisions of the board are taken by an absolute majority of the votes cast.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates.

Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.

Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general shareholders’ meeting by the law of
August 10th, 1915, as subsequently modified, or by the present articles of incorporation of the company, fall within the
competence of the board of directors.

Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members

of the board or to third persons who need not be shareholders of the company. The delegation to a member of the
board is subject to a previous authorization of the general meeting of shareholders.

The first person(s) to whom the daily management of the company is delegated to, may be elected at the first general

meeting of shareholders.

Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of two

directors or by the individual signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. 

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed

by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.

The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting of shareholders for a period not

exceeding six years.

General meeting

Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry

out or ratify such acts as may concern the corporation. The convening notices are made in the form and delays pre-
scribed by law. 

Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in

the convening notice on the last Monday in the month of June at 2.00 p.m.

If such day is a public holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be convened at the

written request of shareholders representing twenty percent of the company’s share capital.

Art. 17.
Each share entitles to the casting of one vote. The company will recognize only one holder for each share; in case a

share is held by more than one person, the company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that
share until one person has been appointed as sole owner in relation to the company.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on first day of January and ends on the last day of December of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month

before the statutory general meeting.

Art. 19. At least five percent of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund.

Such contribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches ten percent of the subscribed capital.

The remaining balance of the net profit is at the disposal of the general meeting. 
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortization of the capital, without

reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation.

Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical

persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remunerations.

General dispositions

Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as

these articles of incorporation do not provide for the contrary.

<i>Transitory dispositions

The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st, 2004.
The first annual general meeting shall be held in 2005.

65301

The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall

take place immediately after the incorporation of the company.

By deviation form article 7 of the articles of incorporation, the first chairman of the board of directors is designated

by the extraordinary general shareholders’ meeting that designates the first board of directors of the company.

<i>Subscription and payment

The one hundred (100) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the amount of

thirty-one thousand Euro (31.000,- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in art. 26 of the law on commercial companies

of August 10th, 1915 as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately fixed at one

thousand eight hundred euro.

<i>Extraordinary general meeting

The above-named parties, acting in the here above stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,

considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three (3).
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the annual general meeting to be held in 2009:
1.- Mr Eric Leclerc, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2.- Mr Jos Hemmer, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
3.- Mrs. Martine Kapp, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Mr Eric Leclerc, prenamed, has been elected as chairman of the board of directors by the extraordinary general meet-

ing.

<i>Second resolution

The number of auditors is fixed at one (1).
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the annual general meeting to be held

in 2009:

Mrs. Diane Wunsch, employee, with professional address in 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Third resolution
The company’s registered office is located at 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read and translated to the appearing persons known to the undersigned notary by their

names, usual surnames, civil status and residences, said appearing persons has signed with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-sept novembre. 
Par-devant Nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A., une société régie par les lois des Iles Vierges Britanniques, établie et ayant

son siège social à Akara Building 24, De Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola (Iles Vierges Britanniques),

ici représentée par: 
Monsieur Jos Hemmer, employée avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 26 novembre 2003. 
2.- Monsieur Jos Hemmer, préqualifié, agissant en son nom personnel.
3.- Monsieur Eric Leclerc, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg,
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par les personnes comparantes et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Lesquelles personnes comparantes, agissant en leur susdite qualité, ont requis le notaire instrumentant d’arrêter ainsi

qu’il suit les statuts d’une société anonyme que les parties prémentionnées vont constituer entre elles.

1.- GALVEN INVESTORS S.A., prenamed, ninety-eight shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

98

2.- Mr Jos Hemmer, prenamed, one share . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

3.- Mr Eric Leclerc, prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: one hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

65302

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de A.2.Z.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger. 

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre lieu du pays
par décision de l’assemblée générale.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés,

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d’apport, de souscrip-
tion, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l’acquisition de brevets
et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles elle s’intéresse, de tous concours,
prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directe-
ment ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier organisé par la loi du 31 juillet
1929 sur les sociétés holding.

La société peut également effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières se rattachant directe-

ment ou indirectement aux objets ci-dessus de nature à en faciliter la réalisation.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR) divisé en cent (100) actions sans dési-

gnation de valeur nominale.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des restrictions prévues par la loi.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts. 

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

La (Les) première(s) personne(s) à qui sera (seront) déléguée(s) la gestion journalière peut (peuvent) être nommée(s)

par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. 

65303

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier lundi du mois de juin de chaque année à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. 
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les activités de la société un mois au moins avant l’assemblée générale ordi-

naire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommées par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2004. 
La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2005.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société. 

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est nommé par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et libération 

Les cent (100) actions ont été souscrites comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la

somme de trente et un mille Euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il
en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Constatation

 Le notaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés commer-

ciales, et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

 Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ mille huit cents euros.

1.- La société GALVEN INVESTORS S.A., prédésignée, quatre-vingt-dix-huit actions   . . . . . . . . . . . . . . . 

98

2.- Monsieur Jos Hemmer, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

3.- Monsieur Eric Leclerc, prénommé, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

100

65304

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Et à l’instant les comparants, ès-qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à

laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont
à l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois (3).
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statutaire à tenir

en 2009: 

1.- Monsieur Eric Leclerc, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
2.- Monsieur Jos Hemmer, employé, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg;
3.- Madame Martine Kapp, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.
Monsieur Eric Leclerc, prénommé, a été désigné président du conseil d’administration par l’assemblée générale ex-

traordinaire.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un (1).
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale annuelle statu-

taire à tenir en 2009: 

Madame Diane Wunsch, employée, avec adresse professionnelle au 6A, Circuit de la Foire, L-1347 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

 L’adresse de la société est fixée au 2, rue Carlo Hemmer, L-1734 Luxembourg.
 Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à l’intérieur de la commune du siège social

statutaire.

 Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes personnes
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes. 
Et après lecture et traduction faite aux personnes comparantes, connues du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, les mêmes personnes comparantes ont signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: J. Hemmer, E. Leclerc, J.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 2 décembre 2003, vol. 881, fol. 44, case 10. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081795.3/239/335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

TRANSMEX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 43.428. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 7 novembre 2003 a ratifié la décision du Con-

seil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A. en remplacement de Ma-
dame Francine Herkes.

Lors de cette même Assemblée, les mandats des administrateurs:
- MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg;
- Monsieur Guy Fasbender, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Puis cette Assemblée a appelé aux fonctions d’administrateur Monsieur Jacques Claeys, 59, boulevard Royal, L-2449

Luxembourg, en remplacement de Monsieur Edward Bruin. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire de 2009.

Enfin, lors de cette Assemblée, le mandat du Commissaire aux Comptes:
- COMCOLUX S.A., 123, avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg;
a été renouvelé et prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00966. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081162.3/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Belvaux, le 8 décembre 2003.

J.J. Wagner.

<i>Pour TRANSMEX S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

65305

YULE CATTO PHARMA HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 94.051. 

In the year two thousand three, on the fifth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.

Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of YULE CATTO PHARMA HOLDINGS, S.à r.l., a limited

liability company («société à responsabilité limitée»), having its registered office at L-1150 Luxembourg, 291, route d’Ar-
lon, incorporated by deed drawn up and enacted on June 11th 2003, inscribed at trade register Luxembourg section B
number 94.051, published in the Mémorial C number 750 on July 16 2003, Recueil des Sociétés et Associations.

 The meeting is presided by Mister Patrick Van Hees, lawyer, residing at Messancy (Belgium).
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mister Hubert Janssen, lawyer, residing at

Torgny (Belgium).

The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance

list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.

II.- As appears from the attendance list, the three thousand seven hundred (3,700) shares of EUR 25.- (twenty-five

Euros) each, representing the whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on
all the items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1.- Increase of the corporate capital by an amount of EUR 22,600.- (twenty-two thousand six hundred Euros) so as

to raise it from its present amount of 92,500.- (ninety-two thousand five hundred Euros) to EUR 115,100.- (one hundred
and fifteen thousand one hundred Euros) by the issue of 904 (nine hundred and four) new shares having a par value of
EUR 25.- (twenty-five Euros) each, on payment of a share premium amounting to EUR 17.- (seventeen Euros).

2.- Subscription, intervention of the subscriber and payment of the capital increase by contribution in kind.
3.- Amendment of article 6 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.

After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the corporate capital by an amount of EUR 22,600.- (twenty-two thousand six hundred Eu-

ros) so as to raise it from its present amount of 92,500.- (ninety-two thousand five hundred Euros) to EUR 115,100.-
(one hundred and fifteen thousand one hundred Euros) by the issue of 904 (nine hundred and four) new shares having
a par value of EUR 25.- (twenty-five Euros) each, on payment of a share premium amounting to EUR 17.- (seventeen
Euros), to be subscribed and fully paid up by contribution in kind.

<i>Second resolution

It is decided to admit to the subscription of the 904 (nine hundred and four) new shares having a par value of EUR

25.- (twenty-five Euros): 

<i>Intervention - Subscription - Payment

Furthermore intervenes the aforenamed company KEERANLAWN LIMITED, S.à r.l., here represented by Hubert

Janssen, aforenamed, by virtue of a proxy given under private seal, which will remain attached to the present deed;

which declares subscribe to the 904 (nine hundred and four) new shares up by conversion into capital of part of an

uncontested, current and immediately exercisable claim, existing in its favour and against the Corporation, and by can-
cellation of such claim by EUR 22,617.- (twenty thousand six hundred and seventeen Euros).

The evidence of existence of the value of such claim and the appearing parties intention to transfer such a claim has

been given to the undersigned notary by a recent balance sheet of the subscriber, and a declaration issued by the man-
agers of both appearing parties attesting to the net value of the contributed asset.

<i>Evaluation

The net value of this contribution in kind is evaluated at EUR 22,617.- (twenty-two thousand six hundred and seven-

teen Euros).

<i>Manager’s intervention

Thereupon intervene Mr Olivier Dorier, director, residing in Olm, Mr Fredy Thyes, director, residing in Luxembourg

and Mr Andrew Burnett, director, residing in Bedfordshire (United Kingdom), managers of YULE CATTO PHARMA
HOLDINGS, S.à r.l., here represented by Mr Hubert Janssen, prenamed, by virtue of a proxy which will remain here
annexed.

Acknowledging having been beforehand informed of the extent of their responsibility, legally engaged as managers of

the company by reason of the here above described contribution in kind, they expressly agree with the description of
the contribution in kind, with its valuation, and confirms the validity of the subscription and payment.

KEERANLAWN LIMITED, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

904 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

904 shares

65306

<i>Third resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the first paragraph of Article 6 of the Articles

of Incorporation to read as follows:

«Art. 6. First paragraph. The Company’s corporate capital is fixed at EUR 115,100.- (one hundred and fifteen

thousand one hundred Euros), represented by 4,604 (four thousand six hundred and four) shares of EUR 25.- (twenty-
five Euros) each, all fully paid-up and subscribed.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately 2,500.- Euros.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with Us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Suit la traduction française:

L’an deux mille trois, le cinq novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée YULE CATTO

PHARMA HOLDINGS, S.à r.l., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 94.051, constituée suivant acte reçu le 11 juin 2003, publié
au Mémorial C numéro 750 du 16 juillet 2003, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny (Belgique).

Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 3.700 (trois mille sept cents) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros)

chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été
préalablement informés.

III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 22.600,- (vingt-deux mille six cents euros)

pour le porter de son montant actuel de EUR 92.500,- (quatre vingt douze mille cinq cents euros) à EUR 115.100,- (cent
quinze mille cent euros) par l’émission de 904 (neuf cent quatre) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de EUR
25,- (vingt-cinq euros) chacune, ce moyennant paiement d’une prime d’émission globale s’élevant à EUR 17 (dix-sept
euros).

2.- Souscription, intervention du souscripteur et libération de l’augmentation de capital par apport en nature.
3.- Modification afférente de l’article 6 des statuts.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:

<i>Première résolution

Il est décidé d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant de EUR 22.600,- (vingt-deux mille six cents

euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 92.500,- (quatre-vingt douze mille cinq cents euros) à EUR
115.100,- (cent quinze mille cent euros) par l’émission de 904 (neuf cent quatre) parts sociales nouvelles d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, avec le paiement d’une prime d’émission qui s’élève à EUR 17,- (dix-
sept euros), le tout souscrit et libéré par apport en nature de partie d’une créance.

<i>Deuxième résolution

Il est décidé d’admettre à la souscription des 904 (neuf cent quatre) parts sociales nouvelles: 

<i>Intervention - Souscription - Libération

Intervient ensuite aux présentes la société prédésignée KEERANLAWN LIMITED, S.à r.l., ici représentée par Mon-

sieur Hubert Janssen, prénommée en vertu d’une procuration sous seing privé qui restera ci-annexée;

laquelle a déclaré souscrire la totalité de l’augmentation de capital et la libérer intégralement ainsi que la prime d’émis-

sion par conversion en capital de partie d’une créance certaine, liquide et immédiatement exigible, existant à son profit

KEERANLAWN LIMITED, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

904 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

904 parts

65307

et à charge de la Société, et en annulation de cette même créance à concurrence de EUR 22.617,- (vingt-deux mille six
cent dix sept euros).

La preuve de l’existence de la valeur de cette créance et l’intention des parties de la transférer, a été donnée au no-

taire soussigné par un bilan récent du souscripteur et la déclaration des gérants des deux sociétés, certifiant la valeur
de l’actif net apporté.

<i>Evaluation

La valeur nette de cet apport en nature est évaluée à EUR 22.617,- (vingt-deux mille six cent dix-sept euros).

<i>Intervention des gérants

Sont alors intervenus: Monsieur Olivier Dorier, administrateur de société, demeurant à Olm, Monsieur Fredy Thyes,

administrateur de société, demeurant à Luxembourg et Monsieur Andrew Burnett, administrateur de société, demeu-
rant à Bedfordshire (Royaume-Uni), gérants de la société YULE CATTO PHARMA HOLDINGS, S.à r.l., ici représentée
par Monsieur Hubert Janssen, prénommé, en vertu d’une procuration qui restera ci-annexée.

Reconnaissant avoir pris connaissance de l’étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité de gé-

rants de la société à raison de l’apport en nature ci-avant décrit, ils marquent expressément leur accord sur la descrip-
tion de l’apport en nature et sur son évaluation, et confirment la validité des souscription et libération.

<i>Troisième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier le premier

paragraphe de l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Premier paragraphe. Le capital social est fixé à EUR 115.100,- (cent quinze mille cent euros) divisé en

4.604 (quatre mille six cent quatre) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa char-

ge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de 2.500,- euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-

digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, vol. 141S, fol. 22, case 5. – Reçu 226,17 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081884.3/211/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

INFRALUX REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8031 Strassen, 11, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 66.991. 

L’an deux mille trois, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

A comparu:

La société INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., avec siège social L-1528 Luxembourg, 5, boulevard

de la Foire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro
66.992,

ici représentée par Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement à

L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire, 

en vertu d’une procuration sous seing privé en date du 13 novembre 2003.
La prédite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant agissant ès-dite qualité, et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement. 

 Lequel comparant agissant ès-dite qualité a exposé au notaire instrumentant et l’a requis d’acter ce qui suit:

 I.- La société INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., préqualifiée est la seule et unique associée de la

société à responsabilité limitée INFRALUX REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., avec siège social à L-8031 Strassen, 11,
rue du Parc, constituée suivant acte reçu par Maître Norbert Muller, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en
date du 11 novembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 29 du 19 janvier 1999,
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, en
date du 16 octobre 2001, publié au Mémorial C, numéro 328 du 27 février 2002, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de et à Luxembourg sous la section B et le numéro 66.991.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

J. Elvinger.

65308

 II.- Le capital social est fixé à EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros), représenté par 10.000 (dix mille) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant
à l’associée unique, la société INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., préqualifiée. 

 III.- La société INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., représentée comme dit ci-avant, représentant

en tant que seule et unique associée l’intégralité du capital social, agissant en lieu et place de l’assemblée générale ex-
traordinaire, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associée unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 600.000,- (six cent mille euros) en vue

de le porter de EUR 250.000,- (deux cent cinquante mille euros) à EUR 850.000,- (huit cent cinquante mille euros) par
la création de 24.000 (vingt-quatre mille) nouvelles parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, à souscrire
en numéraire, émises au pair et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

<i>Souscription, libération

Les 24.000 (vingt-quatre mille) nouvelles parts sociales ont été souscrites à l’instant même par l’associée unique, la

société INFRASTRUCTURE CREATION COMPANY, S.à r.l., préqualifiée.

Les 24.000 (vingt-quatre mille) nouvelles parts sociales ont été entièrement libérées par un versement en espèces,

de sorte que du chef de la présente augmentation de capital, la somme de EUR 600.000,- (six cent mille euros), se trouve
dès maintenant à la libre disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la prédite augmentation de capital, l’associée unique décide de modi-

fier l’article 5 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Le capital social est fixé à EUR 850.000,- (huit cent cinquante mille euros) divisé en 34.000 (trente-quatre mille) parts

sociales d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune.».

 IV.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de EUR

7.500,- (sept mille cinq cents euros), sont à charge de la société qui s’y oblige, l’associée unique en étant solidairement
tenue envers le notaire.

 Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue de lui connue au comparant agissant ès-dite qualité,

connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous, no-
taire.

Signé: P. Lentz, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, vol. 141S, fol. 40, case 6. – Reçu 6.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(081901.3/222/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

INFRALUX REAL ESTATE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8031 Strassen, 11, rue du Parc.

R. C. Luxembourg B 66.991. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081904.3/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

BRENNTAG-INTERFER, Société Anonyme.

Registered office: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 97.256. 

STATUTES

In the year two thousand and three, on the twenty-fifth day of November.
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.

There appeared:

1. BAIN CAPITAL FUND VII-E (UK) L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the United

States of America, with registered office at 111 Huntington Avenue, Boston, MA 02199, USA, registered with the Com-
panies House under Reg No. LP7888,

duly represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 No-

vember 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 décembre 2003.

T. Metzler.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 décembre 2003.

T. Metzler.

65309

2. BAIN CAPITAL FUND VII L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Is-

lands, with registered office at c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cay-
man, Cayman Islands,

duly represented by Mr Marc Elvinger, maître en droit, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 20 No-

vember 2003.

The proxies, after having been signed ne varietur by the proxy-holders and the undersigned notary, shall remain at-

tached to this document in order to be registered therewith.

Such appearing parties, acting in their here-above stated capacities, have drawn up the following articles of association

of a société anonyme, which they declare organised as follows:

A. Name - Duration - Purpose - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of BRENNTAG-INTERFER.

Art. 2. The company is established for an unlimited period of time.

Art. 3. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and

foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and de-
velopment of its portfolio.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or in-

direct participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of its purpose.

Art. 4. The registered office of the company is established in Münsbach, Schuttrange. Within the same municipality,

the registered office of the company may be transferred by resolution of the board of directors. Branches or other of-
fices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

B. Share Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of twenty-four thousand

eight hundred (24,800) shares having a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) each.

The authorised capital, including the issued share capital, is fixed at six hundred thousand euro (EUR 600,000.-) con-

sisting of four hundred eighty thousand (480,000) shares with a par value of one euro twenty-five cent (EUR 1.25) per
share. During the period of five years, from the date of the publication of these articles of association, the directors be
and are hereby authorised to issue shares and to grant options to subscribe for shares, to such persons and on such
terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving for the existing shareholders a
preferential right to subscribe to the shares issued.

The subscribed capital and the authorised capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the

general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association. The
company may, to the extent and under terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the company are in registered form.
A shareholders’ register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any share-

holder. This register will contain all the information required by article 39 of the law of 10 August 1915 governing com-
mercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by inscription in said register.
Certificates of these recordings shall be issued and signed by two directors upon request of the relevant shareholder. 

The company will recognize only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the company.
The company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been desig-
nated as the sole owner in relation to the company.

C. General Meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company.

The general meeting is convened by the board of directors or by the company’s auditor.
It may also be convened by request of shareholders representing at least twenty per cent (20%) of the company’s

share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the thirtieth day of June of
each year at 14.30 p.m. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following busi-
ness day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective no-
tices of meeting.

The quorum and time-limits provided by law shall govern the convening notices and the conduct of the meetings of

shareholders of the company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. Resolutions at
a meeting of shareholders duly convened will be passed with the unanimous consent of the shareholders.

65310

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

D. Board of Directors

Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the company. The directors shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall de-
termine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not exceed six years
and the directors shall hold office until their successors are elected. Directors may be re-elected for successive terms.
The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented. 

Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, by observing the applicable legal provisions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except
in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This
notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile or by any other means of communication,
a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing,

by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A director may represent one or more
of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The entirety will form the minutes giving
evidence of the passing of the resolution.

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise, shall be signed by the chairman or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by these articles to the general meeting
of shareholders fall within the powers of the board of directors.

In accordance with article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended, the daily

management of the company, as well as the representation of the company in relation with this management may be
delegated to one or more directors, officers, managers or other agents, shareholder or not, acting alone or jointly. Their
appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors. The delegation to a
member of the board of directors is subject to prior general authorisation of the general meeting of shareholders.

The company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

Art. 13. The company will be bound vis-à-vis third parties by the joint signature of two directors of the company or

by the sole signature of any persons to whom such signatory power shall be delegated by the board of directors. 

Art. 14. The director(s) do not assume, by reason of his/their position, any personal liability in relation to commit-

ments regularly made by them in the name of the company. They are authorized agents only and are therefore merely
responsible for the execution of their mandate.

The company shall indemnify, to the greatest extent permitted by law, any member of the board of directors and his

heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit, or
proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a member of the board of directors
of the company. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

The company shall pay the expenses incurred by any person indemnifiable hereunder in connection with any pro-

ceeding in advance of the final disposition, so long as the company receives a written and legally binding undertaking by
such person to repay the full amount advanced if there is a final determination that such person is not entitled to in-
demnification. The termination of any action, suit or proceeding by judgment, order, settlement, conviction, or a plea

65311

of nolo contendere or its equivalent, shall not of itself, create a presumption that the indemnifiable person did not satisfy
the standard of conduct entitling him or her to indemnification hereunder. The company shall make a cash payment to
such indemnifiable person equal to the full amount incurred by such person and to be indemnified promptly upon noti-
fication of an obligation to indemnify from the indemnifiable person supported by such information as the company shall
reasonably require.

E. Supervision of the Company

Art. 15. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office, which may not exceed six years. The statutory auditor(s) may be re-appointed
for successive terms.

F. Financial Year - Profits

Art. 16. The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on Decem-

ber thirty-first of the same year.

Art. 17. From the annual net profits of the company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the sub-
scribed capital of the company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided
in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of. Interim dividends may be distributed by the board of directors by
observing the terms and conditions provided for by law.

G. Liquidation

Art. 18. In the event of dissolution of the company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

H. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 19. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted under the conditions of quorum provided for in article 67-1 of the law of 10 August 1915 governing commercial
companies, as amended, and with the unanimous consent of the shareholders.

I. Final Clause - Applicable Law

Art. 20. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended. 

<i>Transitional Provisions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on 31 De-

cember 2004.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2005.

<i>Subscription and Payment

The subscribers have subscribed the shares to be issued as follows:
1) BAIN CAPITAL FUND VII-E (UK) L.P., prenamed, 
paid EUR 3,875.- for the subscription for 12,400 shares; 
2) BAIN CAPITAL FUND VII, LP, prenamed,
paid EUR 3,875.- for the subscription for 12,400 shares;
Total: EUR 7,750.- paid for 24,800 shares.
All the shares have been paid-up for the quarter of their subscription price, so that the amount of seven thousand

seven hundred fifty euro (EUR 7,750.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned
notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of 10 August 1915, governing commercial companies, as amended, and expressly states that they have been ful-
filled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately thousand five hundred euro.

<i>General Meeting of Shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at four (4) and the number of statutory auditors at one (1).
2. The following persons are appointed as directors of the Company:
a) Paul Edgerley, managing director, residing in 119 Hyslop Road, Brookline, MA 02146, U.S.A., born on 12 December

1955 in the U.S.A.

65312

b) Steve Barnes, managing director, residing in One Old Colony drive, Dover, MA 02030, U.S.A., born on 6 April

1960 in the U.S.A.

c) Michel Plantevin, managing director, residing in 16 Belsize Crescent, London MW3 5QU, United Kingdom, born

on 24 October 1956 in Marseilles, France.

d) Ailbhe Jennings, director, residing in 17 rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxembourg, born on 27 March 1963

in Dublin, Ireland.

3. The following entity is appointed as statutory auditor of the Company: PricewaterhouseCoopers with address at

L-1471 Luxemburg, 400, route d’Esch.

4. The registered address of the company is set at L-5365 Münsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
5. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts as of 31 December 2004 or at any time prior to such time as the general meeting of shareholders may
determine.

6. The general meeting, according to article 60 of the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as

amended, hereby authorizes the board of directors to delegate the daily management of the company and the repre-
sentation of the company in relation with this management to any of its members.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des englischen Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den fünfundzwanzigsten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit Amtssitz in Luxemburg.

Sind erschienen:

1. BAIN CAPITAL FUND VII-E UK, L.P., ein limited partnership gegründet nach dem Recht der U.S.A., mit Sitz in 111

Huntington Avenue, Boston, MA 02199, U.S.A., einregistriert beim Companies House unter der Registrierungsnummer
LP7888,

rechtmäßig vertreten durch Herrn Marc Elvinger, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher

Vollmacht, ausgestellt am 20. November 2003.

2. BAIN CAPITAL FUND VII, L.P., ein limited partnership gegründet nach dem Recht der Cayman Islands, mit Sitz in

c/o Walkers SPV Limited, P. O. Box 908GT, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,

rechtmäßig vertreten durch Herrn Marc Elvinger, maître en droit, wohnhaft in Luxemburg, gemäß privatschriftlicher

Vollmacht, ausgestellt am 20. November 2003.

Die Vollmachten werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen und den unterzeichneten Notar

gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden.

A. Name - Sitz - Dauer - Zweck

Art. 1. Es besteht hiermit eine zwischen den Zeichnern, sowie allen zukünftigen Inhaber der in dieser Satzung aus-

gestellten Aktien eine Aktiengesellschaft, welche die Bezeichnung BRENNTAG-INTERFER führt.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften,

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kon-
trolle und Verwertung dieser Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann ebenfalls den Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder

welche der gleichen Gesellschaftsgruppe wie sie selbst angehören, Bürgschaften oder Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte kaufmännischer, gewerblicher oder finanzieller Natur betreiben, die der Errei-

chung ihres Zweckes förderlich sind.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach, Schuttrange. Die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft

innerhalb der Gemeinde erfolgt durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates. Durch einfachen Beschluss des Ver-
waltungsrates können auch jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen, sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im
Ausland, gegründet werden.

B. Kapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000,-) und ist in vierundzwanzig-

tausendachthundert (24.800) Aktien mit einem Nennwert von ein Euro fünfundzwanzig (EUR 1,25) eingeteilt.

Das genehmigte Aktienkapital, inklusive das gezeichnete Kapital, beträgt sechshunderttausend Euro (EUR 600.000,-)

und ist in vierhundertachtzigtausend (480.000) Aktien mit einem Nennwert von ein Euro fünfundzwanzig (EUR 1,25)
pro Aktie eingeteilt. Während einer Dauer von fünf Jahren ab Veröffentlichung dieser Satzung, ist der Verwaltungsrat

65313

ermächtigt Aktien auszugeben oder Optionen zur Zeichnung von Aktien zu erteilen, zugunsten solcher Personen und
zu solchen Bedingungen wie dies der Verwaltungsrat für geeignet hält. Der Verwaltungsrat ist in diesem Zusammenhang
insbesondere berechtigt, neue Aktien auszugeben, ohne dabei den bisherigen Aktionären Vorzugsrechte einzuräumen.

Das gezeichnete und das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft können durch Beschluss der Hauptversammlung

der Aktionäre, entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt wer-
den. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-
ben.

Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Aktionäre geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offen steht. Dieses

Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften
bestimmend, wie abgeändert, vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Re-
gister festgestellt.

Auf Anfrage des entsprechenden Aktionärs, werden Aktienzertifikate ausgestellt, welche die Eintragung im Register

bestätigen und von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt sein, müssen

diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, um die aus
den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Ausübung aller
Rechte bezüglich solcher Aktien aussetzen, solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktien im Verhältnis zur
Gesellschaft benannt worden ist.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 7. Die ordnungsgemäß gebildete Versammlung der Aktionäre vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat

jegliche Befugnis zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte der Ge-
sellschaft.

Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat oder den Rechnungsprüfer einberufen.
Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zwanzig Prozent (20%) des Kapitals vertreten, einberu-

fen werden.

Art. 8. Die jährliche Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen, in der

Einladung bestimmten Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburgs jeweils um 14.30 Uhr nachmittags am Dreißigsten des
Monats Juni eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am nächsten darauf folgenden Werktag
statt. Andere Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten und Orten
einberufen werden.

Die Einberufungsschreiben sowie die Leitung der Versammlungen der Aktionäre der Gesellschaft werden von den

gesetzlich erforderlichen Anwesenheitsquoten und Fristen geregelt, insofern diese Satzung keine anderweitigen Bestim-
mungen trifft.

Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per Fak-

simileübertragung, oder per jede andere Kommunikationsform (eine Kopie ist ausreichend) bevollmächtigten Dritten
vertreten lassen. Beschlüsse auf einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung werden mit Einstimmigkeit der
anwesenden und vertretenen Stimmen gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen festlegen, welche von den Aktionären erfüllt werden müssen,

um an einer Versammlung der Aktionäre teilnehmen zu können. 

Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu ken-

nen, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

D. Verwaltungsrat

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, welcher aus mindestens drei Mitgliedern beste-

hen muss, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der
Hauptversammlung der Aktionäre gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der Haupt-
versammlung festgesetzt. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden für die Dauer eines Mandates, welches sechs Jahre
nicht überschreiten darf, und welches grundsätzlich mit der Bestellung des Nachfolgers endet. Die Mitglieder des Ver-
waltungsrates können mehrmals hintereinander gewählt werden.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktien ge-

wählt.

Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen jedes Mitglied des Verwal-

tungsrates abberufen.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so

kann das freigewordene Amt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung be-
setzt werden.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat auch die Möglich-

keit, einen stellvertretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des
Verwaltungsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder an dem in dem Einberufungs-

schreiben bestimmten Ort einberufen.

Der Vorsitzende hat den Vorsitz in jeder Sitzung des Verwaltungsrates; in seiner Abwesenheit kann der Verwaltungs-

rat mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates ernennen um den Vorsitz dieser Sitzungen
zeitweilig zu führen.

65314

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält wenigstens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Zeitpunkt der

Sitzung per Faksimileübertragung oder per elektronische Post (ohne elektronische Unterschrift), ein Einberufungs-
schreiben, außer im Falle einer Dringlichkeit, in welchem Falle die Natur und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einbe-
rufungsschreiben angegeben werden müssen. Auf schriftliche, durch Faksimileübertragung oder durch ein vergleichbares
Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) gegebene Einwilligung eines jeden Mitgliedes des Verwaltungsrates,
kann auf die Einberufungsschreiben verzichtet werden. Ein spezielles Einberufungsschreiben ist nicht erforderlich für Sit-
zungen des Verwaltungsrates, die zu einer Zeit und an einem Ort abgehalten werden, welche von einem vorherigen
Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt wurden. 

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer schriftlich, durch Faksi-

mileübertragung oder durch vergleichbare Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) erteilten Vollmacht
durch ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere
Verwaltungsratsmitglieder vertreten.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch eine telefonische Konferenzschaltung oder durch ein anderes Kommuni-

kationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, jeder Teilnehmer an der Sitzung kann alle andere verstehen.
Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise entspricht einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der Stimmen seiner auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder ver-

tretenen Mitglieder gefasst.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch durch Rundschreiben mittels einer oder mehrerer schrift-

licher, durch Faksimileübertragung oder andere Kommunikationsmittel (eine Kopie ist ausreichend) belegter Unterlagen
gefasst werden, vorausgesetzt solche Beschlüsse werden schriftlich bestätigt; die Gesamtheit der Unterlagen bildet das
Protokoll das als Nachweis der Beschlussfassung gilt.

Art. 11. Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder, in seiner Abwesen-

heit, vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder
Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche im Interesse der Gesellschaft sind. Der Verwaltungsrat hat sämtliche Befug-
nisse, welche durch das Gesetz oder durch diese Satzung nicht ausdrücklich der Hauptversammlung vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können ge-

mäß Artikel sechzig des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert, auf ein oder meh-
rere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungsberechtigte,
welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und alleinzeichnungsberechtigt sein können, übertragen werden.
Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des Verwaltungsrates geregelt. Die
Übertragung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Hauptversammlung vorab genehmigt werden.

Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte Voll-

macht übertragen.

Art. 13. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch

Einzelunterschrift jeder entsprechend vom Verwaltungsrat bevollmächtigten Person(en) verpflichtet.

Art. 14. Die Verwaltungsratsmitglieder haften nicht persönlich aufgrund ihres Mandates für Verbindlichkeiten welche

sie im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangen sind. Sie handeln lediglich als Bevollmächtigte der Gesellschaft
und sind daher ausschließlich für die Ausübung ihres Mandates verantwortlich.

Die Gesellschaft entschädigt auf die im weitest möglichen Sinne nach Luxemburger Recht zulässige Art und Weise

jedes Mitglied des Verwaltungsrates, seine Erben, Testamenvollstrecker oder Verwalter für angemessene Kosten die im
Zusammenhang mit jeder Handlung, jedem Prozess oder Verfahren in denen er wegen seiner Mitgliedschaft im Verwal-
tungsrat als Partei beteiligt ist oder war, entstanden sind. Das hiervor aufgeführte Recht auf Entschädigung schließt an-
dere Rechte die dem Verwaltungsratsmitglieder zustehen sollten nicht aus.

Die Gesellschaft übernimmt die Kosten jeder Person, die hierdurch Recht auf Entschädigung hat in Verbindung mit

jedem Verfahren, vor dem endgültigen Urteil, insofern die Gesellschaft eine schriftliche und rechtskräftige Verpflichtung
dieser Person erhält, den Vorschussbetrag zurückzuerstatten, im Fall einer endgültigen Feststellung, dass kein Recht auf
Entschädigung von der Gesellschaft besteht. Alleine durch die Beendigung einer Handlung, eines Prozesses oder eines
Verfahrens durch ein Urteil, eine Anweisung, Beilegung, Verurteilung oder nolo contendere oder gleichwertige Vertei-
digung, entsteht nicht die Vermutung, dass die Person, welche Recht auf Entschädigung hat, den Benehmensstandart,
durch den das Entschädigungsrecht entsteht, nicht eingehalten hat. Die Gesellschaft wird eine Barzahlung an den Ent-
schädigungsberechtigten machen, in gleicher Höhe wie die von ihm eingegangene entschädigungsberechtigte Verpflich-
tungen, sofort nach Erhalt der Mitteilung einer Entschädigungspflicht von dem Entschädigungsberechtigten, unterstützt
von den Informationen welche die Gesellschaft vernünftigerweise fordern kann.

E. Überwachung der Gesellschaft

Art. 15. Die Gesellschaft unterliegt der Überwachung durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktio-

näre der Gesellschaft sein müssen. Die Hauptversammlung ernennt diese Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und
setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates, die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer
können mehrmals hintereinander ernannt werden.

F. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 16. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines jeden Jahres.

65315

Art. 17. Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des Reingewinnes der Gesellschaft vorab den gesetzlichen

Rücklagen zugeführt bis diese zehn Prozent (10%) des in Artikel 5 dieser Satzung vorgesehenen Gesellschaftskapitals,
wie gemäß Artikel 5 erhöht oder herabgesetzt, betragen. 

Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des rest-

lichen Betrages des Reingewinns. Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdi-
videnden ausschütten.

G. Auflösung der Gesellschaft

Art. 18. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidation durch eine

oder mehrere Liquidatoren, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt. Die Hauptver-
sammlung ernennt diese Liquidatoren und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest. 

H. Satzungsänderung

Art. 19. Die gegenwärtige Satzung kann von einer Hauptversammlung der Aktionäre geändert werden, unter Beach-

tung der Anwesenheitsquoten gemäß Artikel 67-1 des Gesetzes vom 10. August 1915 bestimmend über Handelsgesell-
schaften, wie abgeändert, und der einstimmigen Zustimmung der Aktionäre.

I. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 20. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gilt das Gesetz vom 10. August 1915

bestimmend über Handelsgesellschaften, wie abgeändert.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2004.
2) Die erste jährliche Hauptversammlung wird im Kalenderjahr 2005 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Die Gründer haben die auszugebenden Aktien wie folgt gezeichnet:
1) BAIN CAPITAL FUND VII-E UK, L.P., vorgenannt,
hat EUR 3.875,- gezahlt und 12.400 Aktien gezeichnet;
2) BAIN CAPITAL FUND VII, L.P., vorgenannt,
hat EUR 3.875,- gezahlt und 12.400 Aktien gezeichnet;
Insgesamt: EUR 7.750,- eingezahlt für 24.800 Aktien.
Alle Aktien wurden für ein Viertel in bar einbezahlt; demgemäß verfügt die Gesellschaft ab sofort uneingeschränkt

über einen Betrag von siebentausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 7.750,-) wie dies dem unterzeichneten Notar
nachgewiesen wurde.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, wie abgeändert, erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf ungefähr tausend fünf hundert Euro. 

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Sodann haben die Erschienenen, die das gesamte Kapital vertreten, sich zu einer außerordentlichen Hauptversamm-

lung der Aktionäre, zu der sie sich als ordentlich einberufen erklären, zusammengefunden. Nachdem die Gültigkeit der
Zusammensetzung nachgeprüft wurde, hat die Hauptversammlung einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf vier (4) festgelegt. Die Zahl der Rechnungsprüfer wird auf einen

(1) festgelegt.

2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Paul Edgerley, managing director, wohnhaft in 119 Hyslop Road, Brookline, MA 02146, U.S.A., geboren am 12. De-

zember 1955 in den U.S.A.

b) Steve Barnes, managing director, wohnhaft in One Old Colony drive, Dover, MA 02030, U.S.A., geboren am 6.

April 1960 in den U.S.A.

c) Michel Plantevin, managing director, wohnhaft in 16 Belsize Crescent, London MW3 5QU, Groß-Britannien, gebo-

ren am 24. Oktober 1956 in Marseilles, Frankreich.

d) Ailbhe Jennings, director, wohnhaft in 17 rue du Verger, L-5372 Schuttrange, Luxemburg, geboren am 27. März

1963 in Dublin, Irland.

3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt: PricewaterhouseCoopers mit Sitz in L-1471 Luxemburg, 400, route d’Esch.
4. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-5365 Munsbach, 5, Parc d’Activité Syrdall.
5. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Hauptversammlung die über

die jährliche Konten zum 31. Dezember 2004 entscheidet oder zu dem von der Hauptversammlung beschlossenen Zeit-
punkt.

6. Gemäß Artikel 60 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften bestimmend, wie abgeändert,

ermächtigt die Hauptversammlung den Verwaltungsrat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäfts-
führung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.

65316

Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Par-

teien, diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von
Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben dieselben mit dem Notar gegen-

wärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: M. Elvinger, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, vol. 141S, fol. 49, case 12.– Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081947.3/211/461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.507.

In the year two thousand and three, on the twenty-first day of November.
Before Us, Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Mondorf-les-Bains.

There appeared:

For an extraordinary general meeting of the sole shareholder of PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen,
registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B 67.507 (the Company).

PRADA HOLDING N.V., a company incorporated and organized under the laws of the Netherlands, having its reg-

istered office at Dam 3-7, 1012 JS, Amsterdam, the Netherlands,

here represented by Mr Vivian Walry, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on 19 No-

vember 2003.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. PRADA HOLDING N.V. is the sole shareholder of the Company.

II. The agenda of the Meeting is as follows:
1. Change of the accounting year of the Company which ran from January 1, 2002 up to and including December 31,

2002 as to have it end in November 30, 2002 and subsequently having an accounting year starting on December 1 of
each year and ending on November 30 of each year;

2. Amendment of article 9 of the articles of association of the Company to reflect the above change of accounting

year as follows:

«The Company’s accounting year runs from the first day of December to the last day of November of each year, for

the first time as of December 1, 2002.»

III. The sole shareholder has taken the following resolutions: 

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the accounting year of the Company which ran from January 1, 2002 up to

and including December 31, 2002 as to have it end on November 30, 2002 and subsequently have an accounting year
starting on December 1 of each year and ending on November 30 of each year.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the sole shareholder resolves to amend article 9 of the articles of associ-

ation of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

«Art. 9. The Company’s accounting year runs from the first day of December to the last day of November of each

year, for the first time of December 1, 2002.»

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimated costs

The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this

deed, are estimated at approximately four hundred and fifty Euros (450.- EUR).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the

present original deed.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

J. Elvinger.

65317

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille trois, le vingt et un novembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, soussigné.

A comparu:

Pour une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., une société à

responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen, inscrite auprès du registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 67.507 (la Société).

PRADA HOLDING N.V., une société de droit néerlandais ayant son siège social à Dam 3-7, 1012 JS Amsterdam,

Pays-Bas, 

ici représentée par Monsieur Vivian Walry, avocat, résidant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 19

novembre 2003.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que le notaire

instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme il est dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter que:
I. PRADA HOLDING N.V. est l’associé unique de la Société;

II. la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Modification de l’année sociale de la Société ayant débuté le 1

er

 janvier 2002 et s’étant terminé le 31 décembre

2002 afin que celle-ci prenne fin le 30 novembre 2002 et ainsi que l’année social commence le 1

er

 décembre de chaque

année et se termine le 30 novembre de chaque année;

2) Modification de l’article 9 des statuts de la société pour refléter la modification d’année sociale comme suit:
«L’année sociale commence le premier jour de décembre et se termine le dernier jour de novembre de chaque année

à compter du 1

er

 décembre 2002.»

III. L’associé unique a pris les résolutions suivantes.

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier l’année sociale de la Société ayant débuté le 1

er

 janvier 2002 et s’étant terminée

le 31 décembre 2002 afin que celle-ci prenne fin le 30 novembre 2002 et ainsi que l’année sociale de la Société com-
mence le 1

er

 décembre de chaque année et se termine le 30 novembre de chaque année.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’associé unique décide de modifier l’article 9 des statuts de la Société,

qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 9. L’année sociale commence le premier jour de décembre et se termine le dernier jour de novembre de cha-

que année à compter du 1

er

 décembre 2002.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la Société en raison du présent acte est estimé approxi-

mativement à la somme de quatre cent cinquante euros (450,- EUR).

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française et ce cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée par le notaire instrumentant, la partie comparante a signé le présent

acte avec le notaire.

Signé: V. Walry, R. Arrensdorff.
Enregistré à Remich, le 1

er

 décembre 2003, vol. 467, fol. 35, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Molling.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081844.3/218/97) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

PRADA PARTICIPATION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.507. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081845.3/218/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Mondorf-les-Bains, le 3 décembre 2003.

R. Arrensdorff.

Luxembourg, le 4 décembre 2003.

R. Arrensdorff.

65318

PINDELLA HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 74.368. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 3 novembre 2003, les mandats des

administrateurs:

- Monsieur Gérard Birchen, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg; 
- Madame Sabine Plattner, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
- Madame Monique Juncker, 59, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
ont été renouvelés et prendront fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.
Cette même Assemblée a nommé aux fonctions de Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE INTERNATIONALE

S.A., 6-12, rue du Fort Wallis, L-2016 Luxembourg, en remplacement de COMCOLUX S.A. Son mandat prendra fin lors
de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2009.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00944. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081157.3/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

PARSIFLOR, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 10.316. 

L’Assemblée Générale Ordinaire du 4 novembre 2003 a ratifié la décision du Conseil d’Administration de nommer

aux fonctions d’administrateur UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., 27, avenue Monterey, L-2163 Luxem-
bourg, en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire
de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00949. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081159.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

IGNI, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 60.894.

L’an deux mille trois, le deux décembre
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

 S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société d’Investissement à Capital Variable

IGNI, avec siège social à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert, constituée suivant acte reçu par Maître Frank
Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 29 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 599 du 30 octobre 1997, et modifiée suivant acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire
de résidence à Luxembourg, en remplacement de son collègue empêché Maître Tom Metzler, prénommé, en date du 9
décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 57 du 21 janvier 2003,

immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous la section B et le numéro 60.894.

<i> Bureau

La séance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Michel Gelhay, directeur, demeurant à

Halanzy (Belgique).

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Mademoiselle Manuella Piron, employée privée, demeurant à Limer-

lé (Belgique).

L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Martine Vermeersch, employée privée, demeurant à Libramont

(Belgique).

Le bureau ayant ainsi été constitué, Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui

suit:

<i>Pour PINDELLA HOLDING S.A.
S. Plattner
<i>Administrateur

<i>Pour PARSIFLOR
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

65319

<i>Composition de l’assemblée

Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée ainsi que le nombre d’actions possédées par chacun d’eux ont

été portés sur une liste de présence, signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés,
et à laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence après avoir été signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Resteront pareillement annexées au présent acte, avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le
notaire instrumentant.

<i>Exposé de Monsieur le Président

Monsieur le Président expose et requiert le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I.- La présente assemblée a l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Refonte complète des statuts de la Société pour notamment:
1. Modification des Articles 4, 23, 28 et 32 des statuts de la Société pour remplacer toute référence à la loi du 30

mars 1988 relative aux organismes de placement collectif par une référence à la loi du 20 décembre 2002 concernant
les organismes de placement collectif.

2. Modification de l’Article 30 §9 et 10 des statuts de la Société pour y insérer une référence à la Partie II de la loi du

20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

II.- La présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés:
- au journal Luxemburger Wort des 12 et 21 novembre 2003;
- au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéros 1184 du 12 novembre 2003 et 1230 du 21 novembre

2003. 

Par convocation contenant l’ordre du jour pour la présente assemblée, adressée aux actionnaires nominatifs par let-

tre missive, le 12 novembre 2003.

Les numéros justificatifs de ces publications ont été posés au bureau pour inspection.

III.- Il résulte de la liste de présence que sur les 716.081 (sept cent seize mille quatre-vingt et une) actions actuellement

en circulation 1 (une) action est présente ou représentée.

L’assemblée, valablement convoquée, constate que le quorum de présence prévu par l’article 67-1 de la loi du 10 août

1915 telle que modifiée n’étant pas atteint, celle-ci ne peut valablement délibérer sur les points à l’ordre du jour. 

Conformément à ce même article, une nouvelle assemblée pourra être convoquée dans les formes statutaires, pour

délibérer aux conditions prévues par la loi sur les susdits points à l’ordre du jour.

<i>Clôture

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

<i>Frais

Le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société en raison des présentes, est estimé sans nul

préjudice à la somme de six cents euros (EUR 600,-).

Dont procès-verbal, fait et dressé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée à l’assemblée en langue d’elle connue, les membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, ont signé le présent procès-verbal avec
Nous, Notaire, aucun autre actionnaire n’ayant demandé à signer.

Signé: J.-M. Gelhay, M. Piron, M. Vermeersch, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, vol. 141S, fol. 54, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations.

(081849.3/222/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

LALLEMANG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4106 Esch-sur-Alzette, 7, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 19.589. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00259, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082000.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Luxembourg-Bonnevoie, le 8 décembre 2003.

T. Metzler.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2003.

Signature.

65320

CALLAWAY INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 56.242. 

L’Assemblée Générale Ordinaire tenue exceptionnellement en date du 3 novembre 2003 a ratifié la décision du Con-

seil d’Administration de nommer aux fonctions d’administrateur MONTEREY SERVICES S.A., 14, rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, en remplacement de Madame Isabelle Wieme. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Or-
dinaire de 2007.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 décembre 2003, réf. LSO-AL00954. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081160.3/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 63.634. 

In accordance with the minutes of the resolutions of the sole shareholder of CWE PROPERTY INVESTMENTS,

S.àr.l., dated 4 September 2003, it has been resolved to accept the resignations of Kenneth MacNaughton and Laura L.
Hamilton, resigning managers of the Company with effect from 15 August 2003, and to appoint Ryan Cregeen and Mar-
tin O’Grady as managers of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Accordingly, the board of managers of the Company is composed as follows: 

<i>Board of Managers:

- A. Richard Moore Jr.
- Ryan Cregeen
- Martin O’Grady
The company is bound by the sole signature of any manager.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

Faisant suite aux décisions prises par résolution de l’actionnaire unique de CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.,

du 4 septembre 2003, il a été décidé d’accepter les démissions de Kenneth MacNaughton et Laura L. Hamilton, gérants
démissionnaires de la Société avec effet au 15 août 2003 et de nommer Ryan Cregeen et Martin O’Grady en tant que
gérants de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Par conséquent, le Conseil de gérants est composé comme suit:

<i>Conseil de gérants: 

- A. Richard Moore Jr.
- Ryan Cregeen
- Martin O’Grady
La Société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant unique. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01927. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081206.3/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

IMMOBILIERE HORTENSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 22.833. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00256, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082002.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

<i>Pour CALLAWAY INVEST S.A.
MONTEREY SERVICES S.A.
<i>Administrateur
Signatures

<i>On behalf of CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.
Signature
<i>Manager

<i>Au nom de CWE PROPERTY INVESTMENTS, S.à r.l.
Gérant

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2003.

Signature.

65321

PAUPINAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.349. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01411, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081180.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

PAUPINAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.349. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01414, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

(081219.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

PAUPINAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.349. 

<i>Extrait des minutes de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, qui s’est tenue le 3 décembre 2003

A l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de PAUPINAL HOLDING S.A. (la «Société»), il a été décidé comme

suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes au 31 décembre 2000,
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2000;
- d’allouer la perte de l’exercice de EUR 4.689,87 dans le compte perte à reporter;
- d’accorder décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour toutes les opéra-

tions effectuées jusqu’au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 3 décembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 4 décembre 2003, réf. LSO-AL01410. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081181.2//20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

AMI CONSULT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2714 Luxembourg, 6-12, rue du Fort Wallis.

R. C. Luxembourg B 79.527. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire du 26 novembre 2003 a pris la résolution suivante:
1) Le siège social est transféré du 243, Val des Bons Malades à L-2121 Luxembourg au 6-12, rue du Fort Wallis à L-

2714 Luxembourg et ce avec effet immédiat.

Luxembourg, le 26 novembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00212. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081955.3/664/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

Pour extrait sincère et conforme
M. Dekkers
<i>Le gérant

65322

SHELTON PROPERTIES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1717 Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 66.977. 

In accordance with the minutes of the resolutions of the sole shareholder of SHELTON PROPERTIES, S.à r.l., dated

4 September 2003, it has been resolved to accept the resignations of Kenneth MacNaughton and Laura L. Hamilton,
resigning managers of the Company with effect from 15 August 2003, and to appoint Ryan Cregeen and Martin O’Grady
as managers of the Company with immediate effect and for an unlimited term of office.

Accordingly, the board of managers of the Company is composed as follows: 

<i>Board of Managers:

- A. Richard Moore Jr.
- Ryan Cregeen
- Martin O’Grady
The company is bound by the sole signature of any manager. 

Suit la traduction française du texte qui précède: 

Faisant suite aux décisions prises par résolution de l’actionnaire unique de SHELTON PROPERTIES, S.à r.l., du 4 sep-

tembre 2003, il a été décidé d’accepter les démissions de Kenneth MacNaughton et Laura L. Hamilton, gérants démis-
sionnaires de la Société avec effet au 15 août 2003 et de nommer Ryan Cregeen et Martin O’Grady en tant que gérants
de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Par conséquent, le Conseil de gérants de la Société est composé comme suit:

<i>Conseil de gérants: 

- A. Richard Moore Jr.
- Ryan Cregeen
- Martin O’Grady
La Société est valablement engagée par la signature individuelle d’un gérant unique. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 décembre 2003, réf. LSO-AL01928. – Reçu 16 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(081208.3/250/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 décembre 2003.

TRANSCOM WorldWide S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.528. 

 In the year two thousand and three, on the fourth of December, 
 Before Us, Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich.

 Has appeared:

 Mr Tom Loesch, maître en droit, residing in Luxembourg, acting as a special attorney in fact of the Board of Directors

of the limited liability company TRANSCOM WorldWide S.A., having its registered office at L-8080 Bertrange, 75, route
de Longwy, incorporated on June 11, 1997 pursuant to a deed of notary Reginald Neuman, then residing in Luxembourg,
published in the Mémorial C N

°

 494 on September 11, 1997, and entered in the Register of Commerce and Companies

in Luxembourg, Section B, under the number B 59.528, the Articles of Association of which were last amended by a
deed of the undersigned notary, on September 23rd, 2003, not yet published in the Mémorial C (the «Company»),

 by virtue of the powers conferred on him by decisions of the Board of Directors of the Company adopted on Sep-

tember 29, 2003.

 A copy of these decisions having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall

remain attached to the present deed and be registered with the present deed.

 The appearing person acting in his afore-mentioned capacity has requested the notary to record the following dec-

larations and facts:

I. The authorised share capital of the Company is set at six hundred fifty-two million seven hundred ninety-three

thousand four hundred euros (EUR 652,793,400.-), divided into one billion one hundred million (1,100,000,000) Class
A voting shares and one billion (1,000,000,000) Class B non-voting shares, each without par value.

II. The Company has an issued capital of twenty-six million one hundred and eighty-one thousand two hundred and

twenty-one euros and sixty-eight cent (EUR 26,181,221.68), divided into thirty-five million ninety-one thousand six hun-
dred and sixty-six (35,091,666) Class A voting shares, each without par value, and thirty-four million three hundred and
seventy-eight thousand one hundred and fifty-nine (34,378,159) Class B non voting shares, each without par value, all
shares being fully paid-in.

III. Article 5, paragraphs 4, 5 and 6 of the Articles of Incorporation of the Company read as follows: 
 «The board of directors is authorised and empowered to:

<i>On behalf of SHELTON PROPERTIES, S.à r.l.
Signature
<i>Manager

<i>Au nom de SHELTON PROPERTIES, S.à r.l.
Gérant

65323

- realise any increase of the corporate capital within the limits of the authorised capital in one or several successive

tranches, by the issuing of new shares, against payment in cash or in kind, by conversion of claims or in any other manner;

- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the

subscription of and paying up on the new shares; and

- remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue of shares against payment in

cash.

 This authorisation is valid for a period expiring 5 (five) years after the date of publication of the deed restating the

Articles of Association of the Company and it may be renewed by a general meeting of shareholders for those shares
of the authorised corporate capital which up to then will not have been issued by the board of directors.

 Following each increase of the corporate capital realised and duly stated in the form provided for by law, the first

paragraph of this article 5 will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded in
authentic form by the board of directors or by any person duly authorised and empowered by it for this purpose.» 

IV. By the circular resolutions adopted on September 29, 2003 the Board of Directors having received evidence of

the payment of an amount of three hundred and twenty-five thousand eight hundred and sixty euros (EUR 325,860.-)
to the Company, resolved to increase within the limits of the authorised share capital the issued corporate capital of
the Company by an amount of three hundred and twenty-five thousand eight hundred and sixty euros (EUR 325,860.-)
represented by three hundred thousand (300,000) new Class B shares, each without par value and to allot the new
shares so issued within the authorised capital to JOSLIN FINANCE, a company incorporated in the British Virgin Islands,
with registered office at 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor, Wickhams Cay, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands. 

V. Proof has been given to the undersigned notary that the Company has received an amount of three hundred and

twenty-five thousand eight hundred and sixty euros (EUR 325,860.-) as subscription moneys for the duly subscribed new
shares.

VI. Following the abovementioned share capital increase article 5, paragraph 1, of the Articles of Incorporation of the

Company be amended and shall forthwith read as follows: 

 «The Company has an issued capital of twenty-six million five hundred and seven thousand eighty-one euros and

sixty-eight cent (EUR 26,507,081.68), divided into thirty-five million ninety-one thousand six hundred and sixty-six
(35,091,666) Class A voting shares, each without par value, and thirty-four million six hundred and seventy-eight thou-
sand one hundred and fifty-nine (34,678,159) Class B non voting shares, each without par value, all shares being fully
paid-in.»

<i> Déclaration - Valuation - Expenses

 The undersigned notary declares, by application of Article 32-1 of the law on commercial companies of 10th August

1915, as amended, that he has examined the conditions imposed by Article 26 of the aforesaid law.

 The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the aforesaid capital in-

crease are estimated at 4,900.- EUR.

 Whereas the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
 The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

 The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with Us, notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille trois, le quatre décembre.
 Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich,

 A comparu:

 M. Tom Loesch, maître en droit, demeurant à Luxembourg, agissant en qualité de mandataire spécial du Conseil

d’Administration de la société anonyme TRANSCOM WorldWide S.A., ayant son siège social à L-8080 Bertrange, 75,
route de Longwy, constituée le 11 juin 1997 par acte de M

e

 Reginald Neuman, alors notaire, de résidence à Luxembourg,

publié au Mémorial C N

°

 494 du 11 septembre 1997, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg, section B, Numéro B 59.528 et dont les statuts furent modifiés la dernière fois par acte du notaire soussigné le
23 septembre 2003, non encore publié au Mémorial C (la «Société»),

 en vertu des pouvoirs lui conférés par les décisions du Conseil d’Administration de la Société adoptées le 29 sep-

tembre 2003. 

 Une copie des décisions paraphée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné restera annexée à l’original

du présent acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

 Le comparant agissant en sa qualité mentionnée ci-dessus a prié le notaire d’acter les déclarations et faits suivants:
I. Le capital social autorisé de TRANSCOM WorldWide S.A. est fixé à six cent cinquante-deux millions sept cent

quatre-vingt-treize mille quatre cent euros (EUR 652.793.400,-), divisé en un milliard cent millions (1.100.000.000) ac-
tions de Classe A avec droit de vote, et un milliard (1.000.000.000) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans
valeur nominale. 

II. Le capital social émis de la Société est de vingt-six millions cent quatre-vingt-un mille deux cent vingt et un euros

et soixante-huit centimes (EUR 26.181.221,68), divisé en trente-cinq millions quatre-vingt-onze mille six cent soixante-
six (35.091.666) actions de Classe A avec droit de vote et trente-quatre millions trois cent soixante-dix-huit mille cent

65324

cinquante-neuf (34.378.159) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement
libérées.

III. Les alinéas 4, 5 et 6 de l’article 5 des Statuts de la Société ont la teneur suivante:
 «Le conseil d’administration est autorisé à et mandaté de:
 - réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital social autorisé en une ou plusieurs tranches

successives, par l’émission d’actions nouvelles, contre le paiement en espèces ou en nature, par conversion de créance
ou de toutes autres manières;

 - fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d’émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles; et

 - supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d’émission d’actions contre paie-

ment en espèces.

 Cette autorisation est valable pour une période expirant 5 (cinq) ans après la date de publication des présents Statuts

reformulés de la Société et elle peut être renouvelée par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du
capital social autorisé qui d’ici là n’auraient pas été émises par le conseil d’administration.

 A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

du présent article se trouve modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera
constatée dans la forme authentique par le conseil d’administration ou par toute personne qu’il aura mandatée à ces
fins.» 

IV. Par résolutions circulaires adoptées le 29 septembre 2003, le Conseil d’Administration ayant reçu la preuve du

paiement d’une somme de trois cent vingt-cinq mille huit cent soixante euros (EUR 325.860,-) à la Société a décidé
d’augmenter le capital de la Société dans le cadre du capital autorisé d’un montant de trois cent vingt-cinq mille huit cent
soixante euros (EUR 325.860,-) représenté par trois cent mille (300.000) nouvelles actions de Classe B, sans valeur no-
minale et d’attribuer les actions nouvelles émises dans le cadre du capital autorisé à JOSLIN FINANCE, une société cons-
tituée aux Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social 325 Waterfront Drive, Omar Hodge Building, 2nd Floor,
Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.

V. La preuve que la Société a reçu le montant de trois cent vingt cinq mille huit cent soixante euros (EUR 325.860)

en contrepartie des actions nouvelles ainsi souscrites a été apportée au notaire soussigné.

VI. Suite à l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus, l’article 5 alinéa 1 des Statuts de la Société sera modifié et

aura dorénavant la teneur suivante:

«Le capital social émis de la Société est de vingt-six millions cinq cent sept mille quatre-vingt-un euros et soixante-

huit centimes (EUR 26.507.081,68), divisé en trente-cinq millions quatre-vingt-onze mille six cent soixante-six
(35.091.666) actions de Classe A avec droit de vote et trente-quatre millions six cent soixante-dix-huit mille cent cin-
quante-neuf (34.678.159) actions de Classe B sans droit de vote, chacune sans valeur nominale, toutes entièrement li-
bérées.»

<i> Déclaration - Evaluation - Dépenses

 Le notaire soussigné déclare qu’en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août

1915 telle que modifiée, il a examiné les conditions imposées par l’article 26 de la loi ci-avant mentionnée.

 Les frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la Société en raison de la présente augmentation de

capital, sont évalués à 4.900,- EUR.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Le notaire soussigné qui parle et comprend la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande du même com-
parant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera. 

 Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom,

prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Loesch, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 5 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 31, case 5.– Reçu 3.258,60 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(081619.3/206/145) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

TRANSCOM WorldWide S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 75, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 59.528. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081621.3/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Luxembourg-Eich, le 8 décembre 2003.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Le notaire

65325

KÄFER GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.534. 

L’an deux mil trois, le vingt-neuf septembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KÄFER GESELLSCHAFT S.A., avec siège

social à L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf, constituée originairement sous la dénomination LES TULIPES S.A. suivant
acte notarié en date du 8 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1196 du 19
décembre 2001, dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié, en date du 26 octobre 2001, publié au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations C numéro 374 du 7 mars 2002.

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Caroline Meyers, employée privée, demeurant à Contern,
qui désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant à B-Chantemelle.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick Eschette, docteur en sciences économiques, demeurant à

Esch-sur-Alzette.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Transfert du siège de la société de L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard

Royal et changement subséquent de l’article 1

er

 alinéa 2 première phrase.

2. Révocation de deux des trois administrateurs actuels de la société et nomination de deux nouveaux administra-

teurs.

3. Révocation du commissaire aux comptes actuel et nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
4. Divers.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transférer le siège de la société de L-1638 Senningerberg, 78, rue du Golf à L-2449

Luxembourg, 25B, boulevard Royal (B.P. 282, L-2012 Luxembourg) et de modifier en conséquence l’article 1

er

 alinéa 2

première phrase des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Alinéa 2, 1

ère

 phrase:

Cette société a son siège à Luxembourg.»

<i> Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer deux des trois administrateurs actuels de la société à savoir:
- Monsieur Romain Schmit, administrateur, demeurant à L-7651 Heffingen, 12, um Knaeppchen, nommé à ces fonc-

tions lors de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2002,

- Monsieur Thomas Büchner, banquier, demeurant à D-01277 Dresden, Rosenbergstrasse 12, lors de la seconde as-

semblée générale extraordinaire du 15 mai 2002.

et de leur donner décharge entière et définitive pour l’exercice de leur mandat jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer deux nouveaux administrateurs:
 - Monsieur Philippe Penning, avocat, né à Luxembourg, le 11 septembre 1968, demeurant professionnellement à L-

2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal,

- Monsieur Jim Penning, avocat, né à Luxembourg, le 12 mai 1942, demeurant professionnellement à L-2449 Luxem-

bourg, 25B, boulevard Royal.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de la société de l’an-

née 2009.

L’assemblée générale confirme Monsieur Patrick Eschette, administrateur de société, né à Luxembourg, le 28 décem-

bre 1971, demeurant à L-5867 Fentange, 22, Ceinture Beau-Site dans ses fonctions d’administrateur de la Société et
d’administrateur-délégué.

<i> Quatrième résolution

L’assemblée générale décide de révoquer l’actuel commissaire aux comptes:
Monsieur Paul Glesener, expert-comptable, demeurant à Mamer,
et de lui donner décharge pour l’exercice de son mandat jusqu’à ce jour.

65326

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes:
Monsieur René Moris, expert-comptable, né le 22 mars 1948 à Luxembourg, demeurant à L-1853 Luxembourg-

Cents, 24, rue Léon Kauffman.

Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé se terminera lors de l’assemblée générale annuelle de la société

de l’année 2009.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ six cents euros (600,- EUR).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Meyers, A. Braquet, P. Eschette, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 8 octobre 2003, vol. 140S, fol. 92, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): T. Kirsch.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081890.3/220/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

KÄFER GESELLSCHAFT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 82.534. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081892.3/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.350. 

In the year two thousand and three, on the twenty-seventh of November.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of

BALTIC ASSETS S.A., R.C. Luxembourg N

°

 B 53.350, having its registered office in Luxembourg, incorporated pursuant

to a deed of the undersigned notary dated December 13, 1995, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations N

°

 106 of March 1, 1996.

The Articles of Incorporation have been amended several times and lastly pursuant to a deed of the undersigned no-

tary dated December 5, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 30 of January 13,

2003.

The meeting begins at four-thirty p.m., Mr Stéphane Das, private employee, with professional address at 6, rue Adol-

phe Fischer, L-1520 Luxembourg, being in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Frank Stolz-Page, private employee, with professional address

at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, «maître en droit», with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg.

The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the two million four

hundred and twenty-four thousand (2,424,000) shares of a par value of one point twenty-five (1.25) Pounds Sterling
each, representing the total capital of three million and thirty thousand (3,030,000.-) Pounds Sterling are duly represent-
ed at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, herein-
after reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the shareholders all represented at the meeting, shall remain attached to the present

deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1. To change the financial year-end of the Company from December 31 to October 31.
2. To change the date and time of the annual general meeting to the third Thursday in the month of March at 3.00 p.m.
3. To subsequently amend Articles 23.1 and 25 of the Articles of Incorporation of the Company.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passes, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 30 octobre 2003.

G. Lecuit.

65327

<i>First resolution

The Company’s financial year-end is changed from December 31 to October 31, so that the financial year which began

on January 1, 2003 has ended on October 31, 2003, and that the following financial year has begun on November 1,
2003 and will end on October 31, 2004.

<i>Second resolution

The date and time of the annual general meeting are changed to the third Thursday in the month of March at 3.00 p.m.

<i>Third resolution

As a consequence of the two preceding resolutions, Articles 23.1 and 25 of the Articles of Incorporation are amended

and shall henceforth read as follows:

«Art. 23.1 A General Meeting shall be held at the registered office on the third Thursday in the month of March at

3.00 p.m. or at any other place indicated in the convening notice of the meeting. If this day is not a Business Day, the
meeting will take place on the first Business Day thereafter at the same time.»

«Art. 25. The Corporation’s financial year shall begin on November 1 of each year and end on October 31 of the

following year.»

Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at five p.m.

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergencies between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated to the persons appearing, said persons appearing signed with Us, the

notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille trois, le vingt-sept novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société établie et avec siège social à Luxem-

bourg sous la dénomination de BALTIC ASSETS S.A., R.C. Luxembourg B N

°

 53.350, constituée suivant acte reçu par

le notaire instrumentaire en date du 13 décembre 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

106 du 1

er

 mars 1996.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 5 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N

°

 30 du 13

janvier 2003. 

La séance est ouverte à seize heures trente sous la présidence de Monsieur Stéphane Das, employé privé, avec adres-

se professionnelle au 6, rue Adolphe Fischer, L-1520 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, avec adresse profession-

nelle au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, avec adresse professionnelle au 74, ave-

nue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I. Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les deux millions

quatre cent vingt-quatre mille (2.424.000) actions d’une valeur nominale d’une virgule vingt-cinq livre Sterling, consti-
tuant l’intégralité du capital social de trois millions trente mille (3.030.000,-) livres Sterling, sont dûment représentées à
la présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convo-
cation préalable après avoir pris connaissance de l’ordre du jour.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés restera annexée au présent procès-

verbal, ensemble avec les procurations, pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

II. Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de changer la fin de l’année sociale de la Société du 31 décembre au 31 octobre.
2. Décision de changer la date et l’heure de l’assemblée générale annuelle au troisième jeudi du mois de mars à 15.00

heures.

3. Décision de modifier en conséquence les articles 23.1 et 25 des statuts de la Société.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, après s’être reconnue régulièrement cons-

tituée, aborde l’ordre du jour et prend, après délibération, à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La fin de l’année sociale de la Société est changée du 31 décembre au 31 octobre, de sorte que l’année sociale qui a

commencé le 1

er

 janvier 2003 s’est terminée le 31 octobre 2003, et que l’année sociale suivante a commencé le 1

er

 no-

vembre 2003 et se terminera le 31 octobre 2004.

<i>Deuxième résolution

La date et l’heure de l’assemblée générale annuelle sont changées au troisième jeudi du mois de mars à 15.00 heures.

65328

<i>Troisième résolution

En conséquence des deux résolutions qui précèdent, les articles 23.1 et 25 des statuts de la Société sont modifiés

pour avoir désormais la teneur suivante:

«Art. 23.1. Une Assemblée Générale sera tenue au siège social le troisième jeudi du mois de mars à 15.00 heures

ou à tout autre endroit indiqué dans l’avis de convocation à l’Assemblée. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assem-
blée aura lieu le premier jour ouvrable suivant à la même heure.»

«Art. 25. L’exercice social de la Société commencera le 1

er

 novembre de chaque année et se terminera le 31 octobre

de l’année suivante.» 

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-sept heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants ceux-ci ont signé avec nous Notaire la présente mi-

nute.

Signé: S. Das, F. Stolz-Page, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2003, vol. 19CS, fol. 25, case 10.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081687.3/230/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

BALTIC ASSETS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 6, rue Adolphe Fischer.

R. C. Luxembourg B 53.350. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1603 du 27 novembre 2003 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(081690.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

ADAM’S ART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3569 Dudelange, 58, rue de Tattenberg.

R. C. Luxembourg B 67.723. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00249, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082008.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

G.T. BIJOUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 95, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 45.123. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 1

er

 décembre 2003, réf. LSO-AL00252, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(082011.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 2003.

Luxembourg, le 8 décembre 2003.

A. Schwachtgen.

A. Schwachtgen.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2003.

Signature.

Esch-sur-Alzette, le 8 décembre 2003.

Signature.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Imagine, S.à r.l.

SangStat Luxembourg, S.à r.l.

SangStat Luxembourg, S.à r.l.

Larchmont Holding S.A.

Larchmont Holding S.A.

Larchmont Holding S.A.

Topaze Finance, S.à r.l.

Topaze Finance, S.à r.l.

Topaze Finance, S.à r.l.

Valley S.A.

Bullstrode Continental, S.à r.l.

Bullstrode Continental, S.à r.l.

Interfer

Keepint International S.A.

Keepint International S.A.

O.A.C.C., S.à r.l.

O.A.C.C., S.à r.l.

O.A.C.C., S.à r.l.

Levlux S.A.

Semerca Investments S.A.

Semerca Investments S.A.

Panna-Com Invest S.A.

Panna-Com Invest S.A.

Panna-Com Invest S.A.

Prada S.A.

Prada S.A.

Nouvelle Hostellerie de la Gare S.A.

A.2.Z

Transmex S.A.

Yule Catto Pharma Holdings, S.à r.l.

Infralux Real Estate Company, S.à r.l.

Infralux Real Estate Company, S.à r.l.

Brenntag-Interfer

Prada Participation, S.à r.l.

Prada Participation, S.à r.l.

Pindella Holding S.A.

Parsiflor

IGNI

Lallemang, S.à r.l.

Callaway Invest S.A.

CWE Property Investments, S.à r.l.

Immobilière Hortense, S.à r.l.

Paupinal Holding S.A.

Paupinal Holding S.A.

Paupinal Holding S.A.

Ami Consult, S.à r.l.

Shelton Properties, S.à r.l.

Transcom WorldWide S.A.

Transcom WorldWide S.A.

Käfer Gesellschaft S.A.

Käfer Gesellschaft S.A.

Baltic Assets S.A.

Baltic Assets S.A.

Adam’s Art, S.à r.l.

G.T. Bijoux, S.à r.l.