This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
62257
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1298
5 décembre 2003
S O M M A I R E
ABF Hyde Park Investments & Co S.N.C., Luxem-
Lollipop, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62261
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62266
Lollipop, S.à r.l., Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62261
Absolute Ventures S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . .
62289
Maine S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62279
Absolute Ventures S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . .
62293
Margil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62277
Agence Immobilière Hélène Grober, S.à r.l., Ei-
Margil S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62277
schen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62260
Medex, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62277
APL, Auto-Parts Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Medic International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . .
62273
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62259
Mercantile Venture S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
62260
Artemis Information Management S.A., Luxem-
Murhold S.A., Livange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62266
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62300
Nei Haus S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62259
Artemis Information Management S.A., Luxem-
Optique Steffen S.A., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . .
62261
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62304
Optis S.A., Bergem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62261
Bestseller Retail Luxembourg, S.à r.l., Luxem-
Peinture Dewald, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . .
62260
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62258
PK Diffusion, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . .
62258
Bufo Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
62298
Power Transmission Finance S.A., Luxembourg. .
62294
Cada, S.à r.l., Leudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62258
Power Transmission Finance S.A., Luxembourg. .
62294
Chimera S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62304
Power Transmission Finance S.A., Luxembourg. .
62294
Concordia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
62260
R.I.I. S.A., Recherche et Investissements Interna-
Concordia Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
62260
tionaux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62259
G.L. et F. Simone & Fils Immobilière, S.à r.l., Lu-
R.I.I. S.A., Recherche et Investissements Interna-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62299
tionaux, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62259
G.L. et F. Simone & Fils Immobilière, S.à r.l., Lu-
R.P.M. Invest, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .
62277
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62299
Saft Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
62297
Gerfed Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
62298
Service Photo Luxembourg S.A., Luxembourg. . .
62258
Hutchison Whampoa 3G IP, S.à r.l., Luxembourg .
62262
SSCP Plastics Holding S.C.A., Luxembourg . . . . .
62286
I.T.T. S.A., International Trading Transport S.A.,
Standard Fund Management (Luxembourg) Um-
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62299
brella Fund, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
62264
International Trading Transport S.A., Luxem-
Tradingcom International S.A., Luxembourg . . . .
62261
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62299
Twopp S.A.H., Hesperange . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62294
International Trading Transport S.A., Luxem-
Twopp S.A.H., Hesperingen . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62293
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62299
United Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
62304
International Trading Transport S.A., Luxem-
United Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
62304
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62299
United Finance Holding S.A., Luxembourg . . . . . .
62304
Komiton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
62295
Welfort International Holding S.A., Luxembourg
62285
Komiton Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
62297
Welfort International Holding S.A., Luxembourg
62285
KV Associates S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
62300
62258
CADA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3355 Leudelange, 140, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 43.473.
Constituée par-devant M
e
Paul Bettingen, notaire de résidence à Wiltz, en date du 24 mars 1993, acte publié au
Mémorial C n
°
295 du 19 juin 1993, capital converti en euros suivant avis publié au Mémorial C n
°
168 du 31 janvier
2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05265, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2003.
(076916.3//16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
PK DIFFUSION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3355 Leudelange, 140, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 38.219.
Constituée par-devant M
e
Paul Bettingen, notaire de résidence à Wiltz, en date du 14 octobre 1991, acte publié au
Mémorial C n
°
111 du 28 mars 1992, modifiée par-devant le même notaire en date du 3 avril 1992, acte publié au
Mémorial C n
°
405 du 16 septembre 1992, modifiée par-devant le même notaire de résidence à Niederanven, en
date du 28 décembre 2000, acte publié au Mémorial C n
°
886 du 16 octobre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05267, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2003.
(076918.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 2, rue Alphonse Weicker.
R. C. Luxembourg B 55.878.
Constituée par-devant M
e
Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage, en date du 19 juillet 1996, acte publié au
Mémorial C n
°
553 du 29 octobre 1996, modifiée par-devant le même notaire, en date du 30 mai 2001, acte publié
au Mémorial C n
°
1176 du 17 décembre 2001, modifiée par acte sous seing privé, en date du 4 octobre 2001, avis
afférent publié au Mémorial n
°
321 du 27 février 2002.
—
Le bilan au 31 mai 2003, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05270, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 novembre 2003.
(076919.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
BESTSELLER RETAIL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 89-93, Grand-rue.
R. C. Luxembourg B 89.710.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05151, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076923.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
<i>Pour CADA, S.à r.l.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature
<i>Pour PK DIFFUSION, S.à r.l.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature
<i>Pour SERVICE PHOTO LUXEMBOURG S.A.
i>KPMG EXPERTS COMPTABLES, S.à r.l.
Signature
Wiltz, le 24 novembre 2003.
Signature.
62259
NEI HAUS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1328 Luxembourg, 6, rue Charlemagne.
R. C. Luxembourg B 65.772.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05170, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076924.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
APL, AUTO-PARTS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1320 Luxembourg, 70, rue de Cessange.
R. C. Luxembourg B 6.023.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04372, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(076925.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
R.I.I. S.A., RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.561.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 20
décembre 1989, acte publié au Mémorial C n
°
223 du 5 juillet 1990, modifiée par-devant le même notaire en date
du 19 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n
°
213 du 14 mai 1991, modifiée par-devant le même notaire en
date du 18 décembre 1991, acte publié au Mémorial C n
°
237 du 3 juin 1992, modifiée par-devant le même notaire
en date du 6 août 1992, acte publié au Mémorial C n
°
578 du 8 décembre 1992, modifiée par-devant le même
notaire en date du 2 avril 1999, acte publié au Mémorial C n
°
317 du 5 mai 1999. Le capital a été converti en euros
par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n
°
881 du 10 juin 2002.
—
Les comptes consolidés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04244,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076927.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
R.I.I. S.A., RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 32.561.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 20
décembre 1989, acte publié au Mémorial C n
°
223 du 5 juillet 1990, modifiée par-devant le même notaire en date
du 19 décembre 1990, acte publié au Mémorial C n
°
213 du 14 mai 1991, modifiée par-devant le même notaire en
date du 18 décembre 1991, acte publié au Mémorial C n
°
237 du 3 juin 1992, modifiée par-devant le même notaire
en date du 6 août 1992, acte publié au Mémorial C n
°
578 du 8 décembre 1992, modifiée par-devant le même
notaire en date du 2 avril 1999, acte publié au Mémorial C n
°
317 du 5 mai 1999. Le capital a été converti en euros
par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2001, acte publié au Mémorial C n
°
881 du 10 juin 2002.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04237, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076933.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Strassen, le 24 novembre 2003.
Signature.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
<i>Pour RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX - R.I.I. S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
<i>Pour RECHERCHE ET INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX - R.I.I. S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
62260
PEINTURE DEWALD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4175 Esch-sur-Alzette, 30, rue Pierre Kersch.
R. C. Luxembourg B 69.605.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04378, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(076931.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
AGENCE IMMOBILIERE HELENE GROBER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8479 Eischen, 9, Cité Bettenwiss.
R. C. Luxembourg B 42.255.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04380, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(076934.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
MERCANTILE VENTURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 19.445.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Luxembourg, en date du 8
juin 1982, acte publié au Mémorial C n
°
205 du 27 août 1982, modifiée par-devant le même notaire en date du 15
décembre 1987, acte publié au Mémorial C n
°
69 du 18 mars 1988, modifiée par-devant le même notaire en date
du 22 décembre 1994, acte publié au Mémorial C n
°
209 du 12 mai 1995. Le capital a été converti en EUR en date
du 14 septembre 2001, avis publié au Mémorial C n
°
321 du 27 février 2002.
—
Le bilan au 31 mars 2003, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04233, a été déposé au regis-
tre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076935.3//17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
CONCORDIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 81.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05201, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077071.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
CONCORDIA FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 81.663.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05204, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077068.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
<i>Pour MERCANTILE VENTURE S.A.
i>KPMG FINANCIAL ENGINEERING, S.à r.l.
Signature
Signature.
Signature.
62261
OPTIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3318 Bergem, 7, Op Felsduerf.
R. C. Luxembourg B 85.575.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04381, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(076937.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
OPTIQUE STEFFEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4010 Esch-sur-Alzette, 32, rue de l’Alzette.
R. C. Luxembourg B 85.384.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04382, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(076939.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
TRADINGCOM INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 73.221.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf.
LSO-AK04090, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076965.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
LOLLIPOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8081 Bertrange, 121, route de Mamer.
R. C. Luxembourg B 30.178.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK05089, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(077003.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
LOLLIPOP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8081 Bertrange, 121, route de Mamer.
R. C. Luxembourg B 30.178.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2003, réf. LSO-AK05090, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
(077002.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
FIDUCIAIRE SOFINTER, S.à r.l.
Signature
Signature.
<i>Pour LOLLIPOP, S.à r.l.
i>Signature
<i>Pour LOLLIPOP, S.à r.l.
i>Signature
62262
HUTCHISON WHAMPOA 3G IP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1728 Luxembourg, 7, rue du Marché-aux-Herbes.
R. C. Luxembourg B 82.517.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the thirty-first day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholder of HUTCHISON WHAMPOA 3G IP, S.à r.l., (the «Com-
pany»), a «société à responsabilité limitée», having its registered office at 7, rue du Marché-aux-Herbes L-1728 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, trade register Luxembourg section B number 82.517, incorporated by deed
enacted on the 7th of June 2001, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1190 of 19
December 2001; and whose Articles of Association have been amended by deed on 12th March 2002, published in the
Mémorial C, number 949 of 21 June 2002.
The meeting is presided by Mr Patrick Van Hees, jurist with professional address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte
d’Eich.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist with professional
address at L-1450 Luxembourg, 15, Côte d’Eich.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The sole shareholder present or represented and the number of shares held by him are shown on an attendance
list. That list and proxy, signed by the appearing person and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 500 (five hundred) shares representing the entire share capital of the
Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- Amendment of the purpose of the Company in order to allow the Company to perform its activities, i.e. to buy
or to sell any intellectual and industrial property and technology of whatsoever kind or nature and licences, protections
and concessions therefor, on behalf of companies in which the Company has an interest direct or indirect, or of com-
panies which belong to the same group of companies as the Company.
2.- Subsequent amendment of the Articles of Association of the Company.
3.- Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the following resolutions have been taken:
<i>First resolutioni>
After careful consideration, it is resolved to amend the purpose of the Company in order to allow the Company to
perform its activities, i.e. to buy or to sell any intellectual and industrial property and technology of whatsoever kind or
nature and licences, protections and concessions therefor, on behalf of companies in which the Company has an interest
direct or indirect, or of companies which belong to the same group of companies as the Company.
<i>Second resolutioni>
Subsequent to the first resolution, it is resolved to amend the Articles of Association of the Company with respect
to the amendment of the purpose of the Company.
Therefore Article 3 of the Articles of Association is amended as follows:
«The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or
other, Luxembourg or foreign enterprises; to purchase, licence or otherwise acquire intellectual property rights rele-
vant to mobile communications; to acquire any securities and rights through participation, contribution, underwriting
firm purchase or option, negotiation or in any other way; to acquire patents and licences, to manage and develop them;
to apply for, register, purchase or otherwise acquire and protect, prolong, and renew, in any part of the world, any
intellectual and industrial property and technology of whatsoever kind or nature and licences, protections and conces-
sion therefor, and to use, turn to account, develop, manufacture, experiment upon, test, improve and licence the same;
to perform its activities, i.e. to buy or to sell the same, on behalf of companies in which the Company has an interest
direct or indirect, or of companies which belong to the same group of companies as the Company; to grant to enter-
prises in which the Company has an interest, any assistance, loans, advances or guarantees, finally to perform any oper-
ation which is directly or indirectly related to its purpose, however without taking advantage of the Act of July 31st,
1929, on Holding Companies.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.»
No other modification is made to this article nor to any other part of the Articles of Association.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, who signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
62263
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
son and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille trois, le trente et un octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée HUTCHISON WHAMPOA 3G
IP, S.à r.l., (la «Société»), ayant son siège social au 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, R. C. Luxembourg section B numéro 82.517, constituée suivant acte reçu le 7 juin 2001, publié au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1190 du 19 décembre 2001 dont les Statuts ont été modifiés suivant
acte reçu le 12 mars 2002, publié au Mémorial C numéro 949 du 21 juin 2002.
L’assemblée est présidée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich à
L-1450 Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste
domicilié professionnellement au 15, Côte d’Eich à L-1450 Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- L’actionnaire présent ou représenté et le nombre d’actions qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence.
Cette liste et la procuration, une fois signée par le comparant et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour
être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 500 (cinq cents) actions représentant l’intégralité du capital social de la
Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement
délibérer sur tous les points portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Modification de l’objet social de la Société dans le but de permettre à la Société d’agir, c’est-à-dire d’acheter ou
de vendre tout droit de propriété intellectuelle, industrielle et technologique de toute nature, et licences, droit de pro-
tection et de concession, pour le compte d’entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect ou d’en-
treprises qui appartiennent au même groupe d’entreprises que la Société.
2.- Subséquente modification des statuts de la Société.
3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Après examen, il est décidé de modifier l’objet social de la Société dans le but de permettre à la Société d’agir, c’est-
à-dire d’acheter ou de vendre tout droit de propriété intellectuelle, industrielle et technologique de toute nature, et
licences, droit de protection et de concession, pour le compte d’entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt direct
ou indirect ou d’entreprises qui appartiennent au même groupe d’entreprises que la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
Consécutivement à l’adoption de la première résolution, il est décidé de modifier les statuts de la Société conformé-
ment à l’approbation de la modification de l’objet social.
En conséquence, l’article 3 des statuts est modifié comme suit:
«L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères; d’acheter, accorder des licences ou ac-
quérir des droits de propriété intellectuelle liés aux communications mobiles; d’acquérir tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou option d’achat, de négociation et de toute autre manière;
d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur; de souscrire, enregistrer, acheter ou autrement
acquérir et protéger, prolonger et remplacer, dans n’importe quelle partie du monde, toute propriété intellectuelle, in-
dustrielle et technologique de toute sorte ou nature, et licences, protections et concession, et d’utiliser, tirer parti, dé-
velopper, fabriquer, expérimenter, essayer, améliorer et autoriser celles-ci; d’agir, c’est-à-dire d’acheter ou de vendre
celles-ci, pour le compte d’entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt direct ou indirect, ou d’entreprises qui
appartiennent au même groupe d’entreprises que la Société; d’octroyer aux entreprises dans laquelle la Société a un
intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations généralement quelconques
se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur
les sociétés holdings.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’ accomplissement de son objet.»
Aucune autre modification n’est apportée à cet article ou à une autre partie des statuts.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à seize heures.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
62264
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, vol. 141S, fol. 18, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077421.3/211/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 33.701.
—
In the year two thousand three, on the twenty-ninth day of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEM-
BOURG) UMBRELLA FUND (the «Company»), R. C. Luxembourg section B numéro 33.701, having its registered office
at 69, route d’Esch L-1470 Luxembourg, incorporated by deed enacted on 8 May 1990, published in Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, number 231 of 12 July 1990, and whose Articles of Incorporation have been amend-
ed on 20 juin 1996, by deed published at Mémorial C, number 461 of 17 September 1996 and on 29 March 2000, by
deed published at Mémorial C n° 539 of 27 July 2000.
The meeting was presided by Ms Samina Lebrun, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Ms Armelle Moulin, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs. Blandine Kisseli, bank employee, residing professionally in Luxembourg.
At 2.00 p.m., the chairman declared and requested the notary to record that:
I. The meeting was first convened by notices published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and
in the Lëtzebuerger Journal on 27th August 2003 and on 5th September 2003, in order to be held on 17th September,
2003. The meeting held on 17th September, 2003 was not authorised to deliberate on the agenda due to a lack of quo-
rum required by article 67.1 of the law dated 10th August 1915 on commercial companies as amended. The meeting
has consequently been duly reconvened by notice sent to the registered shareholders on 8th October 2003 and pub-
lished in the Mémorial, Luxemburger Wort and Lëtzebuerger Journal on 24th September 2003 and 10th October 2003.
II. The present meeting is not subject to any quorum requirement
III. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list, signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary.
IV. The said list as well as the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
V. It appears from the attendance list that out of two thousand three hundred thirty nine point fourteen (2.339.14)
VI. shares in issue, thirty one point zero eighty-six (31,086) shares are present or represented at the present extraor-
dinary general meeting so that the meeting could validly decide on all the items of the agenda.
VII. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
I. To resolve on the liquidation of the Company
II. To appoint a liquidator
After the foregoing was approved by the Meeting, the following resolutions have been taken at an unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The meeting resolves to wind up the Company and puts the Company into liquidation as of this day.
<i>Second resolutioni>
The meeting appoints KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES, société civile, with registered office at Luxem-
bourg, 31, allée Scheffer, represented by Messrs John Li and Eric Collard as liquidator.
The liquidator is granted the most extensive powers provided for by articles 144 to 148bis of the law of 10th August
1915 on commercial companies. The liquidator is, in particular, authorised to redeem the shares of the Company pro-
vided that the equal treatment of the shareholders is complied with.
The liquidator is not required to draw up an inventory and may rely on the accounts of the Company.
The liquidator is authorised, under its responsibility, to delegate, in regard of special and determined operations, to
one or more proxy holders, such part of their authority as it may determine.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed at 2.30 p.m.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that upon request of the above ap-
pearing persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences
between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known by the notary by their names, sur-
names, civil status and residences, the said appearing persons signed together with the notary the present original deed.
Luxembourg, le 21 novembre 2003.
J. Elvinger.
62265
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt-neuf octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société d’investissement à capital variable
STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, R. C. Luxembourg section B numéro
33.701, ayant son siège social à 69, route d’Esch L-1470 Luxembourg, constituée suivant acte reçu le 8 mai 1990, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 231 du 12 juillet 1990; et dont les statuts ont été modifiés
suivant acte reçu le 20 juin 1996, publié au Mémorial C, numéro 461 du 17 septembre 1996 et le 29 mars 2000, publié
au Mémorial C n° 539 du 27 juillet 2000
L’assemblée est présidée par Madame Samina Lebrun, employée de banque, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Madame Armelle Lebrun, employée de banque, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Blandine Kissel, employée de banque, demeurant professionnelle-
ment à Luxembourg.
A quatorze heures, le président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. L’assemblée a été premièrement convoquée par un avis publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations et dans le Lëtzebuerger Journal des 27 août 2003 et 5 septembre 2003 afin qu’elle puisse se tenir le 17 septem-
bre 2003. L’assemblée tenue le 17 septembre 2003 n’a pas pu délibérer sur l’ordre du jour en raison de l’absence du
quorum requis par l’article 67.1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée. L’assemblée
a été en conséquent dûment re-convoquée par un avis envoyé aux actionnaires nominatifs le 8 octobre 2003 et publié
au Mémorial, dans le Luxemburger Wort et dans le Lëtzebuerger Journal les 24 septembre 2003 et 10 octobre 2003.
II. La présente assemblée n’est soumise à aucune exigence de quorum.
III. Les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une
liste de présence, signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire.
IV. Ladite liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec
lui aux formalités de l’enregistrement.
V. Il appert de cette liste de présence que des deux mille trois cent trente-neuf virgule quatorze (2.339,14 actions en
circulation, trente et une virgule zéro quatre-vingt six (31.086) actions sont présentes ou représentées à la présente
assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l’or-
dre du jour.
VI. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
I. Prendre une décision sur la liquidation de la Société.
II. Nommer un liquidateur.
VII. Après approbation de ce qui précède par l’Assemblée, les résolutions suivantes ont été prises par un vote una-
nime:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide la dissolution de la Société et prononce la mise en liquidation de la Société à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer la société civile KPMG FINANCIAL ADVISORY SERVICES, avec siège social à
Luxembourg, 31, allée Scheffer, représentée par Messieurs John Li and Eric Collard comme liquidateur.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales. Le liquidateur est en particulier autorisé à racheter les actions de la Société pour autant que le
traitement d’égalité des actionnaires soit respecté.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peuvent s’en référer aux comptes établis pour la Société.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs
mandataires, une partie de leurs pouvoirs qu’il détermine.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 14.30 heures.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms,
états et demeures, les comparants ont tous signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Lebrun, A. Moulin, B. Kisseli, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2003, vol. 141S, fol. 10, case 12. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077415.3/211/115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
Luxembourg, le 19 novembre 2003.
J. Elvinger.
62266
MURHOLD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires Le 2000.
R. C. Luxembourg B 89.661.
—
Le bilan au ¨31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04183, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077299.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
ABF HYDE PARK INVESTMENTS & CO S.N.C., Société en nom collectif.
Registered office: L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 96.924.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the eleventh day of November.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand
Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) The company ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., a company existing under the laws of Luxembourg, with
registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
duly represented by Ms Figen Eren, lawyer, residing professionally in L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la
Pétrusse, by virtue of a proxy under private seal, given on October 31, 2003, being understood that the proxy holder
may not be considered as founder.
2) The company ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., a company existing under the laws of Luxembourg,
with registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
duly represented by Ms Figen Eren, prenamed, by virtue of a proxy under private seal, given on October 31, 2003
being understood that the proxy holder may not be considered as founder.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person, acting as here above stated and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration author-
ities.
Such appearing parties, represented as hereabove stated, have requested the undersigned notary to state the follow-
ing articles of incorporation of a general partnership («société en nom collectif») governed by the relevant laws and the
present articles:
Title I.- Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established a general partnership (offene Handelsgesellschaft, société en non collectif) under
the firm name ABF HYDE PARK INVESTMENTS & Co S.N.C.
Art. 2. The Partnership is established for a duration of thirty (30) years.
It may be dissolved before its expiration by the unanimous resolution of the general partners’ meeting representing
the whole corporate capital. It may have commitments exceeding its duration.
Art. 3. The registered office of the Partnership is established in Luxembourg City. It may be transferred to any other
place of the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of its partners. Branches or
other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
If political, economical or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal
activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons
abroad, as determined by the management of the Corporation, the registered office may be temporally transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on
the nationality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a
Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the management
of the Corporation.
Art. 4. The object of the Partnership is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial,
financial or other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, option or in any other way.
The Partnership may use its funds to invest in real estate, to establish, manage, develop and dispose of its assets as
they may be composed from time to time and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription,
underwriting or option, securities, and any intellectual property rights, to realize them by way of sale, transfer, exchange
or otherwise, to receive or grant licenses on intellectual property rights and to grant to or for the benefit of companies
in which the Partnership has a direct or indirect participation and to group companies, any assistance including financial
assistance, loans, advances or guarantees. The Partnership may also grant loans and other financial services to any com-
panies being part of the AB FOOD GROUP.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Signature.
62267
Without prejudice to the generality of the object of the Partnership, the Partnership may do all or any of the follow-
ing:
- acquisition, possession, administration, sale, exchange, transfer, trade and investment in and alienation of shares,
bonds, funds, notes, evidences of indebtness and other securities, borrowing of money and issuance of notes therefore,
as well as the lending of money;
- acquisition of income arising from the disposal or licensing of copyrights, patents, designs, secret processes, trade-
marks or other similar interests;
- rendering of technical assistance;
participation in and management of other companies.
The Partnership may borrow in any form and proceed to the private issue of bonds, notes, securities, debentures
and certificates, provided that they are not freely negotiable and that they are issued in registered form only.
Title II.- Capital - Units
Art. 5. The Partnership’s capital is set at fourteen thousand Pounds Sterling (GBP 14,000.-), represented by one hun-
dred and forty (140) partnership units with a par value of one hundred Pounds Sterling (GBP 100.-) each.
Art. 6. The transfer of corporate units inter vivos to other partners or to third parties is conditional upon the unan-
imous approval of the general partners’ meeting representing the whole corporate capital. The transfer of corporate
units mortis causa to other partners or to third parties is conditional upon the unanimous approval of the general part-
ners’ meeting representing the whole corporate capital belonging to the surviving partners.
This approval is not required when the corporate units are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or
to the surviving spouse.
If the transfer is not approved in either case, the remaining partners have a pre-emption right proportional to their
participation in the remaining corporate capital for a duration of two months after the refusal of approval.
Each unexercised pre-emption right is proportionally attributed to the benefit of the other partners for an additional
duration of one month. If the pre-emption rights are not exercised in total or in part, the initial transfer offer is auto-
matically accepted at least for the corporate units which have not been acquired by the existing partners.
Each transfer of corporate units has to respect article 1690 of the civil code.
Art. 7. There is one vote per partnership unit. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted
by partners representing more than half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of asso-
ciation require the unanimous approval of the general partners’ meeting representing the whole corporate capital.
Art. 8. Apart from its initial contribution, each partner may with the previous approval of the other partners make
cash advances to the Partnership through its current account. The advances will be recorded on a specific current ac-
count between the partner who has made the cash advance and the Partnership. They will bear interest at a rate fixed
by the general partners’ meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a partner in the form determined by this article shall not be considered as an additional
contribution and the partner will be recognized as a creditor of the Partnership with respect to the advance and inter-
ests accrued thereon.
Art. 9. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a partner will not put an end to
the Partnership.
Art. 10. The creditors, assigns and heirs of the partners may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the Partnership nor interfere in any manner in the management of the Partnership. They have to
refer to the Partnership’s inventories.
Title III.- Management
Art. 11. The Partnership shall be managed by a sole manager or by a board of managers of at least two managers
who do not need to be partners of the Partnership.
The managers are appointed and removed by the general meeting of partners, which determines their powers, com-
pensation and duration of their mandates.
Art. 12. In case of a board of managers, the latter may choose from among its members a chairman. It may also
choose a secretary, who needs to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the manager or the board of managers and of the partners.
In case of a board of managers, the latter shall meet upon call by the chairman, at the place indicated in the notice of
meeting.
In case of a board of managers, written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers.
This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telefax, or by email of each manager.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.
No notice is required if all the managers are present or represented at a meeting.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax, or by email another manager as his proxy.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers, in Luxembourg at the registered office of the Partnership or at any other
place indicated in the convening notice. Resolutions of the board of managers shall be taken by a majority of votes of
the managers present or represented at such meeting.
62268
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-
agers’ meetings.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
In case of a sole manager, the latter shall also keep minutes of its resolutions signed by itself.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman or by two managers or in case of a sole manager, by such sole manager, if need be.
Art. 14. The sole manager or the board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of ad-
ministration and disposition on behalf of the Partnership in its interests.
All powers not expressly reserved by law or the articles of association to the general meeting of members fall within
the competence of the sole manager or the board of managers.
The sole manager or the board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of
the Partnership and the representation of the Partnership for such management and affairs, with prior consent of the
general meeting of partners, to any manager or managers of the board or to any person or any committee (the members
of which need not to be managers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine.
It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss
all officers and employees, and fix their emoluments.
Art. 15. The Partnership shall be bound by (i) the single signature of the single manager or (ii) the joint signature of
two managers or (iii) the single or joint signature of any person or persons to whom such signatory power has been
delegated by the board of managers.
With regard to transactions and orders on the Partnership’s bank accounts up to and including the amount of two
thousand Pounds Sterling (GBP 2,000.-), the Partnership will be validly bound by the sole signature of the person to
whom such signatory power will be delegated by the sole member of the Partnership or the general meeting of the
members of the Partnership.
With regard to transactions and orders on the Partnership’s bank accounts exceeding the amount of two thousand
Pounds Sterling (GBP 2,000.-), the Partnership will be validly bound by the joint signature of (i) the person to whom
such signatory power will be delegated by the sole member of the Partnership or the general meeting of the members
of the Partnership and (ii) of the sole manager or any one manager in case of two or more managers.
Paragraphs 2 and 3 of the present section do not apply to bank accounts which may be opened by foreign branches
of the Partnership. The sole manager or the board of managers of the Partnership is empowered to define the specific
rules applying to such bank accounts.
Art. 16. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of
the Partnership. As agents of the Partnership, they are responsible for the correct performance of their duties.
Title IV.- Accounts
Art. 17. The Partnership’s financial year runs from the fifteenth September to the fourteenth September of the fol-
lowing year.
Art. 18. Each year, as of the fourteenth day of September, the management will draw up the annual accounts and
will submit them to the partners.
Art. 19. Each partner may inspect the annual accounts at the registered office of the Partnership during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 20. Each year the partners will approve the accounts of the preceding year in their partners’ meeting. The result
of the financial year will be allocated proportionally to each partner’s sharequota on the provisional partners’ accounts.
The balances of these provisional accounts become claims or debts of each partner only if they are transferred by unan-
imous resolution taken by the partners’ general meeting representing the whole capital to each partner’s definitive ac-
count. The claims in favor of each partner will become due only by unanimous resolution taken by the partners’ general
meeting representing the whole capital.
Art. 21. In the event of the dissolution of the Partnership for whatever reason, the liquidation will be carried out by
the management or any other person appointed by the partners.
When the Partnership’s liquidation is closed, the Partnership’s assets will be distributed to the partners proportion-
ally to the corporate units they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly.
Art. 22. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the
Commercial Companies Act dated tenth August nineteen hundred fifteen, as amended.
Art. 23. Any litigation which will occur either between the partners themselves or between the manager(s) and the
Partnership, will be settled, insofar as the Partnership’s business is concerned, by arbitration in compliance with the pro-
visions of the Luxembourg code of civil procedure.
<i>Subscription and Paymenti>
The corporate units have been subscribed as follows:
1) by the company ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 69A, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, seventy (70) corporate units;
62269
2) by the company ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., with registered office at 69A, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, seventy (70) corporate units.
All the corporate units have been fully paid in by the subscribers so that the amount of fourteen thousand Pounds
Sterling (GBP 14,000.-) is at the free disposal of the Partnership, as certified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Partnership as a
result of its incorporation are estimated at approximately two thousand five hundred Euros (EUR 2,500.-).
For the purpose of registration, the Partnership’s capital is evaluated at twenty thousand two hundred eighty-five Eu-
ros sixty-nine Cents (EUR 20,285.69).
<i>Transitory Provisioni>
The first fiscal year will begin on the date of establishment and will end on the fourteenth day of September 2004.
<i>Extraordinary General Meeting of the Partnersi>
Immediately after the establishment of the Partnership, the partners, represented as here above mentioned, repre-
senting the entire Partnership’s capital held an extraordinary general partners’ meeting, and unanimously passed the fol-
lowing resolutions after having acknowledged that they have been validly convened with full knowledge of the agenda
and after having deliberated.
1) The registered office of the Partnership is in L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse;
2) The number of managers is fixed at two.
3) The following persons are appointed managers:
- Mr François Brouxel, lawyer, born in Metz (France) on September 16, 1966, professionally residing in L-2320 Lux-
embourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
- Mr Georges Gudenburg, lawyer, born in Luxembourg on November 25, 1964, professionally residing in L-2320 Lux-
embourg, 69, boulevard de la Pétrusse.
4) The mandate of the managers shall end at the annual general meeting of the partners, which shall be held for ap-
proval of the accounts for the financial year ending September 14, 2004.
5) The following person has single and joint signatory powers on the Corporation’s bank accounts as defined under
section 15, paragraphs 2 and 3, of the articles of association of the Partnership:
Mr Stéphane Weyders, auditor, professionally residing in L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
The undersigned notary, who understands German and English, states herewith that on request of the proxy holder
the present incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same proxy hold-
er and in case of divergences between the German and the English text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-Bonnevoie, in the office, on the day mentioned at
the beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, the latter signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausenddrei, am elften November.
Vor Uns, Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Grossherzogtum
Luxemburg.
Sind erschienen:
1) Die Gesellschaft ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., eine unter luxemburgischem Recht bestehende Gesell-
schaft, mit eingetragenem Sitz in 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
hier vertreten durch Fräulein Figen Eren, Rechtsanwältin, beruflich ansässig in L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de
la Pétrusse, aufgrund einer am 31. Oktober 2003 ausgestellten privatschriftlichen Vollmacht, wobei die Bevollmächtigte
nicht als Gesellschaftsgründerin zu erachten ist.
2) Die Gesellschaft ABF REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., eine unter luxemburgischem Recht bestehende Ge-
sellschaft, mit eingetragenem Sitz in 69A, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
hier vertreten durch Fräulein Figen Eren, vorbenannt, aufgrund einer am 31. Oktober 2003 ausgestellten privatschrift-
lichen Vollmacht, wobei die Bevollmächtigte nicht als Gesellschaftsgründerin zu erachten ist.
Die vorgenannten Vollmachten bleiben nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person, handelnd wie
vorerwähnt, und den unterzeichnenden Notar der vorliegenden Urkunde zum Zwecke der Einregistrierung beigebogen.
Die erschienenen Parteien, vertreten wie vorgenannt, ersuchten den unterzeichnenden Notar, die Satzung einer of-
fenen Handelsgesellschaft («société en nom collectif»), gemäss dem geltenden Recht und den vorliegenden Artikeln auf-
zunehmen:
Titel I.- Bezeichnung - Dauer - Gesellschaftssitz - Gesellschaftszweck
Art. 1. Hiermit wird eine Offene Handelsgesellschaft («société en nom collectif») unter der Firmenbezeichnung ABF
HYDE PARK INVESTMENTS & Co S.N.C. gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft wird für die Dauer von dreissig (30) Jahren gegründet.
Sie kann vor ihrem Ablauftermin durch einen einstimmigen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welche das ge-
samte Gesellschaftskapital vertritt, aufgelöst werden. Sie kann Verpflichtungen haben, die ihre Dauer überschreiten.
62270
Art. 3. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt.
Er kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg
verlegt werden. Niederlassungen oder andere Büros können sowohl in Luxemburg als auch im Ausland, durch Beschluss
der Geschäftsführung eröffnet werden.
Sollten sich Entwicklungen politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art zugetragen haben oder imminent werden,
die die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz und Per-
sonen im Ausland, wie durch die Geschäftsführung bestimmt, gefährden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend
bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden; diese vorübergehenden Massnah-
men betreffen jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Ver-
legung des Gesellschaftssitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Diese vorübergehenden Massnahmen werden
von der Geschäftsführung getroffen und allen betroffenen Parteien mitgeteilt.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist es Beteiligungen, unter welcher Form auch immer, in jeder kaufmännischen, indu-
striellen, finanziellen oder anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen zu halten; sämtliche Wertpapiere
und Rechte durch Beteiligung, Einlage, Optionsrecht oder sonstwie zu erwerben.
Die Gesellschaft kann ihr Vermögen nutzen, um in Grundbesitz zu investieren, um ihre Aktiva, wie sie von Zeit zu
Zeit zusammengesetzt sind, nämlich aber nicht beschränkt auf, über ihr Portfolio von Wertpapieren jeglichen Ursprungs,
zu errichten, verwalten, ausbauen und darüber zu verfügen, um sich an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle von
Unternehmen zu beteiligen, um durch Investition, Zeichnung, Unterzeichnung oder Optionsrecht, Wertpapiere und alle
Rechte des geistigen Eigentums zu erwerben, sie durch Verkauf, Übertragung, Tausch oder sonstwie zu veräußern, um
Lizenzen für Rechte des geistigen Eigentums zu erhalten oder zu gewähren und den Gesellschaften, oder zum Nutzen
der Gesellschaften, in welchen sie eine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung hat, sowie den Gruppegesellschaften
jede Unterstützung, einschließend eine finanzielle Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder Garantien zu gewähren. Die
Gesellschaft kann auch den Gesellschaften die der Gesellschaftsgruppe AB FOOD angehören, Darlehen und andere fi-
nanzielle Unterstützung gewähren.
Ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit des Gesellschaftsobjektes, kann die Gesellschaft noch alles Folgende unter-
nehmen:
- der Erwerb, Besitz, Verwaltung, Verkauf, Tausch, Übertragung, Handel und Investierung in, und Abtretung von An-
teilen, Anleihen, Fonds, Noten, Schuldtitel und anderen Wertpapieren, die Aufnahme von Darlehen und Schuldscheine
hierfür auszugeben, sowie Darlehen gewähren;
- der Erwerb von Einkommen als Folge der Verfügung und Lizenzerteilung von Urheberrechten, Patenten, Mustern,
geheimen Verfahren, eingetragenen Marken oder anderen ähnlichen Interessen;
- die Gewährung von technischer Unterstützung;
die Beteiligung in, und die Geschäftsführung von anderen Gesellschaften.
Die Gesellschaft kann Darlehen in jeder Form aufnehmen und Anleihen, Noten, Wertpapiere, Schuldverschreibungen
und Bescheinigungen privat ausgeben, vorausgesetzt, dass sie nicht frei übertragbar sind und dass sie nur in eingetragener
Form ausgegeben werden.
Titel II.- Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist auf vierzehntausend Pfund Sterling (GPB 14.000,-) festgelegt, eingeteilt in einhun-
dertundvierzig (140) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einhundert Pfund Sterling (GBP 100,-).
Art. 6. Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an andere Gesellschafter oder an Nichtgesellschaf-
ter unterliegt der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital ver-
tritt. Im Todesfall eines Gesellschafters, ist die Übertragung von Gesellschaftsanteilen an andere Gesellschafter oder an
Nichtgesellschafter abhängig von der einstimmigen Zustimmung der Gesellschafterversammlung, die das gesamte Ge-
sellschaftskapital der überlebenden Gesellschafter vertritt.
Es bedarf keiner Zustimmung, falls die Gesellschaftsanteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder an den überlebenden
Ehegatten übertragen werden.
Falls die Übertragung in einem von beiden Fällen nicht genehmigt wird, haben die restlichen Gesellschafter ein Vor-
kaufsrecht verhältnismässig zu ihrer restlichen Beteiligung im Gesellschaftskapital für eine Dauer von zwei Monaten ab
der Verweigerung der Zustimmung.
Jedes nicht ausgeübte Vorkaufsrecht wird verhältnismässig für die zusätzliche Dauer von einem Monat auf die verblei-
benden Gesellschafter übertragen. Falls die Vorkaufsrechte nicht oder nicht gänzlich ausgeübt werden, gilt das ursprüng-
liche Abtretungsangebot automatisch als angenommen zumindest für diejenigen Geschäftsanteile welche nicht von den
aktuellen Gesellschaftern erworben wurden.
Jede Abtretung von Gesellschaftsanteilen muss die Bestimmung des Artikels 1690 des Zivilgesetzbuchs beachten.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur Abgabe einer Stimme. Die gemeinsamen Beschlüsse sind nur ord-
nungsgemäss gefasst, wenn sie von den Gesellschaftern angenommen werden, die zusammen mehr als die Hälfte des
Gesellschaftskapitals vertreten. Nichtsdestotrotz, Entscheidungen, die die Satzung ändern, erfordern eine einstimmige
Zustimmung der Gesellschafterversammlung, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt.
Art. 8. Abgesehen von seinen Kapitaleinlagen, kann jeder Gesellschafter, mit der vorherigen Zustimmung der ande-
ren Gesellschafter, Vorschüsse in Barmitteln auf sein Kontokorrent zugunsten der Gesellschaft leisten. Die Vorschüsse
werden auf ein gesondertes Kontokorrent eingezahlt, welches zwischen dem Gesellschafter der den Vorschuss in Bar-
mittel geleistet hat und der Gesellschaft besteht. Es werden Zinsen erzielt, deren Rate von der Gesellschafterver-samm-
lung mit einer Zweidrittelmehrheit bestimmt wird. Diese Zinsen werden als allgemeine Ausgaben verbucht.
62271
Die von einem Gesellschafter in dieser Form, wie sie in diesem Artikel bestimmt ist, geleisteten Vorschüsse in Bar-
mittel, werden nicht als weitere Kapitaleinlagen erachtet und der Gesellschafter wird in Bezug auf den Vorschuss und
die darauf fälligen Zinsen als Gläubiger der Gesellschaft behandelt.
Art. 9. Der Tod, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit einer der Gesellschaf-
ter werden in keinster Weise die Beendigung der Gesellschaft zur Folge haben.
Art. 10. Die Gläubiger, Rechtsnachfolger und Erben der Gesellschafter können weder, aus welchem Grund auch im-
mer, Siegel an das Vermögen und die Dokumente der Gesellschaft anlegen, noch sich in keinster Weise in die Geschäfts-
führung der Gesellschaft einmischen. Sie müssen sich auf die Inventarliste der Gesellschaft beziehen.
Titel III.- Geschäftsführung
Art. 11. Die Gesellschaft wird durch einen alleinigen Geschäftsführer oder durch einen Rat von Geschäftsführern,
der aus mindestens zwei Geschäftsführern besteht, die nicht Gesellschafter sein müssen, verwaltet.
Die Geschäftsführer werden von der Gesellschafterversammlung, die über ihre Befugnisse, Bezüge und Amtszeit ent-
scheidet, ernannt und abberufen.
Art. 12. Wenn ein Rat von Geschäftsführern eingerichtet wird, kann dieser Rat aus seiner Mitte einen Vorsitzenden
wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wählen, der Geschäftsführer sein muss, und der dafür verantwortlich sein wird,
die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführer und der Gesellschafterversammlungen zu führen.
Wenn ein Rat von Geschäftsführern eingerichtet wird, wird sich der Rat auf Einberufung durch den Vorsitzenden an
dem in diesem Schreiben angegebenen Ort versammeln.
Wenn ein Rat von Geschäftsführern eingerichtet wird, dann muss den Geschäftsführern ein schriftliches Einberu-
fungsschreiben zugeschickt werden. Es kann auf die Einberufung durch Einverständnis per Schreiben oder per Kabel, Te-
legramm, Telex oder Telefax, oder per Email von jedem Geschäftsführer verzichtet werden. Eine spezielle Einberufung
wird nicht notwendig sein für eine Geschäftsführungssitzung, welche zu einer Stunde und an einem Ort, die in einem
vorausgehenden Arbeitsplan der Geschäftsführung festgehalten worden waren, stattfinden soll.
Falls sämtliche Geschäftsführer bei einer Sitzung der Geschäftsführung anwesend oder vertreten sind, ist keine Ein-
berufung erforderlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich an jeder Sitzung der Geschäftsführung durch eine schriftliche, oder per Kabel, Tele-
gramm, Telex oder Telefax, oder per Email erteilte Vollmacht an einen anderen Geschäftsführer vertreten lassen.
Der Rat der Geschäftsführer kann nur ordnungsgemäss beraten und beschliessen, wenn wenigstens die Mehrzahl der
Geschäftsführer an der Geschäftsführungssitzung anwesend oder vertreten ist, anlässlich der Sitzung der Geschäftsfüh-
rung in Luxemburg am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen in dem Einberufungsschreiben ange-
gebenen Ort. Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden mit Stimmenmehrheit der an einer solchen Sitzung
anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Schriftliche Entscheidungen, die von allen Geschäftsführern gutgeheissen und unterschrieben wurden, haben die glei-
che Wirkung wie die Beschlüsse, die in einer Geschäftsführungssitzung getroffen wurden.
Art. 13. Die Protokolle der Geschäftsführungssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, im Falle seiner Abwesen-
heit, vom pro tempore Vorsitzenden, welcher den Vorsitz einer solchen Geschäftsführungssitzung übernahm, unter-
schrieben.
Für den Fall, dass es nur einen alleinigen Geschäftsführer gibt, wird letzterer ebenfalls ein Protokoll mit den von ihm
getroffenen Beschlüsse erstellen und unterzeichnen.
Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle, welche vor Gericht oder anderswo vorgezeigt werden könnten, wer-
den von dem Vorsitzenden oder von zwei Geschäftsführern oder für den Fall, dass es nur einen alleinigen Geschäftsfüh-
rer gibt, von diesem alleinigen Geschäftsführer unterschrieben.
Art. 14. Der alleinige Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer hat die weitgehendsten Befugnisse, jegliche
Verwaltungs- und Verfügungshandlungen im Namen der Gesellschaft und in deren Interesse, vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung
vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Geschäftsführers oder des Rates der Geschäftsführer.
Der alleinige Geschäftsführer oder der Rat der Geschäftsführer kann seine Befugnisse betreffend der täglichen Ge-
schäftsführung und Angelegenheiten der Gesellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Ge-
schäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vorausgehenden Einverständnis der Gesellschafterversammlung, an einen
oder mehrere Geschäftsführer des Rates der Geschäftsführer oder an eine Person oder an ein Komitee (dessen Mit-
glieder nicht Geschäftsführer sein müssen) übertragen, die unter den Bedingungen und Befugnissen, die vom Rat der
Geschäftsführer festgelegt werden, beraten und beschliessen. Die Geschäftsführung kann ausserdem jegliche Befugnisse
und Sondervollmachten an jede Person, die nicht Geschäftsführer sein muss, übertragen, Beamte und Angestellte ein-
stellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.
Art. 15. Die Gesellschaft wird durch (i) die Einzelschrift des alleinigen Geschäftsführers oder (ii) die gemeinsame
Unterschrift von zwei Geschäftsführern oder (iii) die Einzel- oder gemeinsame Unterschrift der Person oder Personen
welcher(n) solche Vertretungsmacht von der Geschäftsführung übertragen werden wird, verpflichtet.
Betreffend Transaktionen und Order auf den Bankkonten der Gesellschaft bis zu und einschliesslich des Betrags von
zweitausend Pfund Sterling (GBP 2.000,-), wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die alleinige Unterschrift
der Person welcher ein solches Unterzeichnungsrecht durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterver-
sammlung übertragen wird.
Betreffend Transaktionen und Order auf den Bankkonten der Gesellschaft welche den Betrag von zweitausend Pfund
Sterling (GBP 2.000,-) übertreffen, wird die Gesellschaft rechtsgültig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift (i)
62272
der Person welcher ein solches Unterzeichnungsrecht durch den alleinigen Gesellschafter oder die Gesellschafterver-
sammlung übertragen wird sowie (ii) des alleinigen Geschäftsführers oder eines Geschäftsführers im Falle von mehreren
Geschäftsführern.
Die Paragraphen 2 und 3 dieses Artikels finden keine Anwendung bei Bankkonten welche gegebenenfalls durch aus-
ländische Niederlassungen der Gesellschaft eröffnet werden. Der alleinige Geschäftsführer oder der Rat der Geschäfts-
führer ist ermächtigt, die spezifischen Regeln bezüglich dieser Bankkonten festzulegen.
Art. 16. Die Geschäftsführer gehen in der Ausübung ihres Mandats keinerlei persönlichen Verpflichtungen hinsicht-
lich der von der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten ein. Als Bevollmächtigte der Gesellschaft haften sie ledig-
lich für die korrekte Ausführung ihrer Aufgaben.
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am fünfzehnten September eines jeden Jahres und endet am vier-
zehnten September des folgenden Jahres.
Art. 18. Jedes Jahr, zum vierzehnten September, wird die Geschäftsführung den Jahresabschluss aufstellen und ihn
den Gesellschaftern zur Verfügung stellen.
Art. 19. Jeder Gesellschafter kann den Jahresabschluss, während fünfzehn Tagen vor seiner Genehmigung, am Sitz
der Gesellschaft einsehen.
Art. 20. Jeder Gesellschafter wird in der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss des vergangenen Jahres ge-
nehmigen. Das Ergebnis des Geschäftsjahres wird verhältnismässig zu den Gesellschaftsanteilen eines jeden Gesellschaf-
ters den vorläufigen Konten der Gesellschafter zugewiesen. Die Bilanzen dieser vorläufigen Konten werden nur zu
Ansprüchen oder Verbindlichkeiten des Gesellschafters, wenn sie durch einstimmigen Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt, auf das endgültige Konto der Gesellschafter abgetreten wer-
den. Die Ansprüche zu Gunsten von jedem Gesellschafter werden nur fällig durch einen einstimmigen Beschluss der
Gesellschafterversammlung, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertritt.
Art. 21. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, aus welchem Grund auch immer, wird die Abwicklung durch die
Geschäftsführung oder eine Person, die durch die Gesellschafter ernannt wird, erfolgen.
Wenn die Auflösung der Gesellschaft beendet ist, wird das Gesellschaftsvermögen unter den Gesellschaftern verhält-
nismässig zu ihren Gesellschaftsanteilen aufgeteilt.
Im Falle von Verlusten, werden diese gleichmässig aufgeteilt.
Art. 22. Sämtliche Punkte die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, unterliegen den Bestimmungen des
Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertundfünfzehn über die Handelsgesellschaften wie abgeändert.
Art. 23. Etwaige Streitigkeiten, welche sich entweder zwischen den Gesellschaftern oder zwischen dem/den Ge-
schäftsführer(n) und der Gesellschaft ereignen, werden, insofern die Geschäfte der Gesellschaft betroffen sind, durch
Schiedsgerichtsbarkeit, entsprechend den Bestimmungen der luxemburgischen Zivilprozessverordnung, geregelt.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Diese Gesellschaftsanteile wurden wie folgt gezeichnet:
1. von der Gesellschaft ABF HYDE PARK INVESTMENTS, S.à r.l., mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 69A, bou-
levard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, siebzig (70) Gesellschaftsanteile;
2. von der Gesellschaft REGENTS PARK INVESTMENTS, S.à r.l., mit eingetragenem Gesellschaftssitz in 69A, boule-
vard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg, siebzig (70) Gesellschaftsanteile.
Sämtliche Geschäftsanteile wurden vollständig einbezahlt durch die Zeichner, so dass der Betrag von vierzehntausend
Pfund Sterling (GBP 14.000,-) der Gesellschaft frei zur Verfügung stehen, wie vom unterzeichnenden Notar festgestellt.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, in welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass
ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr zweitausend fünfhundert Euro (EUR 2.500,-) abgeschätzt.
Zum Zwecke der Einregistrierung, wird das Gesellschaftskapital auf zwanzigtausendzweihundertfünfundachtzig Euro
neunundsechzig Cents (EUR 20.285,69) festgesetzt.
<i>Zwischenbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am vierzehnten September zwei-
tausendundvier.
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Im Anschluss an die Gesellschaftsgründung, haben die Gesellschafter, vertreten wie vorerwähnt, welche das gesamte
Gesellschaftskapital vertreten, eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung abgehalten und einstimmig, nachdem
sie anerkannt haben, dass sie ordnungsgemäss geladen waren und in Kenntnis der Tagesordnung, folgende Beschlüsse
gefasst:
1) Der eingetragene Gesellschaftssitz ist in L-2320 Luxembourg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
2) Die Zahl der Geschäftsführer wird auf zwei bestimmt.
3) Zu den Geschäftsführern werden ernannt:
- Herr François Brouxel, Rechtsanwalt, geboren in Metz (Frankreich) am 16. September 1966, beruflich ansässig in
L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
- Herr Georges Gudenburg, Rechtsanwalt, geboren in Luxemburg am 25. November 1964, beruflich ansässig in
L-2320 Luxemburg, 69, boulevard de la Pétrusse.
62273
4) Das Mandat der Geschäftsführer läuft nach der Gesellschafterversammlung ab, welche den Jahresabschluss zum
14. September 2004 genehmigt.
5) Die nachstehend genannte Person hat alleiniges sowie gemeinsames Unterschriftsrecht auf den Bankkonten der
Gesellschaft wie unter Artikel 15, Paragraph 2 und 3, der Satzung der Gesellschaft vorgesehen:
Herr Stéphane Weyders, Wirtschaftsprüfer, beruflich ansässig in L-2320 Luxemburg, 69A, boulevard de la Pétrusse.
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der Bevollmäch-
tigten, die gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde und der Urkunde eine deutsche Fassung beigefügt
ist. Auf Antrag derselben Bevollmächtigten und im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, wird die englische Fassung massgeblich sein.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Bonneweg, in der Amtsstube, am Datum wie ein-
gangs erwähnt.
Und nach Vorlesung der Urkunde an die Bevollmächtigte hat diese zusammen mit dem Notar die vorliegende Ur-
kunde unterzeichnet.
Gezeichnet: F. Eren, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2003, vol. 141S, fol. 26, case 10. – Reçu 203,02 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(077506.3/222/439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
MEDIC INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 96.888.
—
STATUTES
In the year two thousand three, on the fifteenth of October.
Before Us Maître Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Sten Sture Lundgren, company director, residing in SE-70596 Glanshammar, Esplunda Gârd, born in A Katarina
(Sweden), on November 7th, 1948,
here represented by Mr Benoît Nasr, employee, residing in L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon,
by virtue of a proxy dated September 25th, 2003.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary, to state as follows
the articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incor-
porated:
Art. 1. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) which will be governed
by the laws pertaining to such an entity (hereafter the «Company»), and in particular the law dated 10th August, 1915,
on commercial companies, as amended (hereafter the «Law»), as well as by the articles of association (hereafter the
«Articles»), which specify in the articles 7, 10, 11 and 14 the exceptional rules applying to one member company.
Art. 2. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect
of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes.
The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-
ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.
In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a
portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.
Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. The Company will have the name MEDIC INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the manager or
in case of plurality of managers, by a decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Luxemburg-Bonneweg, den 21. November 2003.
T. Metzler.
62274
Art. 6. The Company’s corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.- EUR) represented
by one hundred and twenty-five (125) shares of one hundred euro (100.- EUR) each.
Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-
holders’ meeting, in accordance with article 14 of these Articles.
Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to
the number of shares in existence.
Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 10. In case of a single shareholder, the Company’s shares held by the single shareholder are freely transferable.
In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Art. 11. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bank-
ruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will
constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-
stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within
the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent’s responsibilities
and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.
Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal
liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the
number of shares which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective
decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders
owning at least three quarter of the Company’s share capital, subject to the provisions of the Law.
Art. 15. The Company’s year starts on the 1st of January and ends on the 31st of December each year.
Art. 16. Each year, with reference to 31st of December, the Company’s accounts are established and the manager,
or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of
the Company’s assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-
ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Com-
pany is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal
share capital.
The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/ their share holding in
the Company.
Art. 18. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 19. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in
these Articles.
<i>Costsi>
The appearer estimate the expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by
the Company as a result of its formation at approximately one thousand two hundred and fifty euros (1,250.- EUR)
<i> Transitory dispositionsi>
The first fiscal year starts the day of Incorporation of the Company and ends on the thirty-first of December two
thousand three.
<i> Subscription and Paymenti>
The one hundred and twenty-five (125) shares are all subscribed by the sole shareholder, Mr Sten Sture Lundgren,
previously named.
62275
All the shares have been fully paid in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred euros (12,500.- EUR)
is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
1) The Company will be administered by the following manager:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., having its registered office in L-2163 Luxembourg, 27, avenue
Monterey, R. C. Luxembourg number B 64.474.
The manager has the most extensive powers to act on behalf of the company in all circumstances and to authorise
acts and activities relating to the company’s objectives by his sole signature.
2) The address of the corporation is fixed at L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le quinze octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Sten Sture Lundgren, directeur de société, demeurant à SE-70596 Glanshammar (Suède) Esplunda Gârd,
né à A Katarina (Suède), le 7 novembre 1948.
ici représenté par Monsieur Benoît Nasr, employé privé, demeurant à L-8008 Strassen, 132, route d’Arlon,
en vertu d’une procuration sous seing privé datée du 25 septembre 2003.
La prédite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à responsabi-
lité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après «La Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après «La Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après «les Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10,
11 et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous trans-
ferts de propriété immobiliers ou mobiliers qui peut lui paraître tuiles dans l’accomplissement de son objet.
La société a en outre pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-
tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination MEDIC INTERNATIONAL, S.à r.l.
Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège sociale peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas
de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu’à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) représenté par cent vingt-cinq (125)
parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe
avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale est
admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu’un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
62276
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de
la faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un
conseil de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour ef-
fectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article
aient été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants pré-
sents ou représentés.
Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues par la loi.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu’il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amor-
tissements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution
d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de
la Société.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, as-
sociés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à
la Loi.
<i> Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cent cinquante euros
(1.250,- EUR).
<i> Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le trente et un décembre deux mille
trois.
<i> Souscription et libérationi>
Les cent vingt-cinq (125) parts sociales sont souscrites à l’instant même par l’associé unique Monsieur Sten Sture
Lundgren, prénommé.
Toutes les parts ont été libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500,- EUR) se trouve à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le
constate expressément.
<i> Décision de l’Associé uniquei>
1) La Société est administrée par le gérant suivant:
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey,
R. C. Luxembourg numéro B 64.474.
Le gérant aura les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et
autoriser les actes et opérations relatifs à son objet par sa signature individuelle.
62277
2) L’adresse de la Société est fixée à L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
<i> Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le comparants l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: B. Nasr, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 2003, vol. 140S, fol. 99, case 11. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077011.3/220/233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
R.P.M. INVEST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 75.236.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 19 novembre 2003, réf. LSO-AK04710, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077313.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
MARGIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 59.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05213, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077083.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
MARGIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 59.392.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05198, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077086.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
MEDEX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MEDEX FINANCIAL, S.à r.l.).
Registered office: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 95.024.
—
In the year two thousand and three, on the fourth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of MEDEX FINANCIAL, S.à r.l., a «société à responsa-
bilité limitée» (limited liability company), having its registered office at L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon, trade
register Luxembourg section B number 95.024, incorporated by deed dated on 21st of July 2003, published in the Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 916 of 6th of September 2003.
The meeting is presided by Mr Olivier Dorier, director, residing professionally in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing profes-
sionally in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
Luxembourg, le 20 novembre 2003.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
A. Schwachtgen.
Signature.
Signature.
62278
I.- The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be regis-
tered with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 6,471 (six thousand four hundred seventy-one) shares, representing the
whole capital of the company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of
which the shareholders have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1.- To change the denomination of the company into MEDEX, S.à r.l.
2.- Amendment of 4 of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After approval of the foregoing, it is unanimously decided what follows:
<i>First resolutioni>
It is decided to change the denomination of the company into MEDEX, S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend 4 of the Articles of Incorporation to read as
follows:
«The company will have the name MEDEX, S.à r.l.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-
inal deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing per-
sons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an deux mille trois, le quatre novembre.
Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MEDEX FINAN-
CIAL, S.à r.l., ayant son siège social à L-1150 Luxembourg, 291, Route d’Arlon, R.C. Luxembourg section B numéro
95.024, constituée suivant acte reçu le 21 juillet 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, nu-
méro 916 du 6 septembre 2003.
L’assemblée est présidée par Monsieur Olivier Dorier, directeur, demeurant professionnellement à Luxembourg
Le président désigne comme secrétaire et l’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,
demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-
sence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-an-
nexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 6.471 (six mille quatre cent soixante et onze) parts, représentant l’inté-
gralité du capital social sont représentées à la présente Assemblée Générale Extraordinaire, de sorte que l’assemblée
peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale de la société en MEDEX, S.à r.l.
2.- Modification afférente de l’article 4 des statuts.
Après approbation de ce qui précède, il est décidé ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de changer la dénomination sociale de la société en MEDEX, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, il est décidé de modifier l’article 4 des sta-
tuts pour lui donner la teneur suivante:
«La Société aura la dénomination: MEDEX, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est ré-
digé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: O. Dorier, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 11 novembre 2003, vol. 141S, fol. 21, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077429.3/211/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
Luxembourg, le 20 novembre 2003.
J. Elvinger.
62279
MAINE S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 96.929.
—
STATUTES
In the year two thousand and three, on the twelfth of November.
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. WOLVERTON FINANCE CORP., with registered office at Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands,
duly represented by Mr Luc Hansen, hereafter named,
by virtue of a proxy dated November 6, 2003.
2. Mr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5,
boulevard de la Foire,
duly represented by Mr Luc Hansen, hereafter named,
by virtue of a proxy dated November 11, 2003.
3. Mr Luc Hansen, licencié en administration des affaires, with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boule-
vard de la Foire.
The said proxies after having been signed ne varietur by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of a joint stock com-
pany to be organized among themselves.
Name - Registered Office - Duration - Object - Capital
Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that might become owners of the shares created here-
after, a joint stock company is herewith formed under the name of MAINE S.A.
Art. 2. The registered office is in Luxembourg City.
The company may establish branches, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Luxem-
bourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.
Without any prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts, in case the registered office
of the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any
other place within the municipality of the registered office, by a simple decision of the board of directors. The registered
office may be transferred to any other municipality of the Grand Duchy by a decision of the general meeting.
If extraordinary events of a political, economic or social character, likely to impair normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the regis-
tered office may be provisionally transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such
temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the provi-
sional transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
One of the executive organs of the company, which has powers to commit the company for acts of daily management,
shall make this declaration of transfer of the registered office and inform third parties.
Art. 3. The company is established for an unlimited period.
Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the
taking of participating interests in any enterprises in whatever form, as well as the administration, the management, the
control and the development of such participating interests.
The company may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of
a portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and
the control of any enterprise, acquire by way of contribution, subscription, underwriting or by option to purchase and
any other way whatever, any type of securities and patents, realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise,
have developed these securities and patents, grant to group companies any support, loans, advances or guarantees.
The company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are directly
or indirectly connected with its purposes and which are liable to promote their development or extension.
Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 1,300,000.- (one million three hundred thousand Euros)
divided into 13,000 (thirteen thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
For the period foreseen herebelow, the authorized capital is fixed at EUR 20,000,000.- (twenty million Euros) to be
divided into 200,000 (two hundred thousand) shares with a par value of EUR 100.- (one hundred Euros) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, during a period of five years from the publication of the deed of
incorporation of November 12, 2003 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, to increase in one or
several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital. Such increased amount of capital may be
subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium, to be paid-up in cash, by contribution
in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable claims against the company, or even
62280
by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums, or by conversion of bonds as men-
tioned below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing share-
holders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of
such increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.
Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, or bonds with warrants, in
bearer or other form, in any denomination and payable in any currency. It is understood that any issue of convertible
bonds or bonds with warrants can only be made under the legal provisions regarding the authorized capital, within the
limits of the authorized capital as specified hereabove and specially under the provisions of art. 32-4 of the company law.
The board of directors shall fix the nature, price, rate of interest, conditions of issue and repayment and all other
terms and conditions thereof.
A register of registered bonds will be kept at the registered office of the company.
Board of Directors and Statutory Auditors
Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-
ed for a term which may not exceed six years by the general meeting and who can be dismissed at any time by the
general meeting.
If the post of a director elected by the general meeting becomes vacant, the remaining directors thus elected, may
provisionally fill the vacancy. In this case, the next general meeting will proceed to the final election.
Art. 7. The board of directors chooses among its members a chairman. If the chairman is unable to be present, his
place will be taken by one of the directors present at the meeting designated to that effect by the board.
The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board of directors can only validly debate and take decisions if all members are present or represented, proxies
between directors being permitted. A director can only represent one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, telegram, telex or telefax, confirmed by letter.
Written resolutions approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the board
of directors’ meetings.
Art. 8. Decisions of the board are taken by the majority vote of the members present or represented.
Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at
the debates.
Copies or extracts shall be certified conform by one director or by a proxy.
Art. 10. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition in the company’s interest. All powers not expressly reserved to the general meeting by the law of August 10,
1915, as subsequently modified, or by the present Articles of Incorporation of the company, fall within the competence
of the board of directors.
Art. 11. The board of directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management to members
of the board or to third persons who need not be shareholders. The delegation to a member of the board is subject to
a previous authorisation of the general meeting.
Art. 12. Towards third parties, the company is in all circumstances committed either by the joint signatures of any
two directors or by the sole signature of the delegate of the board acting within the limits of his powers. In its current
relations with public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally com-
mits the company.
Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, shareholders or not, who are appointed
by the general meeting, which determines their number and their remuneration, and who can be dismissed at any time.
The term of the mandate of the statutory auditor(s) is fixed by the general meeting for a period not exceeding six
years.
General meeting
Art. 14. The general meeting represents the whole body of shareholders. It has the most extensive powers to carry
out or ratify such acts as may concern the corporation.
The convening notices are made in the form and delays prescribed by law.
Art. 15. The annual general meeting will be held in the municipality of the registered office at the place specified in
the convening notice on the second Monday of the month of June, at 11.00 o’clock.
If such day is a holiday, the general meeting will be held on the next following business day.
Art. 16. The board of directors or the auditor(s) may convene an extraordinary general meeting. It must be con-
vened at the written request of shareholders representing 20% of the company’s share capital.
62281
Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.
The company will recognise only one holder for each share; in case a share is held by more than one person, the
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner, in relation to the company.
Business Year - Distribution of Profits
Art. 18. The business year begins on January 1st and ends on December 31st of each year.
The board of directors draws up the annual accounts according to the legal requirements.
It submits these documents with a report of the company’s activities to the statutory auditor(s) at least one month
before the statutory general meeting.
Art. 19. At least 5% of the net profit for the financial year have to be allocated to the legal reserve fund. Such con-
tribution will cease to be compulsory when the reserve fund reaches 10% of the subscribed capital.
The remaining balance is at the disposal of the general meeting.
Advances on dividends may be paid by the board of directors in compliance with the legal requirements.
The general meeting can decide to assign profits and distributable reserves to the amortisation of the capital, without
reducing the subscribed capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the general meeting voting with the same quorum as for
the amendment of the Articles of Incorporation.
Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, legal or physical
persons, appointed by the general meeting which will specify their powers and remuneration.
General Dispositions
Art. 21. The law of August 10, 1915 on Commercial Companies as subsequently amended shall apply in so far as
these Articles of Incorporation do not provide for the contrary.
<i>Transitory dispositionsi>
The first financial year begins on the date of incorporation of the company and ends on December 31st 2003.
The first annual general meeting shall be held in 2004.
The first directors and the first auditor(s) are elected by the extraordinary general shareholders’ meeting that shall
take place immediately after the incorporation of the company.
By deviation from article 7 of the Articles of Incorporation, the first chairman of the board of directors is designated
by the extraordinary general meeting that designates the first board of directors of the company.
<i>Subscription and Paymenti>
The 13,000 shares have been subscribed to as follows:
All the shares have been entirely paid up in cash, so that the company has now at its disposal the sum of EUR
1,300,000.- (one million three hundred thousand Euros) as was certified to the notary executing this deed.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions prescribed in article 26 of the law of August 10th, 1915
on Commercial Companies as subsequently amended have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.
<i>Expensesi>
The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its incorporation is approximately fixed at
sixteen thousand (16,000.-) Euros.
<i>Extraordinary General Meetingi>
The above-named parties, acting in the hereabove stated capacities, representing the whole of the subscribed capital,
considering themselves to be duly convened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The number of directors is fixed at three.
The following have been elected as directors, their mandate expiring at the general meeting which will be called to
deliberate on the first financial year:
1. Mr Armand Haas, born on October 27, 1937 in Esch-sur-Alzette, licencié en sciences commerciales et financières,
with professional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Mr John Seil, born on September 28, 1948 in Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, with pro-
fessional address in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
<i>Subscribersi>
<i> Number of sharesi>
<i>Amount sub-i>
<i>scribed to andi>
<i>paid-up in EURi>
1. WOLVERTON FINANCE CORP., prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,998
1,299,800.-
2. Mr John Seil, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100.-
3. Mr Luc Hansen, prenamed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100.-
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,000
1,300,000.-
62282
3. Mr Luc Hansen, born on June 8, 1969 in Luxembourg, licencié en administration des affaires, with professional ad-
dress in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Mr John Seil, prenamed has been elected as chairman of the board of directors.
<i>Second resolutioni>
The following has been appointed as statutory auditor, his mandate expiring at the general meeting which will be
called to deliberate on the first financial year:
AUDIEX S.A., R. C. B Number 65.469, having its registered office in L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
<i>Third resolutioni>
The company’s registered office is located in L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearing parties, he signed
together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le douze novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. WOLVERTON FINANCE CORP., ayant son siège social à Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams Cay I, Road
Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par Monsieur Luc Hansen, ci-après nommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 6 novembre 2003.
2. Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant professionnellement à L-1528 Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire,
ici représenté par Monsieur Luc Hansen, ci-après nommé,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 6 novembre 2003.
3. Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant professionnellement à L-1528 Luxem-
bourg, 5, boulevard de la Foire.
Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous le mandataire des comparants et le notaire instrumentant,
resteront annexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.
Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme à consti-
tuer entre eux.
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-
tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de MAINE S.A.
Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges
administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est
établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du
Grand-Duché par décision de l’Assemblée Générale.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-
vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes
exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.
Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-
ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.
Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, au développement, à la mise en valeur et à la
liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au déve-
loppement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option
d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autre-
ment, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés du groupe tous concours, prêts, avances ou
garanties.
Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui
se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent.
62283
Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 1.300.000,- (un million trois cent mille euros) représenté par
13.000 (treize mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 20.000.000,- (vingt millions d’euros) qui
sera représenté par 200.000 (deux cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’Assemblée
Générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans à partir de la publication de l’acte
de constitution du 12 novembre 2003 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, à augmenter en une ou plu-
sieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions nouvelles. Ces augmen-
tations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en nature ou par
compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou même par in-
corporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion d’obligations
comme dit ci-après.
Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.
Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-
cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés.
Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de rembour-
sement et toutes autres conditions y ayant trait.
Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.
Administration - Surveillance
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés
pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’Assemblée Générale et toujours révocables par elle.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’Assemblée Générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-
ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si tous les membres sont présents ou repré-
sentés, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un de ses
collègues.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou
téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une
décision prise à une réunion du conseil d’administration.
Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-
ces.
Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration
et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures et les statuts à l’Assemblée Générale.
Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-
ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires. La délégation à un admi-
nistrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale.
Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-
ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.
Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée
générale qui fixe leur nombre et leur rémunération, et toujours révocables.
La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.
62284
Assemblée Générale
Art. 14. L’Assemblée Générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales.
Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.
Art. 15. L’Assemblée Générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la con-
vocation, le deuxième lundi du mois de juin à 11.00 heures.
Si la date de l’Assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.
Art. 16. Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)
commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant 20% du capital social.
Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-
taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.
Année sociale - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-
dinaire au(x) commissaire(s).
Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé 5% au moins pour la formation du fonds de réserve légale;
ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint 10% du capital social.
Le solde est à la disposition de l’Assemblée Générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du
capital sans que le capital exprimé soit réduit.
Dissolution - Liquidation
Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’Assemblée Générale, statuant suivant les modalités prévues
pour les modifications des statuts.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes
physiques ou morales, nommés par l’Assemblée Générale qui détermine leurs pouvoirs et leur rémunération.
Disposition générale
Art. 21. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2003.
La première Assemblée Générale Annuelle se tiendra en 2004.
Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’Assemblée Générale Extraordinaire
des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.
Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’Assemblée
Générale Extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.
<i>Souscription et paiementi>
Les 13.000 actions ont été souscrites comme suit par:
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR
1.300.000,- (un million trois cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales et ses modifications ultérieures ont été accomplies.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ seize mille (16.000,-) euros.
<i>Souscripteursi>
<i> Nombre d’actions Montant souscrit eti>
<i>libéré en EURi>
1. WOLVERTON FINANCE CORP. préqualifiée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.998
1.299.800,-
2. M. John Seil, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100,-
3. M. Luc Hansen, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
100,-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.000
1.300.000,-
62285
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués
en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et ont pris, à l’unanimité des
voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier
exercice:
1. Monsieur Armand Haas, né le 27 octobre 1937 à Esch-sur-Alzette, licencié en sciences commerciales et financiè-
res, demeurant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
2. Monsieur John Seil, né le 28 septembre 1948 à Luxembourg, licencié en sciences économiques appliquées, demeu-
rant professionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
3. Monsieur Luc Hansen, né le 8 juin 1969 à Luxembourg, licencié en administration des affaires, demeurant profes-
sionnellement à L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
Monsieur John Seil, prénommé, est nommé aux fonctions de président du conseil d’administration
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’Assemblée Générale statuant sur le
premier exercice:
AUDIEX S.A., R. C. B Numéro 65.469, ayant son siège au 57, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants les
présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparants, celui-ci a signé avec Nous, notaire, le
présent acte.
Signé: L. Hansen, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 novembre 2003, vol. 141S, fol. 33, case 7. – Reçu 13.000,- euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077653.3/230/395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
WELFORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05630, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
(077121.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
WELFORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.210.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05638, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
(077124.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
A. Schwachtgen.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
62286
SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 94.531.
—
In the year two thousand and three, on the third of November,
Before the undersigned Maître Joseph Elvinger, notary, residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A., a limited part-
nership with a share capital («société en commandite par action»), having its registered office at 398, route d’Esch, BP
2501, L-1025 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 94.531, incorporated under the Luxembourg law, pursuant to a deed of the Luxembourg
notary Joseph Elvinger dated 9 July 2003 whose articles have been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 855 dated 20 August 2003 (page 40994).
The articles of incorporation of the Company have been amended, and in particular the share capital has been in-
creased, pursuant to a deed of the notary Elvinger, pre-named, dated 12 August 2003, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is presided by Hubert Janssen, jurist, residing in Torgny (Belgium), who appoints as secretary Patrick
Van Hees, jurist, residing in Messancy (Belgium).
The meeting elects as scrutineer Patrick Van Hees, pre-named.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attend-
ance list signed by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The said list as well as
the proxies ne varietur will be registered with this deed.
II. It appears from the attendance list, that the sixteen thousand (16,100) registered shares, that is to say fifteen thou-
sand nine hundred and thirty-nine (15,939) Limited Shares (as defined in the articles of incorporation of the Company
(the «Articles»)) and one hundred and sixty-one (161) Unlimited Shares (as defined in the Articles), representing the
entirety of the statutory capital of the Company, are represented in this extraordinary general assembly. All the share-
holders declare having been informed in advance on the agenda of the meeting and waived all convening requirements
and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda
of the meeting.
III. The meeting has been called for with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1) Acknowledgment of receipt of a letter dated October 2003 delivered by the general partner of the Company as
required under article 16 of the Articles which provides that any decision of the shareholders of the Company listed in
such article cannot be taken without the prior written consent of the general partner of the Company;
2) Increase of the subscribed capital of the Company with an amount of six hundred and thirty Euro (EUR 630.-) in
order to raise it from its current amount of one hundred and sixty-one thousand Euro (EUR 161,000.-) to one hundred
and sixty-one thousand six hundred and thirty Euro (EUR 161,630.-) by creating and issuing sixty-three (63) new Limited
Shares, having the same rights and obligations as the existing one, with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each, subject
to the payment of a global share premium in the amount of six hundred and thirty Euro (EUR 630.-);
3) Recognition of waiver of preferential rights of subscription of the existing shareholders with respect to the increase
of share capital;
4) Recording of the subscription and liberation of the new Limited Shares, together with the global share premium,
by way of contribution in cash;
5) Amendment of article 5.1 of the Articles regarding the share capital of the Company so as to reflect the taken
decisions and which shall read as follows:
«The subscribed capital is fixed at one hundred and sixty-one thousand six hundred and thirty Euro (EUR 161,630.-),
represented by one hundred and sixty-one (161) shares of Unlimited Shareholders («actions de commandité», herein
defined as «Unlimited Shares») and sixteen thousand and two (16,002) shares of Limited Shareholders («actions de com-
manditaire», herein defined as «Limited Shares»; together, with the Unlimited Shares and the Preference Shares, upon
issuance, herein defined as the «Shares»), with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.»;
6) Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously and in compliance with articles 16 and 18.3 of
the Articles of the Company:
<i>First resolution i>
Article 16 of the Articles provides, among other things, that any decision of the shareholders of the Company relating
to the alteration of the Articles cannot be taken without the prior written consent of the general partner of the Com-
pany.
SSCP PLASTICS, a private limited liability company, having its registered office at 398, route d’Esch, BP 2501, L-1025
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated under Luxembourg law by a deed drawn up on 9 July 2003
by Luxembourg Notary Joseph Elvinger, residing in Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Com-
merce and Companies under number B 94.530 and whose articles have been published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 827 dated 14 August 2003 (page 39.673) acting as general partner of the Company (the
«General Partner»), declared that it agreed with the amendments to the Articles in the form described in the above
agenda as evidenced in its letter dated 28 October 2003, which shall remain attached to this present deed.
62287
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to increase the subscribed capital of the Company with an amount of six hundred and thirty
Euro (EUR 630.-) in order to raise it from its current amount of one hundred and sixty-one thousand Euro (EUR
161,000.-) to one hundred and sixty-one thousand six hundred and thirty Euro (EUR 161,630.-) by creating and issuing
sixty-three (63) new Limited Shares, having the same rights and obligations as the existing one, with a par value of ten
Euro (EUR 10.-) each, subject to the payment of a global share premium in the amount of six hundred and thirty Euro
(EUR 630.-).
<i>Third resolutioni>
The shareholders, to know:
- The General Partner, as unlimited shareholder of the Company;
- STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, acting as general partner of STIRLING SQUARE CAPITAL
PARTNERS, L.P., a limited partnership established under the laws of England, having its statutory office in 26 New Street,
St. Helier, Jersey, JE2 3RA («SSCP»), as limited shareholder of the Company;
- SWC 1, Inc., having its statutory office at PO Box 25, Britannic House Providenciales, Turks & Caicos Islands, British
West Indies;
- MERLIN OFFSHORE LIMITED, having its statutory office at Trident Chambers, Wickams Cay, Road town, Tortola,
British Virgin Islands and registered under number 493327;
- MAITLAND TRUSTEES LIMITED as Trustee of the Naaikoks Trust, having its statutory office at PO Box 805, 9
Colombus Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands and registered under number 3079;
- Mr Jakob Edzard Förschner, residing at 24 Carlisle Place, London SW1P 1EZ, born in Hamburg, Germany on 16
February 1959; and
- NATASHA FOUNDATION, having its statutory office at Clarendon House 2 Church street, Hamilton HM 11, Ber-
muda and registered under number EC25010.
declare to waive their right to claims and preferential rights of subscription with respect to the increase of the share
capital, as evidence by theirs respective proxy, which shall remain attached to the present minutes.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders records the subscription and the liberation of sixty-three (63) new Limited Shares by SSCP, here
represented by Hubert Janssen, pre-named, by virtue of a proxy established under private seal on 21 October 2003,
who, after having stated that his principal has full knowledge of the Articles, declares to subscribe in the name of his
principal to the ownership of sixty-three (63) new Limited Shares with a nominal value of ten Euro (EUR 10.-) each,
subject to payment of a share premium in the amount of six hundred and thirty Euro (EUR 630.-), for a total amount of
one thousand two hundred sixty Euro (EUR 1,260.-) and to have fully paid up such amount by contribution in cash.
A blocking certificate delivered by the bank certifies that the amount of one thousand two hundred sixty Euro (EUR
1,260.-) is at the disposal of the Company and is allocated to the liberation of the new Limited Shares and the payment
of the share premium in connection thereto.
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles regarding the share capital of the Company so as to
reflect the taken decisions and which shall read as follows:
«The subscribed capital is fixed at one hundred and sixty-one thousand six hundred and thirty Euro (EUR 161,630.-),
represented by one hundred and sixty-one (161) shares of Unlimited Shareholders («actions de commandité», herein
defined as «Unlimited Shares») and sixteen thousand and two (16,002) shares of Limited Shareholders («actions de com-
manditaire», herein defined as «Limited Shares»; together, with the Unlimited Shares and the Preference Shares, upon
issuance, herein defined as the «Shares»), with a par value of ten Euro (EUR 10.-) each.»;
<i>Costsi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately thousand five hundred euros.
Nothing else being on the agenda, and nobody rising to speak, the meeting was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing per-
sons, and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be preponderant.
Whereof the present notarial deed was prepared in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this doc-
ument.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his name, first name, civil status
and residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française:
L’an deux mille trois, le trois novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SSCP PLASTICS HOLDING S.C.A., société en
commandite par actions de droit luxembourgeois, ayant son siège social 398, route d’Esch, BP 2501, L-1025 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le
numéro B 94.531, constituée en vertu d’un acte reçu le 9 juillet 2003 par le notaire luxembourgeois Joseph Elvinger
62288
dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 855 du 20 août
2003 (page 40994).
Les statuts de la Société ont été modifiés, et en particulier le capital social augmenté, en vertu d’un acte reçu par le
notaire Elvinger, précité, le 12 août 2003, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L’assemblée est présidée par Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny (Belgique), lequel désigne comme secré-
taire, Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy (Belgique).
L’assemblée choisit comme scrutateur, Patrick Van Hees, précité.
Le bureau de l’assemblée ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire d’acter que:
I. Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence signée par les actionnaires ou leurs représentants, par le bureau de l’assemblée et par le notaire. Cette liste
et les procurations ne varietur resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. Il ressort de la liste de présence que les seize mille cent (16.100) actions nominatives, soit quinze mille neuf cent
trente-neuf (15.939) Actions de Commanditaire (telles que définies dans les statuts de la Société (les «Statuts»)) et cent
soixante et une (161) Actions de Commandité (telles que définies dans les Statuts), représentant l’intégralité du capital
social de la Société sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que tous les actionnai-
res ayant été préalablement informé de l’agenda et nous ayant dispensé des convocations et formalités requises, l’as-
semblée peut délibérer et décider valablement sur tous les points figurant à son ordre du jour.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Accusé de réception d’une lettre du mois d’octobre 2003 transmise par le gérant de la Société tel que requis à
l’article 16 des Statuts, lequel dispose que toute décision des actionnaires de la Société listée audit article ne pourra être
adoptée sans le consentement préalable et écrit du gérant de la Société;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de six cent trente Euro (630,- EUR) pour le porter de
son montant actuel de cent soixante et un mille Euro (161.000,- EUR) au montant de cent soixante et un mille six cent
trente Euro (161.630,- EUR) par la création et l’émission de soixante-trois (63) nouvelles Actions de Commanditaire
d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les existantes, à sous-
crire moyennant le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de six cent trente Euro (630,- EUR);
3. Constatation de la renonciation des actionnaires existants à leurs droits de souscription préférentiels concernant
l’augmentation du capital souscrit;
4. Souscription et libération des nouvelles Actions de Commanditaire, ainsi que de la prime d’émission globale, par
des apports en numéraire;
5. Modification de l’article 5.1 des Statuts concernant le capital social de la Société afin de refléter les décisions prises,
lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«5.1 Le capital social est fixé à cent soixante et un mille six cent trente Euro (161.630,- EUR) représenté par cent
soixante et une (161) actions de commandité (ci-après «Actions de Commandité») et seize mille deux (16.002) actions
de commanditaire (ci-après «Actions de Commanditaire», ensemble avec les Actions de Commandité et les Actions
Préférentielles, après émission, ci-après les «Actions»), d’une valeur nominale de dix (10,- EUR) Euro, chacune.»
6. Divers.
Après délibérations, les résolutions suivantes ont été adoptées à l’unanimité et conformément aux articles 16 et 18.3
des Statuts de la Société:
<i>Première résolutioni>
L’article 16 des Statuts dispose, notamment, que toute décision des Actionnaires concernant la modification des Sta-
tuts de la Société ne peut être adoptée sans le consentement préalable et écrit du Gérant.
SSCP PLASTICS, société privée à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social 398, route
d’Esch, BP 2501, L-1025 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d’un acte reçu par le notaire
luxembourgeois Joseph Elvinger, demeurant à Luxembourg, le 9 juillet 2003, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 94.530 et dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 827 du 14 août 2003 (page 39673), agissant en qualité de gérant («general partner»)
de la Société (le «Gérant») a déclaré qu’il marquait son accord sur les modifications apportées aux Statuts dans la forme
décrite dans l’ordre du jour ci-dessus, tel qu’il est établi par sa lettre du 28 octobre 2003, qui restera annexée au présent
acte.
<i>Deuxième résolutioni>
Les actionnaires décident d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de six cent trente Euro (630,-
EUR) pour le porter de son montant actuel de cent soixante et un mille Euro (161.000,- EUR) au montant de cent
soixante et un mille six cent trente Euro (161.630,- EUR) par la création et l’émission de soixante-trois (63) nouvelles
Actions de Commanditaire d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obligations
que les existantes, à souscrire moyennant le paiement d’une prime d’émission globale d’un montant de six cent trente
Euro (630,- EUR).
<i>Troisième résolutioni>
Les actionnaires, à savoir:
- le Gérant, en qualité d’associé commandité de la Société;
- STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS LIMITED, en qualité de «general partner» de STIRLING SQUARE CA-
PITAL PARTNERS, L.P., un «limited partnership» de droit anglais, ayant son siège social 26 New Street, St. Helier, Jersey,
JE2 3RA («SSCP»), en qualité d’associé commanditaire de la Société;
62289
- SWC 1, Inc., ayant son siège social PO Box 25, Britannic House Providenciales, Turks & Caicos Islands, British West
Indies;
- MERLIN OFFSHORE LIMITED, ayant son siège social Trident Chambers, Wickams Cay, Road town, Tortola, British
Virgin Islands et inscrite sous le numéro 493327;
- MAITLAND TRUSTEES LIMITED as Trustee of the Naaikoks Trust, ayant son siège social PO Box 805, 9 Colombus
Centre, Pelican Drive, Road Town, Tortola, British Virgin Islands et inscrite sous le numéro 3079;
- M. Jakob Edzard Förschner, demeurant 24 Carlisle Place, London SW1P 1EZ, né à Hambourg, Allemagne, le 16 fé-
vrier 1959; et
- NATASHA FOUNDATION, ayant son siège social Clarendon House 2 Church street, Hamilton HM 11, Bermuda
et inscrite sous le numéro EC25010.
Déclarent renoncer à leurs droits de souscription préférentiels concernant l’augmentation de capital dont question
ci-dessus, tel qu’il est établi par leurs procurations respectives, lesquelles resteront attachées aux présentes.
<i>Quatrième résolutioni>
Les actionnaires enregistrent la souscription et libération des soixante-trois (63) nouvelles Actions de Commanditai-
re, ainsi que la prime d’émission globale, par SSCP, ici représenté par Hubert Janssen, précité, en vertu d’une procuration
sous seing privé établie le 21 octobre 2003; lequel déclare, après avoir fait constater que son mandant a pleine connais-
sance des Statuts de la Société, souscrire au nom du mandant, soixante-trois (63) nouvelles Actions de Commanditaire
d’une valeur nominale de dix Euro (10,- EUR) chacune, à souscrire moyennant le paiement d’une prime d’émission glo-
bale de six cent trente Euro (630,- EUR), pour un montant total de mille deux cent soixante Euro (1.260,- EUR) et libérer
intégralement ce montant moyennant apport en numéraire.
Un certificat de blocage délivré par la banque atteste que le montant de mille deux cent soixante Euro (1.260,- EUR)
est à la disposition de la Société et est alloué à la libération des nouvelles Actions de Commanditaire et au paiement de
la prime d’émission y afférente.
<i>Cinquième résolutioni>
Les actionnaires décident de modifier l’article 5.1
er
des Statuts concernant le capital social de la Société afin de refléter
les décisions prises, lequel sera dorénavant libellé comme suit:
«5.1
er
. Le capital social est fixé à cent soixante et un mille six cent trente Euro (161.630,- EUR) représenté par cent
soixante et une (161) actions de commandité (ci-après «Actions de Commandité») et seize mille deux (16.002) actions
de commanditaire (ci-après «Actions de Commanditaire», ensemble avec les Actions de Commandité et les Actions
Préférentielles, après émission, ci-après les «Actions»), d’une valeur nominale de dix (10,- EUR) Euro, chacune.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ mille cinq cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.
Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare qu’à la requête des comparants, le présent acte est
établi en langue anglaise suivi d’une version française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. Janssen, P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, vol. 141S, fol. 19, case 2. – Reçu 12,60 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077420.3/211/235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
ABSOLUTE VENTURES S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Registered office: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.345.
—
In the year two thousand and three, on the fifth of November.
Before Us, Maître Henri Beck, notary residing in Echternach (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the «société en commandite par actions» established in Luxembourg
under the denomination of ABSOLUTE VENTURES S.C.A., incorporated pursuant to a deed of notary André
Schwachtgen, residing in Luxembourg, on May 6, 2002, published in the Mémorial C Number 1124 of 25 July 2002, the
articles of incorporation of which have been amended as follows:
- by deed of the prenamed notary André Schwachtgen on December 23, 2002, published in the Mémorial C Number
167 of February 17, 2003;
- by deed of the undersigned notary on July 25, 2003, published in the Mémorial C Number 897 of September 2, 2003.
The meeting begins at 3.30 p.m., Mr Jean Lambert, «Maître en sciences économiques», with professional address at
207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg, being in the Chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Elodie Mantilaro, private employee, with professional address
at 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Luxembourg, le 20 novembre 2003.
J. Elvinger.
62290
The meeting elects as scrutineer Mrs Caroline Folmer, private employee, with professional address at 207, route
d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the seventeen thou-
sand five hundred and fifty (17,550) Redeemable Shares («A shares»), seventeen thousand five hundred and fifty (17,550)
Ordinary Shares («B shares») and seventeen thousand five hundred and fifty (17,550) Shares («C shares») having a par
value of two euros (
€ 2.-) each, representing the entire corporate capital of one hundred and five thousand three hun-
dred euros (
€ 105,300.-) are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may de-
liberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders having agreed
to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to
the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
1. Increase of the issued share capital of the Company by the amount of sixteen thousand two hundred euros
(
€ 16,200.-) in order to increase it from the present amount of one hundred and five thousand three hundred euros
(
€ 105,300.-) to the amount of one hundred twenty-one thousand five hundred euros (€ 121,500.-) and by issuing:
- two thousand seven hundred (2,700) Redeemable Shares («A shares») having a par value of two euros (
€ 2.-) each
and a premium of four hundred ninety-six euros (
€ 496.-) each, pay up these shares entirely in cash;
- two thousand seven hundred (2,700) Ordinary Shares («B shares») having a par value of two euros (
€ 2,-) each, pay
up these shares entirely in cash.
- two thousand seven hundred (2,700) Shares («C shares») having a par value of two euros (
€ 2.-) each, pay up these
shares entirely in cash.
Increase of the share premium paid on the «A shares» by the amount of one million three hundred thirty-nine thou-
sand two hundred euros (
€ 1,339,200.-) in order to increase it from the present amount of eight million seven hundred
four thousand eight hundred euros (
€ 8,704,800.-) to the amount of ten million forty-four thousand euros
(
€ 10,044,000.-)
Furthermore, there is an additional premium of sixty-two thousand five hundred sixty-eight euros forty-five cents
(
€ 62,568.45) paid by the subsequent investors as per art. 2.7.6 of the shareholder’s agreement.
After the capital increase, the new issued share capital of the company will be divided into sixty thousand seven hun-
dred fifty (60,750) shares, comprising:
i) twenty thousand two hundred fifty (20,250) Redeemable Shares having a par value of two euros (
€ 2.-) each («A
shares»);
ii) twenty thousand two hundred fifty (20,250) Ordinary Shares having a par value of two euros (
€ 2.-) each («B
shares»);
iii) twenty thousand two hundred fifty (20,250) Shares having a par value of two euros (
€ 2.-) each, allocated to the
Unlimited Shareholder («C shares»).
In addition to the issued capital, the issue premiums will amount to a total of ten million one hundred six thousand
five hundred sixty-eight euros and forty-five cents (
€ 10,106,568.45) on the A Shares.
2. Subscription of the new shares after having stated that the existing shareholders have waived to their preferential
subscription right.
3. Modification of Article 5 of the statutes.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i>First resolutioni>
The general meeting resolved to increase the share capital by sixteen thousand two hundred euros (
€ 16,200.-) to
raise it from one hundred and five thousand three hundred euros (
€ 105,300.-) to the amount of one hundred twenty-
one thousand five hundred euros (
€ 121,500.-) by the creation and issue of eight thousand one hundred (8,100) new
shares having a par value of two euros (
€ 2.-) each.
After having stated that the existing shareholders have waived to their preferential subscription right, the new shares
have been subscribed as follows:
- two thousand seven hundred (2,700) Redeemable Shares («A shares») and two thousand seven hundred (2,700)
Ordinary Shares («B shares») by the company S.I.SV.EL. S.p.A., company incorporated under the Italian law, having its
registered office at Via Castagnole 59, 10060 None (TO), Italy,
here represented by Mr Jean Lambert, prenamed,
by virtue of a proxy given in Castagnole, on October 22, 2003,
- two thousand seven hundred (2,700) Shares («C shares») by ABSOLUTE VENTURES S.A., having its registered of-
fice at L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
here represented by Mr Jean Lambert, prenamed,
by virtue of a proxy given in Luxembourg, on October 22, 2003
which proxies, after having been signed ne varietur by the mandatories and the undersigned notary, shall remain at-
tached to the present deed to be filed at the same time.
Besides the par value of the shares, the subscribers paid in a share premium of a total amount of one million four
hundred and one thousand seven hundred sixty-eight euros forty-five cents (
€ 1,401,768.45).
The proof of the payment of these amounts has been given to the undersigned notary, who expressly states it.
62291
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the two first paragraphs of Article 5 of the Articles of Incorporation
are amended and shall henceforth read as follows:
Art. 5. Share capital. Paragraphs 1 and 2.
The Company has an issued capital of one hundred twenty-one thousand five hundred euros (
€ 121,500.-), divided
into sixty thousand seven hundred fifty (60,750) shares comprising:
i) twenty thousand two hundred fifty (20,250) Redeemable Shares having a par value of two euros (
€ 2.-) each («A
shares»);
ii) twenty thousand two hundred fifty (20,250) Ordinary Shares having a par value of two euros (
€ 2.-) each («B
shares»);
iii) twenty thousand two hundred fifty (20,250) Shares having a par value of two euros (
€ 2.-) each, allocated to the
Unlimited Shareholder («C shares»).
In addition to the issued capital, the issue premiums will amount to a total of ten million one hundred six thousand
five hundred sixty-eight euros and forty-five cents (
€ 10,106,568.45) on the A Shares.
<i>Declarationi>
The undersigned notary declares, by application of article 32-1 of the law on commercial companies of 10th August
1915, as amended, that he has examined the conditions imposed by article 26 of the aforesaid law.
Nothing else being on the agenda and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at 4.00 p.m.
In faith of which we, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing
signed with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le cinq novembre.
Par-devant Maître Henri Beck, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société en commandite par actions établie à Luxembourg,
sous la dénomination de ABSOLUTE VENTURES S.C.A., ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par le notaire André Schwachtgen de résidence à Luxembourg, le 6 mai 2002, publié au Mémorial C Numéro 1124
du 25 juillet 2002, et dont les statuts ont été modifiés comme suit:
- suivant acte reçu par ledit notaire Schwachtgen en date du 23 décembre 2002, publié au Mémorial C numéro 167
du 17 février 2003;
- suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 25 juillet 2003, publié au Mémorial C numéro 897 du 2 sep-
tembre 2003.
La séance est ouverte à 15.30 heures sous la présidence de Monsieur Jean Lambert, Maître en Sciences Economiques,
avec adresse professionnelle à 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Elodie Mantilaro, employée privée, avec adresse profes-
sionnelle à 207, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Madame Caroline Folmer, employée privée, avec adresse professionnelle à 207,
route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les dix-sept mille cinq
cent cinquante (17.550) Actions Rachetables («Actions A»), les dix-sept mille cinq cent cinquante (17.550) Actions Or-
dinaires («Actions B») et les dix-sept mille cinq cent cinquante (17.550) Actions («Actions C») d’une valeur nominale
de deux euros (
€ 2,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de cent cinq mille trois cents euros
(
€ 105.300,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et
peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les action-
naires ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au
présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregis-
trement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Augmentation du capital social émis de la Société à concurrence d’un montant de seize mille deux cents euros
(
€ 16.200,-) pour l’augmenter de son montant actuel de cent cinq mille trois cents euros (€ 105.300,-) à un montant de
cent vingt et un mille cinq cents euros (
€ 121.500,-) par l’émission de:
- deux mille sept cents (2.700) Actions Rachetables («Actions A») d’une valeur nominale de deux euros (
€ 2,-) cha-
cune et une prime d’émission de quatre cent quatre-vingt-seize euros (
€ 496,-) chacune, libérer entièrement ces actions
en espèces;
- deux mille sept cents (2.700) Actions Ordinaires («Actions B») d’une valeur nominale de deux euros (
€ 2,-) chacune,
libérer entièrement ces actions en espèces.
62292
- deux mille sept cents (2.700) «Actions C» d’une valeur nominale de deux euros (
€ 2,-), libérer entièrement des
actions en espèces.
Augmentation de la prime d’émission payée sur les «Actions A» d’un montant de
€ 1.339.200,- (un million trois cent
trente-neuf mille deux cents euros) pour l’augmenter de son montant actuel de
€ 8.704.800,- (huit millions sept cent
quatre mille huit cents euros) à un montant de
€ 10.044.000,- (dix millions quarante-quatre mille euros).
Payement d’une prime d’émission complémentaire d’un montant de soixante-deux mille cinq cent soixante-huit euros
quarante-cinq cents (
€ 62.568,45) par les nouveaux investisseurs conformément à l’article 2.7.6 de la convention d’ac-
tionnaires
Après l’augmentation de capital, le nouveau capital émis de la société sera divisé en soixante mille sept cent cinquante
(60.750) Actions, comprenant:
i) vingt mille deux cent cinquante (20.250) Actions Rachetables d’une valeur nominale de deux euros (
€ 2,-) chacune
(«Actions A»);
ii) vingt mille deux cent cinquante (20.250) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de deux euros (
€ 2,-) chacune
(«Actions B»);
iii) vingt mille deux cent cinquante (20.250) Actions d’une valeur nominale de deux euros (
€ 2,-) chacune, attribuées
à l’Actionnaire Commandité («Actions C»).
En plus du capital émis, des primes d’émission d’un montant total de dix millions cent six mille cinq cent soixante-huit
euros quarante-cinq cents (
€ 10.106.568,45) ont été payées sur les Actions A.»
2. Souscription des nouvelles actions, après avoir constaté que les actionnaires existants renoncent à leur droit de
souscription préférentiel.
3. Modification de l’article 5 des statuts.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolu-
tions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence de seize mille deux cents euros (
€ 16.200,-)
pour l’augmenter de son montant actuel de cent cinq mille trois cents euros (
€ 105.300,-) à un montant de cent vingt
et un mille cinq cents euros (
€ 121.500,-) par la création et l’émission de huit mille cent (8.100) actions nouvelles d’une
valeur nominale de deux euros (
€ 2,-) chacune.
Après avoir constaté que les actionnaires existants renoncent à leur droit de souscription préférentiel, les nouvelles
actions ont été souscrites et entièrement libérées en espèces de la manière suivante:
- deux mille sept cents (2.700) Actions Rachetables («Actions A») et deux mille sept cents (2.700) Actions Ordinaires
(«Actions B») par la société de droit italien S.I.SV.EL. S.p.A, avec siège social à Via Castagnole 59, 10060 None (TO),
Italie,
ici représentée par Monsieur Jean Lambert, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Castagnole, le 22 octobre 2003,
- deux mille sept cents (2.700) «Actions C» par la société ABSOLUTE VENTURES S.A., ayant son siège social à
L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon,
ici représentée par Monsieur Jean Lambert, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 octobre 2003,
lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront annexées
au présent acte pour être enregistrées en même temps.
Outre la valeur nominale des actions le souscripteur a payé une prime d’émission d’un montant total de un million
quatre cent et un mille sept cent soixante-huit euros quarante-cinq cents (
€ 1.401.768,45).
La preuve de ces payements a été rapportée au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, les deux premiers alinéas de l’article 5 des statuts sont modifiés et auront désormais
la teneur suivante:
Art. 5. Capital. Alinéas 1
er
et 2. La Société a un capital émis de cent vingt et un mille cinq cents euros
(
€ 121.500,-), divisé en soixante mille sept cent cinquante (60.750) actions comprenant:
i) vingt mille deux cent cinquante (20.250) Actions Rachetables d’une valeur nominale de deux euros (
€ 2,-) chacune
(«Actions A»);
ii) vingt mille deux cent cinquante (20.250) Actions Ordinaires d’une valeur nominale de deux euros (
€ 2,-) chacune
(«Actions B»);
iii) vingt mille deux cent cinquante (20.250) Actions d’une valeur nominale de deux euros (
€ 2,-) chacune, attribuées
à l’Actionnaire Commandité («Actions C»).
En plus du capital émis, une prime d’émission d’un montant total de dix millions cent six mille euros cinq cent soixan-
te-huit euros quarante-cinq cents (
€ 10.106.568,45) a été payée sur les Actions A.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare qu’en application de l’article 32-1 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915
telle que modifiée, il a examiné les conditions imposées par l’article 26 de la loi ci-avant mentionnée.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’assemblée s’est terminée à 16.00 heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
62293
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente mi-
nute.
Signé: J. Lambert, E. Mantilaro, C. Folmer, H. Beck.
Enregistré à Echternach, le 7 novembre 2003, vol. 356, fol. 31, case 5. – Reçu 14.179,68 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Miny.
Pour expédition conforme, délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(073502.3/201/219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.
ABSOLUTE VENTURES S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 207, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 87.345.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(073503.3/201/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2003.
TWOPP S.A.H., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5885 Hesperingen, 281, route de Thionville.
H. R. Luxemburg B 56.645.
—
Im Jahre zweitausendunddrei, am vierundzwanzigsten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph Wagner, mit dem Amtswohnsitze zu Sassenheim (Luxemburg),
versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft TWOPP S.A.H., eine
Aktiengesellschaft, mit Sitz in 27, rue des Glacis, L-1628 Luxemburg, (R.C. Luxemburg, Sektion B Nummer 56.645), ge-
gründet gemäß notarieller Urkunde vom 24. Oktober 1996, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 8 vom 10. Januar
1997, (hiernach kurz «die Gesellschaft» genannt).
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert auf Grund einer außerordentlichen Generalversammlung der
Aktionäre der Gesellschaft, unter Privatschrift vom 19. März 2002, in der unter anderem das Gesellschaftskapital von
Luxemburger Franken (LUF) in Euro (EUR) umgewandelt wurde; ein Auszug dieser außerordentlichen Generalver-
sammlung vom 19. März 2002, wurde im Mémorial C Nummer 1018 vom 4. Juli 2002, veröffentlicht.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Franc Dreu, Diplom-Ingenieur, wohnhaft in Howald.
Der Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Fred Alessio, Privatbeamter, wohnhaft in Kayl.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Bojan Ploj, Kauffmann, wohnhaft in Celje (Slowenien).
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet.
Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustel-
len:
I.- Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von 17, rue des Glacis, L-1628 Luxemburg, nach 281, route de Thionville, L-5885
Hesperingen.
2.- Dementsprechende Abänderung von Artikel eins (1), Absatz zwei (2) der Satzung der Gesellschaft.
II.- Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste ein-
getragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktio-
näre und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben
einregistriert zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach Unterzeichnung ne varietur durch die Erschienenen eben-
falls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
III.- Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesen-
den oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Ta-
gesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.
IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der sämtliche Aktien der Gesellschaft vertreten sind, ist ordnungs-
gemäß zusammengesetzt und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt den Gesellschaftssitz der Gesellschaft TWOPP
S.A.H., von seiner jetzigen Adresse in 27, rue des Glacis, L-1628 Luxemburg, nach 281, route de Thionville, L-5885 Hes-
peringen zu verlegen.
Echternach, le 11 novembre 2003.
H. Beck.
Echternach, le 11 novembre 2003.
H. Beck.
62294
<i>Zweiter Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre beschließt, zwecks Anpassung der Satzung an den hiervor
genommenen Beschluss, Artikel eins (1), Absatz zwei (2) der Gesellschaft abzuändern. Die außerordentliche General-
versammlung der Aktionäre beschließt Artikel eins (1), Absatz zwei (2) abzuändern wie folgt:
«Art. 1. Absatz 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Hesperingen (Luxemburg).»
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen, ge-
bräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: F. Dreu, F. Alessio, B. Ploj, J.-J. Wagner.
Einregistriert zu Esch/Alzette, am 28. October 2003, Band 881, Blatt 2, Feld 4. – Erhalten 12 Euros.
Der Einvernehmer (gezeichnet): Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(077586.3/239/58) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
TWOPP S.A.H., Société Anonyme.
Siège social: L-5885 Hesperange, 281, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 56.645.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077587.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
POWER TRANSMISSION FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 56.517.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05220, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(077080.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
POWER TRANSMISSION FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 56.517.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05218, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077081.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
POWER TRANSMISSION FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 56.517.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05216, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077082.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Beles, den 24. November 2003.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 24 novembre 2003.
J.-J. Wagner.
Signature.
Signature.
62295
KOMITON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.146.
—
In the year two thousand three, on the fifth of November.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of KOMITON HOLDING S.A., a société anonyme
having its registered office in L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines (the «Company»). The Company was incor-
porated by a notarial deed of October 17, 1990, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number
124 of March 13, 1991, registered in the Luxembourg Company Register under section B number 35.146. The articles
of incorporation have been modified for the last time by a private deed of June 28, 2001, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, number 1026 of July 5, 2002.
The Extraordinary General Meeting appoints Mr Marc Loesch, lawyer, residing in Luxembourg, as Chairman of the
meeting who opens the meeting at 2.15. p.m.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Jean-Michel Schmit, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Grégory Surply, lawyer, residing in Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. To reduce the corporate capital by an amount of one million two hundred and seventy-seven thousand twenty-
three point four thousand nine hundred and thirteen euros (1,277,023.4913 EUR) so as to reduce it from its present
amount of one million three hundred and fourteen thousand two hundred and seven point fifty-two euros
(1,314,207.5200 EUR) to an amount of thirty-seven thousand one hundred and eighty-four point zero two hundred and
eighty-seven euros (37,184.0287 EUR) by cancellation of fifty-one thousand five hundred and fifteen (51,515) shares held
by the Company.
2. To amend article 5 of the articles of incorporation which will now read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty-seven thousand one hundred
and eighty-four point zero two hundred and eighty-seven euros (37,184.0287 EUR) divided into one thousand five hun-
dred (1,500) shares fully paid up without par value.»
3. To delegate powers to the members of the board of directors.
II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their
shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the bureau of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
III) It appears from the said attendance-list that all the shares representing the shareholders entitled to vote are
present or represented at the meeting, which consequently is regularly constituted and may validly deliberate on all the
items on the agenda. The shareholders present or represented declare that they consider themselves as having been
duly convened to this extraordinary general meeting of shareholders and that they have been duly informed on the agen-
da before this meeting.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to reduce the corporate capital by an amount of one
million two hundred and seventy-seven thousand twenty-three point four thousand nine hundred and thirteen euros
(1,277,023.4913 EUR) so as to reduce it from its present amount of one million three hundred and fourteen thousand
two hundred and seven point fifty-two euros (1,314,207.5200 EUR) to an amount of thirty-seven thousand one hundred
and eighty-four point zero two hundred and eighty-seven euros (37,184.0287 EUR) by cancellation of fifty-one thousand
five hundred and fifteen (51,515) shares held by the Company.
<i>Second resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of incorporation which
shall now read as follows:
«Art. 5. Corporate Capital. The corporate capital of the Company is set at thirty-seven thousand one hundred
and eighty-four point zero two hundred and eighty-seven euros (37,184.0287 EUR) divided into one thousand five hun-
dred (1,500) shares fully paid up without par value.»
<i>Third resolutioni>
The Extraordinary General Meeting of shareholders resolves to delegate to each director of the Company all and any
powers to implement the above-mentioned resolutions.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of
this document are estimated at approximately one thousand two hundred euros.
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed at 2.30. p.m.
Whereof the present notarial deed was drawn up Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
62296
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with us the notary this
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le cinq novembre.
Par-devant, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
S’est tenue l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme KOMITON HOLDING S.A.,
ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines (la «Société»). La Société a été constituée par acte
notarié en date du 17 octobre 1990, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 124 du 13 mars
1991, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés, section B, sous le numéro 35.146. Les statuts de la Société
ont été modifiés pour la dernière fois par acte du 28 juin 2001, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1026 du 5 juillet 2002.
La séance est ouverte à quatorze heures quinze sous la présidence de Maître Marc Loesch, avocat, résidant à Luxem-
bourg, comme Président de l’Assemblée.
Le président désigne comme secrétaire Maître Jean-Michel Schmit, avocat, résidant à Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Maître Grégory Surply, avocat, résidant à Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1. Réduction du capital social d’un montant d’un million deux cent soixante-dix-sept mille vingt-trois virgule quatre
mille neuf cent treize euros (EUR 1.277.023,4913) de manière à réduire le capital social de son montant actuel d’un
million trois cent quatorze mille deux cent sept virgule cinquante-deux euros (EUR 1.314.207,5200) à un montant de
trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre virgule zéro deux cent quatre-vingt-sept euros (EUR 37.184,0287) par l’an-
nulation de cinquante et un mille cinq cent quinze (51.515) actions détenues par la Société.
2. Modification de l’article 5 des statuts de la Société pour refléter ce changement. L’article 5 aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre virgule
zéro deux cent quatre-vingt-sept euros (EUR 37.184,0287) divisé en mille cinq cents (1.500) actions entièrement sous-
crites et sans valeur nominale.»
3. Délégation de pouvoirs aux membres du conseil d’administration.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres du
Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les personnes présentes et le notaire instrumentai-
re, resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant les actionnaires ayant le droit de vote sont
présentes ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement déli-
bérer sur son ordre du jour. Les actionnaires déclarent qu’ils se reconnaissent dûment convoqués et qu’ils ont eu con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
Après délibération, l’Assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale des actionnaires décide de réduire le capital social d’un montant d’un million deux cent soixan-
te-dix-sept mille vingt-trois virgule quatre mille neuf cent treize euros (EUR 1.277.023,4913) de manière à réduire le
capital social de son montant actuel d’un million trois cent quatorze mille deux cent sept virgule cinquante-deux euros
(EUR 1.314.207,5200) à un montant de trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre virgule zéro deux cent quatre-vingt-
sept euros (EUR 37.184,0287) par l’annulation de cinquante et un mille cinq cent quinze (51.515) actions détenues par
la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale des actionnaires décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société afin de refléter la mo-
dification du capital social. L’article 5 aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à trente-sept mille cent quatre-vingt-quatre virgule
zéro deux cent quatre-vingt-sept euros (EUR 37.184,0287) divisé en mille cinq cents (1.500) actions entièrement sous-
crites et sans valeur nominale.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée Générale des actionnaires décide de déléguer à chaque administrateur de la Société tous les pouvoirs
nécessaires afin d’exécuter les résolutions mentionnées ci-dessus.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont
estimés à environ mille deux cents euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée à quatorze heures trente.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
62297
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-avant,
le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent
acte.
Signé: M. Loesch, J.-M. Schmit, G. Surply, J-.J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 7 novembre 2003, vol. 881, fol. 13, case 1. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077581.3/239/136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
KOMITON HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.
R. C. Luxembourg B 35.146.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077582.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
SAFT FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. PROJECT SPEED BIDCO, S.à r.l.).
Registered office: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 96.506.
—
In the year two thousand and three, on the thirtieth day of the month of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of PROJECT SPEED BIDCO, S.à r.l. (the «Company»), a
société à responsabilité limitée having its registered office at 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg incorporated by
deed of the undersigned notary as a société à responsabilité limitée on the 13th October, 2003 not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting was presided by M
e
Toinon Hoss, maître en droit, residing in Luxembourg
The meeting appointed as secretary M
e
Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutineer M
e
Antoine Schaus, maître en droit, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state that:
1. The sole shareholder represented and the number of shares held by him is shown on an attendance list which is
signed by the proxyholder, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. Said attendance list
will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
As it appears from said attendance list, out of five hundred shares currently in issue in the Company, all shares are
represented at the present general meeting so that the meeting is validly constituted and can validly deliberate and re-
solve on all the items of the agenda.
2. That the agenda of the meeting is as follows:
- Change of the name of the Company from PROJECT SPEED BIDCO, S.à r.l., to SAFT FINANCE, S.à r.l., and con-
sequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company
After deliberation the following resolution was unanimously taken:
<i>Sole resolutioni>
It was unanimously resolved to change the name of the Company from PROJECT SPEED BIDCO, S.à r.l., to SAFT
FINANCE, S.à r.l., and to consequentially amend article 1 of the articles of association of the Company
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at eight thousand Euro.
There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that of the request of the parties here-
to, the present deed was drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person
in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.
Done in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading the present deed the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le trentième jour du mois d’octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
Belvaux, le 21 novembre 2003.
J.-J. Wagner.
Belvaux, le 24 novembre 2003.
J.-J. Wagner.
62298
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de PROJECT SPEED BIDCO, S.à r.l., (la «Société»),
une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant du 13 octobre 2003 non encore publié dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
L’assemblée est présidée par M
e
Toinon Hoss, maître en droit, résidant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme secrétaire M
e
Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée désigne comme scrutateur M
e
Antoine Schaus, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le président déclare et prie le notaire d’acter que:
1. L’associé représenté et le nombre de parts sociales qu’il détient sont renseignés sur une liste de présence signée
par le mandataire, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Cette liste de présence sera an-
nexée au présent acte pour être soumise avec lui à l’enregistrement.
Il résulte de ladite liste de présence que sur les cinq cents (500) parts sociales émises à ce jour par la Société, toutes
les parts sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l’assemblée est valablement constituée et
peut valablement délibérer et décider sur tous les points portés à l’ordre du jour.
2. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
- Changement du nom de la Société de PROJECT SPEED BIDCO, S.à r.l., en SAFT FINANCE, S.à r.l., et modification
en conséquence de l’article 1
er
des statuts de la Société.
Après délibération, la résolution suivante a été adoptée à l’unanimité:
<i>Résolution uniquei>
Il a été unanimement décidé de changer le nom de la Société de PROJECT SPEED BIDCO, S.à r.l., en SAFT FINANCE,
S.à r.l., et de modifier l’article 1
er
des statuts de la Société en conséquence.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui seront supportés par la Société
sont estimés à huit cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, constate que sur demande des parties, le présent acte est rédigé
en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. Après lecture du présent acte les membres du Bureau
ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. Hoss, A. Schaus, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2003, vol. 141S, fol. 16, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077205.3/211/77) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
BUFO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 67.623.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2002 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf.
LSO-AK04098, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076967.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
GERFED HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 73.139.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 novembre 2003, réf. LSO-AK05638, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
(077126.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Luxembourg, le 19 novembre 2003.
J. Elvinger.
Signature.
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
i>Signatures
62299
G.L. ET F. SIMONE & FILS IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 63.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05209, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077085.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
G.L. ET F. SIMONE & FILS IMMOBILIERE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R. C. Luxembourg B 63.020.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05211, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077084.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
INTERNATIONAL TRADING TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 66.261.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04149, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077275.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
INTERNATIONAL TRADING TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 66.261.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04152, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077276.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
INTERNATIONAL TRADING TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 66.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04153, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077277.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
INTERNATIONAL TRADING TRANSPORT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 66.261.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04157, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077278.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Signature.
Signature.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Signature.
62300
KV ASSOCIATES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 67.559.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05197, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 novembre 2003.
(076794.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.
ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT, Société Anonyme.
Registered office: L-1425 Luxembourg, 1, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 36.326.
—
In the year two thousand three, on the twenty-first of October.
Before us, Maître Jean Joseph Wagner, notary residing at Sanem (Luxembourg).
Is held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT, a «so-
ciété anonyme», having its registered office at L-1425 Luxembourg, 1, rue du Fort Dumoulin, inscribed in the Luxem-
bourg Company and Trade Register, section B number 36.326, incorporated by deed notarial dated on March 31, 1991,
published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 324 of August 28, 1991.
The Articles of Incorporation of said company have been amended for the last time by deed of the undersigned notary
on May 15th, 2003 and published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 806 of July 31, 2003.
The general meeting is opened and presided over by Mr Theodoros Vassiloudis, Business Development Manager of
INFORMER S.A., residing at 4, Chemin Chavanne, CH-1196 Gland (Switzerland).
The chairman appoints as secretary Mr Matthieu Lehr, Business Development Manager of ARTEMIS INFORMATION
MANAGEMENT, residing at 113, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.
The chairman appoints as scrutineer Mr Philippe Petit, Managing Director of ARTEMIS INFORMATION MANAGE-
MENT, residing at 7, Eicherfeld, L-1462 Luxembourg.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Decision to increase the capital of the Company to the extend of 31,250.- Euros, in order to raise it from the
amount of 62,500.- Euros to 93,750.- Euros, by the issue of 250 new shares with a nominal value of 125.- Euros each,
accrued by a global share premium of 1,218,750.- Euros and vested with the same rights and obligations as the existing
shares. All these shares as well as the share premium shall be subscribed and fully paid up by INFORMER INTERNA-
TIONAL LIMITED, a Cypriot company with registered seat at Anni Komninis, 29 A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus, by pay-
ment in cash when the shareholders’ meeting will be held.
2. Resolution to take concerning the waiving by the shareholders to their preferential subscription rights at the above
mentioned capital increase.
3. Statement that 250 shares as well as the share premium have been subscribed and fully paid up by payment in cash.
4. Resolution to take concerning the allocation of the share premium paid at the capital increase mentioned above,
to a share premium account.
5. Decision to take by the shareholders concerning the reimbursement of the share premium account.
6. Amendment of article five of the Articles of Incorporation, which will be, if the above mentioned capital increase
is achieved, as follow:
«Art. 5. The subscribed capital is set at ninety-three thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 93,750,-), repre-
sented by seven hundred and fifty (750) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five Euros (EUR 125)
each, granting one voting right in the general meetings of shareholders.
The shares of the company are in registered or bearer form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
In the event of the establishment of a share premium consecutively to a capital increase, the general meeting should
decide to allocate the amount to a share premium account that stays at its disposal.
The general meeting may also decide to repay part or all of the share premium to the shareholders upon proposal
of the board of directors.
Any share existing or issued at the time of the establishment of a share premium has an equal right of repayment of
this share premium.
Prior to any repayment of a share premium, the shareholders must express in the form of a letter of notice sent to
the Board of Directors their intention to be paid or not.
The general meeting is entitled to decide not to repay the share premium for some of the shares such as requested
by their shareholders provided that (i) the part of the share premium reimbursed to each share shall not exceed its
rights over this share premium repayment and, (ii) the remaining amount of this share premium repayment will be re-
served in the share premium account, in the event that the general meeting decides to proceed to a new repayment in
the future, to the shares which have not received the repayment of their part of the share premium.
<i>Le Conseil d’administration
i>Signature
62301
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.»
7. Miscellaneous.
II) The shareholders present or represented and the number of their shares held by each of them are shown on an
attendance list, which, signed by the shareholders or their representatives and by the bureau of the meeting, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
III) It appears from the said attendance-list that all the five hundred (500) shares representing the total subscribed
capital are present or represented at this meeting. All the shareholders present declare that they have had due notice
and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
IV) The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on all the items on the agenda.
After deliberation, the meeting adopts each time unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting decides to increase the share capital by an amount of thirty-one thousand two hundred and fifty
Euros (31,250.- EUR) to bring it from its present amount of sixty-two thousand five hundred Euros (62,500.- EUR) to
ninety-three thousand seven hundred and fifty Euros (93,750.- EUR) by issuing of two hundred and fifty (250) shares
with a nominal value of one hundred and twenty-five Euros (125.- EUR) each, having the same rights and obligations as
the existing shares, issued with a total share premium of one million two hundred and eighteen thousand seven hundred
and fifty Euros (1,218,750.- EUR).
The meeting admits the company INFORMER INTERNATIONAL LIMITED, a Cypriot company with registered seat
at Anni Komninis, 29 A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus to the subscription of the new shares. The other shareholders waive
their preferential subscription rights.
<i>Subscription and Paymenti>
The two hundred and fifty (250) new shares are subscribed by the company INFORMER INTERNATIONAL LIMIT-
ED, previously named, here represented by Mr Philippe Petit, previously named, by virtue of a proxy given in Nicosia,
on October 10, 2003, which will remain annexed to the present deed.
All the new shares so subscribed have been paid up in cash, so that the amount of one million two hundred and fifty
thousand Euros (1,250,000.- EUR) is at the disposal of the Company, whereof thirty-one thousand two hundred and
fifty Euros (31,250.- EUR) are allocated to the capital and on million two hundred and eighteen thousand seven hundred
and fifty (1,218,750.- EUR) are allocated to a share premium account.
The justifying document of the payment has been produced to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, article 5 of the Articles of Incorporation is amended and now reads
as follows:
«Art. 5. The subscribed capital is set at ninety-three thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 93,750.-), repre-
sented by seven hundred and fifty (750) shares with a nominal value of one hundred and twenty-five Euros (EUR 125)
each, granting one voting right in the general meetings of shareholders.
The shares of the company are in registered or bearer form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in
the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.
In the event of the establishment of a share premium consecutively to a capital increase, the general meeting should
decide to allocate the amount to a share premium account that stays at its disposal.
The general meeting may also decide to repay part or all of the share premium to the shareholders upon proposal
of the board of directors.
Any share existing or issued at the time of the establishment of a share premium has an equal right of repayment of
this share premium.
Prior to any repayment of a share premium, the shareholders must express in the form of a letter of notice sent to
the Board of Directors their intention to be paid or not.
The general meeting is entitled to decide not to repay the share premium for some of the shares such as requested
by their shareholders provided that (i) the part of the share premium reimbursed to each share shall not exceed its
rights over this share premium repayment and, (ii) the remaining amount of this share premium repayment will be re-
served in the share premium account, in the event that the general meeting decides to proceed to a new repayment in
the future, to the shares which have not received the repayment of their part of the share premium.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this present deed are estimated at approximately fifteen thousand Euros.
Nothing else being on the agenda, the meeting was thereupon closed.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, in the registered office of the company.
On the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case
of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.
62302
The document having been read to the persons appearing, the said persons signed together with us the notary this
original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille trois, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg).
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ARTEMIS INFORMATION
MANAGEMENT, ayant son siège social à L-1425 Luxembourg, 1, rue du Fort Dumoulin, inscrite au Registre du com-
merce et des sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 36.326, constituée suivant acte notarié du 31 mars
1991, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 324 du 28 août 1991.
Les statuts de ladite société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 15 mai 2003, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 806 du 31 juillet 2003.
L’Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte et présidée par Monsieur Theodoros Vassiloudis, Business Deve-
lopment Manager de la société INFORMER S.A, demeurant au 4, Chemin Chavanne, CH-1196 Gland (Suisse).
Le président nomme comme secrétaire Monsieur Matthieu Lehr, Business Development Manager de la société AR-
TEMIS INFORMATION MANAGEMENT, demeurant au 113, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Philippe Petit, Managing Director de la société ARTEMIS INFOR-
MATION MANAGEMENT, demeurant au 7, Eicherfeld, L-1462 Luxembourg.
Le bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I) L’ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:
1. Décision d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de 31.250,- EUR, pour le porter de son montant
actuel de 62.500,- EUR à 93.750,- EUR, par l’émission de 250 actions nouvelles d’une valeur nominale de 125,- EUR
chacune, émise avec une prime d’émission totale de 1.218.750,- EUR et ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes. Toutes les actions ainsi que la prime d’émission sont souscrites et entièrement libérées par INFOR-
MER INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit chypriote, ayant son siège social à Anni Komninis 29 A, P.C.
1061, Nicosie, Chypre, par payement en numéraire lors de l’assemblée des actionnaires.
2. Résolution à prendre quant à la renonciation à leur droit de souscription préférentiel des actionnaires actuels de
la Société.
3. Confirmation que les 250 actions émises avec une prime d’émission sont souscrites et entièrement libérées en
numéraire.
4. Décision à prendre concernant l’allocation de la prime d’émission payée lors de l’augmentation de capital ci-dessus,
à un poste prime d’émission.
5. Décision à prendre par les actionnaires concernant le remboursement du poste prime d’émission.
6. Modification de l’article 5 des statuts, qui aura la teneur suivante, si l’augmentation de capital ci-dessus est réalisée.
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante Euros (93.750,- EUR)- représenté
par sept cent cinquante (750) actions de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux
Assemblées Générales.
Les actions de la société sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas d’une augmentation de capital assortie d’une prime d’émission, l’Assemblée Générale décidera d’allouer
le montant à un poste prime d’émission qui reste à sa disposition.
L’Assemblée Générale peut aussi décider de rembourser une partie ou l’entièreté de la prime d’émission aux action-
naires sur proposition du Conseil d’Administration.
Toute action existante ou émise au moment de l’émission de la prime d’émission a un droit égal au remboursement
de cette prime d’émission.
Préalablement à tout remboursement d’une prime d’émission, les actionnaires doivent exprimer leur intention par
lettre au Conseil d’Administration d’être payés ou non.
L’Assemblée Générale a le droit de décider de ne pas payer de prime d’émission pour certaines des actions tel que
demandé par leurs actionnaires sous réserve que (i) la partie de la prime d’émission remboursée à chaque action ne
pourra pas excéder ses droits sur ce remboursement de la prime d’émission (ii) le solde de ce remboursement de la
prime d’émission sera réservé au poste prime d’émission, pour le cas où l’assemblée générale décide de procéder dans
le futur à un nouveau remboursement, pour les actions qui n’ont pas reçu le paiement de leur part de la prime d’émis-
sion.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
7. Divers.
II) Il a été établi une liste de présence renseignant les actionnaires présents ou représentés ainsi que le nombre d’ac-
tions qu’ils détiennent, laquelle liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par
les membres du Bureau, sera enregistrée avec le présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les cinq cents (500) actions représentant l’intégralité du capital
social sont présentes ou représentées à cette Assemblée. Tous les actionnaires présents se reconnaissent dûment con-
voqués et déclarent par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de
sorte qu’il a pu être fait abstraction des convocations d’usage.
IV) La présente Assemblée, représentant l’intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut valable-
ment délibérer sur son ordre du jour.
Après délibération, l’Assemblée prend, chaque fois à l’unanimité, les résolutions suivantes:
62303
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de trente et un mille deux cent cinquante euros
(31.250,- EUR) pour le porter de son montant actuel de soixante-deux mille cinq cents euros (62.500,- EUR) à quatre-
vingt-treize mille sept cent cinquante euros (93.750,- EUR) par la création et l’émission de deux cent cinquante (250)
actions nouvelles d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obli-
gations que les actions existantes, émises avec une prime d’émission globale d’un million deux cent dix-huit mille sept
cent cinquante Euros (1.218.750,- EUR).
L’Assemblée admet la société INFORMER INTERNATIONAL LIMITED, une société de droit chypriote, ayant son
siège social à Anni Komninis 29 A, P.C. 1061, Nicosie, Chypre à la souscription des actions nouvelles, les autres action-
naires renonçant à leur droit de souscription préférentiel.
<i>Souscription et Libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les deux cent cinquante (250) actions nouvelles sont souscrites à l’instant même
par INFORMER INTERNATIONAL LIMITED, prénommée, ici représentée par Monsieur Philippe Petit, prénommé, en
vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à Nicosie, le 10 octobre 2003, ci-annexée.
Toutes les nouvelles actions ainsi souscrites sont entièrement libérées en numéraire, de sorte que la somme d’un
million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société, faisant trente et
un mille deux cent cinquante euros (31.250,- EUR) pour le capital et un million deux cent dix-huit mille sept cent cin-
quante Euros (1.218.750,- EUR) pour le poste prime d’émission.
Le document prouvant le paiement en numéraire a été produit au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, l’article 5 des statuts est modifié est aura désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à quatre-vingt-treize mille sept cent cinquante Euros (93.750,- EUR), représenté
par sept cent cinquante (750) actions de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune, disposant chacune d’une voix aux
Assemblées Générales.
Les actions de la société sont nominatives ou au porteur.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
Dans le cas d’une augmentation de capital assortie d’une prime d’émission, l’assemblée générale décidera d’allouer le
montant à un poste prime d’émission qui reste à sa disposition.
L’Assemblée Générale peut aussi décider de rembourser une partie ou l’entièreté de la prime d’émission aux action-
naires sur proposition du Conseil d’Administration.
Toute action existante ou émise au moment de l’émission de la prime d’émission a un droit égal au remboursement
de cette prime d’émission.
Préalablement à tout remboursement d’une prime d’émission, les actionnaires doivent exprimer leur intention par
lettre au Conseil d’Administration d’être payés ou non.
L’Assemblée Générale a le droit de décider de ne pas payer de prime d’émission pour certaines des actions tel que
demandé par leurs actionnaires sous réserve que (i) la partie de la prime d’émission remboursée à chaque action ne
pourra pas excéder ses droits sur ce remboursement de la prime d’émission (ii) le solde de ce remboursement de la
prime d’émission sera réservé au poste prime d’émission, pour les actions qui n’ont pas reçu le paiement de leur part
de la prime d’émission, pour le cas où, dans le futur, l’assemblée générale décide de procéder à un nouveau rembour-
sement.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte sont évalués à environ quinze mille Euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la société, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: T. Vassiloudis, M. Lehr, P. Petit, J.-J. Wagner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2003, vol. 881, fol. 4, case 10. – Reçu 12.500 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): Ries.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077540.3/239/238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
Belvaux, le 24 novembre 2003.
J.-J. Wagner.
62304
ARTEMIS INFORMATION MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-1425 Luxembourg, 1, rue du Fort Dumoulin.
R. C. Luxembourg B 36.326.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077541.3/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 novembre 2003.
CHIMERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 71.511.
—
Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2003, réf. LSO-AK05469, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(076809.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 novembre 2003.
UNITED FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 41.624.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04122, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077252.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
UNITED FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 41.624.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04124, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077254.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
UNITED FINANCE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R. C. Luxembourg B 41.624.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 18 novembre 2003, réf. LSO-AK04126, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(077255.3//10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Belvaux, le 24 novembre 2003.
J.-J. Wagner.
Luxembourg, le 24 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Signature.
Luxembourg, le 25 novembre 2003.
Signature.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Cada, S.à r.l.
PK Diffusion, S.à r.l.
Service Photo Luxembourg S.A.
Bestseller Retail Luxembourg, S.à r.l.
Nei Haus S.A.
APL, Auto-Parts Luxembourg, S.à r.l.
R.I.I. S.A., Recherche et Investissements Internationaux
R.I.I. S.A., Recherche et Investissements Internationaux
Peinture Dewald, S.à r.l.
Agence Immobilière Hélène Grober, S.à r.l.
Mercantile Venture S.A.
Concordia Finance S.A.
Concordia Finance S.A.
Optis S.A.
Optique Steffen S.A.
Tradingcom International S.A.
Lollipop, S.à r.l.
Lollipop, S.à r.l.
Hutchison Whampoa 3G IP, S.à r.l.
Standard Fund Management (Luxembourg) Umbrella Fund
Murhold S.A.
ABF Hyde Park Investments & Co SNC
Medic International, S.à r.l.
R.P.M. Invest, S.à r.l.
Margil S.A.
Margil S.A.
Medex, S.à r.l.
Maine S.A.
Welfort International Holding S.A.
Welfort International Holding S.A.
SSCP Plastics Holding S.C.A.
Absolute Ventures S.C.A.
Absolute Ventures S.C.A.
Twopp S.A.H.
Twopp S.A.H.
Power Transmission Finance S.A.
Power Transmission Finance S.A.
Power Transmission Finance S.A.
Komiton Holding S.A.
Komiton Holding S.A.
Saft Finance, S.à r.l.
Bufo Holding S.A.
Gerfed Holding S.A.
G.L. et F. Simone & Fils Immobilière, S.à r.l.
G.L. et F. Simone & Fils Immobilière, S.à r.l.
I.T.T. S.A., International Trading Transport S.A.
I.T.T. S.A., International Trading Transport S.A.
I.T.T. S.A., International Trading Transport S.A.
I.T.T. S.A., International Trading Transport S.A.
KV Associates S.A.
Artemis Information Management
Artemis Information Management
Chimera S.A.
United Finance Holding S.A.
United Finance Holding S.A.
United Finance Holding S.A.