logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

48337

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1008

30 septembre 2003

S O M M A I R E

A.O.S. S.A., Altwies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48367

Industrial  Performance  Holding  S.A.,  Luxem-  

A.S.M. Investments S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . .

48376

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48358

Activ’Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

48367

Intergarden S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

48377

Activ’Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

48384

Investissements Multisectoriels Européens S.A., 

Alsgard, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48354

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48375

Altona Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48338

JCBO S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48340

Altona Gestion S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

48357

John Deere Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

48375

Amadeus Beteiligung A.G., Luxembourg  . . . . . . . .

48343

L.H.I.,  Luso  Hispanic  Investment  S.A.,  Luxem-  

Argyle Leisure Fund S.A., Luxembourg. . . . . . . . . .

48383

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48352

Bäte, S.à r.l., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48379

Mamba Investment S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . 

48381

Cameco Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

48378

Mamba Investment S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . 

48381

Cameco Luxembourg S.A., Luxembourg  . . . . . . . .

48381

Merchbanc Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

48382

Cater Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48384

Meres S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48384

CIPE Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48340

Mitte Holdings Management S.A., Luxembourg . . 

48379

Citar-Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

48367

Multinational Investment Corporation S.A.H., Lu-  

Confidea, S.à r.l., Mamer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48338

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48340

Credit Suisse Bond Fund Management Company 

NHS Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48342

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48344

O.C.A. Beteiligung A.G., Luxembourg. . . . . . . . . . 

48351

Credit Suisse Money Plus Fund Management Com- 

Pimiento Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

48383

pany S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48368

S.C.I. Plek, Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48355

CS Private Universe Management Company S.A., 

S.C.I. Plek, Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48356

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48359

S.C.I. Plek, Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48357

Dexia World Alternative, Sicav, Luxembourg  . . . .

48380

Sagicap S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48378

Eastern Investments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . .

48355

Sagicap S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48378

Edvima S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48376

Saint Eugène S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

48342

EL 2 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48354

Silawi S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48382

Eremis Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

48376

Socalux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48384

European Marketing Group (Luxembourg) S.A., 

Société  Européenne  de  Boissons  S.A.,  Luxem-  

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48357

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48339

Fareale S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48343

Sonoco Luxembourg, S.à r.l., Wiltz . . . . . . . . . . . . 

48352

Finpelts S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48341

System Trading S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

48382

Flurwald Finanz S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

48377

Tradenet Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

48380

Fontralux, S.à r.l., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48343

Tyco Group, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

48343

GDL FI S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48377

Tyco International Group S.A., Luxembourg  . . . . 

48341

GIA Global Investment Activity S.A., Luxemburg .

48359

Vinkelberg Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48358

Globe Star Incorporation S.A., Luxembourg  . . . . .

48351

Vinkelberg Company S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

48383

I.P.P. Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

48377

Wam S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48376

Immobilière Grand-Ducale S.A., Luxembourg . . . .

48351

48338

ALTONA GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.462. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 6 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa

nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03118. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054323.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

CONFIDEA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. ETCETERA, S.à r.l.).

Siège social: L-8266 Mamer, 17, rue des Thermes Romains.

R. C. Luxembourg B 60.449. 

L’an deux mille trois, le vingt et un août.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.

A comparu:

- Monsieur Joseph Léopold Lazega, administrateur de société, né le 17 décembre 1950 à Montmorency s/Seine et

Oise, (France), demeurant à B-2018 Anvers, Bexstraat, 34, (Belgique).

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée ETCETERA, S.à r.l. (R.C.S. Luxembourg section B numéro 60.449), avec siège

social à L-4967 Clémency, 69, rue de la Chapelle, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du
5 août 1997, publié au Mémorial C numéro 646 du 19 novembre 1997.

- Que les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire soussigné en date du 17 juillet 2000, publié au

Mémorial C numéro 5 du 4 janvier 2001 et en date du 12 mars 2001, publié au Mémorial C numéro 934 du 29 octobre
2001.

- Que le comparant est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’il s’est réuni en assemblée générale

extraordinaire et a pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique constate qu’en vertu d’une cession de parts sous seing privé du 2 juin 2003:
- Monsieur Benny Mortzy Kwadrat, représentant, né à Brooklyn, New York, (Etats-Unis), le 19 juillet 1958, demeu-

rant à B-2018 Anvers, Lamorinièrestraat, 165, (Belgique), a cédé ses cinq cents (500) parts sociales dans la prédite so-
ciété ETCETERA, S.à r.l., à Monsieur Joseph Léopold Lazega, préqualifié.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de convertir le capital social de cinq cent mille francs luxembourgeois (500.000,- LUF) en

douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68 EUR), au cours de 40,3399 LUF=1,-
EUR.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social à concurrence de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32

EUR), pour le porter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros
(12.394,68 EUR) à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), sans création de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq virgule trente-deux euros (105,32 EUR) a été apporté en numéraire par l’associé unique de

sorte que ledit montant se trouve dès-à-présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire
qui le constate expressément.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de remplacer les cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de mille francs luxem-

bourgeois (1.000,- LUF) chacune par cinq cents (500) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,- EUR)
chacune.

<i>Cinquième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article six des statuts se trouve modifié et aura dorénavant la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de vingt-cinq euros (25,- EUR) chacune, entièrement libérées.

Les parts sociales sont détenues par Monsieur Joseph Léopold Lazega, administrateur de société, né le 17 décembre

1950 à Montmorency s/Seine et Oise, (France), demeurant à B-2018 Anvers, Bexstraat, 34, (Belgique).»

Pour copie conforme
Signatures

48339

<i>Sixième résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination de la société en CONFIDEA, S.à r.l. et de modifier en consé-

quence l’article quatre des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société prend la dénomination de CONFIDEA, S.à r.l.»

<i>Septième résolution

L’associé unique décide de transférer le siège social de L-4967 Clémency, 69, rue de la Chapelle, à L-8266 Mamer,

17, rue des Thermes Romains.

<i>Huitième résolution

Suite à la résolution qui précède, le premier alinéa de l’article cinq des statuts est modifié et aura dorénavant la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le siège social est établi à Mamer.»

<i>Neuvième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article deux des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 2. La société a pour objet toutes les prestations de services administratifs et de secrétariat, la mise en relation

et les démarches avec les professions libres comme avocats, notaires, huissiers, experts comptables, réviseurs de socié-
tés; avec les banques, fiduciaires, clients/fournisseurs; recherche de locaux d’exploitation, de siège social où de logement;
la rédaction ainsi que la traduction des textes et documents, les démarches et l’affiliation auprès les diverses instances
de l’administration et autorités fiscales, judiciaires, et publiques, comme C.C.S.S., Enregistrement et Domaines (TVA),
Autorisation de Commerce, Fiche d’impôts RTS, etc, à toute personne physique, morale, juridique où association. La
société a également pour objet la réception, l’entreposage, l’inspection, la manipulation, et l’expédition de marchandises
pour tiers, de même que la représentation de tiers, dans le domaine commercial, industriel, financier, et foncier, mobilier
et immobilier, la consultation, l’assistance, le conseil et le courtage dans tous les domaines au Grand-Duché de Luxem-
bourg ainsi qu’à l’étranger.

Elle peut avoir des intérêts dans toutes les sociétés, associations et entreprises, par apport, souscription, acquisition,

participation et autres. La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes
morales ou physiques.

Cette énumération n’est pas limitative, et se comprend dans le plus large sens possible.
Elle pourra effectuer toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant direc-

tement ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.»

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de sept cents euros.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J. L. Lazega, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 2 septembre 2003, vol. 524, fol. 42, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): C. Bentner.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054114.3/231/87) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

SOCIETE EUROPEENNE DE BOISSONS, Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 55.650. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 août 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Patrick Dhondt de son poste d’administrateur avec

effet au 20 août 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Michel Di Benedetto demeurant à Luxembourg. Sa nomination sera

ratifiée lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03069. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054349.3/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Junglinster, le 3 septembre 2003.

J. Seckler.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

48340

CIPE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 58.491. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu au siège social de la Société le 5 août 2003

Le Conseil d’Administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Alastair Macgowan en tant qu’ad-

ministrateur de la Société avec effet au 2 juillet 2003.

Conformément à l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, le Conseil

d’Administration de la Société a décidé de nommer Monsieur Olivier Lambinet, Conseiller Europe (European Counsel),
avec adresse professionnelle au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la Société, et ce avec effet au 2 juillet 2003 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
de la Société qui approuvera les comptes annuels de l’exercice clos au 30 septembre 2002, afin de remplacer et d’ache-
ver le mandat de Monsieur Macgowan.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00790. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054351.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

JCBO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 86.148. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Michel Di Benedetto, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03070. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054353.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.315. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 25 avril 2003

- Monsieur Harald Charbon, employé privé, 69, rue Edouard Oster, L-2272 Howald et Madame Antonella Graziano,

employée privée, 12, rue Théodore Eberhard, L-1452 Luxembourg sont nommés nouveaux Administrateurs en rempla-
cement de Monsieur Jean-Robert Bartolini et Monsieur François Mesenburg, qui ne se présentent plus aux suffrages.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009;

- les mandats d’Administrateurs de Monsieur Pierre Mestdagh, employé privé, 19, rue Batty Weber, L-5254 Sandwei-

ler et de Monsieur Marc Limpens, employé privé, 34, rue de Vianden, L-2680 Luxembourg sont reconduits pour une
nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2009;

- le mandat du Commissaire aux Comptes de la société FIN-CONTROLE S.A., Société Anonyme, 13, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg est reconduit pour une nouvelle période statutaire de six ans jusqu’à l’Assemblée Générale Statu-
taire de l’an 2009.

Fait à Luxembourg, le 25 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00363. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054438.3/795/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour extrait et publication
CIPE LUXEMBOURG S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signatures

Certifié sincère et conforme
MULTINATIONAL INVESTMENT CORPORATION
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

48341

TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.939. 

<i>Extrait des résolutions du Conseil d’Administration tenu au siège social de la Société le 5 août 2003

Le Conseil d’Administration de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Alastair Macgowan en tant qu’ad-

ministrateur de la Société avec effet au 2 juillet 2003.

Conformément à l’article 51 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, le Conseil

d’Administration de la Société a décidé de nommer Monsieur Olivier Lambinet, Conseiller Europe (European Counsel),
avec adresse professionnelle au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant qu’administra-
teur de la Société, et ce avec effet au 2 juillet 2003 jusqu’à la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires
de la Société qui approuvera les comptes annuels de l’exercice clos au 30 septembre 2003, afin de remplacer et d’ache-
ver le mandat de Monsieur Macgowan.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00796. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054358.3/253/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

FINPELTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 72.270. 

 L’an deux mille trois, le premier août.
 Par-devant Maître Alex Weber, notaire de résidence à Bascharage.

 S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire de la société FINPELTS S.A., avec siège social à L-1233 Luxembourg,

13, rue Bertholet, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.270, consti-
tuée suivant acte reçu par le notaire Paul Bettingen, de résidence à Niederanven, en date du 28 octobre 1999, publié au
Mémorial C, numéro 1004 du 28 décembre 1999.

 L’assemblée est présidée par Mademoiselle Regina Rocha Melanda, employée privée, demeurant à Dudelange,
 qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Anne-Françoise Fouss, employée privée, demeurant à Arlon (Belgique).
 L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Gaby Trierweiler, employée privée, demeurant à Leudelange.
 Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que l’ordre du jour est conçu comme suit:
 1) Mise en liquidation de la société.
 2) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
 3) Décharge à accorder au conseil d’administration et au commissaire aux comptes.
 4) Nomination d’un commissaire-vérificateur.
 II.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de pré-

sence, laquelle, après avoir été paraphée ne varietur par les actionnaires présents ou représentés et les membres du
bureau, restera annexée au présent acte pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.

 III.- Qu’il résulte de ladite liste de présence que toutes les trois cent soixante (360) actions de la société sont pré-

sentes ou représentées et qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer va-
lablement sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

 L’assemblée décide de dissoudre anticipativement la société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

 L’assemblée décide de nommer comme liquidateur Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises agréé, né à Luxem-

bourg, le 29 mai 1954, demeurant professionnellement à L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

 Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus pour exécuter son mandat et spécialement tous les pouvoirs prévus

aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sans devoir recourir à l’autorisation
de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise par la loi.

 Le liquidateur peut, sous sa seule responsabilité, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs manda-

taires, pour des opérations spéciales et déterminées.

 Le liquidateur est dispensé de faire l’inventaire et peut s’en référer aux livres et écritures de la société.
 Le liquidateur doit signer toutes les opérations de liquidation.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de nommer Monsieur Jean-Marie Boden, expert-comptable, né à Luxembourg, le 14 juin 1954,

demeurant à L-1140 Luxembourg, 47, route d’Arlon, comme commissaire-vérificateur.

Pour extrait et publication
TYCO INTERNATIONAL GROUP S.A.
Signature
<i>Un mandataire

48342

<i>Quatrième résolution

L’assemblée accorde décharge pleine et entière au conseil d’administration et au commissaire aux comptes pour les

travaux exécutés jusqu’à ce jour.

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée.

<i>Frais

 Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués approximativement à six cent vingt-cinq euros (

€ 625,-), sont à

charge de la société.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, ils ont signé avec Nous notaire le présent

acte.

Signé: R. Rocha Melanda, A-F. Fouss, G. Trierweiler, A. Weber.
Enregistré à Capellen, le 8 août 2003, vol. 427, fol. 45, case 9.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Santioni.

Pour expédition conforme, délivrée à la société à sa demande, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(054116.3/236/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2003.

SAINT EUGENE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.409. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03095. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054359.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

NHS INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1643 Luxembourg, 4, rue de la Grève.

R. C. Luxembourg B 70.348. 

 Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle, qui s’est tenue à Luxembourg, le 7 avril 2003, que

l’Assemblée a pris, entre autres, les résolutions suivantes:

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée prend acte que le mandat du Commissaire est venu à échéance en date de ce jour.
L’Assemblée décide de nommer, pour un terme de -1- (un) an, la société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., ayant son

siège social à L-1471 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 400, route d’Esch, en qualité de Commissaire.

Le mandat du Commissaire prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clôturé

au 31 décembre 2003.

<i>Cinquième résolution

L’Assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Madame Silva Lepore, employée privée, demeurant à

Turin (Italie), de sa fonction d’Administrateur de la société. La lettre de démission restera annexée au présent procès-
verbal pour en faire partie intégrante.

L’Assemblée donne décharge pleine et entière à l’Administrateur démissionnaire concernant l’exécution de son man-

dat jusqu’à la date de ce jour.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 septembre 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00595. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054701.3/043/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Bascharage, le 27 août 2003.

A. Weber.

Pour copie conforme
Signatures

NHS INVESTMENTS S.A.
S. Bosi / S.Vandi
<i>Administrateurs

48343

TYCO GROUP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 21.000,-.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 61.111. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’associé unique le 5 août 2003 à Luxembourg

L’associé unique de la Société a pris acte de la démission de Monsieur Alastair Macgowan en tant que gérant de la

Société avec effet au 2 juillet 2003 et lui a accordé décharge pleine et entière pour l’exécution de son mandat jusqu’au
2 juillet 2003.

L’associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Olivier Lambinet, Conseiller Europe (European Coun-

sel), avec adresse professionnelle au 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, en tant que gérant
de la Société avec effet au 2 juillet 2003 pour une période indéterminée.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00798. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054361.3/253/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

AMADEUS BETEILIGUNG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.153. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03098. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054364.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

FAREALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.378. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03113. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054365.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

FONTRALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6113 Junglinster, 9, rue des Cerises.

R. C. Luxembourg B 54.192. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, a été déposé au registre de commerce

et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054410.3/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour extrait et publication
TYCO GROUP, S.à r.l.
Signature
<i>Un mandataire

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Signature.

48344

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 44.866. 

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination

of CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, R. C. B Number 44.866, incorporated under the de-
nomination of CS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, pursuant to a deed of Maître Reginald Neuman, then
notary residing in Luxembourg, dated September 1, 1993, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associ-
ations, Number 461 of October 7, 1993.

The Articles of Incorporation have been amended several times and finally by a deed of the same notary dated Sep-

tember 25, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Number 38 of January 19, 1998.

The meeting begins at ten fifteen a.m. Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, being in
the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice-President, CREDIT SUISSE AS-

SET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue
Jean Monnet.

The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Breger, mandatory, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman then states that:
I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the one thousand

five hundred (1,500) shares with a par value of two hundred (200.-) Swiss francs each, representing the entire corporate
capital of three hundred thousand (300,000.-) Swiss francs are duly represented at this meeting which is consequently
regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all
the shareholders represented having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the members of the bureau and the notary, shall remain attached to the present deed,

together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
Resetting of the Articles of Incorporation of the company (as described in the attachment to the proxy).
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The par value of the shares is deleted.

<i>Second resolution

It is resolved to introduce a prevailing English version of the Articles of Incorporation and to proceed to a total re-

statement.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Corporation shall henceforth read as follows: 

Art. 1. There exists a corporation under Luxembourg Law in the form of a société anonyme under the name of

CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY. 

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period. 
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-

ment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof. 

Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of a mutual investment fund

known as CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX) (the «Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation
evidencing undivided co-proprietorship interests therein.

The Corporation shall manage any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, adminis-

tration and promotion of such Fund and with respect thereto it may set up one or more branches. On behalf of the
Fund, it may enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions
and transfer in the name of the Fund or in third parties’ names in the register of shares or debentures of any Luxembourg
or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, es-
pecially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be
considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may take any measures and carry out any operation directly or indirectly connected with its pur-

pose while remaining within the limits of Chapter 14 of the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective
Investment. 

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place in the same commune by decision of the board of direc-

tors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of direc-
tors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political developments have occurred or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of

48345

communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on the na-
tionality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg corporation. 

Art. 5. The corporate capital is set at three hundred thousand (300,000.-) Swiss Francs divided into one thousand

five hundred (1,500) shares in registered form with no par value, all fully paid up.

The Corporation will issue shares in registered form.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation. 

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof. 

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation. 

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the second Monday of the month of May of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in
the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The meeting of shareholders may fix an emolument, travelling and day to day accommodation for all members of the

Board of Directors. 

Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting

of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile trans-
mission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the total number of shares outstanding and entitled to vote at the meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication. 

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders. 

Art. 12. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or

another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro-tempore or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another director, an officer of the Corporation or such other individual
as they may determine as chairman pro-tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such
meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, general managers and any

assistant general managers, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Corporation, who need not be Directors or shareholders of the Corporation. Any such ap-
pointment may be revoked at any time by the board of directors. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

48346

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by

other electronic means of transmission to all Directors at least twenty four hours in advance of the day set for the meet-
ing. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business
other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board
not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or
telex or telefax or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by any
director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram, telex

or telefax another director as his proxy. Any director may attend a meeting of the board of directors using teleconfer-
ence, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of
board of directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of board of directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of

communication, in which a quorum of directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall

have a casting vote.

Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and

held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evi-
denced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as men-
tioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which
the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be

formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Corporation via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the
decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors. 

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors

shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of
the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically per-
mitted by resolution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more directors of the Cor-
poration («managing directors» - «administrateurs-délégués»), if authorized by the general meeting of shareholders. 

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be af-

fected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not
include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Corporation any subsidiary
or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of direc-
tors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit

48347

such a breach of duty. The foregoing privilege of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 15 may be advanced by the Corporation prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 15. 

Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, officers or of any other persons

to whom authority has been delegated by the board of directors. 

Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor («réviseur
d’entreprises»). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause. 

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the thirty-first of December of each year. 

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to
ten percent (10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time
to time as provided in Article six hereof.

The annual general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be dis-

posed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate pur-
pose and policy.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Luxembourg law. 

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation. 

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg. 

Art. 22. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the relevant law
on undertakings for collective investment.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at ten thirty

a.m.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den sechsundzwanzigsten August.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY, mit Sitz in

Luxemburg, R. C. Nummer B 44.866, gegründet unter der Bezeichnung CS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY
durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Reginald Neuman, damals mit dem Amtssitz in Luxemburg, am
1. September 1993, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 461 vom 7. Oktober 1993,
veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den-

selben Notar, am 25. September 1997, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 38 vom
19. Januar 1998, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um zehn Uhr fünfzehn unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, «Director»,

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxem-
burg, 5, rue Jean Monnet.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Jacqueline Siebenaller, «Vice-President», CREDIT SUISSE ASSET MANA-

GEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet 

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Daniel Breger, «mandatory», CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:
I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die eintausendfünfhundert (1.500) Aktien mit einem Nennwert von zweihundert (200,-) Schwei-
zer Franken, welche das gesamte Kapital von dreihunderttausend (300.000,-) Schweizer Franken darstellen hier in dieser

48348

Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der
Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren,
ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zu-

sammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
Neufassung der Satzung der Gesellschaft (wie in der Anlage zu der Vollmacht beschrieben).
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben.

<i>Zweiter Beschluss

Es wird beschlossen eine massgebende englische Fassung der Satzung einzuführen.
Infolgedessen wird die Satzung der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT

COMPANY.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen,

so wie in Artikel einundzwanzig dieser Satzung festgesetzt, gefasst wurde aufgelöst werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen CREDIT

SUISSE BOND FUND (LUX) (der «Fonds») und die Ausgabe von Zertifikaten und Bestätigungserklärungen welche das
ungeteilte Eigentum daran nachweisen.

Die Gesellschaft wird alle Aktivitäten, in Luxemburg und im Ausland ausüben, welche die Verwaltung und die Förde-

rung dieses Fonds betreffen und diesbezüglich eine oder mehrere Zweigstellen errichten. Für den Fonds kann sie Kon-
trakte abschliessen, Wertpapiere verkaufen, kaufen, tauschen und ausgeben, im Namen des Fonds oder im Namen von
Drittpersonen, jedwede Eintragungen und Übertragungen tätigen im Aktien- oder Obligationsregister von luxemburgi-
schen oder ausländischen Gesellschaften, sowie im Namen des Fonds und der Anteilsinhaber des Fonds alle Rechte und
Privilegien, insbesondere das Stimmrecht ausüben bezüglich der Wertpapiere aus welchen die Aktiva der Gesellschaft
bestehen. Die vorgenannten Befugnisse sind nicht als erschöpfend, sondern lediglich als erklärend zu betrachten.

Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt ihrem Ge-

sellschaftszweck dienlich sind im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
die Investmentfonds.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort in derselben Gemeinde

verlegt werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche politische Umstände eingetreten sind oder bevorstehen

welche die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern, oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörig-
keit. 

Art. 5. Das Aktienkapital beträgt dreihunderttausend (300.000,-) Schweizer Franken, eingeteilt in eintausendfünfhun-

dert (1.500) Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt. 

Die Aktien der Gesellschaft werden in Form von Namensaktien herausgegeben. 
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt. Dieses Register beinhaltet für jeden Aktionär seinen Namen,

seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort, die Zahl der Aktien, den eingezahlten Betrag für jede Aktie und die Aktienüber-
tragungen und das Datum solcher Übertragungen.

Die Übertragung einer Aktie wird getätigt durch eine schriftliche Übertragungserklärung welche ins Aktienregister

eingetragen wird; diese Übertragung wird durch den Abtreter und den Übernehmer oder durch diejenigen Personen,
welche diesbezüglich Vollmachten haben, datiert und unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch als Übertragungsbeweis
andere Dokumente annehmen welche ihr ausreichend erscheinen.

Art. 6. Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist gemäss Artikel einundzwanzig der Satzung.

Art. 7. Jede ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, oder an einem anderen,

in der Einberufung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Montag des Monats
Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt. Die ordentliche Ge-
neralversammlung kann jederzeit, nach definitivem und schlussendlichem Beschluss des Verwaltungsrats, falls besondere
Umstände es erfordern, an einem beliebigen Ort einberufen werden.

48349

Andere Generalversammlungen können an dem in den betreffenden Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt

stattfinden.

Die Generalversammlung kann Zuschüsse, Reise- und Tagesspesen für alle Mitglieder des Verwaltungsrates festset-

zen.

Art. 9. Das Quorum und die Fristen welche vom Gesetz vorgeschrieben sind regeln die Einberufung und den Ablauf

der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, unter Vorbehalt dieser Bestimmungen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Aktionär kann

an jeder Versammlung teilnehmen indem er einen Dritten als seinen Bevollmächtigten bezeichnet schriftlich, per Kabel,
Telegramm, Telex oder Fax.

Falls nicht anders vom Gesetz verordnet, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Versammlung

durch einfache Mehrheit aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festsetzen welche durch die Aktionäre erfüllt sein müssen um an

einer Versammlung teilzunehmen.

Art. 10. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen durch Einschreibebrief mit der Tages-

ordnung welcher mindestens acht Tage vor der Versammlung an die Aktionäre gesandt wird an ihre im Aktienregister
vermerkte Adresse.

Wenn jedoch alle Aktionäre präsent oder vertreten sind auf der Versammlung und wenn sie feststellen dass über die

Tagesordnung informiert sind, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. 

Die Verwaltungsratmitglieder werden ernannt durch die jährliche Versammlung der Aktionäre für einen Zeitraum bis

zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger; ein Verwaltungsratmitglied kann jederzeit mit
oder ohne Grund ersetzt werden durch einen Beschluss der Aktionäre.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Postens als Verwaltungsratmitglied durch Tod, Rücktritt oder sonstwie können

die verbliebenen Mitglieder zusammenkommen und durch Mehrheitsbeschluss einen Nachfolger bestellen bis zur näch-
sten Versammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vize-Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, welcher nicht Verwaltungsratmitglied
sein muss, und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen aufsetzt. Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Ein-
berufen des Präsidenten, oder zweier Verwaltungsratmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Der Präsident steht allen Versammlungen vor, oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vizepräsident

oder ein anderes Verwaltungsratmitglied, welches pro tempore vorstehen wird. Die Aktionäre können, durch Mehr-
heitsbeschluss einen anderen Angestellten oder eine andere Person bestimmen, welche pro tempore der Sitzung vor-
stehen wird.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Beamte der Gesellschaft, Generalverwalter und assistierende Generalver-

walter, Sekretäre und Hilfssekretäre bestimmen welche für die Operationen und die Verwaltung der Gesellschaft zu-
ständig sind welche nicht Verwaltungsratmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen. Eine solche Bestimmung kann
jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgerufen werden. Die ernannten Beamten, falls nicht anders in der Satzung vorge-
sehen werden die Befugnisse und Aufgaben haben welche ihnen durch den Verwaltungsrat zuerteilt werden.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates wird schriftlich einberufen oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf

elektronischem Wege an alle Verwaltungsratmitglieder wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung. Die
Bekanntmachung enthält die Tagesordnung der Versammlung und kein anderer Punkt kann gültig auf der Versammlung
beraten werden. Auf die Einberufung kann verzichtet werden durch schriftliche Einwilligung oder durch Kabel, Tele-
gramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege und jedes anwesende Verwaltungsratmitglied ist erachtet darauf verzich-
tet zu haben. Eine separate Einberufung ist nicht notwendig für individuelle Sitzungen welche abgehalten werden nach
einem Schema des Verwaltungsrates.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen, in dem es schriftlich, per

Kabel, Telefax oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als seinen Bevoll-
mächtigten ernennt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon oder
Video-Konferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen er-
laubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als
persönliche Teilnahme an der Sitzung. 

Eine Versammlung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschaltung an welcher ein Quorum des

Verwaltungsrates teilnimmt ist bindend wie wenn alle persönlich anwesend gewesen wären, unter der Voraussetzung
dass ein Protokoll unterzeichnet wird durch den Präsidenten der Versammlung.

Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Die Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Die Mitglieder
welche nicht persönlich anwesend sind oder vertreten sind können schriftlich abstimmen oder durch Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischem Wege.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Rundbeschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind, sind genauso gültig und genauso

bindend, wie wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des Rundbeschlusses. Im Falle wo kein
spezielles Datum vermerkt ist wird der Rundbeschluss gültig am Tag wo die letzte Unterschrift getätigt wird.

48350

Beschlüsse welche durch andere elektronische Mittel gefasst werden wie e-mail, Telegramm oder Telex werden for-

malisiert durch den nachfolgenden Beschluss. Das Inkrafttreten des Beschlusses ist dann diejenige der letzten Genehmi-
gung welche die Gesellschaft erhielt durch elektronische Mittel. Die Genehmigungen von allen Mitgliedern des
Verwaltungsrates werden dem Rundbeschluss beigefügt bleiben und einen integralen Bestandteil bilden welche die vor-
her gefassten Beschlüsse billigen.

Rundbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Verwaltungsratmitglieder gefasst werden.

Art. 13. Die Protokolle des Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge dieser Urkunden welche zu gerichtlichen Zwecken gebraucht werden oder sonstwie werden

durch den Präsidenten unterzeichnet oder den pro tempore Präsidenten oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder.

Art. 14. Die Verwaltungsratmitglieder können nur an ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Rates teilnehmen.

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis die Gesellschaftspolitik festzulegen und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft.
Die Verwaltungsratmitgllieder können die Gesellschaft jedoch nicht durch ihre persönlichen Handlungen binden, ausser
spezieller Erlaubnis des Rates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die einem

oder mehreren Verwaltern der Gesellschaft übertragen (delegiertes Verwaltungsratmitglied) wenn die Generalver-
sammlung es erlaubt hat.

Art. 15. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wer-

den nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder
leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein persönliches
Interesse haben oder dort Mitglied des Verwaltungsrates, Aktionär, leitender oder sonstiger Angestellter sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Mitglied des Verwaltungs-

rates, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit
der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit
der anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder
einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Im Falle wo ein Verwalter oder Beamter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesell-

schaft hat muss dieser Verwalter dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse kundtun und nicht über diese Ange-
legenheit abstimmen und von diesem persönlichen Interesse wird der nächsten Generalversammlung berichtet. Der
Ausdruck «persönliches Interesse» wie vorher benutzt begreift nicht eine Beziehung oder ein Interesse eine Position
oder ein Geschäft welches die Gesellschaft oder eine Filiale betrifft oder jede andere Gesellschaft welche der Verwal-
tungsrat zu jeder Zeit nach seinem Ermessen festsetzen kann.

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Er-

ben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von ihm im Zusammen-
hang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund
seiner Stellung als Mitglied des Verwaltungsrates oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag
hin, auch einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist, oder bei der die Gesellschaft Gläu-
biger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in denen er auf Grund dieser Klagen,
Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig verur-
teilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachen, die von dem
Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu entschä-
digende Person keine Pflicht verletzt hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus. 

Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und der Verteidigung bei einer Klage oder Prozess wie in diesem Ar-

tikel beschrieben können durch die Gesellschaft vorgeschoben werden vor einem endgültigen Urteil unter der Bedin-
gung dass dieser Betrag zurückgezahlt werden muss wenn das Verwaltungsratmitglied nicht berechtigt ist zu einer
Entschädigung gemäss diesem Artikel.

Art. 16. Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrat-

mitgliedern, Beamten oder anderer Personen, welche vom Verwaltungsrat hierzu delegiert wurden.

Art. 17. Die Geschäfte der Gesellschaft, begreifend insbesondere ihre Bücher und Steuerangelegenheiten oder an-

dere Berichte welche das Luxemburger Gesetz verlangt, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer
(«réviseur d’entreprises»). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur
nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit durch die Aktionäre abberufen werden mit oder ohne Grund.

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreissigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 19. Vom dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf (5%) Prozent dem gesetzlichen Reserve-

fonds zugeführt. Diese Speisung ist nicht mehr erforderlich sobald und solange die Reserve zehn (10%) Prozent des Ge-
sellschaftskapitals ausmacht.

Die jährliche Versammlung bestimmt wie der Restbetrag des Gewinns verteilt wird und kann alleine Dividenden fest-

legen wie sie es in ihrem Ermessen für gut befindet für die Gesellschaftspolitik.

Interimdividende kann gemäss dem Luxemburger Gesetz ausgezahlt werden. 

Art. 20. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

physische Personen oder Körperschaften sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidato-
ren und setzt deren Vergütung fest.

48351

Art. 21. Die Satzung kann jederzeit durch eine Generalversammlung abgeändert werden unter den luxemburgischen

gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Quorum und das Stimmrecht.

Art. 22. Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf das Gesetz vom zehnten August

neunzehnhudertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und das Gesetz über Investmentfonds verwiesen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zehn Uhr dreissig für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Trichies, J. Siebenaller, D. Breger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 36, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054552.3/230/460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

IMMOBILIERE GRAND-DUCALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 39.899. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00969, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 avril 2003.

(054366.3//12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

GLOBE STAR INCORPORATION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.439. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur François Dereme de son poste d’administrateur avec

effet au 20 décembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur Philippe De Castellane, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 13 juin 2003, réf. LSO-AF03111. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054367.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

O.C.A. BETEILIGUNG A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 75.445. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 6 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur José Mouzon, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03247. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054371.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Pour copie conforme
Signatures

Pour copie conforme
Signatures

48352

L.H.I., LUSO HISPANIC INVESTMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 35.601. 

Les comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-

AI00704, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002, enregistrés à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00704, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

AFFECTATION DU RESULTAT RELATIVE AUX COMPTES ARRETES AU 31 DECEMBRE 2002 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054370.3//19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-9519 Wiltz, 2, route d’Ettelbruck.

R. C. Luxembourg B 80.610. 

In the year two thousand and three, on the sixteenth day of April.
Before Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, in place of Maître Joseph

Elvinger, notary residing in Luxembourg, currently prevented, who will guard the original of the present deed. 

Was held:

an Extraordinary General Meeting of shareholders of SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., a société à responsabilité

limitée (hereafter: the «Company») having its registered office at 2, route d’Ettelbruck, L-9519 Wiltz, registered with
the trade register in Luxembourg under number B 80.610, incorporated pursuant to a notarial deed of demerger of 27
December 2000, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 779, dated 19 September
2001.

The Articles of Incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of

Maître Paul Bettingen of 19 March 2003, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened with Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium, in the chair,
who appointed as secretary and the meeting elected as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rou-

vroy, Belgium.

The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the restatement and, where necessary, correction of the changes in the articles

of association relative to the share capital of the Company that have been adopted since 27 December, 2000.

II. That the shareholder represented, the proxy of the represented shareholder and the number of its shares are

shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy of the represented shareholder and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxy of the represented shareholder will also remain annexed to the present deed after being initialled ne varietur
by the parties appearing.

III. That the whole corporate capital being represented at the present meeting and the shareholder represented de-

claring that it has had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices were
necessary.

IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly de-

liberate on all the items of the agenda.

The Chairman then stated that after the formation of the Company its sole shareholder inter alia adopted the fol-

lowing changes to the Company’s share capital:

On 27 December 2000, by deed adopted before Maître Joseph Elvinger, registered in Luxembourg but not published

in Mémorial C, the share capital of the company was increased by EUR 9,450,000.- (nine million four hundred and fifty
thousand Euros);

(i) On 11 July 2001, by deed adopted before Maître Jean-Joseph Wagner, registered in Esch-sur-Alzette A.C. on 16

July 2001, volume 861, folio 21, case 1 and published in the Mémorial C numéro 1210 of 14 August 2002, amended
through a corrective deed adopted before Maître Jean-Joseph Wagner on 25 September 2002, registered in Esch-sur-
Alzette A.C., on 25 September 2002, volume 871, folio 56, case 2 and published in the Mémorial C number 1504 of 17
October 2002, the share capital of the Company was increased by EUR 1,000.- (one thousand Euro). 

That due to material errors the minutes of the extraordinary general meetings of 11 July 2001 and 25 September

2002 indicate that the Company’s share capital was being increased from EUR 115,674,000.- (one hundred and fifteen
million six hundred and seventy-four thousand) to EUR 115,675,000.- (one hundred and fifteen million six hundred and

- Résultat de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

991.167,- EUR

- Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.582.262,- EUR

- Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . . .

- 49.558,- EUR

- Acompte sur dividende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 600.414,- EUR

- Dividende final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 344.500,- EUR

- Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.578.957,- EUR

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

Signature.

48353

seventy-five thousand), while they should in reality have stated that the Company’s share capital was being increased
from EUR 125,124,000.- (one hundred and twenty-five million one hundred and twenty-four thousand Euro) to EUR
125,125,000.- (one hundred and twenty-five million one hundred and twenty-five thousand Euro).

That the deeds of 11 July 2001 and 25 September 2002 must therefore be rectified through the statement that the

Company’s share capital was being increased from EUR 125,124,000.- (one hundred and twenty-five million one hundred
and twenty-four thousand Euro) to EUR 125,125,000.- (one hundred and twenty-five million one hundred and twenty-
five thousand Euro) and the statement that the first sentence of article six (6) of the articles of association was to be
changed as set out in the resolution below.

Then the general meeting, after deliberation, unanimously adopted the following resolution:

<i>Sole resolution

It is resolved to rectify the deeds of 11 July 2001 and 25 September 2002 through the statement that the Company’s

share capital was being increased from EUR 125,124,000.- (one hundred and twenty-five million one hundred and twen-
ty-four thousand Euro) to EUR 125,125,000.- (one hundred and twenty-five million one hundred and twenty-five thou-
sand Euro) and the statement that the first sentence of article six (6) of the articles of association is to be changed into:

«Art. 6. First sentence. The Company’s capital is fixed at one hundred and twenty-five million one hundred and

twenty-five thousand euro (EUR 125,125,000.-) represented by one hundred and twenty-five thousand one hundred and
twenty-five (125,125) shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.»

There being no further business before the meeting, it was thereupon adjourned. 

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present orig-

inal deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states that on request of the above appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Version française:

L’an deux mille trois, le seize avril.
Par devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en remplacement

de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, actuellement empêché, lequel aura la garde de la pré-
sente minute. 

S’est tenue:

Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de SONOCO LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée (ci-après: la «Société») ayant son siège social 2, route d’Ettelbruck, L-9519 Wiltz, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, section B sous le numéro 80.610, issue d’un acte de scission de
société, reçu sous forme d’un acte notarié, en date du 27 décembre 2000, publié au Mémorial C numéro 779 du 19
septembre 2001.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte notarié de Maître Paul Bettingen du 19

mars 2003, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée s’est ouverte sous la présidence de Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste,

demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique. 

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et a requis le notaire instrumentant de dresser

acte:

I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est la réitération et, où nécessaire, rectification des changements relatifs à son

capital social des statuts de la Société adoptés depuis le 27 décembre 2000.

II. Que l’actionnaire représenté, le mandataire de l’actionnaire représenté et le nombre d’actions sont indiqués sur

la liste de présence, laquelle liste de présence, signée par le mandataire de l’actionnaire représenté et le bureau de l’as-
semblée, restera annexée au présent acte pour être enregistré simultanément auprès des autorités d’enregistrement.
Le pouvoir de l’actionnaire représenté restera également annexé au présent acte après avoir été paraphé ne varietur
par les comparants.

III. Que l’intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée et l’actionnaire représenté déclarant

qu’il a été dûment convoqué et été informé de l’ordre du jour préalablement à l’assemblée, des convocations ne sont
pas nécessaires.

IV. Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valable-

ment délibérer sur tous les objets inscrits à l’ordre du jour.

Le président déclare alors qu’après la fondation de la Société son actionnaire unique a notamment adopté les modi-

fication suivantes du capital de la Société:

(i) Le 27 Décembre 2000, par acte adopté par-devant Maître Joseph Elvinger, enregistré à Luxembourg mais pas publié

au Mémorial C, le capital de la Société a été augmenté de EUR 9.450.000,- (neuf millions quatre cent cinquante mille
euros);

(ii) Le 11 juillet 2001, par acte adopté par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C. le

16 juillet 2001, volume 861, folio 21, case 1 et publié au Mémorial C numéro 1210 du 14 août 2002, modifié par un acte
adopté par-devant Maître Jean-Joseph Wagner le 25 septembre 2002, enregistré à Esch-sur-Alzette A.C. le 25 septem-

48354

bre 2002, volume 871, folio 56, case 2 et Publié au Mémorial C numéro 1504 du 17 octobre 2002, le capital de la Société
a été augmenté de EUR 1.000,- (mille euros). 

Que par suite d’erreurs matérielles les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires des 11 juillet 2001

et 25 septembre 2002 indiquent que le capital de la Société était augmenté de 115.674.000,- (cent-quinze millions six
cent septante-quatre mille) à EUR 115.675.000,- (cent-quinze millions six cent septante cinq mille), alors qu’en réalité
ils auraient dû déclarer que le capital de la Société était augmenté de EUR 125.124.000,- (cent vingt-cinq millions cent
vingt-quatre mille euros) à EUR 125.125.000,- (cent vingt-cinq millions cent vingt-cinq mille euros).

Que les actes des 11 juillet 2001 et 25 septembre 2002 sont par conséquent à rectifier par la déclaration que le capital

de la Société était augmenté de EUR 125.124.000,- (cent vingt-cinq millions cent vingt-quatre mille euros) à EUR
125.125.000,- (cent vingt-cinq millions cent vingt-cinq mille euros) et la déclaration que la première phrase de l’article
six (6) des statuts est à modifier comme énoncé dans la résolution ci-dessous.

Puis l’assemblée générale, après délibération, a adopté à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution unique

Les actes des 11 juillet 2001 et 25 septembre 2002 sont rectifiés par la déclaration que le capital de la Société a été

augmenté de EUR 125.124.000,- (cent vingt-cinq millions cent vingt-quatre mille euros) à EUR 125.125.000,- (cent vingt-
cinq millions cent vingt-cinq mille euros) et la déclaration que la première phrase de l’article six (6) des statuts est à
modifier comme suit:

«Art. 6. 1

ère

 phrase. Le capital social de la Société est fixé à cent vingt-cinq millions cent vingt-cinq mille euros (EUR

125.125.000,-) représenté par cent vingt-cinq mille cent vingt-cinq (125.125) parts sociales, d’une valeur nominale de
mille euros (EUR 1.000,-) chacune.»

Dans la mesure où il n’y a plus d’autre objet à l’ordre du jour, l’assemblée est alors close.

Dont le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, le jour indiqué en tête du présent acte.
Cet acte ayant été lu aux comparants, ils ont signé conjointement avec nous, notaire, le présent acte original.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête des comparants ci-dessus, le présent acte

est rédigé en anglais suivi d’une traduction française. A la requête des même comparants et en case de divergences entre
les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: P. Van Hees, H. Janssen, J. Seckler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2003, vol. 138S, fol. 83, case 2.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054147.3/211/140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

EL 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 79.600. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 6 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur José Mouzon, employé privé, demeurant à Luxembourg. Sa nomina-

tion sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03261. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054372.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

ALSGARD, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 64.290. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01091, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

(054401.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 7 mai 2003.

J. Elvinger.

Pour copie conforme
Signatures

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

48355

EASTERN INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 78.491. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 6 novembre 2002

Le Conseil d’Administration accepte la démission de Monsieur Marc Collard de son poste d’administrateur avec effet

au 6 novembre 2002. Quitus pour son mandat lui sera donné lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

Le Conseil nomme en remplacement Monsieur José Mouzon, employé privé, demeurant à Luxembourg.
Sa nomination sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03252. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054373.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

S.C.I. PLEK, Société Civile Immobilière Familiale.

Siège social: L-4996 Schouweiler, 2, rue du IX Septembre.

R. C. Luxembourg E 89. 

L’an deux mille trois, le trente et un juillet. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

 Ont comparu:

 1) Monsieur Jean-Pierre Henri dit Pierrick Guillou, restaurateur, né à Nantes (France) le 20 juin 1945, et son épouse

Madame Lysiane Abeline Germaine Robert, sans état particulier, née à Tours (France) le 29 avril 1951, demeurant en-
semble à L-4996 Schouweiler, 19, rue de la Résistance,

 mariés sous le régime de la communauté légale de biens aux termes d’une convention matrimoniale reçue par le

notaire instrumentaire en date du 24 avril 1997, 

 2) Mademoiselle Katell Guillou, employée privée, née à Bastogne, Belgique, le 15 décembre 1972, demeurant à L-

4996 Schouweiler, 19, rue de la Résistance,

 ici représentée par Monsieur Jean-Pierre Henri dit Pierrick Guillou, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 25 juillet 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que les comparants sont les seuls sociétaires de la société civile immobilière familiale S.C.I. PLEK, ayant son siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 juin 2003, publié au Recueil
du Mémorial C n

°

 709 du 4 juillet 2003.

- Le fonds social est représenté par mille (1.000) parts d’intérêt d’une valeur nominale d’un (1,-) euro chacune.
- Les sociétaires décident d’augmenter le capital social à concurrence de cinq cent vingt-trois mille (523.000,-) euros

pour le porter de son montant actuel de mille (1.000,-) euros à cinq cent vingt-quatre mille (524.000,-) euros par la
création et l’émission de cinq cent vingt-trois mille (523.000) nouvelles parts d’intérêt d’une valeur nominale d’un (1,-)
euro chacune.

Ces nouvelles parts d’intérêt ont été souscrites de la manière suivante:
- cinq cent vingt-trois (523) parts d’intérêt par Mademoiselle Katell Guillou, préqualifiée,
- cinq cent vingt-deux mille quatre cent soixante-dix-sept (522.477) parts d’intérêt par Monsieur Jean-Pierre Henri

dit Pierrick Guillou et son épouse Madame Lysiane Abeline Germaine Robert, préqualifiés.

Elles ont été intégralement libérées de la façon suivante:
a) pour Mademoiselle Katell Guillou, préqualifiée, par un apport en espèces d’un montant de cinq cent vingt-trois

(523,-) euros; 

b) pour Monsieur Jean-Pierre Henri dit Pierrick Guillou et son épouse Madame Lysiane Abeline Germaine Robert:
- par un apport en espèces d’un montant de quatre cent soixante-dix-sept (477,-) euros;
Les apports libérés en espèces ont été mis à la disposition de la société, ainsi que les sociétaires le reconnaissent.
- pour le surplus de leur contribution par l’apport de l’immeuble ci-après décrit:

<i>Désignation

 Une maison de commerce avec toutes ses appartenances et dépendances sise à Schouweiler, 2, rue du IX Septembre

et inscrite au cadastre comme suit:

Commune de Dippach, section D de Schouweiler, Numéro 517/2920, lieu-dit «Schouweiler», maison, place, conte-

nant 26 ares 50 centiares.

<i>Estimation

L’immeuble ci-dessus décrit est estimé à un montant principal de quatre cent cinquante-trois mille neuf cent treize

euros quatre cents (453.913,04) augmenté de 15% de TVA soit soixante-huit mille quatre-vingt-six euros quatre-vingt-
seize cents (68.086,96), soit un montant total de cinq cent vingt-deux mille (522.000,-) euros.

La société déclare opter pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière.

Pour copie conforme
Signatures

48356

<i>Origine de propriété

L’immeuble a été acquis par les époux Jean-Pierre Guillou-Robert suivant un acte de vente reçu par le notaire instru-

mentaire en date du 30 juillet 1998, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de et à Luxembourg, le 20 août
1998, volume 1148, numéro 48.

Suite à l’augmentation de capital qui précède, il y a lieu de modifier l’article cinq des statuts pour lui donner la teneur

suivante:

«Art. 5. Il existe cinq cent vingt-quatre mille (524.000) parts d’intérêt d’une valeur nominale d’un (1,-) euro chacune

attribuées comme suit à chacun des sociétaires en fonction de son apport: 

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: P. Guillou, L. Robert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, vol. 930B, fol. 28, case 5. – Reçu 2.615 euros. 

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054458.3/230/71) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

S.C.I. PLEK, Société Civile Immobilière Familiale.

Siège social: L-4996 Schouweiler, 2, rue du IX Septembre.

R. C. Luxembourg E 89. 

L’an deux mille trois, le trente et un juillet.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg,

 Ont comparu:

 1) Monsieur Jean-Pierre Henri dit Pierrick Guillou, restaurateur, né à Nantes (France) le 20 juin 1945, et son épouse

Madame Lysiane Abeline Germaine Robert, sans état particulier, née à Tours (France) le 29 avril 1951, demeurant en-
semble à L-4996 Schouweiler, 19, rue de la Résistance,

 mariés sous le régime de la communauté légale de biens aux termes d’une convention matrimoniale reçue par le

notaire instrumentaire en date du 24 avril 1997, 

 2) Mademoiselle Katell Guillou, employée privée, née à Bastogne, Belgique, le 15 décembre 1972, demeurant à L-

4996 Schouweiler, 19, rue de la Résistance,

 ici représentée par Monsieur Jean-Pierre Henri dit Pierrick Guillou, préqualifié,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, en date du 25 juillet 2003.
Laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Que les comparants sont les seuls associés de la société civile immobilière familiale S.C.I. PLEK, ayant son siège social

à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 9 juin 2003, publié au Recueil du
Mémorial C n

°

 709 du 4 juillet 2003.

Les statuts de ladite société ont été modifiés par un acte du notaire instrumentaire en date de ce jour.
- Le fonds social est représenté par cinq cent vingt-quatre mille (524.000) parts d’intérêt d’une valeur nominale d’un

(1,-) euro chacune.

Monsieur Jean-Pierre Henri dit Pierrick Guillou, et son épouse Lysiane Abeline Germaine Robert, préqualifiés, ici pré-

sents, cèdent cent vingt-quatre mille quatre cent soixante-seize (124.476) parts d’intérêt qu’ils possèdent dans la société
à Mademoiselle Katell Guillou, préqualifiée, pour un prix de cent vingt-quatre mille quatre cent soixante-seize (124.476)
euros, ce dont quittance.

Cette cession a été effectuée de l’accord de tous les sociétaires et, pour autant que de besoin, acceptée pour la so-

ciété par ses gérants.

- Suite à la cession qui précède, la répartition des parts d’intérêt est désormais la suivante et le deuxième alinéa de

l’article 5 des statuts est modifié en conséquence:

«Les parts d’intérêt sont réparties comme suit: 

1) Monsieur Jean-Pierre Henri dit Pierrick Guillou, et son épouse Lysiane Abeline Germaine Robert, préqua-

lifiés, en tant que partiaires de la communauté légale de biens existant entre eux, cinq cent vingt-trois mille qua-
tre cent soixante-seize parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523.476

 2) Mademoiselle Katell Guillou, préqualifiée, cinq cent vingt-quatre parts d’intérêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

524

Total: cinq cent vingt-quatre mille parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.000

Luxembourg, le 29 août 2003.

A. Schwachtgen.

1) Monsieur Jean-Pierre Henri dit Pierrick Guillou, et son épouse Lysiane Abeline Germaine Robert, préqua-

lifiés, en tant que partiaires de la communauté légale de biens existant entre eux, trois cent quatre-vingt-dix-
neuf mille parts d’intérêt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399.000

 2) Mademoiselle Katell Guillou, préqualifiée, cent vingt-cinq mille parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000

Total: cinq cent vingt-quatre mille parts d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.000

48357

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, Notaire, la présente

minute.

Signé: P. Guillou, L. Robert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 août 2003, vol. 18CS, fol. 44, case 2. – Reçu 7.468,56 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054460.3/230/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

S.C.I. PLEK, Société Civile Immobilière Familiale.

Siège social: L-4996 Schouweiler, 2, rue du IX Septembre.

R. C. Luxembourg E 89. 

Statuts coordonnés suivant les actes n

°

 982 du 31 juillet 2003 et n

°

 983 du 31 juillet 2003, déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054461.3/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

ALTONA GESTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 10, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 80.462. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire qui s’est tenue le 5 mai 2003

Le mandat des administrateurs venant à expiration avec la présente assemblée, celle-ci décide de renouveler le man-

dat des administrateurs pour une période de un an.

Leurs mandats prendront fin lors de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2003, réf. LSO-AG03235. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054374.3/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

EUROPEAN MARKETING GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 16.575. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 2 avril 2003 au siège social

L’assemblée par un vote spécial donne décharge aux administrateurs, à Messieurs Raymond Jonkers et Michel Carlier,

qui ont remis leur démission le 19 février 2002, et au commissaire de leur mandat au cours de l’exercice écoulé.

La décharge est accordée à l’unanimité.
Aucun mandat d’administrateur ni de commissaire ne vient à échéance à l’issue de la présente assemblée.
L’assemblée prend acte de la démission avec effet au 18 février 2003 de Monsieur Alain Vervaet, Administrateur et

Président, demeurant à Waarschoot, Sparrenstraat 7, et décide, à l’unanimité, de ratifier la décision du Conseil du 18
février 2003 de pourvoir au remplacement en tant qu’Administrateur de Monsieur A. Vervaet par la nomination de Mon-
sieur Jean Paul Cames, demeurant à Bridel, Impasse Michel Kieffer, 16, qui a accepté. Ce mandat viendra à expiration à
l’issue de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’exercice 2003. Monsieur Jan Ingelbrecht a été nom-
mé Président du Conseil d’Administration en remplacement de Monsieur Vervaet.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01077. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054501.3/806/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Luxembourg, le 29 août 2003.

A. Schwachtgen.

Signature.

Pour copie conforme
Signatures

Pour extrait conforme
J. S. Cornelis / J. Ingelbrecht
<i>Administrateur-Délégué / <i>Président

48358

INDUSTRIAL PERFORMANCE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 33, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 42.254. 

DISSOLUTION

L’an deux mille trois, le vingt-sept août.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

UP TO DATE Inc., une société avec siège social à Alofi Suites 21, Maluaga, Niue,
ici représentée par Maître Jean-Paul Kill, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 22, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg,

en vertu d’une procuration donnée le 11 juin 2003.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire restera an-

nexée au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante a, par son mandataire, prié le notaire d’acter que:
- La société anonyme INDUSTRIAL PERFORMANCE HOLDING S.A., R.C. Luxembourg B 42.254, dénommée ci-

après «la Société», fut constituée suivant acte reçu par Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg,
en date du 26 novembre 1992, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 99 du 3 mars 1993.

Les statuts de ladite société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire

instrumentaire en date du 2 mai 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n

°

 1115 du 22 juillet

2002.

 - La Société a actuellement un capital social de cinq millions d’euros (EUR 5.000.000,-), divisé en cinq mille (5.000)

actions d’une valeur nominale de mille euros (EUR 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et intégralement libérées.

- La comparante s’est rendue successivement propriétaire de la totalité des actions de la Société.
- Par la présente la comparante en tant qu’actionnaire unique prononce la dissolution de la Société avec effet immé-

diat.

- La comparante déclare qu’elle a pleine connaissance des statuts de la Société et qu’elle connaît parfaitement la si-

tuation financière de la Société.

- La comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare que l’activité de la Société a cessé, que le passif

connu de ladite Société a été payé ou provisionné, que l’actionnaire unique est investi de tout l’actif et qu’il s’engage
expressément à prendre à sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé
ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne; partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite
et clôturée.

- L’actionnaire unique donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire pour leurs mandats

jusqu’à ce jour.

- Les documents et pièces relatifs à la Société dissoute resteront conservés durant cinq ans au 22, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg.

Sur ce, le mandataire de la comparante a présenté au notaire vingt certificats d’actions toutes au porteur lesquels ont

été immédiatement lacérés. 

Sur base de ces faits le notaire a constaté la dissolution de la société INDUSTRIAL PERFORMANCE HOLDING S.A.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes. 
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, celui-ci a signé avec Nous, Notaire,

la présente minute.

Signé: J-P. Kill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003, vol. 140S, fol. 40, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054497.3/230/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

VINKELBERG COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 59.939. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01028, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2003.

(054412.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

48359

GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 38.673. 

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausenddrei, den siebenundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen

UP TO DATE Inc., eine Gesellschaft mit Sitz in Alofi Suites 21, Maluaga, Niue,
hier vertreten durch Herrn Jean-Paul Kill, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in 22, boulevard de la Foire, L-1528 Lu-

xemburg,

aufgrund einer Vollmacht gegeben am 11. Juni 2003.
Welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, den instrumentierenden Notar ersucht hat folgendes zu beurkun-

den:

- Die Komparentin ist alleiniger Besitzer aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GIA GLOBAL IN-

VESTMENT ACTIVITY S.A., mit Sitz in Luxemburg, R. C. Luxemburg B 38.673, gegründet unter der Bezeichnung GRA-
SETTO FINANCE (HOLDING) INTAL durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Gérard Lecuit, mit dem
damaligen Amtssitz in Mersch, am 3. November 1991, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 183 vom 6. Mai 1992 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den

instrumentierenden Notar, am 9. April 2003, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations Nummer 474
vom 2. Mai 2003 veröffentlicht wurde.

- Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf vierhundertfünfundneunzigtausendsiebenhundertsiebenundachtzig Euro

und fünf Cent (EUR 495.787,05), eingeteilt in zwanzigtausend (20.000) Aktien ohne Nennwert, alle voll gezeichnet und
eingezahlt.

- Die Komparentin ist Besitzerin aller Aktien der Gesellschaft geworden.
- Andurch erklärt die Komparentin als einzige Aktionärin die vorzeitige Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger

Wirkung.

- Die einzige Aktionärin erklärt, dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.
- Die einzige Aktionärin erklärt, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Gesellschaft

aufgehört hat, dass die bekannte Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass sie sich ausdrücklich
dazu verpflichtet, alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt oder un-
bekannt bis zum heutigen Tage sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an ihre Person als einzige
Gesellschafterin getätigt wird; mithin ist die Liquidation der Gesellschaft als getan und abgeschlossen zu betrachten.

- Die einzige Aktionärin erteilt dem Verwaltungsrat und dem Kommissar Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate

bis zum heutigen Tage.

Die betreffenden Dokumente der aufgelösten Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in 22, bou-

levard de la Foire, L-1528 Luxemburg aufbewahrt.

Worauf der Bevollmächtigte der Komparentin dem unterfertigten Notar vier Inhaberzertifikate vorgelegt hat welche

sofort zerstört wurden.

Somit hat der instrumentierende Notar die endgültige Auflösung der Gesellschaft GIA GLOBAL INVESTMENT AC-

TIVITY S.A. festgestellt.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, hat derselbe mit Uns, Notar,

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J.-P. Kill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003, vol. 140S fol. 40, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054515.3/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

CS PRIVATE UNIVERSE MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 85.398. 

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination

of CS PRIVATE UNIVERSE MANAGEMENT COMPANY, R.C. B Number 85 398, incorporated pursuant to a deed of
Maître Reginald Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated December 18, 2001, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Number 188 of February 2, 2002.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

48360

The meeting begins at twelve Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERV-

ICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, being in the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice-President, CREDIT SUISSE AS-

SET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue
Jean Monnet.

The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Breger, mandatory, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred

(500) shares with no par value, representing the entire corporate capital of two hundred and fifty thousand (250,000)
Swiss francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon
the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the shareholders represented having agreed
to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the members of the bureau and the notary, shall remain attached to the present deed,

together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
Resetting of the Articles of Incorporation of the company (as described in the attachment to the proxy).
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolution by unanimous vote:

<i>First resolution

It is resolved to introduce a prevailing English version of the Articles of Incorporation and to proceed to a total re-

statement.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Corporation shall henceforth read as follows:

Art. 1. There exists a corporation under Luxembourg Law in the form of a société anonyme under the name of CS

PRIVATE UNIVERSE MANAGEMENT COMPANY.

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period.
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-

ment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of a mutual investment fund

known as CS PRIVATE UNIVERSE (LUX) (the «Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation evi-
dencing undivided co-proprietorship interests therein.

The Corporation shall manage any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, adminis-

tration and promotion of such Fund and with respect thereto it may set up one or more branches. On behalf of the
Fund, it may enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions
and transfer in the name of the Fund or in third parties’ names in the register of shares or debentures of any Luxembourg
or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, es-
pecially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be
considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may take any measures and carry out any operation directly or indirectly connected with its pur-

pose while remaining within the limits of Chapter 14 of the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective
Investment.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place in the same commune by decision of the board of direc-

tors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of direc-
tors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political developments have occurred or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on the na-
tionality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg corporation.

Art. 5. The corporate capital is set at two hundred and fifty thousand (250,000.-) Swiss Francs divided into five hun-

dred (500) shares in registered form with no par value, all fully paid up.

The Corporation will issue shares in registered form.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

48361

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the second Monday of the month of May of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in
the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The meeting of shareholders may fix an emolument, traveling and day to day accommodation for all members of the

Board of Directors.

Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting

of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile trans-
mission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the total number of shares outstanding and entitled to vote at the meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 12. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or

another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro tempore or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another director, an officer of the Corporation or such other individual
as they may determine as chairman pro tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such
meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, general managers and any

assistant general managers, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Corporation, who need not be Directors or shareholders of the Corporation. Any such ap-
pointment may be revoked at any time by the board of directors. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by

other electronic means of transmission to all Directors at least twenty four hours in advance of the day set for the meet-
ing. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business
other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board
not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or
telex or telefax or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by any
director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram, telex

or telefax another director as his proxy. Any director may attend a meeting of the board of directors using teleconfer-
ence, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of
board of directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of board of directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of

communication, in which a quorum of directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

48362

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall

have a casting vote.

Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and

held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evi-
denced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as men-
tioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which
the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be

formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Corporation via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the
decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors

shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of
the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically per-
mitted by resolution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more directors of the Cor-
poration («managing directors» - «administrateurs-délégués»), if authorized by the general meeting of shareholders.

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be af-

fected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not
include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Corporation any subsidiary
or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of direc-
tors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered
by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing privilege of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 15 may be advanced by the Corporation prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 15.

Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, officers or of any other persons

to whom authority has been delegated by the board of directors.

Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor («réviseur
d’entreprises»). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the thirty-first of December of each year.

48363

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to
ten percent (10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time
to time as provided in Article six hereof.

The annual general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be dis-

posed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate pur-
pose and policy.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Luxembourg law.

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 22. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the relevant law
on undertakings for collective investment.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve fif-

teen.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den sechsundzwanzigsten August.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CS PRIVATE UNIVERSE MANAGEMENT COMPANY, mit Sitz in Luxem-

burg, H. R. Nummer B 85.398, gegründet durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Reginald Neuman,
damals mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 18. Dezember 2001, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 188 vom 2. Februar 2002, veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zu-
sammengetreten.

Die Versammlung beginnt um zwölf Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, «Director», CREDIT SUIS-

SE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue
Jean Monnet.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Jacqueline Siebenaller, «Vice-President», CREDIT SUISSE ASSET MANA-

GEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Daniel Breger, «mandatory», CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die fünfhundert (500) Aktien ohne Nennwert, welche das gesamte Kapital von zweihundertfünf-
zigtausend (250.000,-) Schweizer Franken darstellen hier in dieser Versammlung gültig vertreten sind, welche somit ord-
nungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen
Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zu-

sammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
Neufassung der Satzung der Gesellschaft (wie in der Anlage zu der Vollmacht beschrieben).
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
genden Beschluss:

<i>Beschluss

Es wird beschlossen eine massgebende englische Fassung der Satzung einzuführen.
Infolgedessen wird die Satzung der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CS PRIVATE UNIVERSE MANAGEMENT COM-

PANY.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktio-

näre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen, so wie in Artikel einundzwanzig dieser Satzung festge-
setzt, gefasst wurde aufgelöst werden.

48364

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen CS PRIVA-

TE UNIVERSE (LUX) (der «Fonds») und die Ausgabe von Zertifikaten und Bestätigungserklärungen welche das unge-
teilte Eigentum daran nachweisen.

Die Gesellschaft wird alle Aktivitäten, in Luxemburg und im Ausland ausüben, welche die Verwaltung und die Förde-

rung dieses Fonds betreffen und diesbezüglich eine oder mehrere Zweigstellen errichten. Für den Fonds kann sie Kon-
trakte abschliessen, Wertpapiere verkaufen, kaufen, tauschen und ausgeben, im Namen des Fonds oder im Namen von
Drittpersonen, jedwede Eintragungen und Übertragungen tätigen im Aktien- oder Obligationsregister von luxemburgi-
schen oder ausländischen Gesellschaften, sowie im Namen des Fonds und der Anteilsinhaber des Fonds alle Rechte und
Privilegien, insbesondere das Stimmrecht ausüben bezüglich der Wertpapiere aus welchen die Aktiva der Gesellschaft
bestehen. Die vorgenannten Befugnisse sind nicht als erschöpfend, sondern lediglich als erklärend zu betrachten.

Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt ihrem Ge-

sellschaftszweck dienlich sind im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
die Investmentfonds.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort in derselben Gemeinde

verlegt werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche politische Umstände eingetreten sind oder bevorstehen

welche die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern, oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörig-
keit.

Art. 5. Das Aktienkapital beträgt zweihundertfünfzigtausend (250.000,-) Schweizer Franken, eingeteilt in fünfhundert

(500) Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

Die Aktien der Gesellschaft werden in Form von Namensaktien herausgegeben.
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt. Dieses Register beinhaltet für jeden Aktionär seinen Namen,

seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort, die Zahl der Aktien, den eingezahlten Betrag für jede Aktie und die Aktienüber-
tragungen und das Datum solcher Übertragungen.

Die Übertragung einer Aktie wird getätigt durch eine schriftliche Übertragungserklärung welche ins Aktienregister

eingetragen wird; diese Übertragung wird durch den Abtreter und den Übernehmer oder durch diejenigen Personen,
welche diesbezüglich Vollmachten haben, datiert und unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch als Übertragungsbeweis
andere Dokumente annehmen welche ihr ausreichend erscheinen.

Art. 6. Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist gemäss Artikel einundzwanzig der Satzung.

Art. 7. Jede ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, oder an einem anderen,

in der Einberufung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Montag des Monats
Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt. Die ordentliche Ge-
neralversammlung kann jederzeit, nach definitivem und schlussendlichem Beschluss des Verwaltungsrats, falls besondere
Umstände es erfordern, an einem beliebigen Ort einberufen werden.

Andere Generalversammlungen können an dem in den betreffenden Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt

stattfinden.

Die Generalversammlung kann, Zuschüsse, Reise- und Tagesspesen für alle Mitglieder des Verwaltungsrates festset-

zen.

Art. 9. Das Quorum und die Fristen welche vom Gesetz vorgeschrieben sind regeln die Einberufung und den Ablauf

der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, unter Vorbehalt dieser Bestimmungen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Aktionär kann

an jeder Versammlung teilnehmen indem er einen Dritten als seinen Bevollmächtigten bezeichnet schriftlich, per Kabel,
Telegramm, Telex oder Fax.

Falls nicht anders vom Gesetz verordnet, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Versammlung

durch einfache Mehrheit aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festsetzen welche durch die Aktionäre erfüllt sein müssen um an

einer Versammlung teilzunehmen.

Art. 10. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen durch Einschreibebrief mit der Tages-

ordnung welcher mindestens acht Tage vor der Versammlung an die Aktionäre gesandt wird an ihre im Aktienregister
vermerkte Adresse.

Wenn jedoch alle Aktionäre präsent oder vertreten sind auf der Versammlung und wenn sie feststellen dass über die

Tagesordnung informiert sind, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. 

48365

Die Verwaltungsratmitglieder werden ernannt durch die jährliche Versammlung der Aktionäre für einen Zeitraum bis

zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger; ein Verwaltungsratmitglied kann jederzeit mit
oder ohne Grund ersetzt werden durch einen Beschluss der Aktionäre.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Postens als Verwaltungsratmitglied durch Tod, Rücktritt oder sonstwie können

die verbliebenen Mitglieder zusammenkommen und durch Mehrheitsbeschluss einen Nachfolger bestellen bis zur näch-
sten Versammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vize-Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, welcher nicht Verwaltungsratmitglied
sein muss, und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen aufsetzt. Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Ein-
berufen des Präsidenten, oder zweier Verwaltungsratmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Der Präsident steht allen Versammlungen vor, oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vizepräsident

oder ein anderes Verwaltungsratmitglied, welches pro tempore vorstehen wird. Die Aktionäre können, durch Mehr-
heitsbeschluss einen anderen Angestellten oder eine andere Person bestimmen, welche pro tempore der Sitzung vor-
stehen wird.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Beamte der Gesellschaft, Generalverwalter und assistierende Generalver-

walter, Sekretäre und Hilfssekretäre bestimmen welche für die Operationen und die Verwaltung der Gesellschaft zu-
ständig sind welche nicht Verwaltungsratmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen. Eine solche Bestimmung kann
jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgerufen werden. Die ernannten Beamten, falls nicht anders in der Satzung vorge-
sehen werden die Befugnisse und Aufgaben haben welche ihnen durch den Verwaltungsrat zuerteilt werden.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates wird schriftlich einberufen oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf

elektronischem Wege an alle Verwaltungsratmitglieder wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung. Die
Bekanntmachung enthält die Tagesordnung der Versammlung und kein anderer Punkt kann gültig auf der Versammlung
beraten werden. Auf die Einberufung kann verzichtet werden durch schriftliche Einwilligung oder durch Kabel, Tele-
gramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege und jedes anwesende Verwaltungsratmitglied ist erachtet darauf verzich-
tet zu haben. Eine separate Einberufung ist nicht notwendig für individuelle Sitzungen welche abgehalten werden nach
einem Schema des Verwaltungsrates.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen, in dem es schriftlich, per

Kabel, Telefax oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als seinen Bevoll-
mächtigten ernennt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon oder
Video-Konferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen er-
laubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als
persönliche Teilnahme an der Sitzung. 

Eine Versammlung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschaltung an welcher ein Quorum des

Verwaltungsrates teilnimmt ist bindend wie wenn alle persönlich anwesend gewesen wären, unter der Voraussetzung
dass ein Protokoll unterzeichnet wird durch den Präsidenten der Versammlung.

Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Die Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Die Mitglieder
welche nicht persönlich anwesend sind oder vertreten sind können schriftlich abstimmen oder durch Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischem Wege.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
Rundbeschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind, sind genauso gültig und genauso

bindend, wie wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des Rundbeschlusses. Im Falle wo kein
spezielles Datum vermerkt ist wird der Rundbeschluss gültig am Tag wo die letzte Unterschrift getätigt wird.

Beschlüsse welche durch andere elektronische Mittel gefasst werden wie e-mail, Telegram oder Telex werden for-

malisiert durch den nachfolgenden Beschluss. Das Inkrafttreten des Beschlusses ist dann diejenige der letzten Genehmi-
gung welche die Gesellschaft erhielt durch elektronische Mittel. Die Genehmigungen von allen Mitgliedern des
Verwaltungsrates werden dem Rundbeschluss beigefügt bleiben und einen integralen Bestandteil bilden welche die vor-
her gefassten Beschlüsse billigen.

Rundbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Verwaltungsratmitglieder gefasst werden.

Art. 13. Die Protokolle des Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge dieser Urkunden welche zu gerichtlichen Zwecken gebraucht werden oder sonstwie werden

durch den Präsidenten unterzeichnet oder den pro tempore Präsidenten oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder.

Art. 14. Die Verwaltungsratmitglieder können nur an ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Rates teilnehmen.

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis die Gesellschaftspolitik festzulegen und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft.
Die Verwaltungsratmitgllieder können die Gesellschaft jedoch nicht durch ihre persönlichen Handlungen binden, ausser
spezieller Erlaubnis des Rates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die einem

oder mehreren Verwaltern der Gesellschaft übertragen (delegiertes Verwaltungsratmitglied) wenn die Generalver-
sammlung es erlaubt hat.

Art. 15. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wer-

den nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder
leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein persönliches
Interesse haben oder dort Mitglied des Verwaltungsrates, Aktionär, leitender oder sonstiger Angestellter sind. Jedes

48366

Mitglied des Verwaltungsrates und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Mitglied des Verwaltungsrates,
leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit der
die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit der
anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder
einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Im Falle wo ein Verwalter oder Beamter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesell-

schaft hat muss dieser Verwalter dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse kundtun und nicht über diese Ange-
legenheit abstimmen und von diesem persönlichen Interesse wird der nächsten Generalversammlung berichtet. Der
Ausdruck «persönliches Interesse» wie vorher benutzt begreift nicht eine Beziehung oder ein Interesse eine Position
oder ein Geschäft welches die Gesellschaft oder eine Filiale betrifft oder jede andere Gesellschaft welche der Verwal-
tungsrat zu jeder Zeit nach seinem Ermessen festsetzen kann.

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Er-

ben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von ihm im Zusammen-
hang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund
seiner Stellung als Mitglied des Verwaltungsrates oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag
hin, auch einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist, oder bei der die Gesellschaft Gläu-
biger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in denen er auf Grund dieser Klagen,
Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig verur-
teilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachen, die von dem
Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu entschä-
digende Person keine Pflicht verletzt hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus. 

Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und der Verteidigung bei einer Klage oder Prozess wie in diesem Ar-

tikel beschrieben können durch die Gesellschaft vorgeschoben werden vor einem endgültigen Urteil unter der Bedin-
gung dass dieser Betrag zurückgezahlt werden muss wenn das Verwaltungsratmitglied nicht berechtigt ist zu einer
Entschädigung gemäss diesem Artikel.

Art. 16. Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrat-

mitgliedern, Beamten oder anderer Personen, welche vom Verwaltungsrat hierzu delegiert wurden.

Art. 17. Die Geschäfte der Gesellschaft, begreifend insbesondere ihre Bücher und Steuerangelegenheiten oder an-

dere Berichte welche das Luxemburger Gesetz verlangt, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer
(«réviseur d’entreprises»). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur
nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit durch die Aktionäre abberufen werden mit oder ohne Grund.

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreissigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 19. Vom dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf (5%) Prozent dem gesetzlichen Reserve-

fonds zugeführt. Diese Speisung ist nicht mehr erforderlich sobald und solange die Reserve zehn (10%) Prozent des Ge-
sellschaftskapitals ausmacht.

Die jährliche Versammlung bestimmt wie der Restbetrag des Gewinns verteilt wird und kann alleine Dividenden fest-

legen wie sie es in ihrem Ermessen für gut befindet für die Gesellschaftspolitik.

Interimdividende kann gemäss dem Luxemburger Gesetz ausgezahlt werden.

Art. 20. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

physische Personen oder Körperschaften sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidato-
ren und setzt deren Vergütung fest.

Art. 21. Die Satzung kann jederzeit durch eine Generalversammlung abgeändert werden unter den luxemburgischen

gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Quorum und das Stimmrecht.

Art. 22. Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf das Gesetz vom zehnten August

neunzehnhudertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und das Gesetz über Investmentfonds verwiesen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr fünfzehn für geschlos-

sen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Trichies, J. Siebenaller, D. Breger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 36, case 12. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054571.3/230/449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

48367

ACTIV’INVEST, Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.828. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 21 mai 2003

- la cooptation Monsieur Maxime Uhl, étudiant, 5 Place du Marché Neuf, F-Strasbourg, en tant qu’Administrateur en

remplacement de Monsieur Aloyse Scholtes, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’As-
semblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00367. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054386.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

CITAR-INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 80.271. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05545. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054387.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

A.O.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5670 Altwies, 2, rue J.-P. Koppes.

R. C. Luxembourg B 37.812. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003

<i>ad. 5) Nominations statutaires

L’Assemblée, à l’unanimité, décide de renouveler les mandats venus à expiration de Madame Marianne Chaussy-

Weyer et Messieurs Marc Cigrang et Jean-Marc Heitz, administrateurs, pour 6 (six) années, leurs mandats prenant fin à
l’issue de l’Assemblée générale à tenir en 2009.

D’autre part, l’Assemblée, à l’unanimité, décide de renouveler les mandats venus à expiration de Messieurs Jacques

Deutsch et Jean-Paul Krier, commissaires, pour 6 (six) années, leurs mandats prenant fin à l’issue de l’Assemblée géné-
rale à tenir en 2009.

Suite à cette décision de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 mai 2003,

<i>le Conseil d’Administration de AOS S.A. se compose de la façon suivante

a) Madame Marianne Chaussy-Weyer, employée privée, demeurant 43, rue des Trois Cantons à L-8352 Dahlem;
b) Monsieur Marc Cigrang, indépendant, demeurant 9, rue Michel Rodange à L-7624 Larochette;
c) Monsieur Jean-Marc Heitz, employé privé, demeurant 1, Huelgaass à L-5671 Altwies.

<i>les commissaires de AOS S.A., au nombre de deux, sont

a) Monsieur Jacques Deutsch, employé privé e.r., demeurant 2, rue de la Gare à L-6985 Hostert;
b) Monsieur Jean-Paul Krier, employé privé, demeurant 1, Huelgaass à L-5671 Altwies. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01016. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054445.3/000/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Certifié sincère et conforme
ACTIV’INVEST
F. Uhl
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
A.O.S. S.A.
M. Chaussy / J-M. Heitz
<i>Administrateur / Administrateur

48368

CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY, Société Anonyme.

Registered office: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 49.227. 

In the year two thousand and three, on the twenty-sixth of August.
Before Us Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the corporation established in Luxembourg under the denomination

of CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY, R.C. B Number 49.227, incorporated under
the denomination of DYNAMIC ENHANCED FUND MANAGEMENT COMPANY, pursuant to a deed of Maître Regi-
nald Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated November 15, 1994, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, Number 542 of December 23, 1994.

The Articles of Incorporation have been amended by a deed of Maître Jacques Delvaux, notary residing in Esch-sur-

Alzette, in replacement of Maître Reginald Neuman dated April 4, 1998, published in the Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations, Number 294 of April 29, 1998.

The meeting begins at eleven forty-five a.m. Mr Germain Trichies, Director, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet, being in
the Chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mrs Jacqueline Siebenaller, Vice-President, CREDIT SUISSE AS-

SET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue
Jean Monnet.

The meeting elects as scrutineer Mr Daniel Breger, mandatory, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., with professional address at L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

The Chairman then states that:

I.- It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the five hundred

(500) shares with a par value of five hundred (500,-) Swiss francs each, representing the entire corporate capital of two
hundred and fifty thousand (250,000.-) Swiss francs are duly represented at this meeting which is consequently regularly
constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced, without prior notice, all the share-
holders represented having agreed to meet after examination of the agenda.

The attendance list, signed by the members of the bureau and the notary, shall remain attached to the present deed,

together with the proxies, and shall be filed at the same time with the registration authorities.

II.- The agenda of the meeting is worded as follows:
Resetting of the Articles of Incorporation of the company (as described in the attachment to the proxy).
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting

passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:

<i>First resolution

The par value of the shares is deleted.

<i>Second resolution

It is resolved to introduce a prevailing English version of the Articles of Incorporation and to proceed to a total re-

statement.

Consequently, the Articles of Incorporation of the Corporation shall henceforth read as follows:

Art. 1. There exists a corporation under Luxembourg Law in the form of a société anonyme under the name of

CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY.

Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period. 
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amend-

ment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 3. The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of a mutual investment fund

known as CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX) (the 'Fund') and the issue of certificates or statements of con-
firmation evidencing undivided co-proprietorship interests therein.

The Corporation shall manage any activities, in Luxembourg and abroad, connected with the management, adminis-

tration and promotion of such Fund and with respect thereto it may set up one or more branches. On behalf of the
Fund, it may enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, proceed to any inscriptions
and transfer in the name of the Fund or in third parties’ names in the register of shares or debentures of any Luxembourg
or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the unitholders of the Fund, all rights and privileges, es-
pecially all voting rights attached to the securities constituting assets of the Fund. The foregoing powers shall not be
considered as exhaustive, but only as declaratory.

The Corporation may take any measures and carry out any operation directly or indirectly connected with its pur-

pose while remaining within the limits of Chapter 14 of the Law of 20 December 2002 on Undertakings for Collective
Investment.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. 
The registered office may be transferred to any other place in the same commune by decision of the board of direc-

tors. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of direc-
tors.

48369

In the event that the board of directors determines that extraordinary political developments have occurred or are

imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on the na-
tionality of the Corporation which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Lux-
embourg corporation.

Art. 5. The corporate capital is set at two hundred and fifty thousand (250,000.-) Swiss Francs divided into five hun-

dred (500) shares in registered form with no par value, all fully paid up.

The Corporation will issue shares in registered form.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Corporation. Such register shall set forth the

name of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid up on
each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.

The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed on the register of shareholders,

such declaration of transfer to be dated and signed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney to act therefore. The Corporation may also accept as evidence of transfer other instruments of
transfer satisfactory to the Corporation.

Art. 6. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation, as prescribed in Article twenty-one hereof.

Art. 7. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the
operations of the Corporation.

Art. 8 The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of
meeting, on the second Monday of the month of May of each year at 11.00 a.m. If such day is a legal holiday, the annual
general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting may be held abroad if, in
the absolute and final judgment of the board of directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The meeting of shareholders may fix an emolument, traveling and day to day accommodation for all members of the

Board of Directors.

Art. 9. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by law. A shareholder may act at any meeting

of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram, telex or facsimile trans-
mission.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of the total number of shares outstanding and entitled to vote at the meeting.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon call by the board of directors, pursuant to notice setting forth the agenda sent

by registered mail at least eight days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder’s address in the register
of shareholders.

If however, all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they

have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 11. The Corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, who need

not be shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period ending at the next

annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be
removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

In the event of vacancy in the office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 12. The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors. The board of directors shall meet upon
call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or

another director appointed by the Board of Directors shall preside as chairman pro tempore or in their absence or
inability to act, the shareholders may appoint another director, an officer of the Corporation or such other individual
as they may determine as chairman pro tempore by vote of the majority of shares present or represented at any such
meeting.

The board of directors from time to time may appoint the officers of the Corporation, general managers and any

assistant general managers, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation
and management of the Corporation, who need not be Directors or shareholders of the Corporation. Any such ap-

48370

pointment may be revoked at any time by the board of directors. The officers appointed, unless otherwise stipulated in
these Articles, shall have the powers and duties given to them by the board of directors.

Notice of any meeting of the Board of Directors shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by

other electronic means of transmission to all Directors at least twenty four hours in advance of the day set for the meet-
ing. The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business
other than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board
not referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or
telex or telefax or by other electronic means of transmission of each director and shall be deemed to be waived by any
director who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for
individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable or telegram, telex

or telefax another director as his proxy. Any director may attend a meeting of the board of directors using teleconfer-
ence, video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of
board of directors by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.

A meeting of board of directors held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means of

communication, in which a quorum of directors participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Directors who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.

In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall

have a casting vote.

Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and

held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evi-
denced by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as men-
tioned therein. In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which
the last signature of a board member is affixed.

Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be

formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Corporation via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the
decisions formerly approved by electronic means of communication.

Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of Directors.

Art. 13. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

the chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.

Art. 14. The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. The board of directors

shall have power to determine corporate policy and the course and conduct of the management and business affairs of
the Corporation. Directors may not, however, bind the Corporation by their individual acts, except as specifically per-
mitted by resolution of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Corporation and

its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to one or more directors of the Cor-
poration ('managing directors' - 'administrateurs-délégués'), if authorized by the general meeting of shareholders.

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be af-

fected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in,
or is a director, associate, officer or employee of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, officer or employee of any corporation or firm

with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to
such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction and such director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders. The term 'personal interest', as used in the preceding sentence, shall not in-
clude any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving the Corporation any subsidiary
or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the board of direc-
tors in its discretion.

The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses

reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or
misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered

48371

by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit
such a breach of duty. The foregoing privilege of indemnification shall not exclude other rights to which he may be en-
titled.

Expenses in connection with the preparation and presentation of a defense to any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this article 15 may be advanced by the Corporation prior to final disposition thereof upon
receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director to repay such amount if it is ultimately determined
that he is not entitled to indemnification under this article 15.

Art. 16. The Corporation will be bound by the joint signature of any two directors, officers or of any other persons

to whom authority has been delegated by the board of directors.

Art. 17. The operations of the Corporation, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor ('réviseur
d’entreprises'). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period
ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and until his successor is elected.

The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin on the first of January of each year and shall terminate

on the thirty-first of December of each year.

Art. 19. From the annual net profit of the Corporation, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required

by Luxembourg law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to
ten percent (10%) of the capital of the Corporation as stated in Article five hereof or as increased or reduced from time
to time as provided in Article six hereof.

The annual general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be dis-

posed of and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate pur-
pose and policy.

Interim dividends may be paid out in accordance with the provisions of Luxembourg law.

Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.

Art. 21. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject to the quorum and

voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 22. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto and the relevant law
on undertakings for collective investment.

Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at twelve.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the German texts, the English version will be prevailing.

The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing

signed with Us, the notary, the present original deed.

Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendunddrei, den sechsundzwanzigsten August.
Vor Uns Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, Notar mit dem Amtsitz in Luxemburg.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY, mit

Sitz in Luxemburg, H. R. Nummer B 49.227, gegründet unter der Bezeichnung DYNAMIC ENHANCED FUND MANA-
GEMENT COMPANY durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Maître Reginald Neuman, damals mit dem Amts-
sitz in Luxemburg, am 15. November 1994, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 542
vom 23. Dezember 1994, veröffentlicht wurde, zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.

Die Satzung der Gesellschaft wurde abgeändert durch eine Urkunde aufgenommen durch Notar Jacques Delvaux, mit

dem Amtssitz in Luxemburg, in Vertretung von Maître Reginald Neuman, am 8. April 1998, welche im Mémorial C, Re-
cueil des Sociétés et Associations, Nummer 294 vom 29. April 1998, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung beginnt um elf Uhr fünfundvierzig unter dem Vorsitz von Herrn Germain Trichies, 'Director',

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxem-
burg, 5, rue Jean Monnet.

Derselbe ernennt zur Schriftführerin Frau Jacqueline Siebenaller, 'Vice-President', CREDIT SUISSE ASSET MANAGE-

MENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Zum Stimmzähler wird ernannt Herr Daniel Breger, 'mandatory', CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND

SERVICE (LUXEMBOURG) S.A., mit Berufsanschrift in L-2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet.

Sodann stellt der Vorsitzende fest:

I.- Dass aus einer Anwesenheitsliste, welche durch das Bureau der Versammlung aufgesetzt und für richtig befunden

wurde, hervorgeht dass die fünfhundert (500) Aktien mit einem Nennwert von fünfhundert (500.-) Schweizer Franken,
welche das gesamte Kapital von zweihundertfünfzigtausend (250.000,-) Schweizer Franken darstellen hier in dieser Ver-

48372

sammlung gültig vertreten sind, welche somit ordnungsgemäss zusammengestellt ist und gültig über alle Punkte der Ta-
gesordnung abstimmen kann, da alle vertretenen Aktionäre, nach Kenntnisnahme der Tagesordnung, bereit waren, ohne
Einberufung hierüber abzustimmen.

Diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem instrumentierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt zu-

sammen mit den Vollmachten gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage beigefügt.

 II.- Dass die Tagesordnung dieser Generalversammlung folgende Punkte umfasst:
Neufassung der Satzung der Gesellschaft (wie in der Anlage zu der Vollmacht beschrieben).
Die Ausführungen des Vorsitzenden wurden einstimmig durch die Versammlung für richtig befunden und, nach Über-

prüfung der Richtigkeit der Versammlungsordnung, fasste die Versammlung nach vorheriger Beratung, einstimmig fol-
gende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Nennwert der Aktien wird aufgehoben.

<i>Zweiter Beschluss

Es wird beschlossen eine massgebende englische Fassung der Satzung einzuführen.
Infolgedessen wird die Satzung der Gesellschaft in Zukunft folgenden Wortlaut haben:

Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND MANAGE-

MENT COMPANY.

Art. 2. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet. Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktio-

näre, welcher unter den Bedingungen der Satzungsänderungen, so wie in Artikel einundzwanzig dieser Satzung festge-
setzt, gefasst wurde aufgelöst werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Gründung und Verwaltung eines Investmentfonds mit dem Namen CREDIT

SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX) (der 'Fonds') und die Ausgabe von Zertifikaten und Bestätigungserklärungen welche
das ungeteilte Eigentum daran nachweisen.

Die Gesellschaft wird alle Aktivitäten, in Luxemburg und im Ausland ausüben, welche die Verwaltung und die Förde-

rung dieses Fonds betreffen und diesbezüglich eine oder mehrere Zweigstellen errichten. Für den Fonds kann sie Kon-
trakte abschliessen, Wertpapiere verkaufen, kaufen, tauschen und ausgeben, im Namen des Fonds oder im Namen von
Drittpersonen, jedwede Eintragungen und Übertragungen tätigen im Aktien- oder Obligationsregister von luxemburgi-
schen oder ausländischen Gesellschaften, sowie im Namen des Fonds und der Anteilsinhaber des Fonds alle Rechte und
Privilegien, insbesondere das Stimmrecht ausüben bezüglich der Wertpapiere aus welchen die Aktiva der Gesellschaft
bestehen. Die vorgenannten Befugnisse sind nicht als erschöpfend, sondern lediglich als erklärend zu betrachten.

Die Gesellschaft kann alle Massnahmen treffen und alle Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt ihrem Ge-

sellschaftszweck dienlich sind im Rahmen der Bestimmungen des Kapitels 14 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über
die Investmentfonds.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz jederzeit an einen anderen Ort in derselben Gemeinde

verlegt werden. Zweigniederlassungen oder andere Büros können in Luxemburg oder im Ausland durch Beschluss des
Verwaltungsrates errichtet werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche politische Umstände eingetreten sind oder bevorstehen

welche die Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz behindern, oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz, vorübergehend, bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse, ins Ausland verlegt werden, und zwar unter Beibehaltung der luxemburgischen Staatszugehörig-
keit. 

Art. 5. Das Aktienkapital beträgt zweihundertundfünfzigtausend (250.000,-) Schweizer Franken, eingeteilt in fünfhun-

dert (500) Aktien ohne Nennwert, alle voll eingezahlt.

Die Aktien der Gesellschaft werden in Form von Namensaktien herausgegeben.
Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt. Dieses Register beinhaltet für jeden Aktionär seinen Namen,

seinen Wohnsitz oder Aufenthaltsort, die Zahl der Aktien, den eingezahlten Betrag für jede Aktie und die Aktienüber-
tragungen und das Datum solcher Übertragungen.

Die Übertragung einer Aktie wird getätigt durch eine schriftliche Übertragungserklärung welche ins Aktienregister

eingetragen wird; diese Übertragung wird durch den Abtreter und den Übernehmer oder durch diejenigen Personen,
welche diesbezüglich Vollmachten haben, datiert und unterzeichnet. Die Gesellschaft kann auch als Übertragungsbeweis
andere Dokumente annehmen welche ihr ausreichend erscheinen.

Art. 6. Das Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Generalver-

sammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist gemäss Artikel einundzwanzig der Satzung.

Art. 7. Jede ordentlich einberufene Generalversammlung vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die weitest-

gehenden Befugnisse, um über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg, oder an einem anderen,

in der Einberufung bestimmten Ort in der Gemeinde Luxemburg jeweils um 11.00 Uhr am zweiten Montag des Monats
Mai eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am darauffolgenden Tag statt. Die ordentliche Ge-
neralversammlung kann jederzeit, nach definitivem und schlussendlichem Beschluss des Verwaltungsrats, falls besondere
Umstände es erfordern, an einem beliebigen Ort einberufen werden.

48373

Andere Generalversammlungen können an dem in den betreffenden Einberufungen angegebenen Ort und Zeitpunkt

stattfinden.

Die Generalversammlung kann, Zuschüsse, Reise- und Tagesspesen für alle Mitglieder des Verwaltungsrates festset-

zen.

Art. 9. Das Quorum und die Fristen welche vom Gesetz vorgeschrieben sind regeln die Einberufung und den Ablauf

der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft, unter Vorbehalt dieser Bestimmungen.

Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen. Ein Aktionär kann

an jeder Versammlung teilnehmen indem er einen Dritten als seinen Bevollmächtigten bezeichnet schriftlich, per Kabel,
Telegramm, Telex oder Fax.

Falls nicht anders vom Gesetz verordnet, werden Beschlüsse auf einer ordnungsgemäss einberufenen Versammlung

durch einfache Mehrheit aller ausgegebenen und stimmberechtigten Aktien gefasst.

Der Verwaltungsrat kann alle anderen Bedingungen festsetzen welche durch die Aktionäre erfüllt sein müssen um an

einer Versammlung teilzunehmen.

Art. 10. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen durch Einschreibebrief mit der Tages-

ordnung welcher mindestens acht Tage vor der Versammlung an die Aktionäre gesandt wird an ihre im Aktienregister
vermerkte Adresse.

Wenn jedoch alle Aktionäre präsent oder vertreten sind auf der Versammlung und wenn sie feststellen dass über die

Tagesordnung informiert sind, kann die Versammlung ohne Einberufung abgehalten werden.

Art. 11. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen.

Die Verwaltungsratmitglieder werden ernannt durch die jährliche Versammlung der Aktionäre für einen Zeitraum bis

zur nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger; ein Verwaltungsratmitglied kann jederzeit mit
oder ohne Grund ersetzt werden durch einen Beschluss der Aktionäre.

Im Falle einer unbesetzten Stelle eines Postens als Verwaltungsratmitglied durch Tod, Rücktritt oder sonstwie können

die verbliebenen Mitglieder zusammenkommen und durch Mehrheitsbeschluss einen Nachfolger bestellen bis zur näch-
sten Versammlung.

Art. 12. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere

stellvertretende Vize-Vorsitzenden. Er kann ebenfalls einen Sekretär ernennen, welcher nicht Verwaltungsratmitglied
sein muss, und der die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen aufsetzt. Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Ein-
berufen des Präsidenten, oder zweier Verwaltungsratmitglieder, an dem in der Einberufung angegebenen Ort.

Der Präsident steht allen Versammlungen vor, oder im Fall von Abwesenheit oder Unfähigkeit, der Vizepräsident

oder ein anderes Verwaltungsratmitglied, welches pro tempore vorstehen wird. Die Aktionäre können, durch Mehr-
heitsbeschluss einen anderen Angestellten oder eine andere Person bestimmen, welche pro tempore der Sitzung vor-
stehen wird.

Der Verwaltungsrat kann von Zeit zu Zeit Beamte der Gesellschaft, Generalverwalter und assistierende Generalver-

walter, Sekretäre und Hilfssekretäre bestimmen welche für die Operationen und die Verwaltung der Gesellschaft zu-
ständig sind welche nicht Verwaltungsratmitglieder oder Aktionäre zu sein brauchen. Eine solche Bestimmung kann
jederzeit vom Verwaltungsrat zurückgerufen werden. Die ernannten Beamten, falls nicht anders in der Satzung vorge-
sehen werden die Befugnisse und Aufgaben haben welche ihnen durch den Verwaltungsrat zuerteilt werden.

Eine Versammlung des Verwaltungsrates wird schriftlich einberufen oder per Kabel, Telegramm, Telex, Fax oder auf

elektronischem Wege an alle Verwaltungsratmitglieder wenigstens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung. Die
Bekanntmachung enthält die Tagesordnung der Versammlung und kein anderer Punkt kann gültig auf der Versammlung
beraten werden. Auf die Einberufung kann verzichtet werden durch schriftliche Einwilligung oder durch Kabel, Tele-
gramm, Telex, Fax oder elektronischem Wege und jedes anwesende Verwaltungsratmitglied ist erachtet darauf verzich-
tet zu haben. Eine separate Einberufung ist nicht notwendig für individuelle Sitzungen welche abgehalten werden nach
einem Schema des Verwaltungsrates.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an jeder Sitzung des Verwaltungsrates teilnehmen, in dem es schriftlich, per

Kabel, Telefax oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates als seinen Bevoll-
mächtigten ernennt. Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann an einer Sitzung des Verwaltungsrates per Telefon oder
Video-Konferenzschaltung oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen er-
laubt, die an der Sitzung teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als
persönliche Teilnahme an der Sitzung. 

Eine Versammlung des Verwaltungsrates per Telefon oder Video-Konferenzschaltung an welcher ein Quorum des

Verwaltungsrates teilnimmt ist bindend wie wenn alle persönlich anwesend gewesen wären, unter der Voraussetzung
dass ein Protokoll unterzeichnet wird durch den Präsidenten der Versammlung.

Der Verwaltungsrat kann gültig beschliessen wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Die Beschlüsse werden durch eine Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst. Die Mitglieder
welche nicht persönlich anwesend sind oder vertreten sind können schriftlich abstimmen oder durch Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder elektronischem Wege.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
Rundbeschlüsse, die von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterzeichnet sind, sind genauso gültig und genauso

bindend, wie wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des Rundbeschlusses. Im Falle wo kein
spezielles Datum vermerkt ist wird der Rundbeschluss gültig am Tag wo die letzte Unterschrift getätigt wird.

48374

Beschlüsse welche durch andere elektronische Mittel gefasst werden wie e-mail, Telegramm oder Telex werden for-

malisiert durch den nachfolgenden Beschluss. Das Inkrafttreten des Beschlusses ist dann diejenige der letzten Genehmi-
gung welche die Gesellschaft erhielt durch elektronische Mittel. Die Genehmigungen von allen Mitgliedern des
Verwaltungsrates werden dem Rundbeschluss beigefügt bleiben und einen integralen Bestandteil bilden welche die vor-
her gefassten Beschlüsse billigen.

Rundbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Verwaltungsratmitglieder gefasst werden.

Art. 13. Die Protokolle des Verwaltungsratssitzungen werden durch den Präsidenten unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge dieser Urkunden welche zu gerichtlichen Zwecken gebraucht werden oder sonstwie werden

durch den Präsidenten unterzeichnet oder den pro tempore Präsidenten oder durch zwei Verwaltungsratmitglieder.

Art. 14. Die Verwaltungsratmitglieder können nur an ordnungsgemäss einberufenen Sitzungen des Rates teilnehmen.

Der Verwaltungsrat hat die Befugnis die Gesellschaftspolitik festzulegen und die Führung der Geschäfte der Gesellschaft.
Die Verwaltungsratmitgllieder können die Gesellschaft jedoch nicht durch ihre persönlichen Handlungen binden, ausser
spezieller Erlaubnis des Rates.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft und die einem

oder mehreren Verwaltern der Gesellschaft übertragen (delegiertes Verwaltungsratmitglied) wenn die Generalver-
sammlung es erlaubt hat.

Art. 15. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wer-

den nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, dass ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates oder
leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein persönliches
Interesse haben oder dort Mitglied des Verwaltungsrates, Aktionär, leitender oder sonstiger Angestellter sind.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, der als Mitglied des Verwaltungs-

rates, leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit
der die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung mit
der anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag oder
einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Im Falle wo ein Verwalter oder Beamter der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesell-

schaft hat muss dieser Verwalter dem Verwaltungsrat sein persönliches Interesse kundtun und nicht über diese Ange-
legenheit abstimmen und von diesem persönlichen Interesse wird der nächsten Generalversammlung berichtet. Der
Ausdruck 'persönliches Interesse' wie vorher benutzt begreift nicht eine Beziehung oder ein Interesse eine Position oder
ein Geschäft welches die Gesellschaft oder eine Filiale betrifft oder jede andere Gesellschaft welche der Verwaltungsrat
zu jeder Zeit nach seinem Ermessen festsetzen kann.

Die Gesellschaft wird jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Er-

ben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen Auslagen freihalten, die von ihm im Zusammen-
hang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund
seiner Stellung als Mitglied des Verwaltungsrates oder leitender Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag
hin, auch einer anderen Gesellschaft, an der die Gesellschaft als Aktionär beteiligt ist, oder bei der die Gesellschaft Gläu-
biger ist und von der er keine Entschädigung erhält, beteiligt ist, außer in Fällen, in denen er auf Grund dieser Klagen,
Rechtsverfolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig verur-
teilt wird. Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachen, die von dem
Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, dass die zu entschä-
digende Person keine Pflicht verletzt hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere Ansprüche nicht aus. 

Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und der Verteidigung bei einer Klage oder Prozess wie in diesem Ar-

tikel beschrieben können durch die Gesellschaft vorgeschoben werden vor einem endgültigen Urteil unter der Bedin-
gung dass dieser Betrag zurückgezahlt werden muss wenn das Verwaltungsratmitglied nicht berechtigt ist zu einer
Entschädigung gemäss diesem Artikel.

Art. 16. Die Gesellschaft ist rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrat-

mitgliedern, Beamten oder anderer Personen, welche vom Verwaltungsrat hierzu delegiert wurden.

Art. 17. Die Geschäfte der Gesellschaft, begreifend insbesondere ihre Bücher und Steuerangelegenheiten oder an-

dere Berichte welche das Luxemburger Gesetz verlangt, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschaftsprüfer
('réviseur d’entreprises'). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis zur
nächsten Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.

Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit durch die Aktionäre abberufen werden mit oder ohne Grund.

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreissigsten Dezember

desselben Jahres.

Art. 19. Vom dem jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf (5%) Prozent dem gesetzlichen Reserve-

fonds zugeführt. Diese Speisung ist nicht mehr erforderlich sobald und solange die Reserve zehn (10%) Prozent des Ge-
sellschaftskapitals ausmacht.

Die jährliche Versammlung bestimmt wie der Restbetrag des Gewinns verteilt wird und kann alleine Dividenden fest-

legen wie sie es in ihrem Ermessen für gut befindet für die Gesellschaftspolitik.

Interimdividende kann gemäss dem Luxemburger Gesetz ausgezahlt werden.

Art. 20. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche

physische Personen oder Körperschaften sein können) durchgeführt. Die Generalversammlung bestimmt die Liquidato-
ren und setzt deren Vergütung fest.

48375

Art. 21. Die Satzung kann jederzeit durch eine Generalversammlung abgeändert werden unter den luxemburgischen

gesetzlichen Bestimmungen betreffend das Quorum und das Stimmrecht.

Art. 22. Für sämtliche Punkte, welche in dieser Satzung nicht geregelt sind, wird auf das Gesetz vom zehnten August

neunzehnhudertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und das Gesetz über Investmentfonds verwiesen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärte der Vorsitzende die Versammlung um zwölf Uhr für geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, dass der Text der vorlie-

genden Satzung auf Wunsch der Parteien in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; er bestätigt
weiterhin, dass es der Wunsch der Parteien ist, dass im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text der englische Text Vorrang hat.

Und nach Vorlesung alles Vorhergehenden an die Komparenten, haben dieselben mit Uns Notar gegenwärtige Ur-

kunde unterschrieben.

Gezeichnet: G. Trichies, J. Siebenaller, D. Breger, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, vol. 140S, fol. 36, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054568.3/230/460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 41.753. 

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 avril 2003

- la cooptation de la société LOUV, S.à r.l., S.à r.l. de droit luxembourgeois, avec siège social au 23, avenue Monterey,

L-2086 Luxembourg en tant qu’Administrateur en remplacement de la société FINIM LIMITED, démissionnaire, est ra-
tifiée. Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2004.

Fait à Luxembourg, le 4 avril 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00362. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054440.3/795/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

JOHN DEERE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1016 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 88.466. 

<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société le 27 août 2003 au siège social

L’assemblée a décidé de nommer Monsieur Jon Douglas Volkert, demeurant au 601 41

st

 Street, Des Moines, Iowa

50312, Etats-Unis d’Amérique, en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 11 septembre 2003 pour remplacer
Monsieur Paul Enz, démissionnaire avec effet au 10 septembre 2003.

Au terme de cette résolution, le conseil d’administration de la Société se compose de:
Patrick E. Mack, administrateur et administrateur-délégué,
James Alan Israel, administrateur,
James Roger Jabanoski, administrateur,
David Charles Everitt, administrateur,
Stephen Pullin, administrateur, et
Jon Douglas Volkert, administrateur.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01220. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054715.3/253/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

Certifié sincère et conforme
INVESTISSEMENTS MULTISECTORIELS EUROPEENS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

Pour extrait et publication
JOHN DEERE FINANCE S.A.
Signature
<i>Un mandataire

48376

EDVIMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 85.378. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05552. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054400.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

A.S.M. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 34.024. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2003.

Elle appelle aux fonctions de commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18a, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Bernard Ewen, démissionnaire, pour une même période.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05556. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054403.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

WAM S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 24.259. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 avril 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05559. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054404.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

EREMIS HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 4.664. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00383, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2003.

(054437.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

EREMIS HOLDING S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

48377

FLURWALD FINANZ S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 25.003. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, Monsieur Bernard Ewen, pour une période venant à échéance à
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05562. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054407.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

INTERGARDEN S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 78.031. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05565. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054408.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

I.P.P. LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 77.310. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05540. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054411.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

GDL FI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 88.030. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05572. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054414.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

48378

CAMECO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.009. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 29 juillet 2003 que:
- Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, les actionnaires décident de réélire les personnes suivantes

comme administrateurs:

1. Monsieur Kim Goheen, employé privé, né le 13 janvier 1954, à Clovis, USA, demeurant professionnellement à

2121, 11th Street West, SK S7M 1J3, Saskatoon, Canada.

2. Monsieur Gary M.S. Chad, employé privé, né le 18 novembre 1951, à Prince Albert, Canada, demeurant à 414,

Charlebois Court, S7K, 5J9, Saskatoon, Canada.

3. Monsieur Teunis Akkerman, employé privé, né le 30 décembre 1948, à Dirksland, Pays-Bas, demeurant profession-

nellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

4. Madame Maggy Kohl, directeur de sociétés, née le 18 mai 1941, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

5. Monsieur Rui Fernandes Da Costa, employé privé, né le 2 mai 1974, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-1724, 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg.

- Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité d’élire KPMG

AUDIT, société civile, ayant son siège social à L-2520, 31, allée Scheffer, Luxembourg, en tant que commissaire aux
comptes.

- Leurs mandats expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera

les comptes au 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01096. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054529.3/805/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

SAGICAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 62.789. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement le 23 novembre 2001 que:
Monsieur Michel Mengal, conseil privé, demeurant à L-2510 Luxembourg a été nommé administrateur de la société

en remplacement de Monsieur Henri Bernet, démissionnaire. Monsieur Mengal reprendra le mandat de son prédéces-
seur.

Luxembourg, le 4 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01084. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054538.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

SAGICAP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1469 Luxembourg, 74, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 62.789. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 octobre 2001 que:
FIDEI REVISION, Société à Responsabilité Limitée, ayant son siège au 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, a été nom-

mé Commissaire en remplacement de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, Société à responsabilité limitée, démissionnaire.
FIDEI REVISION reprendra le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 4 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01082. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054536.3/727/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour avis conforme
M. Kohl
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
Signature

48379

MITTE HOLDINGS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 78.611. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 26 août 2003 que:
- Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, l’assemblée décide d’augmenter le nombre d’administra-

teurs de trois (3) à quatre (4) et de nommer les personnes suivantes comme administrateurs de la société:

1. Monsieur Charles Pardoe, employé privé, né le 26 juillet 1960, à Washington DC, Etats-Unis, demeurant profes-

sionnellement à 8, Campus Drive, Parsippany, NJ 070054, Etats-Unis;

2. Monsieur Jonathan Short, employé privé, né le 19 juillet 1961, à Bromley, United Kingdom, demeurant profession-

nellement à 166, Sloane Street, Londres, SW1X9QF, Royaume-Uni;

3. Monsieur Bodo Demisch, administrateur de sociétés, né le 2 octobre 1944 à Hahnenklee/Harz, Allemagne, demeu-

rant à L-1641 Luxembourg, 16, rue Nicolas Gredt;

4. TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard

du Prince Henri, enregistrée à la Chambre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous n

°

 B 84.993.

- Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, l’assemblée décide de nommer ERNST AND

YOUNG, société anonyme, ayant son siège social à L-5365 Luxembourg, 7, Parc d’Activité, Syrdall en tant que commis-
saire aux comptes.

- Les mandats des administrateurs ainsi que du commissaire aux comptes expireront immédiatement à l’issue de l’as-

semblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003.

- L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri

à L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume avec effet au 1

er

 août 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00818. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054539.3/805/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

BÄTE, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2763 Luxemburg, 12, rue Sainte Zithe.

H. R. Luxemburg B 60.692. 

AUFLÖSUNG

Im Jahre zweitausenddrei, den siebenundzwanzigsten August.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître André Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

UP TO DATE Inc., eine Gesellschaft mit Sitz in Alofi Suites 21, Maluaga, Niue,
hier vertreten durch Herrn Jean-Paul Kill, Rechtsanwalt, mit Berufsanschrift in 22, boulevard de la Foire, L-1528 Lu-

xemburg,

aufgrund einer Vollmacht gegeben am 11. Juni 2003.
Welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterfertigten Notar ge-

genwärtiger Urkunde beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparentin, vertreten wie vorgenannt, den instrumentierenden Notar ersucht hat folgendes zu beurkun-

den:

- Die Komparentin ist alleinige Besitzerin aller Anteile der Gesellschaft mit beschränkter Haftung BÄTE, S.à r.l., R. C.

Luxemburg B 60.692, mit Sitz in Luxemburg, gegründet durch Urkunde aufgenommen durch Notar Christine Doerner,
mit dem Amtssitz in Bettemburg, am 14. August 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associati-
ons, Nummer 680 vom 4. Dezember 1997.

Die Satzung der Gesellschaft wurde mehrmals abgeändert und zuletzt durch eine Urkunde aufgenommen durch den

unterzeichneten Notar, vom 9. April 2003, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
478 vom 3. Mai 2003.

- Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausenddreihundertvierundneunzig Euro achtundsechzig Cent

(12.394,68) aufgeteilt in einhundert (100) Anteile mit einem Nennwert von einhundertdreiundzwanzig Euro vierund-
neunzig Cent (123,94) pro Anteil.

- Durch Anteilsübertragung unter Privatschrift vom 19. August 2003, welche der gegenwärtigen Urkunde beigebogen

bleiben wird um mit ihr einregistriert zu werden, hat GIA GLOBAL INVESTMENT ACTIVITY S.A., mit Sitz in L-2763
Luxemburg, 12, rue Ste Zithe, ihre 100 Anteile an der Gesellschaft zum Preis von EUR 1,- an die Komparentin abgetre-
ten, worüber Quittung.

Diese Anteilsübertragung wurde getätigt mit dem Einverständnis der Gesellschaft und soweit wie nötig durch den

Geschäftsführer der Gesellschaft angenommen.

Pour avis conforme
TMF CORPORATE SERVICES S.A.
<i>Un administrateur
Signatures

48380

- Die Komparentin welche somit alleinige Besitzerin aller Anteile der Gesellschaft geworden ist erklärt andurch die

Auflösung der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

- Die Komparentin erklärt dass sie genaue Kenntnis der Satzung sowie der Finanzlage der Gesellschaft besitzt.
- Die einzige Gesellschafterin erklärt, in ihrer Eigenschaft als Liquidator der Gesellschaft, dass die Aktivität der Ge-

sellschaft aufgehört hat, dass die bekannten Passiva der Gesellschaft bezahlt oder gedeckt wurden und dass sie sich aus-
drücklich dazu verpflichtet alle Passiva welche eventuell noch zu Lasten der Gesellschaft bestehen und noch unbezahlt
oder unbekannt sind zu übernehmen, bevor irgendwelche Zuteilung der Aktiva an ihre Person als einzige Gesellschaf-
terin getätigt wird.

- Die einzige Gesellschafterin erteilt dem Geschäftsführer Entlastung für die Ausübung seines Mandats bis zum heu-

tigen Tag.

- Die betreffenden Dokumente der Gesellschaft werden während einer Dauer von fünf Jahren in 22, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxemburg aufbewahrt.

Somit hat der instrumentierende Notar die Auflösung der Gesellschaft BÄTE, S.à r.l., festgestellt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorherstehenden an den Bevollmächtigten der Komparentin, hat derselbe mit Uns, Notar,

gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J.-P. Kill, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 1

er

 septembre 2003, vol. 140S, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054530.3/230/55) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

DEXIA WORLD ALTERNATIVE, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 82.737. 

Suite à la démission en date du 21 juillet 2003 de Monsieur Nicolas Gomart de ses fonctions d’administrateur le Con-

seil d’Administration se compose désormais comme suit:

- Monsieur Luc Hernoux, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

- Monsieur Daniel Kuffer, Senior Vice-President, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69,

route d’Esch, L-2953 Luxembourg.

- Monsieur Hugo Lasat, Conseiller du Comité de Direction, DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.,

283, route d’Arlon, L-1150 Luxembourg.

- Monsieur François Pauly, Directeur, DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route

d’Esch, L-2953 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00440. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054546.3/1126/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

TRADENET EUROPE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 79.814. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Monsieur Alfred Degen et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05499. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054415.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Luxembourg, le 3 septembre 2003.

A. Schwachtgen.

<i>Pour DEXIA WORLD ALTERNATIVE, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

<i>Pour la société
Signature

48381

CAMECO LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 62.009. 

Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 29 juillet 2003 que:
- L’assemblée prend acte de la démission avec effet au 31 juillet 2003 de Monsieur Rui Fernandes Da Costa, employé

privé, en tant qu’administrateur de la société;

- Les mandats des administrateurs étant venus à échéance, les actionnaires décident d’élire les personnes suivantes

comme administrateurs:

1. Monsieur Kim Goheen, employé privé, né le 13 janvier 1954, à Clovis, USA, demeurant professionnellement à

2121, 11th Street West, SK S7M 1J3, Saskatoon, Canada;

2. Monsieur Gary M.S. Chad, employé privé, né le 18 novembre 1951, à Prince Albert, Canada, demeurant à 414,

Charlebois Court, S7K, 5J9, Saskatoon, Canada;

3. Monsieur Teunis Akkerman, employé privé, né le 30 décembre 1948, à Dirksland, Pays-Bas, demeurant profession-

nellement à L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert;

4. Madame Maggy Kohl, directeur de sociétés, née le 18 mai 1941, à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri;

5. TMF CORPORATE SERVICES S.A., société anonyme, inscrite au registre de commerce et de sociétés de Luxem-

bourg sous n

°

 B 84.993, ayant son siège social à L-1724, 33, boulevard du Prince Henri, Luxembourg;

- Le mandat du commissaire aux comptes étant venu à échéance, les actionnaires décident à l’unanimité d’élire KPMG

AUDIT, société civile, ayant son siège social à L-2520, 31, Allée Scheffer, Luxembourg, en tant que commissaire aux
comptes.

- Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes expireront immédiatement à l’issue de l’assemblée

générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes au 31 décembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 septembre 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI00814. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054541.3/805/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

MAMBA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 43.531. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00459, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(054554.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

MAMBA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines.

R. C. Luxembourg B 43.531. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00460, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 septembre 2003.

(054551.3//15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour avis conforme
M. Kohl
<i>Un administrateur

<i>Pour MAMBA INVESTMENT S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

<i>Pour MAMBA INVESTMENT S.A.
Société Anonyme Holding
EXPERTA LUXEMBOURG
Société Anonyme
A. Garcia Hengel / S. Wallers

48382

MERCHBANC SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 51.646. 

En date du 29 janvier 2003, l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires a décidé de réélire:
- Monsieur Léon Hilger
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A.
69, route d’Esch
L-2953 Luxembourg,
- Monsieur José Isern Rovira
MERCHBANC
Diputacion 279
E-08007 Barcelona,
- Monsieur Joaquin Lopez Veraza
MERCHBANC
Diputacion 279
E-08007 Barcelona,
- Monsieur John Pauly
FIRST EUROPEAN TRANSFERT AGENT S.A.
5, rue Thomas Edison
L-1445 Strassen,
- Monsieur Henry Verrey
SEMELY CONSULT &amp; MANAGEMENT LTD
84, rue du Rhône
CH-1204 Genève,
en qualité d’Administrateurs pour un mandat d’un an prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en

2004. 

Enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00445. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054550.3/1126/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

SYSTEM TRADING S.A., Société Anonyme.

Capital social: 7.972.200,- EUR.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 79.774. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01095, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(054560.3//11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

SILAWI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 21.312. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
2003.

Elle appelle aux fonctions de commissaire aux comptes la FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., 18a, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Bernard Ewen, démissionnaire, pour une même période.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05516. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054420.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

<i>Pour MERCHBANC SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
Signatures

 

B. Zech.

<i>Pour la société
Signature

48383

PIMIENTO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding,

(anc. VIGORIS HOLDING S.A.).

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 84.783. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet, Monsieur Pierre

Schill, Monsieur Yvon Python et Maître Alexandre Davidoff, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE
GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exer-
cice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05534. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054422.3/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

VINKELBERG COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R. C. Luxembourg B 59.939. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue le 12 juin 2003

1. L’Assemblée décide de nommer comme nouvel administrateur en remplacement de Maître Roy Reding, son man-

dat venant à terme, la société CD-GEST, S.à r.l., ayant son siège social au 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-
1331 Luxembourg.

Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.
Le mandat des autres administrateurs et du Commissaire aux Comptes est reconduit jusqu’à l’Assemblée Générale

Annuelle statuant sur les comptes au 31 décembre 2009.

2. L’Assemblée décide de transférer le siège social du 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxem-

bourg, au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 4 septembre 2003, réf. LSO-AI01025. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054423.3/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

ARGYLE LEISURE FUND S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 84.318. 

<i>Extract of the resolution passed on 30 June 2003 by the Board of Directors of the company

It was resolved to transfer the registered office of the company from its present address to 52-54, avenue du X Sep-

tembre, L-2550 Luxembourg with effect from 1 January 2003.

Translation into French - Traduction en français:

<i>Extrait des décisions prises en date du 30 juin 2003 par les gérants de la société

Il est décidé de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle au 52-54, avenue du X Septembre,

L-2550 Luxembourg avec effet au 1

er

 janvier 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2003, réf. LSO-AI01079. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054502.3/806/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 septembre 2003.

<i>Pour la société
Signature

Signature
<i>Un mandataire

Certified true extract - Extrait certifié conforme
M. Kremenliev / Q. Marshall
<i>Director / <i>Director
Administrateur / <i>Administrateur

AMACO (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Director
Signatures

48384

ACTIV’INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 66.828. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00386, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2003.

(054436.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

SOCALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 39.683. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00381, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2003.

(054446.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

CATER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 89.853. 

Le bilan au 31 décembre 2002, enregistré à Luxembourg, le 3 septembre 2003, réf. LSO-AI00378, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 septembre 2003.

(054447.3//13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

MERES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 83.265. 

<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 juin 2003

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs, Madame Joëlle Lietz, Madame Denise Vervaet et Monsieur Pier-

re Schill, ainsi que celui du commissaire aux comptes, FIDUCIAIRE GLACIS, S.à r.l., pour une période venant à échéance
à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2003.

Luxembourg, le 28 août 2003. 

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2003, réf. LSO-AH05512. – Reçu 14 euros.

<i>Le Receveur (signé): D. Hartmann.

(054417.3/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2003.

ACTIV’INVEST
F. Uhl
<i>Administrateur-Délégué

<i>Pour SOCALUX S.A.
SERVICES GENERAUX DE GESTION S.A.
Signatures

CATER INVESTMENTS S.A.
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateur

<i>Pour la société
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Altona Gestion S.A.

Confidea, S.à r.l.

Société Européenne de Boissons

CIPE Luxembourg S.A.

JCBO S.A.

Multinational Investment Corporation

Tyco International Group S.A.

Finpelts S.A.

Saint Eugène S.A.

NHS Investments S.A.

Tyco Group, S.à r.l.

Amadeus Beteiligung A.G.

Fareale S.A.

Fontralux, S.à r.l.

Credit Suisse Bond Fund Management Company

Immobilière Grand-Ducale S.A.

Globe Star Incorporation S.A.

O.C.A. Beteiligung A.G.

L.H.I., Luso Hispanic Investment S.A.

Sonoco Luxembourg, S.à r.l.

EL 2 S.A.

Alsgard

Eastern Investments S.A.

S.C.I. Plek

S.C.I. Plek

S.C.I. Plek

Altona Gestion S.A.

European Marketing Group (Luxembourg) S.A.

Industrial Performance Holding S.A.

Vinkelberg Company S.A.

GIA Global Investment Activity S.A.

CS Private Universe Management Company

Activ’Invest

Citar-Invest S.A.

A.O.S. S.A.

Credit Suisse Money Plus Fund Management Company

Investissements Multisectoriels Européens S.A.

John Deere Finance S.A.

Edvima S.A.

A.S.M. Investments S.A.

Wam S.A.

Eremis Holding S.A.

Flurwald Finanz S.A.

Intergarden S.A.

I.P.P. Luxembourg S.A.

GDL FI S.A.

Cameco Luxembourg S.A.

Sagicap S.A.

Sagicap S.A.

Mitte Holdings Management S.A.

Bäte, S.à r.l.

Dexia World Alternative

Tradenet Europe S.A.

Cameco Luxembourg S.A.

Mamba Investment S.A.

Mamba Investment S.A.

Merchbanc Sicav

System Trading S.A.

Silawi S.A.

Pimiento Holding S.A.

Vinkelberg Company S.A.

Argyle Leisure Fund S.A.

Activ’Invest S.A.

Socalux S.A.

Cater Investments S.A.

Meres S.A.