logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

3985

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 84

28 janvier 2003

S O M M A I R E

DEXIA PROTECTED, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 84.728. 

Le bilan au 30 juin 2002, enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 12, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

(95038/006/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ABM Merchant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4007

Happy Greens S.A., Bourglinster  . . . . . . . . . . . . . . 

4006

ABM Merchant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

4007

Jabe S.A., Olm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4018

Amara, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3986

Leopold Holding, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . 

3999

Amara, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3987

Luxembourg Online S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

3986

AOL Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .

3997

Norfin II S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4008

Arctotis S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3988

Opson Holdings S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

3999

Aristée S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3997

Pradera Holdco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

4018

Avail  Medical  Products  Europe, S.à r.l., Luxem- 

Pradera Holdco, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

4030

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3988

Promotra S.A., Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4013

Comitalu S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4005

Prophète S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3999

Dasolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3987

Ratanja S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3992

Dasolux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3987

Rodolphe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3997

Dexia Protected, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . .

3985

Sigma  Capital  Hospitality, Leisure and Tourism 

Frides, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . . . . . .

4031

Holding Company S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . 

4000

Gemex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4008

Sigma Capital Investments S.A., Luxembourg  . . . 

4013

Gemex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4008

Viender Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4032

Gemex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4008

Viender Finance S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

4032

Gemex S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4008

Villeroy & Boch, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

4031

Happy Greens S.A., Bourglinster . . . . . . . . . . . . . . .

4005

<i>Pour DEXIA PATRIMONIAL, Société d’Investissement à Capital Variable
DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signatures

3986

LUXEMBOURG ONLINE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, rue du X Septembre.

R. C. Luxembourg B 52.947. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case

6, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2002.

(94878/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AMARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 53.619. 

L’an deux mille deux, le onze décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

 1) R.A.L. HOLDING S.A., une société avec siège social à L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden,
ici représentée par son administrateur-délégué Monsieur Gaguik Adibekian, économiste, demeurant à L-1515 Luxem-

bourg, 28, Boulevard Dr. Ernest Feltgen.

 2) Monsieur Dominique Fontaine, employé privé, demeurant à B-6747 Saint-Léger, 17, rue du Château.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
- Les comparants sont les seuls associés de la Société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de AMA-

RA, S.à r.l., R.C. B numéro 53.619, ayant son siège social à Luxembourg, constituée par acte reçu par Maître Paul Frie-
ders, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 janvier 1996, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C Numéro 166 du 3 avril 1996.

 - Le capital social de cette société était fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs, représenté par cinq cents (500) parts

sociales antérieurement d’une valeur nominale de mille (1.000,-) francs chacune, toutes intégralement souscrites et en-
tièrement libérées.

- L’ordre du jour est conçu comme suit:
1.- Fixation du capital social à EUR 12.394,68.
2.- Augmentation du capital social à concurrence de EUR 105,32 pour le porter de son montant actuel converti de

EUR 12.394,68 à EUR 12.500,- sans émission de parts sociales nouvelles.

- Libération en espèces.
3.- Fixation de la valeur nominale des parts sociales à 25,- euros.
4.- Modification subséquente de l’article 6 des statuts.
5.- Divers. 
Les associés ont abordé l’ordre du jour et ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le capital social est désormais exprimé en euros, de sorte qu’il est fixé à 12.394,68 euros.

<i>Deuxième résolution

Le capital social de la société est augmenté à concurrence de cent cinq euros trente-deux cents (105,32) pour le por-

ter de son montant actuel de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros soixante-huit cents (12.394,68) à douze
mille cinq cents (12.500,-) euros sans émission de parts sociales nouvelles.

Le montant de cent cinq euros trente-deux cents (105,32) a été entièrement libéré en espèces par les associés, ainsi

qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Troisième résolution

La valeur nominale des parts sociales est fixée à 25,- euros.

<i>Quatrième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l’article 6 des statuts est modifié et aura la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500,-) euros (EUR), représenté par cinq cents (500)

parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq (25,-) euros (EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et intégra-
lement libérées.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ceux-ci ont signé avec

Nous, Notaire, la présente minute.

Signé: G. Adibekian, D. Fontaine, A. Schwachtgen.

<i>Pour la LUXEMBOURG ONLINE S.A.
Signature

3987

Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 49, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94823/230/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AMARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2652 Luxembourg, 142-144, rue Albert Unden.

R. C. Luxembourg B 53.619. 

Statuts coordonnés suivant l’acte n

°

 1561 du 11 décembre 2002 déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94824/230/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DASOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 69.793. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 27 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95043/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

DASOLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 69.793. 

<i>Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire tenue le 24 mai 2002 à 11.00 heures à Luxembourg

<i>Mode de convocation

Toutes les actions étant présentes ou représentées, il a été fait abstraction des convocations d’usage.

<i>Présences

Voir liste en annexe.

<i>Bureau

<i>Ordre du jour:

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport des Commissaires aux Comptes.
- Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2001 et affectation des résultats.
- Quitus à donner aux Administrateurs et Commissaires aux Comptes.

<i>Exposés

- Rapport de gestion du Conseil d’Administration.
- Rapport des Commissaires aux Comptes.

<i>Résolutions

- L’Assemblée, après avoir entendu le rapport de gestion du Conseil d’Administration et le rapport des Commissaires

aux Comptes, approuve à l’unanimité les comptes annuels au 31 décembre 2001 tels qu’ils lui sont présentés par le Con-
seil d’Administration et décide l’affectation des résultats conformément aux propositions de ce dernier.

- L’Assemblée donne à l’unanimité quitus aux Administrateurs et aux Commissaires aux Comptes de leur mandat

pour l’exercice écoulé.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11.30 heures.

Enregistré à Capellen, le 27 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

(95044/000/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Président:

M. Soetens

Scrutateur:

M. Ancion

Secrétaire:

B. Davreux.

Signature / Signature / Signature
<i>Secrétaire / Scrutateur / Président de l’Assemblée

3988

ARCTOTIS S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 61.969. 

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ARCTOTIS S.A. (la «Société») qui s’est tenue le 6 décembre

2002 a décidé de clôturer la liquidation de la Société.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à l’ancien siège social de la société.
Le passif ayant été complètement apuré et le produit de liquidation distribué aux actionnaires de la Société, aucune

somme n’a dû être déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Luxembourg, le 19 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(94936/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AVAIL MEDICAL PRODUCTS EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

STATUTES

 In the year two thousand two, on December sixth.
 Before Us, Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette.

Appeared:

 The company AVAIL MEDICAL PRODUCTS Inc., a company having its registered office in 1660, Chase Texas Tower

- 201, Main Street - Forth Worth, US 76102 Texas, here represented by Mr Tommy Jansson, managing director, residing
in Luxembourg, by virtue of a proxy given to him in Forth Worth on the 8th of November 2002, which proxy, after
having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to this deed to
be filed with it with the registration authorities. 

 This appearing party has incorporated a société à responsabilité limitée, the articles of which it has established as

follows:

Form - Object - Name - Office - Duration

Art. 1. There is hereby formed a société à responsabilité limitée which will be governed by actual laws, especially

the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité
limitée», as amended, especially by the law of December 28th, 1992, and the present articles of incorporation. 

At any moment, the member may join with one or more joint members and, in the same way, the following members

may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.

Art. 2. The company is incorporated under the name of AVAIL MEDICAL PRODUCTS EUROPE. 

Art. 2. The company’s purpose is the sale and marketing of goods for health care and industrial use.
In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-

complishment and development of its purpose. 

Art. 4. The company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-

tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.

Art. 5. The company is established for an unlimited period from the date thereof. 

Capital - Shares

Art. 6. The company’s capital is set at thirteen thousand euros (

€ 13,000.00), represented by five hundred (500)

shares of twenty-six euros (

€ 26.00) each.

Art. 7. The shares are freely transferable among the members.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without

having been first offered to them.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the company, which admit only one owner for each of them.

Art. 8. The life of the company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any partner.

Art. 9. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any partner are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the company, nor to interfere in any manner in the administration
of the company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the meet-
ings.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
J. Seil
<i>Le liquidateur

3989

Management

Art. 10. The company is managed by one or more managers either partners or not, appointed by the partners with

or without limitation or their period of office. 

The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the company; as mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

Decisions of the sole member - Collective decisions of the members

Art. 12. The sole member exercises the powers devolved to the meeting of members by the dispositions of section

XII of the law of August 10th, 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole member.
In case of more members, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the meeting.
Resolutions are validly adopted when by partners representing more than half of the capital. However, decisions con-

cerning a modification of the articles of incorporation must be taken by a majority vote of partners representing the
three quarters of the capital. If this majority is not attained at a first meeting, the partners are convened by registered
letters to a second meeting with at least thirty days notice, which will be held within three months from the first meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting partners whatever majority of capital be rep-

resented.

Financial year - Balance sheet - Distribution

Art. 13. The company’s financial year runs from first of January to the thirty-first of December.

Art. 14. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will

contain a record of the properties of the company and the profit and loss account, as also an appendix according to the
prescriptions of the law in force.

Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization, charg-

es and provisions presents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined

by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.

Dissolution

Art. 17. In the event of a dissolution of the company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner

upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.

When the liquidation of the company is closed, the assets of the company will be attributed to the partners propor-

tionally to the shares they hold.

General provisions

Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing

laws.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31st, 2003.

<i>Payment - Contributions

The appearing parties have subscribed for the number of shares mentioned hereafter: 

All these shares have been paid-up to the extent of 100% by payments in cash, so that the sum of thirteen thousand

euros (

€ 13,000.00) is forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary,

who certifies it.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand euros (

€ 1,000.-). 

<i>Extraordinary general meeting

Immediately after the incorporation of the company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and considering himself as duly convened, has proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, he has passed the following resolutions:
1. Is appointed as Managing Director for an unlimited duration:
Monsieur Tommy Jansson, managing director, residing in Luxembourg

The company AVAIL MEDICAL PRODUCTS Inc., prenamed, five hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Total: five hundred shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

3990

The company is validly bound by the single signature of the Managing Director.
2. The company shall have its registered office at L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same per-
son and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

 Whereof this notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of this deed.
 This deed having been read to the appearing person, said person appearing signed together with Us, the notary, this

original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

 L’an deux mille deux, le six décembre. 
 Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

 La société AVAIL MEDICAL PRODUCTS Inc., une société ayant son siège social à 1660, Chase Texas Tower-201,

Main Street-Forth Worth, US 76102 Texas, ici représentée par Monsieur Tommy Jansson, managing director, demeu-
rant à Luxembourg, en vertu d’une procuration, lui délivrée à Forth Worth, le 8 novembre 2002, 

 Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant, et le notaire instrumentant, restera an-

nexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

 Lequel comparant a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée, dont il a arrêté les statuts comme

suit:

Forme - Objet - Dénomination - Siège- Durée

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en

vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1915 sur les sociétés
à responsabilité limitée, telles que modifiées, particulièrement par la loi du 28 décembre 1992, ainsi que par les présents
statuts.

A tout moment, l’associé peut s’adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent pendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère initial unipersonnel de la société.

Art. 2. La société prend la dénomination de AVAIL MEDICAL PRODUCTS EUROPE, S.à r.l.

Art. 3. La société a pour objet le commerce de produits médicaux et hygiéniques en milieux hospitaliers et indus-

triels. 

Elle pendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques qui se

rattachent à son objet ou le favorisent.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, au Grand Duché de Luxembourg
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand Duché du Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour.

Capital - Parts

Art. 6. Le capital social de la société est fixé à treize mille euros (

€ 13.000,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-six euros (

€ 26,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres

associés et après leur avoir été offerte en priorité.

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société. 

Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soi, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés avec ou sans

limitation de la durée de leur mandat.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société, simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.

Décisions de l’associé unique - Décisions collectives d’associés

Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la

section XII de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.

3991

En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assem-

blées.

Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus

de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première assemblée, une
seconde assemblée sera convoquée par lettres recommandées avec un préavis d’un mois au moins et tenue dans un
délai de trois mois à dater de la première assemblée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année avec effet au trente et un décembre la gérance établit le bilan qui contriendra l’inventaire des

avoirs de la société et toutes les dettes actives et passives, et le compte de profits et pertes ainsi qu’une annexe con-
forme aux dispositions de la loi en vigueur.

Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la société de l’inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserves légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés.
Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le

bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution

Art. 17. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants

ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la société.

La liquidation terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils

détiennent.

Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n’est par prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Libération - Apports

Les parts sociales indiquées à l’article six ont été souscrites comme suit:  

Toutes les parts sociales ont été libérées à concurrence de 100% par des versements en espèces de sorte que la

somme de treize mille euros (

€ 13.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu’il en a été

justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille euros (

€ 1.000,-). 

<i>Assemblée générale extraordinaire

Immédiatement après la constitution de la société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social et

se considérant dûment convoqué, s’est réuni en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté qu’elle était régulièrement constituée, il a pris les résolutions suivantes:
1) Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Tommy Jansson, managing director, demeurant à Luxembourg. 
La société est valablement engagée par la seule signature du gérant.
2) Le siège social de la société est établi à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d’une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: T. Jansson, F. Kesseler.

La société AVAIL MEDICAL PRODUCTS Inc., prénommée, cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Total: cinq cents parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

3992

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 9 décembre 2002, vol. 884, fol. 21, case 9. – Reçu 130 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(94922/219/225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

RATANJA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

STATUTES

In the year two thousand and two, on December tenth.
Before Notary Francis Kesseler, having his official residence in Esch-sur-Alzette.

The following appeared:

1. The company FINACAP HOLDING S.A., having its registered office at 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, here

represented by Mr Emile Dax, Notary’s Clerk, residing in Garnich, under the terms of a power of attorney given him
by private agreement;

2. Mr Norbert Schmitz, a graduate in commercial and consular sciences, residing in Luxembourg, here represented

by Miss Sofia Da Chao Conde, a private employee, residing in Differdange, under the terms of a power of attorney given
to her by private agreement.

Which appears, represented as aforesaid, requested the Notary acting in this matter to document as follows the stat-

utes of a société anonyme (public limited company) which they wish to constitute as between themselves. 

Art. 1. A société anonyme (public limited company) under the name of RATANJA S.A. is hereby formed between

the appearers and all those who shall become owners of the shares hereinafter created.

Art. 2. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved in anticipation by resolution of

the General Meeting passed in the manner laid down for amendments to the statutes. 

Art. 3. The Company’s seat shall be established in Luxembourg.
In the event that extraordinary events of a political, economic or social nature liable to jeopardize normal business

at the seat of the Company or ready communications with the seat or between the seat and places abroad take place
or are imminent, the seat may be transferred provisionally to a foreign country until such time as the said abnormal
circumstances have completely ceased to obtain; nevertheless such provisional measure shall have no effect on the na-
tionality of the Company, which, notwithstanding the provisional transfer of its seat, shall remain a Luxembourg Com-
pany.

Art. 4. The sole objects of the Company shall be taking out of participations in any form whatsoever in Luxembourg

or foreign enterprises or companies, the acquisition by purchase, exchange, subscription, contribution of any other kind,
and the alienation by sale, exchange and any other method of securities of all kinds; the control and exploitation of those
participations, in particular through the grant to the entreprises in which it is interested of all assistance, loans, advances
or guarantees; the use of those funds for the creation, management, exploitation and liquidation of a portfolio consisting
of any securities and licences of any origin, the acquisition by contribution, subscription, direct underwriting or purchase
option and any other method of any securities and licences, the realisation by sale, transfer, exchange or otherwise and
the exploitation of those transactions and licences and, more generally, any commercial, financial or securities transac-
tions related directly or indirectly to the Company’s objects or liable to contribute to its development.

The Company may also and subsidiarily purchase, sell, rent and manage any immoveable property whether located

in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

Art. 5. The Company’s capital shall be fixed at thirty-one thousand euros (

€ 31,000.-), represented by three hundred

and ten (310) shares of a nominal value of one hundred euros (

€ 100.-), each having a vote at the General Meetings.

The shares shall be registered or bearer shares at the election of the Shareholder.
In the event of a division of property in the shares, the exercise of the totality of the rights appertaining to the Com-

pany, and in particular the right to vote at General Meetings, shall be reserved for Shareholders having the rights of
usufruct in the shares, to the exclusion of Shareholders holding the bare legal interest therein; the exercise of property
rights, as determined by the ordinary law, shall be reserved for Shareholders holding the bare legal interest in the shares
to the exclusion of Shareholders having the interest of usufruct.

The authorized capital shall be fixed at one million euros (

€ 1,000,000.-) represented by ten thousand (€ 1,000,000.-)

shares of a nominal value of one hundred euros (

€ 100.-) each.

The authorized capital and the subscribed capital of the Company may be increased or reduced by resolution of the

General Meeting of Shareholders passed in the manner laid down for amendments to the statutes.

For a period of five (5) years from the date of publication of this act, the Board of Directors shall be authorized to

increase at such time is fitting the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such capital increases
may be subscribed for an issued in the form of shares with or without share premium as to be determined by the Board
of Directors. Such capital increases may be made for contribution in cash or in kind and by the capitalization of reserves.

The Board of Directors is specifically authorized to make such issue without reserving for existing Shareholders a

preferential right to subscribe for the shares to be issued. The Board of Directors may delegate any board member,

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002.

F. Kesseler.

3993

manager, proxy holder or any other person duly authorized to receive subscriptions and payment of the price of the
shares representing the whole or part of the increase in capital.

Each time the Board of Directors proceeds to have an increase in the subscribed capital authentically attested to, this

article shall be deemed to have been automatically amended to suit the change which has been made.

The Company may buy back its own shares on the terms laid down by law. In the event of the sale of the right of

usufruct or bare legal property, the value of the beneficial or bare legal interest shall be determined by the value of the
full ownership of the shares and by values representing the usufruct and bare legal interest in accordance with the ac-
tuarial tables in force in the Grand Duchy of Luxembourg.

Art. 6. The Company shall be administered by a Board of Directors made up of a minimum of three members. Mem-

bers of the Board of Directors, who need not be Shareholders in the Company, shall be appointed for a term of office
which may not exceed six years. Directors may be re-elected.

The Directors may be divided in two different categories, category A and category B. The Directors may be dismissed

at any time and at the sole discretion of the General Meeting of Shareholders.

In the event of a post of Director appointed by General Meeting becoming vacant, the remaining Directors so ap-

pointed shall be entitled to fill the post provisionally; in such case, the next General Meeting shall proceed to the defin-
itive election.

Art. 7. The Board of Directors shall be vested with the broadest powers to manage the business of the Company

and to carry out all acts of disposal and administration which come within the objects of the Company, and everything
which is not reserved to the General Meeting by the statutes or by law shall be within its competence. It may in partic-
ular compromise, settle and authorize any waivers and releases, with or without payment.

The Board of Directors is authorized to distribute interim dividends in accordance with the terms and procedures

laid down by law.

The Board of Directors may delegate all or part of the day-to-day management of the Company’s business, together

with the representation of the Company as regards the said management, to one or more Directors, Managers, Admin-
istrators and/or Agents, whether members of the Company or not.

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two directors, each sig-

natory representing one category of directors, if several categories of directors have been created, or the single signa-
ture of any person to whom such signatory power has been granted by the Board of Directors, but only within the limits
of such power.

Art. 8. Judicial actions shall be pursued, whether as plaintiff or as defendant, in the name of Company by a Member

of the Board or the person delegated for that purpose by the Board.

Art. 9. The Company shall be supervised by one or more Auditors; they shall be appointed for a term which may

not exceed six years. They may be re-elected. 

Art. 10. The financial year shall commence on 1 January and end on 31 December each year. 

Art. 11. The annual General Meeting of Shareholders shall meet automatically at the Company’s seat or at any other

place in Luxembourg indicated in the notice of meeting on the second Monday in June at 10.00 a.m. If that day should
fall on a holiday, the meeting shall be held on the first following working day.

Art. 12. Every Shareholder shall have the right to vote himself or by proxy. Proxies need not themselves be Share-

holders.

Art. 13. The General Meeting shall have the widest powers to carry out or ratify any acts affecting the Company. It

shall decide on the allocation and distribution of the net profit.

The General Meeting may decide that the distributable reserves and profits are to be used to pay off the capital, with-

out any reduction in the stated capital.

Art. 14. For all points not dealt with in the present Statute, the parties shall defer to the provisions of the Law of

10 August 1915 and amending laws.

<i>Transitional Provision

- By way of exception, the first Ordinary Meeting of Shareholders shall be held on the second Monday in June 2004.
- By way of exception, the first financial year shall commence today and end on 31 December 2003.

<i>Subscription

The Company’s capital has been subscribed as follows: 

All the shares so subscribed have been paid up in cash so that the sum of thirty-one thousand euros (

€ 31,000.-) is

now at the disposal of the Company, as has been proved to the Notary, who attests expressly to this fact. 

<i>Attestation

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26

of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with

1. The company FINACAP HOLDING S.A., as aforesaid, three hundred and nine share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2. Mr Norbert Schmitz, as aforesaid, one share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

3994

<i>Costs

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any form whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation amount to approximately one thousand three hundred euros (

€ 1,300.-).

<i>Extraordinary general meeting

And at the same time, the appearers, in their respective capacities, representing the whole of the Company’s capital,

held an Extraordinary General Meeting, to which they recognized they had been duly convened, and adopted the fol-
lowing unanimous resolutions:

<i>First resolution

The number of directors is fixed at three and that of the statutory auditor at one:
The following have been appointed as Category «A» directors:
- Bengt Stenvinkel, Fonte dei Giuchi, Pereto, I-61019 S. Agata Feltria; 
The following have been appointed as Category «B» directors:
- Mr Norbert Schmitz, graduate in commercial and consular sciences, residing at 16, rue Eugène Wolff, L-2736 Lux-

embourg;

- Mr Jean-Marie Poos, graduate in economics, residing at 45, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess.

<i>Second resolution

The number of Auditors is fixed at one.
The following is appointed Auditor:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

<i>Third resolution

The mandate of the directors and of the Auditor so appointed is unpaid and will terminate at the end of the Statutory

General Meeting of 2008.

<i>Fourth resolution

The Company’s address is fixed in L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
The General Meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new address within the locality of the

statutory seat of the Company.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named

persons, this deed is worded in French followed by a English translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the French and English texts, the French version will be prevailing.

Whereof an act, drawn up in Esch-sur-Alzette, at the Notary’s Chambers, date as stated at the head of these presents.
This deed having been read to the appearing persons, said persons appearing signed together with Us, the notary,

this original deed. 

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le dix décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

Ont comparu:

1. La société FINACAP HOLDING S.A., dont le siège social est au 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, ici repré-

sentée par Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich, en vertu d’une procuration sous seing privé lui
délivrée;

2. Monsieur Norbert Schmitz, Licencié en Sciences Commerciales et Consulaires, demeurant à Luxembourg,
ici représenté par Mademoiselle Sofia Da Chao Conde, employée privée, demeurant à Differdange, en vertu d’une

procuration sous seing privé lui délivrée. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société anonyme qu’ils

vont constituer entre eux. 

Art. 1

er

. Il est constitué par les présentes entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des ac-

tions ci-après créées une société anonyme sous la dénomination de RATANJA S.A.

Art. 2. La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l’assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Si des événements extraordinaires, d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’activité nor-

male au siège ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l’étranger se produisaient ou seraient immi-
nents, le siège pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce
transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Art. 4. La société a pour objet toutes prises de participations sous quelques formes que ce soit, dans des entreprises

ou sociétés luxembourgeoises ou étrangères; l’acquisition par voie d’achat, d’échange, de souscription, d’apport de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par voie de vente, d’échange et de toute autre manière de valeurs mobilières de
toutes espèces; le contrôle et la mise en valeur de ces participations, notamment grâce à l’octroi aux entreprises aux-
quelles elle s’intéresse de tous concours, prêts, avances ou garanties; l’emploi de ses fonds à la création, à la gestion, à
la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, l’acquisition

3995

par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, de tous titres et bre-
vets, la réalisation par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement et la mise en valeur de ces affaires et brevets,
et plus généralement toutes opérations commerciales, financières ou mobilières se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet de la société ou susceptible de contribuer à son développement.

La société pourra également, et accessoirement, acheter, vendre, louer, gérer tout bien immobilier tant au Grand-

Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (

€ 31.000,-) représenté par trois cent dix (310) actions

d’une valeur nominale de cent euros (

€ 100,-), chacune disposant d’une voix aux assemblées générales.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
En cas de démembrement de la propriété des actions, l’exercice de l’ensemble des droits sociaux, et en particulier le

droit de vote aux assemblées générales, est réservé aux actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions à l’exclusion
des actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions; l’exercice des droits patrimoniaux, tels que ces derniers
sont déterminés par le droit commun, est réservé aux actionnaires détenteurs de la nue-propriété des actions à l’ex-
clusion des actionnaires détenteurs de l’usufruit des actions.

Le capital autorisé est fixé à un million d’ euros (

€ 1.000.000,-) représenté par dix mille (10.000,-) actions d’une valeur

nominale de cent euros (

€ 100,-) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-
mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations du capital peuvent être réalisées moyennant apport
en espèces ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi. En cas de vente de

l’usufruit ou de la nue-propriété, la valeur de l’usufruit ou de la nue-propriété sera déterminée par la valeur de la pleine
propriété des actions et par les valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété conformément aux tables de mor-
talité en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Les administrateurs peuvent être répartis en deux catégories, c’est-à-dire la catégorie A et la catégorie B. Les admi-

nistrateurs pourront être révoqués à tout moment à la seule discrétion de l’Assemblée Générale des actionnaires.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l’assemblée générale, lors de sa première réunion, pro-
cède à l’élection définitive. 

Art. 7. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires sociales et faire

tous les actes de disposition et d’administration qui rentrent dans l’objet social, et tout ce qui n’est pas réservé à l’as-
semblée générale par les statuts ou par la loi, est de sa compétence. Il peut notamment compromettre, transiger, con-
sentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.

Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformément aux

conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la société, ainsi que

la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants
et/ou agents, associés ou non-associés.

La société se trouve engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux adminis-

trateurs, dont chacun relèvera d’une catégorie d’administrateurs différente si plusieurs catégories ont été créées ou la
signature individuelle de la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 8. Les actions judiciaires, tant en demandantqu’en défendant, seront suivies au nom de la société par un membre

du conseil ou la personne à ce déléguée par le conseil.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires; ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Art. 10. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

à Luxembourg indiqué dans l’avis de convocation, le deuxième lundi du mois de juin à dix heures. Si ce jour est férié,
l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Tout actionnaire aura le droit de voter lui-même ou par mandataire, lequel peut ne pas être lui-même ac-

tionnaire.

3996

Art. 13. L’assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la

société. Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.

L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Art. 14. Pour tous points non réglés aux présents statuts, les parties se soumettent aux dispositions de la loi du 10

août 1915 et aux lois modificatives.

<i>Disposition transitoire

- Par dérogation, la première assemblée ordinaire des actionnaires se tiendra le deuxième lundi du mois de juin en

2004.

- Par dérogation, le premier exercice commencera aujourd’hui même pour finir le 31 décembre 2003.

<i>Souscription

Le capital social a été souscrit comme suit: 

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées par des versements en numéraires de sorte que la somme de tren-

te et un mille euros (

€ 31.000,-) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire

qui le constate expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à mille trois cents euros (

€ 1.300,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants ès qualités qu’ils agissent, représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en

assemblée générale extraordinaire, à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et à l’unanimité ils ont pris les ré-
solutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre des administrateurs est fixé à trois.
Est nommé administrateur de la catégorie A:
- Bengt Stenvinkel, Fonte dei Giuchi, Pereto, I-61019 S. Agata Feltria; 
Sont nommés administrateur de la catégorie B:
- Monsieur Norbert Schmitz, licencié en sciences commerciales et consulaires, demeurant à Luxembourg;
- Monsieur Jean-Marie Poos, licencié en sciences économiques, demeurant au 45, rue Haard, L-4970 Bettange/Mess.

<i>Deuxième résolution

Le nombre de commissaires est fixé à un.
Est nommé commissaire aux comptes:
Monsieur Eric Herremans, Sous-Directeur, demeurant à L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer

<i>Troisième résolution

Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés est gratuit et il prendra fin à l’issue de l’assemblée

générale de 2008.

<i>Quatrième résolution

L’adresse de la société est fixée au 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.
L’assemblée autorise le conseil d’administration à fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

Le notaire soussigné qui connaît la langue française constate que sur demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue française, suivi d’une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, le texte français fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte. 
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 884, fol. 40, case 2. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Oehmen.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial, Re-

cueil des Sociétés et Associations.

(94923/219/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

- La société FINACAP HOLDING S.A., préqualifiée, trois cent neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
- Monsieur Norbert Schmitz, préqualifié, une action  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002.

F. Kesseler.

3997

ARISTEE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.970. 

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de ARISTEE S.A. (la «Société») qui s’est tenue le 6 décembre

2002 a décidé de clôturer la liquidation de la Société.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à l’ancien siège social de la société.
Le passif ayant été complètement apuré et le produit de liquidation distribué à l’actionnaire de la société, aucune som-

me n’a dû être déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Luxembourg, le 19 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(94937/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

RODOLPHE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.912. 

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PROPHETE S.A. (la «Société») qui s’est tenue le 6 décembre

2002 a décidé de clôturer la liquidation de la Société.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à l’ancien siège social de la société.
Le passif ayant été complètement apuré et le produit de liquidation distribué aux actionnaires de la Société, aucune

somme n’a dû être déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Luxembourg, le 19 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(94938/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

AOL LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share Capital: EUR 269,036,000.

Registered office: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R. C. Luxembourg B 72.210. 

DISSOLUTION

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth of November, at 11.30 a.m.
Before Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared for an extraordinary general meeting of the sole shareholder of AOL LUXEMBOURG, S.à r.l., a Lux-

embourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 67, rue Ermesinde in L-1469 Luxembourg, reg-
istered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 72.210 (the «Company»),
incorporated pursuant to a deed of M

e

 Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated October 12, 1999, published

in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 995 of December 24, 1999. The articles of association of
the Company have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of M

e

 Gérard Lecuit, dated

November 23, 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, C - N° 482 of June 27, 2001:

EJV REORGANIZATION INC., a Delaware corporation having its registered office at 22000 AOL Way, Dulles, VA

20166, USA («EJV»),

hereby represented by Mrs Céline Pignon, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Dulles, USA

on November 22, 2002 (the «Proxy»).

A copy of the Proxy, having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, shall remain

attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

EJV, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:
- that pursuant to a subscription and contribution agreement dated November 20, 2002, duly accepted by the Com-

pany in accordance with article 190 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, EJV is the
sole shareholder of the Company.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
J. Seil
<i>Le liquidateur

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
J. Seil
<i>Le liquidateur

3998

A copy of the aforesaid subscription and contribution agreement, after having been signed ne varietur by the proxy-

holder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be reg-
istered with it.

- that the capital of the Company is set at EUR 269,036,000 (two hundred sixty-nine million thirty-six thousand Euro)

divided into 2,690,360 (two million six hundred ninety thousand three hundred and sixty) shares, having a par value of
EUR 100 (hundred Euro) each; 

- that EJV has decided to dissolve the Company with immediate effect;
- that EJV, in its capacity of liquidator of the Company, declares that it has received all assets of the Company and

that it shall assume all outstanding liabilities (if any) of the Company in particular those hidden and unknown at the
present time;

- that the Company be and hereby is liquidated and that the liquidation is closed;
- that full discharge is granted to the managers of the Company for the exercise of their mandate; and
- that the books, documents and records of the Company shall be kept during a period of five years at 67, rue Ermes-

inde in L-1469 Luxembourg.

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is word-

ed in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the
English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with

us, the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt six novembre, à 11.30 heures
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg). 
A comparu pour l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de AOL LUXEMBOURG, S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 67, rue Ermesinde, L-1469 Luxembourg, im-
matriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72.210 (la «Société»), constituée
par acte du notaire Gérard Lecuit, résidant à Hesperange, en date du 12 octobre 1999, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations, C - N° 995 du 24 décembre 1999. Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises
et pour la dernière fois par acte du notaire Gérard Lecuit en date du 23 novembre 2000, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations, C - N° 482 du 27 juin 2001:

EJV REORGANIZATION INC., une société constituée sous les lois de l’état de Delaware, ayant son siège social au

22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, USA, («EJV»),

ici représentée par Maître Céline Pignon, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée à Dulles, USA en date du 22 novembre 2002,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

EJV, représentée comme il est dit ci-dessus, a exposé au notaire et l’a prié d’acter que:
- suite à un contrat de souscription et d’apport du 20 novembre 2002, dûment accepté par la Société conformément

à l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, EJV est l’associé unique de la Société.

Une copie dudit contrat de souscription et d’apport, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire

instrumentant, restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

- le capital social de la Société s’élève à EUR 269.036.000 (deux cent soixante-neuf millions trente-six mille Euros)

divisé en 2.690.360 (deux millions six cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante) parts sociales ayant une valeur no-
minale de EUR 100 (cent Euros) chacune;

- EJV a décidé de liquider la Société avec effet immédiat;
- EJV, en sa capacité de liquidateur de la Société, déclare avoir reçu tous les actifs de la Société et qu’elle prendra en

charge tout le passif de la Société (s’il y en a) et en particulier le passif occulte et inconnu à ce moment;

- la Société est partant liquidée et la liquidation est clôturée;
- EJV donne plein et entière décharge aux gérants de la Société pour l’exercice de leur mandat; et
- les livres, documents et pièces relatives à la Société resteront conservés durant cinq ans au 67, rue Ermesinde, L-

1469 Luxembourg. 

Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la comparante, qui a requis le notaire de documenter le

présent acte en langue anglaise, le mandataire de la comparante a signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir
connaissance personnelle de la langue anglaise. Le présent acte en langue anglais et suivi d’une traduction française. En
cas de divergences entre le texte anglais et français, le texte anglais primera.

Signé: C. Pignon, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 32, case 1. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94960/220/88) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Hesperange, le 19 décembre 2002.

G. Lecuit.

3999

PROPHETE S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 61.984. 

DISSOLUTION

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de PROPHETE S.A. (la «Société») qui s’est tenue le 6 décembre

2002 a décidé de clôturer la liquidation de la Société.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à l’ancien siège social de la société.
Le passif ayant été complètement apuré et le produit de liquidation distribué aux actionnaires de la Société, aucune

somme n’a dû être déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Luxembourg, le 19 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(94939/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

LEOPOLD HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée (en liquidation).

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 61.903. 

DISSOLUTION

Par une décision de l’actionnaire unique de LEOPOLD HOLDING, S.à r.l. (la «Société») en date du 6 décembre 2002,

la procédure de liquidation de la société a été clôturée.

Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans à l’ancien siège social de la société.
Le passif ayant été complètement apuré et le produit de liquidation distribué à l’actionnaire de la société, aucune som-

me n’a dû être déposée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Luxembourg, le 19 décembre 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 36, case 1.– Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(94940/534/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

OPSON HOLDINGS S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 87.971. 

<i>Meeting of sharesholders

A special meeting of the shareholders of OPSON HOLDINGS S.A. was held on November 2, 2002 at the company’s

offices in Luxembourg at 14.00.

Present were Rick Genderson of the SCHNEIDERS Group, Serge Hauchart, and John Gidding, representing 100 %

of the outstanding shares of stock in OPSON HOLDINGS S.A. The majority of stockholders were therefore present
and the meeting was called to order.

Mr Gidding was elected as the chairman of the meeting:
Mr Gidding proposed:

<i>Resolution

Mr Gidding should be elected as the Delegated Administrator of OPSON HOLDINGS S.A.
This resolution was put to a vote and unanimously accepted.

<i>Resolved

Mr Gidding is elected the Delegated Administrator of OPSON HOLDINGS and that he should notify the respective

Luxembourg authorities and the companies Banks of this resolution.

There being no further business the meeting was adjourned.
Signé: J. Gidding, S. Hauchart, R. Genderson.
Enregistré à Luxembourg, le 10 décembre 2002, vol. 577, fol. 70, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(94989/503/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
J. Seil
<i>Le liquidateur

BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE
J. Seil
<i>Le liquidateur

4000

SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A.,

Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

STATUTES

In the year two thousand two, on the fifteenth of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, having its registered at Wickhams Cay, PO Box 662,

Road Town, Tortola, BVI,

2. BRADWELL FINANCIAL SERVICES INC., having its registered at Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tor-

tola, BVI,

both here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in L-2519

Luxembourg, 9, rue Schiller, itself represented by Mr José Correia, accountant, residing in Longwy (France) and Miss
Séverine Canova, lawyer, residing in Thionville (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A and
B,

by virtue of two proxies established on November 13, 2002.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE

AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are all transactions pertaining directly or indirectly to the

taking of participating interests in any enterprises in whatever form, to the administration, the management, the control
and the development of these participating interests.

It may particularly use its funds for the setting-up, the management, the development and the disposal of a portfolio

consisting of any securities and patents of whatever origin, participate in the creation, the development and the control
of any enterprise, to acquire by way of investment, subscription, underwriting or by option to purchase and any other
way whatever, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, have developed
these securities and patents, grant to the companies in which it has participating interests any support, loans, advances
or guarantees.

The company may take any action to safeguard its rights and make any transaction whatsoever which are directly or

indirectly connected with its purposes and which are liable to further their development or extension.

In all operations indicated hereabove, as well as in its whole activity, the company will remain within the limits estab-

lished by the law of July 31st, 1929.

Title II.- Capital, Shares 

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at fifty thousand Euro (50,000.- EUR) represented by five

thousand (5,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The authorized capital of the corporation is fixed at seventy million Euro (70,000,000.- EUR) to be divided into seven

million (7,000,000) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The authorized and subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general

meeting of shareholders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

The board of directors may, during a period of five years from the date of publication of the present articles increase

the subscribed capital within the limits of the authorized capital. Such increase may be subscribed for and issued in the
form of shares with or without an issue premium, as the board of directors shall determine.

Moreover, the board of directors is authorized to issue ordinary or convertible bonds, in registered or bearer form,

with any denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits
of the authorized capital.

The board of directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue and reimburse-

ment and any other conditions which may be related to such bond issue.

A ledger of the registered bondholders will be held at the registered office of the company.

4001

The board of directors is specifically authorized to make such issues, without reserving for the then existing share-

holders, a preferential right to subscribe for the shares to be issued. The board of directors may delegate to any duly
authorized person, the duty of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.

After each increase in the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the

present article will be adapted to this modification.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Title III.- Management 

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders. 

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a die, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision 

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years. 

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting 

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the first day of March at 11.00 a.m. and the first time in the year 2004.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits 

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

4002

Title VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of fifty thousand Euro (50,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand five hundred
Euro (2,500.- EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:
a) Mr Vesselin Danev, Banker, having his domicile at 195 Boardwalk Place, London E14 5SQ, United Kingdom,
b) Mr Georgi Veltchev, Securities Dealer, having his domicile at 56 Kensington Heights, 91-95 Campden Hill Road,

London W8 7BD, United Kingdom,

c) Mr Ivo Evgeniev, Manager, having his domicile at 58, Leva str, V4D, Vratza 3.000, Bulgaria.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2008: 

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendzwei, am fünfzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Sind erschienen:

1. SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, mit Gesellschaftssitz in Wickhams Cay, PO Box 662,

Road Town, Tortola, BVI,

2. BRADWELL FINANCIAL SERVICES INC., mit Gesellschaftssitz in Wickhams Cay, PO Box 662, Road Town, Tor-

tola, BVI,

beide Gesellschaften hier vertreten durch LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., mit Gesellschaftssitz

in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn José Correia, comptable, wohnhaft in Longwy (France) und Fräulein Séverine
Canova, juriste, wohnhaft in Thionville (France), handelnd in ihrer Eigenschaft als Prokurist A und B,

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt 13. November 2002,
welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vorlie-

gender Urkunde beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie vorbenannt, ersuchten den amtierenden Notar nachfolgenden durch alle Kompa-

renten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

1. SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, prenamed, four thousand nine hundred and

ninety-nine shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.999

2. BRADWELL FINANCIAL SERVICES INC., prenamed, one share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: five thousand shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000

4003

Titel I. Bezeichnung, Gesellschaftssitz, Zweck, Dauer 

Art. 1. Es wird eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEI-

SURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg ver-

legt werden.

Falls aussergewöhnliche politische oder wirtschaftliche Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, welche die

normale Tätigkeit dieses Sitzes oder die Kommunikation dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden, kann die provisori-
sche Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland erklärt werden, dies solange bis zur vollständigen Beendigung der
anormalen Umstände. Eine solche Entscheidung wird die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigen. Die
Erklärung betreffend den Verleg des Gesellschaftssitzes wird Dritten durch das Gesellschaftsorgan mitgeteilt, das unter
den gegebenen Umständen am besten hierfür geeignet ist.

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer gegründet.

Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung sämtlicher Geschäfte welche direkt oder indirekt mit dem

Erwerb, der Verwaltung, der Kontrolle und der Verwertung von Beteiligungen an allen europäischen oder aussereuro-
päischen Unternehmen zusammenhängen.

Sie kann ihre Mittel verwenden für die Schaffung, Verwaltung, Verwertung und Liquidation eines Portfolios, das sich

aus allen Arten von Wertpapieren und Patenten zusammensetzt, sowie zum Erwerb von Wertpapieren und Patenten
durch Einlagen, Zeichnung, Festübernahme und Kaufsoption oder auf jede andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann
diese Wertpapiere durch Verkauf, Übertragung, Austausch oder sonstwie realisieren, diese Wertpapiere und Patente
auswerten, den Unternehmen, an denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschüssen oder Ga-
rantien gewähren.

Sie wird alle Massnahmen zum Schutz ihrer Rechte ergreifen und jede Art von Geschäften abschliessen, die mit ihrem

Gesellschaftszweck zusammenhängen oder diesen fördern.

In ihren sämtlichen Geschäftstätigkeiten bleibt die Gesellschaft im Rahmen des Gesetzes vom 31. Juli 1929.

Titel II. Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital wurde festgesetzt auf fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), eingeteilt in fünftausend

(5.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,- EUR).

Das genehmigte Gesellschaftskapital wird auf siebzig Millionen Euro (70.000.000,- EUR) festgesetzt, eingeteilt in sie-

ben Millionen (7.000.000) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,- EUR).

Das genehmigte und gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfas-

sung der Generalversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Desweiteren ist der Verwaltungsrat ermächtigt, während einer Zeitspanne von fünf Jahren vom Datum der Veröf-

fentlichung dieser Satzung an gerechnet, das gezeichnete Kapital im Rahmen des genehmigten Kapitals zu erhöhen. Diese
Kapitalerhöhungen können gezeichnet und ausgegeben werden mittels Aktien mit oder ohne Ausgabeprämie ganz nach
Belieben des Verwaltungsrates. 

Der Verwaltungsrat ist ausserdem ermächtigt Anleihen auszugeben, in Form einfacher Anleihen, Optionsanleihen

oder Wandelanleihen, in Form von Inhaberobligationen oder in anderer Form, unter welcher Bezeichnung auch immer
und zahlbar in jeder Währung, jedoch mit der Massgabe, dass die Ausgabe von Wandelobligationen oder Optionsanlei-
hen nur im Rahmen des oben genannten genehmigten Kapitals erfolgen kann.

Der Verwaltungsrat bestimmt die Art, den Preis, den Zinssatz, die Ausgabe- und Rückzahlungsbedingungen, sowie

alle anderen Bedingungen im Zusammenhang mit dieser Ausgabe. 

Ein Register bezüglich der auf den Namen laufenden Schuldverschreibungen wird am Gesellschaftssitz geführt.
Der Verwaltungsrat ist insbesondere ermächtigt diese Aufstockungen vorzunehmen ohne den jetzigen Aktionären

ein Zeichnungsprivileg auf den auszugebenden Aktien vorzubehalten. Der Verwaltungsrat kann jedem Verwaltungsrats-
mitglied, Direktor oder Prokurist oder jeder anderen ermächtigten Person, Vollmacht erteilen um die Zeichnungen zu
empfangen und die Zahlung des Preises der Aktien welche diese ganze oder teilweise Kapitalerhöhung darstellen, zu
erhalten.

Jedesmal wenn der Verwaltungsrat eine solche Kapitalerhöhung amtlich festgestellt hat, wird dieser Artikel als auto-

matisch an die vorgenommene Änderung angepasst, betrachtet.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Global- oder Einzelaktien ausstellen.
Die Aktien können als Namens- oder Inhaberaktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann den Wiederkauf ihrer eigenen Aktien unter den gesetzlich gegebenen Bedingungen veranlassen.

Titel III. Verwaltung 

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat mit wenigstens drei Mitgliedern, Teilhaber oder nicht, verwaltet, die

von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Zeitspanne genannt sind, die nicht mehr als sechs Jahre betragen
kann. Sie können zu jeder Zeit von der Generalversammlung wiedergewählt oder abberufen werden.

Die Zahl der Verwalter und die Dauer ihres Mandates werden von der Generalversammlung der Gesellschaft fest-

gesetzt.

Im Falle einer unbesetzten Stelle im Verwaltungsrat haben die bleibenden Verwalter das Recht diese provisorisch zu

besetzen, die getroffene Entscheidung wird in der nächsten Versammlung ratifiziert.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tagt auf Einberufung des Vorsitzenden oder auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.

4004

Die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheidungen und Beschlüsse sind nur gültig wenn die Mehrheit der Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Eine Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist möglich und kann durch Brief, Tele-
gramm, Telex oder Fax erfolgen.

In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder per Brief, Telegramm, Telex oder Fax ihre Stimme ab-

geben.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

Art. 8. Dem Verwaltungsrat obliegen die weitreichendsten Befugnisse zur Durchführung aller Verwaltungshandlun-

gen und Beschlüsse, die sich im Rahmen des im vorhergehenden Artikel 4 erläuterten Gesellschaftszweckes befinden.

Er ist zu allen Handlungen ermächtigt, die nicht ausschliesslich durch das Gesetz und die Statuten der Generalver-

sammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt unter den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen, Dividendenvorschüsse auszu-

zahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse
betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandaten, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10
der Satzung erteilt werden. 

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen,

welche als Delegierte des Verwaltungsrates ernannt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch die Geschäftsführung ganz oder teilweise an einen oder mehrere Direktoren übertra-

gen oder einem oder mehreren Bevollmächtigten besondere Vollmachten erteilen. Bei dem Bevollmächtigten oder Di-
rektor muss es sich nicht unbedingt um ein Verwaltungsratsmitglied oder Aktionär handeln.

Die Übertragung von Befugnissen an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Zustimmung der

Generalversammlung.

Art. 11. Alle gerichtlichen Streitigkeiten der Gesellschaft, sei es als Kläger oder als Angeklagter, werden vom Ver-

waltungsrat verfolgt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch eines hierzu ermächtigten Mitgliedes vertreten ist.

Titel IV. Überwachung 

Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Kommissaren

überwacht. Sie setzt ihre Zahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest, welches nicht mehr als sechs Jahre betra-
gen kann.

Sie können zu jedem Zeitpunkt wiedergewählt oder abberufen werden.

Titel V. Generalversammlung 

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tagt innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, an dem in den Ein-

berufungen angegebenen Ort, am 1. März eines jeden Jahres um 11.00 Uhr und zum ersten Male im Jahre 2004. 

Falls dieses Datum ein gesetzlicher Feiertag ist, tagt die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Arbeitstag.
Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu ha-

ben, kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung stattfinden.

Titel VI. Geschäftsjahr, Aufteilung des Gewinns 

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr erstreckt sich ausnahmsweise über die Zeit von der Gründung der Gesellschaft an bis zum

31. Dezember 2003.

Art. 15. Der positive Überschuss des Jahresabschlusses, nach Abzug der Sozialbeiträge und Abschreibungen bildet

den Nettogewinn der Gesellschaft. Diesem Gewinn werden fünf Prozent für die Erstellung eines legalen Reservefonds
entnommen; diese Entnahme ist nicht mehr erforderlich, wenn die Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapitals beträgt,
muss jedoch wieder aufgenommen werden, wenn zu einem gewissen Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer,
auf den Reservefonds zurückgegriffen wurde.

Die Generalversammlung kann darüberhinaus über den Saldo verfügen.

Titel VII. Auflösung, Liquidation 

Art. 16. Die Gesellschaft kann auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere von der Generalversammlung er-

nannten Liquidatoren, deren Befugnisse und Entgeld sie bestimmt.

Titel VIII. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 17 Für alle in den vorliegenden Statuten nicht erfassten Punkte beziehen sich die Parteien auf die Bestimmungen

des luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften wie deren Abänderungen, denen
sie sich unterwerfen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Aktien wurden gezeichnet wie folgt: 
SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.999 Aktien
BRADWELL FINANCIAL SERVICES INC., vorbenannt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 Aktie

Total:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 Aktien

4005

Das gezeichnete Kapital wurde vollständig in bar eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft ab sofort über einen Betrag

von fünfzigtausend Euro (50.000,- EUR), worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Schätzung und Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausendfünfhundert Euro (2.500,- EUR).

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten einstimmig folgende Be-
schlüsse:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die Zahl der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern, deren Mandate bei der Generalversammlung des Geschäftsjahres 2008 enden,

wurden bestellt:

a) Herr Vesselin Danev, Banker, wohnhaft in 195 Boardwalk Place, London E14 5SQ, England,
b) Herr Georgi Veltchev, Securities Dealer, wohnhaft in 56 Kensington Heights, 91-95 Campden Hill Road, London

W8 7BD, England,

c) Herr Ivo Evgeniev, Manager, wohnhaft in 58, Leva str, V4D, Vratza 3.000, Bulgarien.
3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wurde bestellt:
C.A.S. SERVICES S.A. mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.
4) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller. 
Der amtierende Notar, welcher Kenntnis der englischen Sprache hat, bestätigt dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in englischer Sprache gehalten ist gefolgt von einer deutsche Übersetzung, und dass im Falle von
Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit Uns, Notar, vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Correia, S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 137S, fol. 17, case 6. – Reçu 500 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Abschrift, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,

erteilt. 

(94925/220/339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

COMITALU S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 28.627. 

<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002

Les actionnaires de la société COMITALU S.A., réunis en assemblée générale extraordinaire au siège de la société le

28 novembre 2002, ont décidé, à l’unanimité, de nommer Monsieur Philippe Canu, demeurant à F-57950 Montigny-les-
Metz, 2, rue Albert Haefeli, directeur de la société.

Luxembourg, le 28 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 décembre 2002, vol. 577, fol. 92, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(95002/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

HAPPY GREENS S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6162 Bourglinster, 36, rue de l’Ecole.

H. R. Luxemburg B 36.615. 

Im Jahre zweitausendundzwei, am zwölften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Aloyse Biel, mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette.

Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft HAPPY GREENS S.A., mit Sitz in L-6162 Bourglinster, 36, rue de l’Ecole,

eingetragen im Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 36.615 zu einer ausserordentlichen Generalver-
sammlung zusammengetreten.

Hesperingen, den 12. Dezember 2002.

G. Lecuit.

Pour extrait conforme
Signatures

4006

Die Aktiengesellschaft HAPPY GREENS S.A. wurde gegründet gemäss Urkunde vom 8. April 1991, aufgenommen

durch den Notar Joseph Elvinger, damals mit Amtswohnsitz in Düdelingen, in Vertretung seines verhinderten Kollegen
Gérard Lecuit, Notar mit dem damaligen Amtssitze in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, Nummer 367 vom 7. Oktober 1991.

Die Satzungen genannter Gesellschaft wurden umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch den Notar Gérard Lecuit

am 14. Dezember 1992, mit damaligem Amtssitze in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, Nummer 139 vom 31. März 1993;

umgeändert gemäss Akt aufgenommen durch Notar Edmond Schroeder am 10.03.1998, mit damaligem Amtssitze in

Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 550 vom 28. Juli 1998;

und zuletzt umgeändert gemäss Akt aufgenommen Buch Notar Edmond Schroeder am 13.12.2001, mit damaligem

Amtssitze in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 521 vom 4. April
2002.

Die Versammlung wird unter dem Vorsitz von Herrn Dieter Kolb, wohnhaft in Bourglinster eröffnet.
Der Vorsitzende beruft zum Sekretär Herrn Jean-Pascal Cambier, wohnhaft in Esch-sur-Alzette.
Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler, Herrn Marc Treichel, wohnhaft in Junglinster.
Der Vorsitzende stellt unter Zustimmung der Versammlung folgendes fest:
I. Gegenwärtigem Protokoll liegt ein Verzeichnis der Aktien der Gesellschaft bei, welche Liste von den Gesellschaf-

tern, beziehungsweise deren Vertretern, sowie den Mitgliedern der Versammlung und dem amtierenden Notar unter-
zeichnet ist und gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

II. Die von den Gesellschaftern ausgestellten Vollmachten werden, nachdem sie von den Mitgliedern der Versamm-

lung ne varietur unterschrieben wurden, zusammen mit der Anwesenheitsliste, diesem Protokoll beigebogen, um mit
demselben einregistriert zu werden.

III. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist. Die Versammlung ist also rechtsgültig zusammengesetzt, betrachtet sich als wirksam einberufen und befugt über
nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist, zu beschliessen.

IV. Die Tagesordnung der Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Änderung von Artikel 6 der Satzung um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder,

Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.».
2. Ermächtigung des Verwaltungsrates, Herrn Dieter Kolb für eine Dauer von vier Jahren zum Delegierten des Ver-

waltungsrates zu ernennen.

Nach Beratung fasst die Generalversammlung dann einstimmig folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, Artikel 6 der Satzung abzuändern und ihm den folgenden Wortlaut zu geben:
«Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder,

Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.».

<i>Zweiter Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst, den Verwaltungsrat zu ermächtigen, Herrn Dieter Kolb für die Dauer von vier

Jahren zum Delegierten des Verwaltungsrates zu ernennen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für abgeschlossen.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt, in Esch-sur-Alzette, in der Amts-

stube.

Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vorna-

men, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit uns Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: D. Kolb, J.-P. Cambier, A. Biel. 
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 13 décembre 2002, vol. 884, fol. 30, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée aux parties sur leurs demande pour servir aux fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(94946/203/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

HAPPY GREENS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6162 Bourglinster, 36, rue de l’Ecole.

R. C. Luxembourg B 36.615. 

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94947/203/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Esch-sur-Alzette, le 23 décembre 2002.

A. Biel.

4007

ABM MERCHANT S.A., Société Anonyme,

(anc. ABM INTERNATIONAL S.A.).

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.342. 

 L’an deux mille deux, le vingt et un novembre.
 Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

S’est réunie:

 L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ABM INTERNATIONAL S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 18 juillet 2000, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 53 du 25 janvier 2001.

 L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Sara Cipollini, administrateur de sociétés, demeurant à Le-

gnano (Milan),

 qui désigne comme secrétaire Madame Anne Compère, employée privée, demeurant à Luxembourg.
 L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrice Gallasin, juriste, demeurant à Hettange-Grande (France).
 Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
 I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
 1. Changement de la dénomination de la société en ABM MERCHANT S.A.
 2. Modification afférente des articles des statuts.
 3. Divers.
 II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

 Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été si-

gnées ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

 III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

 IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-

rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

 Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du Jour.

 L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Résolution unique

 L’assemblée décide de changer la dénomination sociale de ABM INTERNATIONAL S.A. en ABM MERCHANT S.A.

de sorte que l’article 1

er

 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de ABM MERCHANT S.A.»

<i>Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

en raison des présentes est évalué à environ cinq cents euros (500,- EUR).

 Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: S. Cipollini, A. Compère, P. Gallasin, D. C. Oppelaar, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 2 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 32, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94965/220/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

ABM MERCHANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.342. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94966/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Hesperange, le 18 décembre 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 18 décembre 2002.

G. Lecuit.

4008

GEMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.499. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95007/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GEMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.499. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95005/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GEMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.499. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95006/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

GEMEX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 105, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 68.499. 

EXTRAIT

Conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, les actionnaires de la société GEMEX S.A., réu-

nis en assemblée générale extraordinaire en date du 6 décembre 2002, ont pris unanimement la décision de maintenir
l’activité sociale de la société.

Luxembourg, le 6 décembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 30 décembre 2002, vol. 578, fol. 46, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(95008/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

NORFIN II S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

STATUTES

In the year two thousand and two, on the thirteenth of December. 
Before Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1) TECNICA S.p.A., a company with registered office at Via Fante d’Italia, 56, I-31040 Giavera del Montello (TV), Italy,
2) NORFIN S.r.l., a company with registered office at Via Fante d’Italia, 56, I-31040 Giavera del Montello (TV), Italy,
both here represented by Mr Alexis De Bernardi, private employee, with professional address at 17, rue Beaumont,

L-1219 Luxembourg,

by virtue of two proxies given in Giavera del Montello (TV), Italy, on December 9, 2002.
Said proxies after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Signature.

<i>Pour GEMEX S.A.
Signature
<i>Le mandataire

4009

 Such appearing parties, through their mandatory, have decided to form amongst themselves a corporation (Société

Anonyme) in accordance with the following Articles of Incorporation: 

Art. 1. There is hereby formed a limited corporation under the name of NORFIN II S.A.
The registered office is established in Luxembourg.
 It may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General

Meeting of Shareholders.

If extraordinary events of a political, economic, or social nature, likely to impair normal activity at the registered office

or easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the registered office
may be provisionally transferred abroad. Such temporary measure shall, however, have no effect on the nationality of
the Company which, notwithstanding such provisional transfer of the registered office, shall remain a Luxembourg com-
pany.

The Company is established for an unlimited period.
 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for

the amendment of these Articles of Incorporation.

Art. 2. The Company’s object is, as well in Luxembourg as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial,

financial, personal or real estate property transactions, which are directly or indirectly in connection with the creation,
management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and companies which object is any activities in what-
soever form, as well as the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this
purpose, as far as the Company shall be considered as a «Société de Participations Financières» according to the appli-
cable provisions.

The Company may take participating interests by any means in any businesses, undertakings or companies having the

same, analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations. 

Art. 3. The corporate capital is set at one hundred and fifty thousand (150,000.-) euro, divided into one hundred

and fifty (150) shares with a par value of one thousand (1,000.-) euro each. 

Art. 4. The shares shall be registered or bearer shares, at the option of the shareholders.
The Company’s shares may be issued, at the owner’s option, in certificates representing single shares or two or more

shares.

The Company may repurchase its own shares by means of its free reserves under the provisions set forth in Article

49-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended by the law of April 24, 1983.

The capital of the Company may be increased or reduced in one or several steps by resolution of the general meeting

of shareholders, adopted in accordance with the provisions applicable to changes in the Articles of Incorporation

Art. 5. The Company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not

be shareholders.

The Directors shall be appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed

at any time.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the

vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next General Meeting. 

Art. 6. The Board of Directors has full power to perform all such acts as shall be necessary or useful to the object

of the Company.

All matters not expressly reserved to the General Meeting by law or by the present Articles of Incorporation are

within the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors may elect a Chairman. In the absence of the Chairman, another Director may preside over

the meeting.

The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax, being permitted.

In case of urgency, Directors may vote by letter, telegram, telex or telefax.
Resolutions shall require a majority vote. In case of a tie, the Chairman has the casting vote.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the day-to-day management and the rep-

resentation of the Company in connection therewith to one or more Directors, managers or other officers; they need
not be shareholders of the Company.

Delegation to a member of the Board of Directors is subject to the previous authorization of the General Meeting.
The Company is either bound by the joint signatures of any two Directors or by the sole signature of the managing

director. 

Art. 7. The Company shall be supervised by one or more Auditors, who need not be shareholders; they shall be

appointed for a maximum period of six years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time. 

Art. 8. The Company’s financial year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of

each year. 

Art. 9. The Annual General Meeting shall be held in Luxembourg at the registered office or such other place as in-

dicated in the convening notices on the last Friday in the month of May at 1.00 p.m.

If the said day is a public holiday, the meeting shall be held on the next following working day. 

Art. 10. Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions.

4010

If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have knowledge of the agenda submit-

ted to their consideration, the general meeting may take place without convening notices.

The Board of Directors may decide that the shareholders wishing to attend the General Meeting must deposit their

shares five clear days before the date fixed therefore.

Every shareholder has the right to vote in person or by proxy, who need not be a shareholder.
Each share gives the right to one vote. 

Art. 11. The General Meeting of shareholders has the most extensive powers to carry out or ratify such acts as may

concern the Company. 

 It shall determine the appropriation and distribution of the net profits. 

Art. 12. Under the provisions set forth in Article 72-2 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as

amended by the law of April 24, 1983, the Board of Directors is authorized to distribute interim dividends. 

Art. 13. The law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, shall apply providing these Articles of

Incorporation do not state otherwise.

<i>Transitory provisions

1) The first financial year shall begin today and end on the thirty-first of December, 2003.
2) The first annual general meeting shall be held in 2004.

<i>Subscription and payment

The above-named parties have subscribed the shares as follows: 

These shares have been fully paid up in cash, so that the sum of one hundred and fifty thousand (150,000.-) euro is

forthwith at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary who expressly bears witness to it.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declared that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about three thousand four hundred (3,400)
euro.

<i>Constitutive meeting

Here and now, the above-named parties, representing the entire subscribed share-capital and considering themselves

as duly convened, have proceeded to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly con-
stituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:

1) The number of Directors is set at three and that of the Auditors at one. 
2) The following have been appointed Directors:
a) Mr Ruggero Zanatta, manufacturer, residing at Via VIII Armata, 26, I-31040 Treviso, Italy,
b) Mr Vincenzo Arno’, maître en droit, with professional address at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
c) Mrs Marie-Fiore Ries-Bonani, private employee, with professional address at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxem-

bourg.

3) The following is appointed Auditor:
INDEPENDENT, S.à r.l., with registered office at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
4) The mandates of the Directors and the Auditor shall expire immediately after the annual general meeting of the

year 2004.

5) The Company shall have its registered office at 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg. 

In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of the document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

The document having been read and translated into the language of the mandatory of the appearers, said mandatory

signed together with Us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le treize décembre. 
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) TECNICA S.p.A., une société avec siège social à Fante d’Italia, 56, I-31040 Giavera del Montello (TV), Italie,
2) NORFIN S.r.l., une société avec siège social à Via Fante d’Italia, 56, I-31040 Giavera del Montello (TV), Italie,
toutes les deux ici représentées par Monsieur Alexis De Bernardi, employé privé, domicilié professionnellement au

17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,

1) TECNICA S.p.A., prenamed, one hundred and forty-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
2) NORFIN S.r.l., prenamed, one share  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: one hundred and fifty shares   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

4011

en vertu de deux procurations sous seing privé données à Giavera del Montello (TV), Italie, en date du 9 décembre

2002. 

Lesquelles procurations, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire resteront an-

nexées au présent acte pour être enregistrées en même temps. 

Lesquelles comparantes, ès qualités qu’elles agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’el-

les vont constituer entre elles: 

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de NORFIN II S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée

générale des actionnaires.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le siège social
pourra être transféré provisoirement à l’étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La durée de la Société est illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’assemblée générale des actionnaires, délibérant dans

les formes prescrites par la loi pour la modification des statuts. 

Art. 2. La Société a pour objet, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes opérations généralement quelconques,

industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à la
création, la gestion et le financement, sous quelque forme que ce soit, de toutes entreprises et sociétés ayant pour objet
toute activité, sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion et la mise en valeur, à titre permanent ou temporaire,
du portefeuille créé à cet effet, dans la mesure où la Société sera considérée selon les dispositions applicables comme
«Société de Participations Financières». 

La Société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique,

analogue ou connexe, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à le lui faciliter. 

Art. 3. Le capital social est fixé à cent cinquante mille (150.000,-) euros, divisé en cent cinquante (150) actions d’une

valeur nominale de mille (1.000,-) euros chacune.

Art. 4. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la Société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

La Société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-

positions de l’article 49-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Le capital social de la Société peut être augmenté ou diminué en une ou plusieurs tranches par une décision de l’As-

semblée Générale des actionnaires prise en accord avec les dispositions applicables au changement des statuts. 

Art. 5. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours

révocables.

En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;

dans ce cas, l’Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive. 

Art. 6. Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.

Le Conseil d’Administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion

peut être conférée à un administrateur présent.

 Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le

mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou télécopie, étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopie.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix de

celui qui préside la réunion est prépondérante.

Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la représentation

de la société à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’Assemblée

Générale.

La Société se trouve engagée soit par les signatures conjointes de deux administrateurs, soit par la signature indivi-

duelle de l’administrateur-délégué. 

Art. 7. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour

une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. 

Art. 9. L’Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit le dernier vendredi du mois de mai à 13.00 heures à

Luxembourg au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.

Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. 

Art. 10. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales.

4012

Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et qu’ils déclarent avoir eu

préalablement connaissance de l’ordre du jour.

Le Conseil d’Administration peut décider que pour pouvoir assister à l’Assemblée Générale, le propriétaire d’actions

doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion.

Tout actionnaire aura le droit de voter en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix. 

Art. 11. L’Assemblée Générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes

qui intéressent la Société.

Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net. 

Art. 12. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales, le Conseil d’Administration est autorisé à procéder à un versement d’acomptes sur dividendes. 

Art. 13. La loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales trouvera son application partout où il n’y est

pas dérogé par les présents statuts. 

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence aujourd’hui même et finit le 31 décembre 2003.
2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2004.

<i>Souscription et libération

Les comparantes précitées ont souscrit aux actions créées de la manière suivante: 

Toutes les actions ont été entièrement libérées en espèces de sorte que le montant de cent cinquante mille

(150.000,-) euros est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate
expressément.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les so-

ciétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de trois mille quatre
cents (3.400,-) euros.

<i>Assemblée constitutive

Et à l’instant les comparantes préqualifiées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constituées en assem-

blée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci
était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2) Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Ruggero Zanatta, industriel, demeurant à Via VIII Armata, 26, I-31040 Treviso, Italie,
b) Monsieur Vincenzo Arno’, maître en droit, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg,
c) Madame Marie-Fiore Ries-Bonani, employée privée, avec adresse professionnelle au 17, rue Beaumont, L-1219

Luxembourg.

3) Est appelée aux fonctions de commissaire:
 INDEPENDENT, S.à r.l., avec siège social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
4) Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an

2004.

5) Le siège de la société est fixé au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparantes les

présents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française; à la requête des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des comparantes, celui-ci a signé avec Nous, notaire, la

présente minute.

Signé: A. De Bernardi, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 15CS, fol. 50, case 3. – Reçu 1.500 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): W. Kerger.

Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94929/230/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

1) TECNICA S.p.A., préqualifiée, cent quarante-neuf actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
2) NORFIN S.r.l., préqualifiée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: cent cinquante actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Luxembourg, le 27 décembre 2002.

A. Schwachtgen.

4013

PROMOTRA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8311 Capellen, 77, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 60.204. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 30 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95010/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SIGMA CAPITAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

STATUTES

In the year two thousand two, on the fifteenth of November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange.

There appeared the following:

1. SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A., having its registered of-

fice at L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller,

2. SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, having its registered at Wickhams Cay, PO Box 662,

Road Town, Tortola, BVI,

both here represented by LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., having its registered office in Luxem-

bourg, itself represented by Mr José Correia, accountant, residing in Longwy (France) and Miss Séverine Canova, lawyer,
residing in Thionville (France), acting jointly in their respective qualities of proxyholders A and B,

by virtue of two proxies established on November 13, 2002. 
The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will re-

main annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the hereabove stated capacities, have requested the notary to inscribe as follows the

articles of association of a société anonyme which they form between themselves:

Title I.- Denomination, Registered office, Object, Duration 

Art. 1. There is established hereby a société anonyme under the name of SIGMA CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activities

of the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office shall
be declared to have been transferred abroad provisionally, until the complete cessation of such extraordinary events.
Such provisional transfer shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the
registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the corporation which is
best situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 4. The corporation may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect

of real estate or moveable property, which the corporation may deem useful to the accomplishment of its purposes. 

The corporation may furthermore carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquiring of par-

ticipating interests in any enterprises in whatever form and the administration, management, control and development
of those participating interests.

In particular, the corporation may use its funds for the establishment, management, development and disposal of a

portfolio consisting of any securities and patents of whatever origin, and participate in the creation, development and
control of any enterprise, the acquisition, by way of investment, subscription, underwriting or option, of securities and
patents, to realize them by way of sale, transfer, exchange or otherwise develop such securities and patents, grant to
companies in which the corporation has a participating interest, any support, loans, advances or guarantees.

Title II.- Capital, Shares 

Art. 5. The subscribed capital of the corporation is fixed at thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) represented

by three thousand one hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a decision of the general meeting of share-

holders, voting with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be evidenced at the owners option, in certificates representing single shares or in certificates representing

two or more shares.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder’s option.
The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

Signature.

4014

Title III.- Management 

Art. 6. The corporation shall be managed by a board of directors composed of at least three members, either share-

holders or not, who shall be appointed for a term not exceeding six years, by a general meeting of shareholders. They
may be reelected and may be removed at any time by a general meeting of shareholders. 

The number of directors and their term of office shall be fixed by a general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy on the board of directors, the remaining directors have the right to fill in the vacancy, which

decision has to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
A meeting of the board of directors shall be convened at any time upon call by the chairman or at the request of not

less than two directors.

The board of directors may validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,

a proxy between directors, which may be given by letter, telegram, telex or telefax being permitted. In case of emer-
gency, directors may vote by letter, telegram, telex or telefax. Resolutions shall require a majority vote.

In case of a tie, the chairman has a casting vote.

Art. 8. The board of directors shall have the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object stated in Article 4 hereof.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to a general meeting of sharehold-

ers, shall fall within the competence of the board of directors.

The board of directors may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 9. The corporation shall be bound in all circumstances by the joint signature of two directors or by the sole

signature of the managing director, provided that special arrangements have been reached concerning the authorized
signature in the case of a delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to Article 10 hereof.

Art. 10. The board of directors may delegate its powers for the conduct of the daily management of the corporation,

to one or more directors, who will be called managing directors.

The board of directors may also commit the management of all or part of the affairs of the corporation, to one or

more managers, and give special powers for determined matters to one or more proxyholders. Such proxyholder or
manager shall not be required to be a director or a shareholder.

Delegation to a member of the board of directors is subject to a prior authorization of the general meeting.

Art. 11. Any litigation involving the corporation either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

corporation by the board of directors, represented by its chairman or by a director delegated for such purpose.

Title IV.- Supervision 

Art. 12. The corporation shall be supervised by one or more statutory auditors, appointed by a general meeting of

shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such office not to exceed six years. 

They may be reelected and removed at any time.

Title V.- General meeting 

Art. 13. The annual general meeting of shareholders will be held in the commune of the registered office at the place

specified in the convening notices on the first day of March at 11.30 a.m. and the first time in the year 2004.

If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
If all the shareholders are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda,

the general meeting may take place without previous convening notices. Each share gives the right to one vote.

Title VI.- Accounting year, Allocation of profits 

Art. 14. The accounting year of the corporation shall begin on the 1st of January and shall terminate on the 31st of

December of each year, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation
of the corporation and shall terminate on the 31st of December 2003.

Art. 15. After deduction of any and all expenses and amortizations of the corporation, the credit balance represents

the net profits of the corporation. Of such net profit, five per cent (5%) shall be compulsorily appropriated for the legal
reserve; such appropriation shall cease when the legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the cor-
poration, but shall be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time and for whatever reason, the
legal reserve has fallen below the required ten per cent of the capital of the corporation (10%).

The balance of the net profit is at the disposal of the general meeting.

Title VII.- Dissolution, Liquidation 

Art. 16. The corporation may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation

will be carried out by one or more liquidators, appointed by the general meeting of shareholders which will specify their
powers and fix their remuneration.

Title VIII.- General provisions 

Art. 17. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of

August 10th 1915 on commercial companies and the amendments thereto.

4015

<i>Subscription and payment

The shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th

1915 on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately two thousand Euro (2,000.-
EUR).

<i>Extraordinary general meeting

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convoked,

have immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, they have passed the following resolutions by unanimous vote:
1.- The number of directors is fixed at three and the number of auditors at one.
2.- The following have been elected as directors, their term of office expiring at the General Meeting of the year 2008:
a) Mr Vesselin Danev, Banker, having his domicile at 195 Boardwalk Place, London E14 5SQ, United Kingdom,
b) Mr Georgi Veltchev, Securities Dealer, having his domicile at 56 Kensington Heights, 91-95 Campden Hill Road,

London W8 7BD, United Kingdom,

c) Mr Ivo Evgeniev, Manager, having his domicile at 58, Leva str, V4D, Vratza 3.000, Bulgaria.
3.- The following has been appointed as statutory auditor, his term of office expiring at the General Meeting of the

year 2008: 

C.A.S. SERVICES S.A., having its registered office in Luxembourg.
4.- The registered office of the company is established in L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is

worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German text,
the English version will be binding.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present original

deed.

Folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahre zweitausendzwei, am fünfzehnten November.
Vor dem unterzeichneten Notar Gérard Lecuit, im Amtswohnsitze zu Hesperingen.

Sind erschienen:

1. SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A., mit Gesellschaftssitz in

L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller,

2. SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, mit Gesellschaftssitz in Wickhams Cay, PO Box 662,

Road Town, Tortola, BVI,

beide Gesellschaften hier vertreten durch LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A., mit Gesellschaftssitz

in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn José Correia, comptable, wohnhaft in Longwy (France) und Fräulein Séverine
Canova, juriste, wohnhaft in Thionville (France), handelnd in ihrer Eigenschaft als Prokurist A und B,

auf Grund von zwei Vollmachten unter Privatschrift ausgestellt 13. November 2002,
welche Vollmachten, nach ne varietur Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar, vorlie-

gender Urkunde beigebogen bleiben, um mit derselben einregistriert zu werden.

Diese Komparenten, vertreten wie angegeben, ersuchten den amtierenden Notar nachfolgenden durch alle Kompa-

renten vereinbarten Gesellschaftsvertrag einer anonymen Gesellschaft zu beurkunden wie folgt:

Titel I. Bezeichnung, Gesellschaftssitz, Zweck, Dauer 

Art. 1. Es wird eine anonyme Gesellschaft gegründet unter der Bezeichnung SIGMA CAPITAL INVESTMENTS S.A.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort im Grossherzogtum Luxemburg ver-

legt werden.

Falls aussergewöhnliche politische oder wirtschaftliche Ereignisse eintreten oder unmittelbar bevorstehen, welche die

normale Tätigkeit dieses Sitzes oder die Kommunikation dieses Sitzes mit dem Ausland gefährden, kann die provisori-
sche Verlegung des Gesellschaftssitzes ins Ausland erklärt werden, dies solange bis zur vollständigen Beendigung der
anormalen Umstände. Eine solche Entscheidung wird die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft nicht beeinträchtigen. Die
Erklärung betreffend den Verleg des Gesellschaftssitzes wird Dritten durch das Gesellschaftsorgan mitgeteilt, das unter
den gegebenen Umständen am besten hierfür geeignet ist.

1. SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A., prenamed, three

thousand ninety-nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,099

2. SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, prenamed, one share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three thousand one hundred shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,100

4016

Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 4. Die Gesellschaft ist ermächtigt alle geschäftlichen, industriellen oder finanziellen Operationen sowie alle Ue-

berträge von beweglichem und unbeweg-lichem Eigentum durchzuführen.

Gesellschaftszweck sind ausserdem alle direkt oder indirekt mit der Beteiligung, gleich in welcher Form, an jeglichen

Unternehmen verbundenen Operationen, sowie die Verwaltung, die Führung, die Kontrolle und die Verwertung dieser
Beteiligungen.

Sie kann ihre Mittel zur Erstellung, Führung, Verwertung und Liquidation eines aus allen Titeln und Patenten jeglicher

Herkunft zusammengesetzten Portfolios verwenden, an der Gründung, Entwicklung und Kontrolle jeglicher Unterneh-
men teilnehmen, jegliche Titel und Patente durch Übertragung, Zeichnung, Übernahme oder Kaufoption und auf jegliche
andere Art erstehen, sie durch Kauf, Abtretung, Austausch oder auf sonst eine Weise veräussern, diese Geschäfte und
Patente verwerten lassen, den Gesellschaften, an denen sie Interesse hat, sämtliche Hilfe, Darlehen, Vorschüsse oder
Garantien geben.

Titel II. Kapital, Aktien 

Art. 5. Das Gesellschaftskapital wurde festgesetzt auf einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR) eingeteilt in drei-

tausendeinhundert (3.100) Aktien mit einem Nominalwert von je zehn Euro (10,- EUR).

Das gezeichnete Gesellschaftskapital kann aufgestockt oder vermindert werden mittels Beschlussfassung der Gene-

ralversammlung der Aktionäre in Übereinstimmung mit den Bestimmungen über Satzungsänderungen.

Die Gesellschaft kann je nach Wunsch der Aktieninhaber Global- oder Einzelaktien ausstellen.
Die Aktien können als Namens- oder Inhaberaktien ausgestellt werden, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft kann den Wiederkauf ihrer eigenen Aktien unter den gesetzlich gegebenen Bedingungen veranlassen.

Titel III. Verwaltung 

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat mit wenigstens drei Mitgliedern, Teilhaber oder nicht, verwaltet, die

von der Generalversammlung der Aktionäre für eine Zeitspanne genannt sind, die nicht mehr als sechs Jahre betragen
kann. Sie können zu jeder Zeit von der Generalversammlung wiedergewählt oder abberufen werden.

Die Zahl der Verwalter und die Dauer ihres Mandates werden von der Generalversammlung der Gesellschaft fest-

gesetzt.

Im Falle einer unbesetzten Stelle im Verwaltungsrat haben die bleibenden Verwalter das Recht diese provisorisch zu

besetzen, die getroffene Entscheidung wird in der nächsten Versammlung ratifiziert. 

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt eines seiner Mitglieder zum Vorsitzenden.
Der Verwaltungsrat tagt auf Einberufung des Vorsitzenden oder auf Anfrage von zwei Verwaltungsratsmitgliedern.
Die vom Verwaltungsrat getroffenen Entscheidungen und Beschlüsse sind nur gültig wenn die Mehrheit der Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Eine Vertretung unter Verwaltungsratsmitgliedern ist möglich und kann durch Brief, Tele-
gramm, Telex oder Fax erfolgen.

In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder per Brief, Telegramm, Telex oder Fax ihre Stimme ab-

geben.

Die Beschlüsse werden durch Stimmenmehrheit getroffen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.
Art. 8. Dem Verwaltungsrat obliegen die weitreichendsten Befugnisse zur Durchführung aller Verwaltungshandlun-

gen und Beschlüsse, die sich im Rahmen des im vorhergehenden Artikel 4 erläuterten Gesellschaftszweckes befinden.

Er ist zu allen Handlungen ermächtigt, die nicht ausschliesslich durch das Gesetz und die Statuten der Generalver-

sammlung vorbehalten sind.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt unter den vom Gesetz vorgesehenen Bedingungen, Dividendenvorschüsse auszu-

zahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird in allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die Unterschrift eines Delegierten des Verwaltungsrates verpflichtet, unbeschadet der Beschlüsse
betreffend die Erteilung von Untervollmachten und Mandaten, welche vom Verwaltungsrat im Rahmen von Artikel 10
der Satzung erteilt werden. 

Art. 10. Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder übertragen,

welche als Delegierte des Verwaltungsrates ernannt werden.

Der Verwaltungsrat kann auch die Geschäftsführung ganz oder teilweise an einen oder mehrere Direktoren übertra-

gen oder einem oder mehreren Bevollmächtigten besondere Vollmachten erteilen. Bei dem Bevollmächtigten oder Di-
rektor muss es sich nicht unbedingt um ein Verwaltungsratsmitglied oder Aktionär handeln.

Die Übertragung von Befugnissen an ein Mitglied des Verwaltungsrates unterliegt der vorherigen Zustimmung der

Generalversammlung.

Art. 11.  Alle gerichtlichen Streitigkeiten der Gesellschaft, sei es als Kläger oder als Angeklagter, werden vom Ver-

waltungsrat verfolgt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch eines hierzu ermächtigten Mitgliedes vertreten ist.

Titel IV. Überwachung 

Art. 12. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren, von der Generalversammlung ernannten Kommissaren

überwacht. Sie setzt ihre Zahl, Vergütung und die Dauer ihres Mandates fest, welches nicht mehr als sechs Jahre betra-
gen kann.

Sie können zu jedem Zeitpunkt wiedergewählt oder abberufen werden.

Titel V. Generalversammlung 

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung tagt innerhalb der Gemeinde des Gesellschaftssitzes, an dem in den Ein-

berufungen angegebenen Ort, am 1. März eines jeden Jahres um 11.30 Uhr und zum ersten Male im Jahre 2004. 

Falls dieses Datum ein gesetzlicher Feiertag ist, tagt die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Arbeitstag.

4017

Wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und erklären, von der Tagesordnung Kenntnis genommen zu ha-

ben, kann die Generalversammlung auch ohne vorherige Einberufung stattfinden.

Titel VI. Geschäftsjahr, Aufteilung des Gewinns 

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember eines jeden Jahres.
Das erste Geschäftsjahr erstreckt sich ausnahmsweise über die Zeit von der Gründung der Gesellschaft an bis zum

31. Dezember 2003.

Art. 15. Der positive Ueberschuss des Jahresabschlusses, nach Abzug der Sozialbeiträge und Abschreibungen bildet

den Nettogewinn der Gesellschaft. Diesem Gewinn werden fünf Prozent für die Erstellung eines legalen Reservefonds
entnommen; diese Entnahme ist nicht mehr erforderlich, wenn die Reserve ein Zehntel des Gesellschaftskapitals beträgt,
muss jedoch wieder aufgenommen werden, wenn zu einem gewissen Zeitpunkt und aus welchem Grund auch immer,
auf den Reservefonds zurückgegriffen wurde.

Die Generalversammlung kann darüberhinaus über den Saldo verfügen.

Titel VII. Auflösung, Liquidation 

Art. 16. Die Gesellschaft kann auf Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden.
Bei Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere von der Generalversammlung er-

nannten Liquidatoren, deren Befugnisse und Entgeld sie bestimmt.

Titel VIII. Allgemeine Bestimmungen 

Art. 17. Für alle in den vorliegenden Statuten nicht erfassten Punkte beziehen sich die Parteien auf die Bestimmungen

des luxemburger Gesetzes vom 10. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften wie deren Abänderungen, denen
sie sich unterwerfen.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Aktien wurden gezeichnet wie folgt: 

Das gezeichnete Kapital wurde vollständig in bar eingezahlt. Somit verfügt die Gesellschaft ab sofort über einen Betrag

von einunddreissigtausend Euro (31.000,- EUR), worüber dem amtierenden Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Feststellung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaf-

ten vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

<i>Schätzung und Gründungskosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr zweitausend Euro (2.000,- EUR). 

<i>Ausserordentliche Hauptversammlung

Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen

Hauptversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekannten und fassten einstimmig folgende Be-
schlüsse:

1) Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und die Zahl der Kommissare auf einen festgesetzt.
2) Zu Verwaltungsratsmitgliedern, deren Mandate bei der Generalversammlung des Geschäftsjahres 2008 enden,

wurden bestellt:

a) Herr Vesselin Danev, Banker, wohnhaft in 195 Boardwalk Place, London E14 5SQ, England,
b) Herr Georgi Veltchev, Securities Dealer, wohnhaft in 56 Kensington Heights, 91-95 Campden Hill Road, London

W8 7BD, England,

c) Herr Ivo Evgeniev, Manager, wohnhaft in 58, Leva str, V4D, Vratza 3.000, Bulgarien.
3) Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wurde bestellt:
C.A.S. SERVICES S.A. mit Gesellschaftssitz in Luxemburg.
4) Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-2519 Luxemburg, 9, rue Schiller.
Der amtierende Notar, welcher Kenntnis der englischen Sprache hat, bestätigt dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in englischer Sprache gehalten ist gefolgt von einer deutsche Übersetzung, und dass im Falle von
Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der deutschen Fassung, die englische Fassung massgebend ist.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen am Datum wie eingangs erwähnt zu Luxemburg.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben diese mit Uns, Notar, vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: J. Correia, S. Canova, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 27 novembre 2002, vol. 137S, fol. 17, case 3. – Reçu 310 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Anfrage erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil

des Sociétés et Associations.

(94926/220/294) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

SIGMA CAPITAL HOSPITALITY, LEISURE AND TOURISM HOLDING COMPANY S.A., vorbenannt  3.099 Aktien
SIGMA CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEMENT LTD, vorbenannt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 Aktie

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.100 Aktien

Hesperingen, den 12. Dezember 2002.

G. Lecuit.

4018

JABE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8322 Olm, 21, rue Charles de Gaulle.

R. C. Luxembourg B 81.177. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Capellen, le 30 décembre 2002, vol. 139, fol. 61, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95011/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PRADERA HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Share capital: EUR 12,500.-.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.621. 

In the year two thousand and two, on the twenty-sixth November.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange (Grand Duchy of Luxembourg).

There appeared:

PRADERA MANAGEMENT, S.à r.l., a limited liability company («société à responsabilité limitée») incorporated un-

der the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (Grand Duchy of Lux-
embourg), incorporated by deed of Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch (Grand Duchy of
Luxembourg), of September 26, 2000, published in the Mémorial C n° 794 on October 30, 2000, registered with the
Luxembourg register of commerce and companies under n° B 77.910, acting for the account of and in the exclusive
interest of the unitholders of PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, a Fonds Commun de Placement established under
the Luxembourg law of July 19, 1991 on undertakings for collective investment, the securities of which are not intended
to be placed with the public;

hereby represented by Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg

(Grand Duchy of Luxembourg) on 26 November 2002,

The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, acting in its capacity as single partner of PRADERA HOLDCO, S.à r.l., has requested the under-

signed notary to document the following:

The appearing party is the single partner of PRADERA HOLDCO, S.à r.l., a limited liability company («société à re-

sponsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-
1470 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), (the «Company»), incorporated by deed of Maître Jean-Joseph Wag-
ner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), of February 5, 2002, published in the Mémorial C n° 950
of June 2, 2002, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under n° B 86.621.

The appearing party, represented as above mentioned, recognises that it has been fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. To increase the Company’s subscribed capital by an amount of thirty-six million six hundred and twenty-four thou-

sand five hundred euro (EUR 36,624,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred twenty-five (125) shares, each share with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-) to thirty-six million six hundred and thirty-seven thousand euro (EUR 36,637,000.-) divided into three
hundred and sixty-six thousand three hundred seventy (366,370) shares, each share with a nominal value of one hundred
euro (EUR 100.-).

2. To issue, with a total share premium of two million seven hundred and forty-one thousand nine hundred ninety-

nine euro and forty cent (EUR 2,741,999.40), three hundred and sixty-six thousand two hundred and forty-five (366,245)
new shares with ten (10) warrants per share so as to raise the number of shares from one hundred twenty-five (125)
shares to three hundred and sixty-six thousand three hundred seventy (366,370) shares, each share with a nominal value
of one hundred euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and
entitlement to dividends as from the day of the decision of the single partner resolving on the proposed capital increase.

3. To accept the subscription of three hundred and sixty-six thousand two hundred and forty-five (366,245) shares

with ten (10) warrants per share, each share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) by the following
companies (collectively the «Contributors»):

(i) COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à re-

sponsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe,
L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and com-
panies under n° B 79.533;

(ii) COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à responsa-

bilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-
2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and compa-
nies under n° B 84.832;

(iii) COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à

responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte

Signature.

4019

Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and
companies under n° B 79.534;

(iv) COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à responsabilité

limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763
Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and companies un-
der n° B 79.535;

(v) COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à respon-

sabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-
2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and compa-
nies under n° B 79.536;

(vi) COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à respon-

sabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe, L-
2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and compa-
nies under n° B 84.833;

(vii) COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à re-

sponsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe,
L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and com-
panies under n° B 79.537;

(viii) COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à re-

sponsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe,
L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and com-
panies under n° B 84.834;

(ix) COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à re-

sponsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe,
L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and com-
panies under n° B 79.538;

and to accept payment in full of each of these shares with ten (10) warrants per share by a contribution in kind con-

sisting of all the assets and liabilities of each of the Contributors.

4. To amend article 6 of the articles of incorporation of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted

under items 1 to 3 of the agenda.

5. To amend the articles of incorporation of the Company to provide for the possibility to set-up a share premium

account into which any payment made on any share in addition to its nominal value (including any payment made on
warrants attached to any shares) is transferred.

6. To create an authorized capital in an amount of four hundred and two million eight hundred and eighty-two thou-

sand euro (EUR 402,882,000.-) divided into four million twenty-eight thousand eight hundred and twenty (4,028,820)
shares, each share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), and to authorize the management of the Com-
pany, during a period ending five (5) years after the date of publication of the minutes of the general meeting of partners
creating the authorized capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share capital within the limits of the author-
ized capital, on one or several occasions, by issuing shares to the existing holders of shares or any persons that have
been approved by the partners subject to the same quorum and majority requirements as provided by article 189 par-
agraph 1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

and has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The single partner resolves to increase the Company’s subscribed capital by an amount of thirty-six million six hun-

dred and twenty-four thousand five hundred euro (EUR 36,624,500.-) so as to raise it from its current amount of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) divided into one hundred twenty-five (125) shares, each share with a nominal
value of one hundred euro (EUR 100.-) to thirty-six million six hundred and thirty-seven thousand euro (EUR
36,637,000.-) divided into three hundred and sixty-six thousand three hundred seventy (366,370) shares, each share
with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-).

<i>Second resolution

The single partner resolves to issue three hundred and sixty-six thousand two hundred and forty-five (366,245) new

shares with warrants, corresponding to, in aggregate, ten (10) warrants per share so as to raise the number of shares
from one hundred twenty-five (125) shares to three hundred and sixty-six thousand three hundred seventy (366,370)
shares, each share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), having the same rights and privileges as the
existing shares and an entitlement to dividends as from the day of these resolutions, with a total share premium of two
million seven hundred and forty-one thousand nine hundred ninety-nine euro and forty cent (EUR 2,741,999.40) corre-
sponding to the total subscription price of the three million six hundred and sixty-two thousand four hundred and fifty
(3,662,450) warrants attached to these three hundred and sixty-six thousand two hundred and forty-five (366,245) new
shares, each warrant granting to its holder the right and option to subscribe for one (1) share of the Company on the
terms and conditions as set out by the management of the Company.

<i>Subscription

1. Thereupon appeared Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized at-

torney in fact of COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («so-
ciété à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of com-

4020

merce and companies under n° B 79.533; by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on
26 November 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBEN-

DAS (N°1), S.à r.l., for twelve thousand six hundred and thirty-nine (12,639) shares with one hundred and twenty-six
thousand three hundred ninety-four (126,394) warrants of the Company, with a share premium of ninety-four thousand
six hundred and twenty-eight euro and fifty-three cent (EUR 94,628.53) and to make payment in full for each such new
shares with the above-mentioned warrants attached by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities
of COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., (the «ALCOBENDAS Assets and Liabilities»).

The ALCOBENDAS Assets and Liabilities represent a net contribution of an aggregate amount of one million three

hundred and fifty-eight thousand five hundred sixty-eight euro and fifty-four cent (EUR 1,358,568.54).

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., acting through its duly authorized attorney in fact de-

clared that there exists no impediments to the free transferability of all the ALCOBENDAS Assets and Liabilities to the
Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the ALCOBENDAS Assets and Liabilities to
the Company.

Proof of the ownership by COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., of the ALCOBENDAS As-

sets and Liabilities has been given to the undersigned notary.

2. Thereupon appeared Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized at-

torney in fact of COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société
à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and
companies under n° B 84.832; by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on 26 Novem-
ber 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE

(N°1), S.à r.l., for twenty-two thousand one hundred and forty-seven (22,147) shares with two hundred and twenty-one
thousand four hundred and sixty-eight (221,468) warrants of the Company, with a share premium of one hundred and
sixty-five thousand eight hundred and eight euro and forty-four cent (EUR 165,808.44) and to make payment in full for
each such new shares with the above-mentioned warrants attached by a contribution in kind consisting of all the assets
and liabilities of COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l. (the «ALICANTE Assets and Liabilities»).

The ALICANTE Assets and Liabilities represent a net contribution of an aggregate amount of two million three hun-

dred eighty thousand four hundred eighty-one euro and eighty-one cent (EUR 2,380,481.81).

COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l., acting through its duly authorized attorney in fact declared

that there exist no impediments to the free transferability of all the ALICANTE Assets and Liabilities to the Company
without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registra-
tions or other formalities necessary to perform a valid transfer of the ALICANTE Assets and Liabilities to the Company.

Proof of the ownership by COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l. of the ALICANTE Assets and

Liabilities has been given to the undersigned notary.

3. Thereupon appeared Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized at-

torney in fact of COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l., a private limited liability company
(«société à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40,
rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of com-
merce and companies under n° B 79.534; by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on
26 November 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE

SEVILLA (N°1), S.à r.l. for fifty-three thousand two hundred and seventy-six (53,276) shares with five hundred and thir-
ty-two thousand seven hundred and sixty-five (532,765) warrants of the Company, with a share premium of three hun-
dred and ninety-eight thousand eight hundred and sixty-nine euro and ninety-seven cent (EUR 398,869.97) and to make
payment in full for each such new shares with the above-mentioned warrants attached by a contribution in kind consist-
ing of all the assets and liabilities of COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l. (the «ALJARAFE
Assets and Liabilities»).

The ALJARAFE Assets and Liabilities represent a net contribution of an aggregate amount of five million seven hun-

dred and twenty-six thousand five hundred and twenty-three euro and twenty-two cent (EUR 5,726,523.22).

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l. acting through its duly authorized attorney in fact

declared that there exist no impediments to the free transferability of all the ALJARAFE Assets and Liabilities to the
Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the ALJARAFE Assets and Liabilities to the
Company.

Proof of the ownership by COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l. of the ALJARAFE Assets

and Liabilities has been given to the undersigned notary.

4. Thereupon appeared Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized at-

torney in fact of COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société à re-
sponsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte Zithe,
L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and com-
panies under n° B 79.535; by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on 26 November
2002.

4021

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ

(N°1), S.à r.l. for eighty-one thousand four hundred and eighty-nine (81,489) shares with eight hundred and fourteen
thousand eight hundred and eighty-six (814,886) warrants of the Company, with a share premium of six hundred and
ten thousand eighty-eight euro and four cent (EUR 610,088.04) and to make payment in full for each such new shares
with the above-mentioned warrants attached by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of COM-
MERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l. (the «CADIZ Assets and Liabilities»).

The CADIZ Assets and Liabilities represent a net contribution of an aggregate amount of eight million seven hundred

and fifty-eight thousand nine hundred and forty-two euro and ninety-seven cent (EUR 8,758,942.97).

COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l. acting through its duly authorized attorney in fact declared that

there exist no impediments to the free transferability of all the CADIZ Assets and Liabilities to the Company without
any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registrations or
other formalities necessary to perform a valid transfer of the CADIZ Assets and Liabilities to the Company.

Proof of the ownership by COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l. of the CADIZ Assets and Liabilities

has been given to the undersigned notary.

5. Thereupon appeared Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized at-

torney in fact of COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société
à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and
companies under n° B 79.536; by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on 26 Novem-
ber 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA

(N°1), S.à r.l. for one hundred and one thousand eight hundred and ninety-seven (101,897) shares with one million eight-
een thousand nine hundred and seventy-four (1,018,974) warrants of the Company, with a share premium of seven hun-
dred and sixty-two thousand eight hundred and eighty-four euro and forty-four cent (EUR 762,884.44) and to make
payment in full for each such new shares with the above-mentioned warrants attached by a contribution in kind consist-
ing of all the assets and liabilities of COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l. (the «CORDOBA Assets
and Liabilities»).

The CORDOBA Assets and Liabilities represent a net contribution of an aggregate amount of ten million nine hun-

dred and fifty-two thousand six hundred and thirty euro and forty-four cent (EUR 10,952,630.44).

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l. acting through its duly authorized attorney in fact declared

that there exist no impediments to the free transferability of all the CORDOBA Assets and Liabilities to the Company
without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registra-
tions or other formalities necessary to perform a valid transfer of the CORDOBA Assets and Liabilities to the Company.

Proof of the ownership by COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l. of the CORDOBA Assets and

Liabilities has been given to the undersigned notary.

6. Thereupon appeared Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized at-

torney in fact of COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («société
à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue Sainte
Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of commerce and
companies under n° B 84.833; by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on 26 Novem-
ber 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE

(N°1), S.à r.l. for eight thousand four hundred and thirty (8,430) shares with eighty-four thousand two hundred and
ninety-six (84,296) warrants of the Company, with a share premium of sixty-three thousand one hundred and ten euro
and sixty-four cent (EUR 63,110.64) and to make payment in full for each such new shares with the above-mentioned
warrants attached by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of COMMERCIAL INVESTMENT
GALLARTE (N°1), S.à r.l. (the «GALLARTE Assets and Liabilities»).

The GALLARTE Assets and Liabilities represent a net contribution of an aggregate amount of nine hundred six thou-

sand seventy-four euro and thirty-eight cent (EUR 906,074.38).

COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l. acting through its duly authorized attorney in fact declared

that there exist no impediments to the free transferability of all the GALLARTE Assets and Liabilities to the Company
without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications, registra-
tions or other formalities necessary to perform a valid transfer of the GALLARTE Assets and Liabilities to the Company.

Proof of the ownership by COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l. of the GALLARTE Assets and

Liabilities has been given to the undersigned notary.

7. Thereupon appeared Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized at-

torney in fact of COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («so-
ciété à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of com-
merce and companies under n° B 79.537; by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on
26 November 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMMERCIAL INVESTMENT MANRE-

GALERY (N°1), S.à r.l. for thirteen thousand eight hundred and seventeen (13,817) shares with one hundred and thirty-
eight thousand one hundred and sixty-eight (138,168) warrants of the Company, with a share premium of one hundred
and three thousand four hundred and forty-three euro and forty-eight cent (EUR 103,443.48) and to make payment in
full for each such new shares with the above-mentioned warrants by a contribution in kind consisting of all the assets

4022

and liabilities of COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l. (the «MANREGALERY Assets and Lia-
bilities»).

The MANREGALERY Assets and Liabilities represent a net contribution of an aggregate amount of one million four

hundred eighty-five thousand one hundred twenty-four euro and fifty three cent (EUR 1,485,124.53).

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l. acting through its duly authorized attorney in fact de-

clared that there exist no impediments to the free transferability of all the MANREGALERY Assets and Liabilities to the
Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the MANREGALERY Assets and Liabilities to
the Company.

Proof of the ownership by COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l. of the MANREGALERY

Assets and Liabilities has been given to the undersigned notary.

8. Thereupon appeared Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized at-

torney in fact of COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («so-
ciété à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of com-
merce and companies under n° B 84.834; by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on
26 November 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMMERCIAL INVESTMENT SAN

GIULIANO (N°1), S.à r.l. for thirty-three thousand nine hundred and fifty-three (33,953) shares with three hundred and
thirty-nine thousand five hundred and thirty-two (339,532) warrants of the Company, with a share premium of two hun-
dred and fifty-four thousand two hundred euro and forty-eight cent (EUR 254,200.48) and to make payment in full for
each such new shares with the above-mentioned warrants by a contribution in kind consisting of all the assets and lia-
bilities of COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l. (the «SAN GIULIANO Assets and Liabilities»).

The SAN GIULIANO Assets and Liabilities represent a net contribution of an aggregate amount of three million six

hundred forty-nine thousand five hundred and nineteen euro and ninety-seven cent (EUR 3,649,519.97).

COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l. acting through its duly authorized attorney in fact de-

clared that there exist no impediments to the free transferability of all the SAN GIULIANO Assets and Liabilities to the
Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the SAN GIULIANO Assets and Liabilities to
the Company.

Proof of the ownership by COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l. of the SAN GIULIANO

Assets and Liabilities has been given to the undersigned notary.

9. Thereupon appeared Jean-Paul Spang, avocat, residing in Luxembourg, acting in his capacity as duly authorized at-

torney in fact of COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l., a private limited liability company («so-
ciété à responsabilité limitée») incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 38-40, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg register of com-
merce and companies under n° B 79.538; by virtue of a proxy given in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg) on
26 November 2002.

The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of COMMERCIAL INVESTMENT TERRA-

GALERY (N°1), S.à r.l. for thirty-eight thousand five hundred and ninety-seven (38,597) shares with three hundred and
eighty-five thousand nine hundred and sixty-seven (385,967) warrants of the Company, with a share premium of two
hundred and eighty-eight thousand nine hundred and sixty-five euro thirty-nine cent (EUR 288,965.39) and to make pay-
ment in full for each such new shares with the above-mentioned warrants by a contribution in kind consisting of all the
assets and liabilities COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l. (the «TERRAGALERY Assets and Li-
abilities»).

The TERRAGALERY Assets and Liabilities represent a net contribution of an aggregate amount of four million one

hundred forty-eight thousand six hundred and thirty-seven euro twenty-seven cent (EUR 4,148,637.27).

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l. acting through its duly authorized attorney in fact de-

clared that there exist no impediments to the free transferability of all the TERRAGALERY Assets and Liabilities to the
Company without any restriction or limitation and that valid instructions have been given to undertake all notifications,
registrations or other formalities necessary to perform a valid transfer of the TERRAGALERY Assets and Liabilities to
the Company.

Proof of the ownership by COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l. of the TERRAGALERY As-

sets and Liabilities has been given to the undersigned notary.

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à

r.l., COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l., COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à
r.l., COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l., COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l.,
COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l., COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1),
S.à r.l. and COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l. (collectively the «Contributors») acting
through their respective duly authorized attorney in fact further stated that a report has been drawn up by DELOITTE
&amp; TOUCHE S.A. Luxembourg and signed by Mr Benjamin Lam, réviseur d’entreprises, in Luxembourg, on November
26, 2002, wherein the ALCOBENDAS, ALICANTE, ALJARAFE, CADIZ, CORDOBA, GALLARTE, MANREGALERY,
SAN GIULIANO and TERRAGALERY Assets and Liabilities so contributed are described and valued.

The persons appearing produced that report, the conclusions of which read as follows:
«Based on the verification procedures applied as described above, we are of the opinion that the value of the Con-

tribution is at least equal to the number and value of the 366,245 shares of nominal value EUR 100,00 each along with

4023

3,662,450 warrants with a nominal value of EUR 0.748679. We have no further comment to make on the value of the
Contribution»

That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authori-

ties.

<i>Third resolution

The single partner resolves to accept the said subscriptions and payment of each of these shares with three million

six hundred and sixty-two thousand four hundred and fifty (3,662,450) warrants corresponding to, in aggregate, ten (10)
warrants per share by a contribution in kind consisting of all the assets and liabilities of each of the Contributors and to
allot the three hundred sixty-six thousand two hundred and forty-five (366,245) shares with the above-mentioned war-
rants attached, each share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) as follows: 

<i>Fourth resolution

As a result of the above resolutions, the general meeting of partners resolves to amend article 6 of the Company’s

articles of incorporation, which shall forthwith read as follows:

«Art. 6. Capital. The capital is set at thirty-six million six hundred thirty-seven thousand euro (EUR 36,637,000.-)

represented by three hundred sixty-six thousand three hundred and seventy (366,370) shares of a nominal value of one
hundred Euro (EUR 100.-) each.»

<i>Fifth resolution

The general meeting of partners resolves to amend the articles of incorporation of the Company to provide for the

possibility to set-up a share premium account into which any payment made on any share in addition to its nominal value
(including any payment made on warrants attached to any shares) is transferred.

As a result of the above resolution, the general meeting of partners resolves to add a new paragraph 2 to article 6 of

the Company’s articles of incorporation, which shall read as follows:

«In addition to the share capital, there may be set up a share premium account into which any payment made on any

share in addition to its nominal value (including any payment made on warrants attached to any shares) is transferred.
The amount of the share premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company
may redeem from its shareholders, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to
allocate funds to the legal reserve.» 

<i>Sixth resolution

The general meeting of partners acknowledges the special report of the managers on the creation of an authorized

capital, a copy of which report will remain attached to the present deed.

The general meeting of partners resolves to create an authorized capital in an amount of four hundred and two million

eight hundred and eighty-two thousand euro (EUR 402,882,000.-) divided into four million twenty-eight thousand eight
hundred and twenty (4,028,820) shares, each share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-), and to au-
thorize the management of the Company, during a period ending five (5) years after the date of publication of the min-
utes of the general meeting of partners creating the authorized capital in the Mémorial, Recueil C, to increase the share
capital within the limits of the authorized capital, in one or several times, by issuing shares to the existing holders of
shares or any persons that have been approved by the partners at the same quorum and majority requirements as pro-
vided by article 189 paragraph 1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

As a result of the above resolution, the general meeting of partners resolves to add a new paragraph 3 to article 6 of

the Company’s articles of incorporation, which shall read as follows:

«The authorized capital of the Company is set at four hundred and two million eight hundred and eighty-two thou-

sand euro (EUR 402,882,000.-) divided into four million twenty-eight thousand eight hundred and twenty (4,028,820)
shares, each share with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-). 

The management of the Company is authorised, during a period ending five (5) years following the date of publication

of the minutes of the general meeting of partners creating the authorized capital in the Mémorial, Recueil C, to increase
the share capital within the limits of the authorized capital in one or several times by issuing shares to the existing hold-
ers of shares or any persons that have been approved by the partners at the same quorum and majority requirements
as provided by article 189 paragraph 1 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended.

Such shares may be subscribed for and issued under the terms and conditions as the management of the Company

may determine.

Contributors

Number of Number of

 shares

 warrants

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,639

126,394

COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22,147

221,468

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53,276

532,765

COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81,489

814,886

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101,897

1,018,974

COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8,430

84,296

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,817

138,168

COMMERCIAL INVESTMENT SAN GUILIANO (N°1), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33,953

339,532

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,597

385,967

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366,245

3,662,450

4024

The management of the Company may in particular determine:
* the time and the number of shares to be subscribed and issued; 
* whether a share premium will be paid on the shares to be subscribed and issued and the amount of such share

premium if any; 

* whether the shares will be paid-in by a contribution in cash or in kind; and
* that shares will be issued following the exercise of the subscription and/or conversion rights granted by the man-

agement of the Company under the terms of warrants (which may be separate or attached to shares, bonds, notes or
similar instruments), convertible bonds or notes or similar instruments issued from time to time by the Company. 

The management of the Company may delegate to any authorised manager or officer of the Company or to any other

duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all
of such increased amounts of capital. 

Upon each increase of the share capital of the Company by the management of the Company within the limits of the

authorized capital, the present article 6 shall be amended accordingly.» 

<i>Expenses

Insofar as the contribution in kind results in each of the companies listed herebelow, contributing all its assets and

liabilities to the Company, the latter refers to Article 4-1 of the law of December 29, 1971 which provides for a capital
tax exemption in such case:

(i) COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l.; 
(ii) COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l.; 
(iii) COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l.; 
(iv) COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l.;
(v) COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l.; 
(vi) COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l.; 
(vii) COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l.;
(viii) COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l.; and 
(ix) COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l.
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of

this document are estimated at approximately seven thousand five hundred Euro (7,500.- EUR).

Whereof the present deed was drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of this document. 
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-six novembre,
Par devant Nous, Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à Hesperange (Grand-Duché de Luxembourg).

A comparu:

PRADERA MANAGEMENT, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), constituée par acte de Maître Edmond
Schroeder, notaire résidant à Mersch (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 septembre 2000, publié au Mémorial C nu-
méro 794 le 30 octobre 2000, enregistré au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
77.910, agissant pour le compte et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts de PRADERA EUROPEAN RETAIL
FUND, un Fonds Commun de Placement établi selon la loi luxembourgeoise du 19 juillet 1991 concernant les organis-
mes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public;

représentée aux fins des présentes par Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, aux termes d’une procuration

sous seing privé donnée à Luxembourg, le 26 novembre 2002.

Ladite procuration sera annexée au présent acte pour les besoins de l’enregistrement. 
Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de PRADERA HOLDCO, S.à r.l., a demandé au notaire

soussigné de prendre acte de ce qui suit:

Lequel comparant est l’associé unique de PRADERA HOLDCO, S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit

luxembourgeois, ayant son siège social au 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), (la
«Société»), constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxem-
bourg), le 5 février 2002, publié au Mémorial C numéro 950 du 2 juin 2002, enregistré au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro B 86.621.

Lequel comparant, représenté comme mentionné ci-dessus, reconnaît être parfaitement au courant des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour:

1. Augmentation du capital souscrit de la Société d’un montant de trente-six millions six cent vingt-quatre mille cinq

cents euros (EUR 36.624.500,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100)
chacune, à trente-six millions six cent trente-sept mille euros (EUR 36.637.000,-) divisé en trois cent soixante-six mille
trois cent soixante-dix (366.370) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

4025

2. Emission, avec une prime d’émission totale de deux millions sept cent quarante et un mille neuf cent quatre-vingt-

dix-neuf euros et quarante cents (EUR 2.741.999,40), de trois cent soixante-six mille deux cent quarante-cinq (366.245)
nouvelles parts sociales auxquelles sont attachés dix (10) warrants par part sociale, de façon à porter le nombre de parts
sociales de cent vingt-cinq (125) parts sociales à trois cent soixante-six mille trois cent soixante-dix (366.370) parts so-
ciales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, ces parts sociales ayant les mêmes droits et privi-
lèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à partir du jour de la
décision de l’associé unique décidant de l’augmentation de capital proposée.

3. Acceptation de la souscription de trois cent soixante-six mille deux cent quarante-cinq (366.245) parts sociales

auxquelles sont attachés dix (10) warrants par part sociale, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros
(EUR 100), par les sociétés suivantes (collectivement les «Apporteuses»):

(i) COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.533;

(ii) COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.832;

(iii) COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en-
registrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.534;

(iv) COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.535;

(v) COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.536;

(vi) COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.833;

(vii) COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en-
registrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.537;

(viii) COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en-
registrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.834;

(ix) COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en-
registrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.538;

et acceptation de la libération intégrale de chacune de ces parts sociales auxquelles sont attachés dix (10) warrants

par part sociale, par un apport en nature consistant dans l’ensemble des actifs et passifs de chacune des Apporteuses.

4. Modification de l’article 6 des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions devant être adoptées sous

les points 1 à 3 de l’ordre du jour.

5. Modification des statuts de la Société afin de prévoir la possibilité d’ouvrir un compte de prime d’émission sur le-

quel sera transféré tout paiement effectué sur toute part sociale en supplément de sa valeur nominale (comprenant tout
paiement effectué sur les warrants attachés aux parts sociales).

6. Création d’un capital autorisé d’un montant de quatre cent deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille euros

(EUR 402.882.000,-) divisé en quatre millions vingt-huit mille huit cent vingt (4.028.820) parts sociales, ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100) chacune, et autorisation de la gérance de la Société, pendant une période prenant
fin cinq (5) années après la date de publication dans le Mémorial, Recueil C, du procès-verbal de l’assemblée générale
des associés créant le capital autorisé, d’augmenter le capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plu-
sieurs fois, par l’émission de parts sociales aux détenteurs de parts sociales existants ou à toute personne qui a été ap-
prouvée par les associés aux mêmes conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 189, alinéa 1, de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

et a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de trente-six millions six cent vingt-

quatre mille cinq cents euros (EUR 36.624.500,-) de manière à porter le capital social de son montant actuel de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent vingt-cinq (125) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent
euros (EUR 100) chacune à trente-six millions six cent trente-sept mille euros (EUR 36.637.000,-) divisé en trois cent
soixante-six mille trois cent soixante-dix (366.370) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euro (EUR 100)
chacune.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’émettre trois cent soixante-six mille deux cent quarante-cinq (366.245) nouvelles parts so-

ciales auxquelles sont attachés des warrants correspondant, de manière agrégée, à dix (10) warrants par part sociale,
de façon à porter le nombre de parts sociales de cent vingt-cinq (125) parts sociales à trois cent soixante-six mille trois
cent soixante-dix (366.370), ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, ces parts sociales ayant les

4026

mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes et participant aux bénéfices de la Société à
partir du jour de ces résolutions, avec une prime d’émission totale de deux millions sept cent quarante et un mille neuf
cent quatre-vingt dix-neuf euros et quarante cents (EUR 2.741.999,40) correspondant au prix de souscription total de
trois millions six cent soixante-deux mille quatre cent cinquante (3.662.450) warrants attachés à ces trois cent soixante-
six mille deux cent quarante-cinq (366.245) nouvelles parts sociales, chaque warrant conférant à son propriétaire le
droit et l’option de souscrire une (1) part sociale de la Société aux termes et conditions tels que définis par la gérance
de la Société.

<i>Souscription

1. Est intervenu ensuite Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.533; en vertu d’une procu-
ration donnée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2002.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS

(N°1), S.à r.l., douze mille six cent trente-neuf (12.639) nouvelles parts sociales de la Société, auxquelles sont attachés
cent vingt-six mille trois cent nonante-quatre (126.394) warrants, avec une prime d’émission de quatre-vingt-quatorze
mille six cent vingt-huit euros et cinquante-trois cents (EUR 94.628,53) et libérer intégralement la totalité de ces nou-
velles parts sociales auxquelles sont attachés les warrants susvisés, par un apport en nature consistant dans l’ensemble
des actifs et passifs de COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l. (les «Actifs et Passifs ALCOBEN-
DAS»).

Les Actifs et Passifs ALCOBENDAS représentent un apport net d’un montant total de un million trois cent cinquante-

huit mille cinq cent soixante-huit euros et cinquante-quatre cents (EUR 1.358.568,54).

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., agissant par le biais de son mandataire dûment autorisé

déclare qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de tous les Actifs et Passifs ALCOBENDAS à la Société sans aucu-
ne restriction ni limitation, et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifications, ins-
criptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs ALCOBENDAS à la
Société.

La preuve de la propriété par COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l. des Actifs et Passifs AL-

COBENDAS a été rapportée au notaire soussigné.

2. Est intervenu ensuite Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en-
registrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.832; en vertu d’une procuration
donnée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2002.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1),

S.à r.l. vingt-deux mille cent quarante-sept (22.147) nouvelles parts sociales de la Société, auxquelles sont attachés deux
cent vingt et un mille quatre cent soixante-huit (221.468) warrants, avec une prime d’émission de cent soixante-cinq
mille huit cent huit euros et quarante-quatre cents (EUR 165.808,44) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles
parts sociales auxquelles sont attachés les warrants susvisés, par un apport en nature consistant dans l’ensemble des
actifs et passifs de COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l. (les «Actifs et Passifs ALICANTE»).

Les Actifs et Passifs ALICANTE représentent un apport net d’un montant total de deux millions trois cent quatre-

vingt mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-un cents (EUR 2.380.481,81).

COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l. agissant par le biais de son mandataire dûment autorisé dé-

clare encore qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de tous les Actifs et Passifs ALICANTE à la Société sans
aucune restriction ni limitation, et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifications,
inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs ALICANTE à la So-
ciété.

La preuve de la propriété par COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l. des Actifs et Passifs ALICAN-

TE a été rapportée au notaire soussigné.

3. Est intervenu ensuite Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.534; en vertu d’une procu-
ration donnée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2002.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA

(N°1), S.à r.l., cinquante-trois mille deux cent soixante-seize (53.276) nouvelles parts sociales de la Société, auxquelles
sont attachés cinq cent trente-deux mille sept cent soixante-cinq (532.765) warrants, avec une prime d’émission de trois
cent nonante huit mille huit cent soixante-neuf euros et nonante-sept cents (EUR 398.869,97) et libérer intégralement
la totalité de ces nouvelles parts sociales auxquelles sont attachés les warrants susvisés, par un apport en nature con-
sistant dans l’ensemble des actifs et passifs de COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l. (les «Ac-
tifs et Passifs ALJARAFE»).

Les Actifs et Passifs ALJARAFE représentent un apport net d’un montant total de cinq millions sept cent vingt-six

mille cinq cent vingt-trois euros et vingt-deux cents (EUR 5.726.523,22).

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l., agissant par le biais de son mandataire dûment

autorisé déclare encore qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de tous les Actifs et Passifs ALJARAFE à la Société
sans aucune restriction ni limitation, et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifi-

4027

cations, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs ALJARAFE
à la Société.

La preuve de la propriété par COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l. des Actifs et Passifs

ALJARAFE a été rapportée au notaire soussigné.

4. Est intervenu ensuite Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembour-
geois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), enregistrée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.535; en vertu d’une procuration donnée
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2002.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l.,

quatre-vingt et un mille quatre cent quatre-vingt-neuf (81.489) nouvelles parts sociales de la Société, auxquelles sont
attachés huit cent quatorze mille huit cent quatre-vingt-six (814.886) warrants, avec une prime d’émission de six cent
dix mille quatre-vingt-huit euros et quatre cents (EUR 610.088,04) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles
parts sociales auxquelles sont attachés les warrants susvisés, par un apport en nature consistant dans l’ensemble des
actifs et passifs de COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l. (les «Actifs et Passifs CADIZ»).

Les Actifs et Passifs CADIZ représentent un apport net d’un montant total de huit millions sept cent cinquante-huit

mille neuf cent quarante-deux euros et quatre-vingt-dix-sept cents (EUR 8.758.942,97).

COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l. agissant par le biais de son mandataire dûment autorisé déclare

encore qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de tous les Actifs et Passifs CADIZ à la Société sans aucune res-
triction ni limitation, et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifications, inscriptions
ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs CADIZ à la Société.

La preuve de la propriété par COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l. des Actifs et Passifs CADIZ a été

rapportée au notaire soussigné.

5. Est intervenu ensuite Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en-
registrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.536; en vertu d’une procuration
donnée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2002.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1),

S.à r.l., cent et un mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (101.897) nouvelles parts sociales de la Société, auxquelles sont
attachés un million dix-huit mille neuf cent soixante-quatorze (1.018.974) warrants, avec une prime d’émission de sept
cent soixante-deux mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-quatre cents (EUR 762.884,44) et libérer in-
tégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales auxquelles sont attachés les warrants susvisés, par un apport en
nature consistant dans l’ensemble des actifs et passifs de COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l. (les
«Actifs et Passifs CORDOBA»).

Les Actifs et Passifs CORDOBA représentent un apport net d’un montant total de dix millions neuf cent cinquante-

deux mille six cent trente euros et quarante-quatre cents (EUR 10.952.630,44).

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l., agissant par le biais de son mandataire dûment autorisé

déclare encore qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de tous les Actifs et Passifs CORDOBA à la Société sans
aucune restriction ni limitation, et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifications,
inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs CORDOBA à la
Société.

La preuve de la propriété par COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l. des Actifs et Passifs COR-

DOBA a été rapportée au notaire soussigné.

6. Est intervenu ensuite Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en-
registrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.833; en vertu d’une procuration
donnée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2002.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1),

S.à r.l., huit mille quatre cent trente (8.430) nouvelles parts sociales de la Société, auxquelles sont attachés quatre-vingt-
quatre mille deux cent quatre-vingt-seize (84.296) warrants, avec une prime d’émission de soixante-trois mille cent dix
euros et soixante-quatre cents (EUR 63.110,64) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales aux-
quelles sont attachés les warrants susvisés, par un apport en nature consistant dans l’ensemble des actifs et passifs de
COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l. (les «Actifs et Passifs GALLARTE»).

Les Actifs et Passifs GALLARTE représentent un apport net d’un montant total de neuf cent six mille soixante-qua-

torze euros et trente-huit cents (EUR 906.074,38).

COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l., agissant par le biais de son mandataire dûment autorisé dé-

clare encore qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de tous les Actifs et Passifs GALLARTE à la Société sans
aucune restriction ni limitation, et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifications,
inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs GALLARTE à la
Société.

La preuve de la propriété par COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l. des Actifs et Passifs Gallarte

a été rapportée au notaire soussigné.

7. Est intervenu ensuite Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit

4028

luxembourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.537; en vertu d’une procu-
ration donnée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2002.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY

(N°1), S.à r.l., treize mille huit cent dix-sept (13.817) nouvelles parts sociales de la Société, auxquelles sont attachés cent
trente-huit mille cent soixante-huit (138.168) warrants, avec une prime d’émission de cent trois mille quatre cent qua-
rante-trois euros et quarante-huit cents (EUR 103.443,48) et libérer intégralement la totalité de ces nouvelles parts so-
ciales auxquelles sont attachés les warrants susvisés, par un apport en nature consistant dans l’ensemble des actifs et
passifs de COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l. (les «Actifs et Passifs MANREGALERY»).

Les Actifs et Passifs MANREGALERY représentent un apport net d’un montant total de un million quatre cent quatre-

vingt-cinq mille cent vingt-quatre euros et cinquante-trois cents (EUR 1.485.124,53).

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l., agissant par le biais de son mandataire dûment auto-

risé déclare encore qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de tous les Actifs et Passifs MANREGALERY à la So-
ciété sans aucune restriction ni limitation, et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes
notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs MAN-
REGALERY à la Société.

La preuve de la propriété par COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l. des Actifs et Passifs

MANREGALERY a été rapportée au notaire soussigné.

8. Est intervenu ensuite Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 84.834; en vertu d’une procu-
ration donnée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2002.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO

(N°1), S.à r.l. trente-trois mille neuf cent cinquante-trois (33.953-) nouvelles parts sociales de la Société, auxquelles sont
attachés trois cent trente-neuf mille cinq cent trente-deux (339.532) warrants, avec une prime d’émission de deux cent
cinquante-quatre mille deux cents euros et quarante-huit cents (EUR 254.200,48) et libérer intégralement la totalité de
ces nouvelles parts sociales auxquelles sont attachés les warrants susvisés, par un apport en nature consistant dans l’en-
semble des actifs et passifs de COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l. (les «Actifs et Passifs SAN
GIULIANO»). 

Les Actifs et Passifs SAN GIULIANO représentent un apport net d’un montant total de trois millions six cent qua-

rante-neuf mille cinq cent dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-sept cents (EUR 3.649.519,97).

COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l., agissant par le biais de son mandataire dûment auto-

risé déclare encore qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de tous les Actifs et Passifs SAN GIULIANO à la So-
ciété sans aucune restriction ni limitation, et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes
notifications, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs SAN
GIULIANO à la Société.

La preuve de la propriété par COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l. des Actifs et Passifs SAN

GIULIANO a été rapportée au notaire soussigné.

9. Est intervenu ensuite Jean-Paul Spang, avocat, résidant à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire dûment

autorisé de COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 38-40, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
enregistrée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 79.538; en vertu d’une procu-
ration donnée à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 26 novembre 2002.

Le comparant a déclaré souscrire au nom et pour le compte de COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY

(N°1), S.à r.l. trente-huit mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept (38.597) nouvelles parts sociales de la Société, auxquelles
sont attachés trois cent quatre-vingt-cinq mille neuf cent soixante-sept (385.967) warrants, avec une prime d’émission
de deux cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-cinq euros et trente-neuf cents (EUR 288.965,39) et libérer in-
tégralement la totalité de ces nouvelles parts sociales auxquelles sont attachés les warrants susvisés, par un apport en
nature consistant dans l’ensemble des actifs et passifs de COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l.
(les «Actifs et Passifs TERRAGALERY»).

Les Actifs et Passifs TERRAGALERY représentent un apport net d’un montant total de quatre millions cent quarante-

huit mille six cent trente-sept euros et vingt-sept cents (EUR 4.148.637,27).

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l., agissant par le biais de son mandataire dûment autorisé

déclare encore qu’il n’existe aucun obstacle au libre transfert de tous les Actifs et Passifs TERRAGALERY à la Société
sans aucune restriction ni limitation, et que des instructions valables ont été données en vue d’effectuer toutes notifi-
cations, inscriptions ou autres formalités nécessaires pour effectuer un transfert valable des Actifs et Passifs TERRAGA-
LERY à la Société.

La preuve de la propriété par COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l. des Actifs et Passifs TER-

RAGALERY a été rapportée au notaire soussigné.

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l., COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à

r.l., COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l., COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à
r.l., COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l., COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l.,
COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l., COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1),
S.à r.l. et COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l. (collectivement les «Apporteuses»), agissant par
le biais de leur mandataire respectif dûment autorisé déclarent ensuite qu’un rapport a été établi par DELOITTE &amp; TOU-

4029

CHE S.A. Luxembourg, et signé par M. Benjamin Lam, réviseur d’entreprises, à Luxembourg, en date du 26 novembre
2002, dans lequel les Actifs et Passifs ALCOBENDAS, ALICANTE, ALJARAFE, CADIZ, CORDOBA, GALLARTE, MAN-
REGALERY, SAN GIULIANO et TERRAGALERY ainsi apportés en nature sont décrits et évalués.

Le comparant produit le prédit rapport, lequel contient les conclusions (en traduction libre) suivantes:
«Sur la base des procédures de vérification appliquées comme décrites ci-avant, nous sommes d’avis que la valeur de

l’Apport est au moins égale au nombre et à la valeur des 366.245 parts sociales d’une valeur nominale de 100 euros
auxquelles sont attachés 3.662.450 warrants d’une valeur nominale de 0,748679 euro chacun. Nous n’avons pas d’autre
commentaire à formuler quant à la valeur de l’Apport.»

Ce rapport restera annexé au présent acte pour être soumis aux formalités de l’enregistrement.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d’accepter lesdites souscriptions et la libération de la totalité des parts sociales auxquelles

sont attachés trois millions six cent soixante-deux mille quatre cent cinquante (3.662.450) warrants correspondant, de
manière agrégée, à dix (10) warrants par part sociale, par un apport en nature consistant dans l’ensemble des actifs et
passifs de chacune des Apporteuses et d’attribuer trois cent soixante-six mille deux cent quarante-cinq (366.245) parts
sociales auxquelles sont attachés les warrants susvisés, chaque part sociale ayant une valeur nominale de cent euros
(EUR 100), comme suit: 

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l’assemblée générale des associés décide de modifier l’article 6

des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Art. 6. Capital. Le capital est fixé à trente-six millions six cent trente-sept mille euros (EUR 36.637.000) repré-

senté par trois cent soixante-six mille trois cent soixante-dix (366.370) parts sociales ayant une valeur nominale de cent
euros (EUR 100) chacune.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée générale des associés décide de modifier les statuts de la Société afin de prévoir la possibilité d’ouvrir un

compte de prime d’émission sur lequel sera transféré tout paiement effectué sur toute part sociale en supplément de
sa valeur nominale (comprenant tout paiement effectué sur les warrants attachés aux parts sociales).

En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l’assemblée générale des associés décide d’ajouter un nouveau

paragraphe 2 à l’article 6 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«En plus du capital social, il peut être créé un compte de prime d’émission sur lequel sera transféré tout paiement

effectué sur toute part sociale en supplément de sa valeur nominale (comprenant tout paiement effectué sur les warrants
attachés aux parts sociales). Le montant du compte de prime d’émission peut être utilisé pour le paiement de toute part
sociale que la Société peut racheter à ses porteurs de parts, pour l’apurement de toute perte nette réalisée, afin d’ef-
fectuer des distributions au profit des porteurs de parts ou pour l’allocation de fonds à la réserve légale.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée générale des associés accuse réception du rapport spécial de la gérance de la Société quant à la création

d’un capital autorisé, une copie de ce rapport restera annexée au présent acte.

L’assemblée générale des associés décide de créer un capital autorisé d’un montant de quatre cent deux millions huit

cent quatre-vingt-deux mille euros (EUR 402.882.000,-) divisé en quatre millions vingt-huit mille huit cent vingt
(4.028.820) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent euros (EUR 100) chacune, et d’autoriser la gérance de la
Société, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date de publication dans le Mémorial, Recueil C, du
procès-verbal de l’assemblée générale des associés créant le capital autorisé, d’augmenter le capital social dans les limites
du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l’émission de parts sociales au profit des détenteurs de parts sociales
existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum et de majorité prévues à l’article
189, alinéa 1, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

En conséquence de la résolution adoptée ci-dessus, l’assemblée générale des associés décide d’ajouter un nouveau

paragraphe 3 à l’article 6 des statuts de la Société qui sera dorénavant rédigé comme suit:

«Le capital autorisé de la Société est fixé à quatre cent deux millions huit cent quatre-vingt-deux mille euros (EUR

402.882.000,-) représenté par quatre millions vingt-huit mille huit cent vingt (4.028.820) parts sociales ayant une valeur
nominale de cent euros (EUR 100) chacune.

Apporteuses

Nombre

Nombre

de parts de warrants

 sociales

COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.639

126.394

COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22.147

221.468

COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53.276

532.765

COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.489

814.886

COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101.897

1.018.974

COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.430

84.296

COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.817

138.168

COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33.953

339.532

COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.597

385.967

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

366.245

3.662.450

4030

La gérance de la Société est autorisée, pendant une période prenant fin cinq (5) années après la date de publication

dans le Mémorial, Recueil C, du procès-verbal de l’assemblée générale des associés créant le capital autorisé, à augmen-
ter le capital social dans les limites du capital autorisé, en une ou plusieurs fois, par l’émission de parts sociales au profit
des détenteurs de parts sociales existants ou de toute personne approuvée par les associés aux conditions de quorum
et de majorité prévues à l’article 189, alinéa 1, de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Ces parts sociales peuvent être souscrites et émises selon les termes et conditions déterminés par la gérance de la

Société.

La gérance de la Société peut en particulier déterminer:
* la période et le nombre de parts sociales à souscrire et émettre;
* si une prime d’émission sera payée sur les parts sociales à souscrire et à émettre, et le montant de cette prime

d’émission, le cas échéant;

* si les parts sociales seront libérées par un apport en espèces ou en nature; et
* que les parts sociales seront émises après l’exercice du droit de souscription et/ou du droit de conversion octroyé

par la gérance de la Société selon les termes des warrants (qui peuvent être séparés ou attachés aux parts sociales,
obligations, billets ou instruments similaires), obligations convertibles, billets ou instruments similaires émis par la So-
ciété de temps à autre.

La gérance de la Société peut déléguer à tout gérant de la Société autorisé ou fondé de pouvoir de la Société ou toute

autre personne dûment autorisée, l’obligation d’accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des parts sociales
représentant une partie ou l’entièreté de telles augmentations de capital.

A chaque augmentation du capital social de la Société par la gérance de la Société dans les limites du capital autorisé,

le présent article 6 sera modifié en conséquence.»

<i>Evaluation des frais

Dans la mesure où l’apport en nature consiste dans l’apport par chacune des sociétés énumérées ci-dessous de la

totalité de ses actifs et passifs à la Société, cette dernière se réfère à l’article 4-1 de la loi du 29 décembre 1971 pour
bénéficier de l’exemption du droit d’apport:

(i) COMMERCIAL INVESTMENT ALCOBENDAS (N°1), S.à r.l.;
(ii) COMMERCIAL INVESTMENT ALICANTE (N°1), S.à r.l.;
(iii) COMMERCIAL INVESTMENT ALJARAFE SEVILLA (N°1), S.à r.l.; 
(iv) COMMERCIAL INVESTMENT CADIZ (N°1), S.à r.l.;
(v) COMMERCIAL INVESTMENT CORDOBA (N°1), S.à r.l.; 
(vi) COMMERCIAL INVESTMENT GALLARTE (N°1), S.à r.l.;
(vii) COMMERCIAL INVESTMENT MANREGALERY (N°1), S.à r.l.;
(viii) COMMERCIAL INVESTMENT SAN GIULIANO (N°1), S.à r.l.; et 
(ix) COMMERCIAL INVESTMENT TERRAGALERY (N°1), S.à r.l.
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont éva-

lués à approximativement sept mille cinq cents euros (7.500,- EUR).

Dont acte, le présent acte a été établi à Hesperange, à la date donnée en tête des présentes. 
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande des comparants ci-

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; à la demande des mêmes comparants,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leur nom, prénom usuel, état civil et domi-

cile, ces derniers ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: J.-P. Spang, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 6 décembre 2002, vol. 16CS, fol. 14, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94958/220/815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

PRADERA HOLDCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 86.621. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(94959/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Hesperange, le 20 décembre 2002.

G. Lecuit.

Hesperange, le 20 décembre 2002.

G. Lecuit.

4031

FRIDES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 118, rue de Belvaux.

R. C. Luxembourg B 73.923. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 19 décembre 2002, vol. 578, fol. 11, case

7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2002.

(94988/503/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

VILLEROY &amp; BOCH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1018 Luxembourg, 330, rue de Rollingergrund.

R. C. Luxembourg B 5.160. 

L’an deux mille deux, le 29 novembre 2002
se sont réunis les associées: 

représentant ensemble l’intégralité et chacun à titre particulier comme ci-avant les parts sociales de la société à res-

ponsabilité limitée, établie et ayant son siège à la Faïencerie de Septfontaines-les-Luxembourg, L-1018 Luxembourg, 330,
rue de Rollingergrund (R.C.S. Luxembourg B 5.160),

se reconnaissant valablement convoqués au regard de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1.- Nomination comme fondés de pouvoir pour une durée indéterminée de
- Monsieur Nuyt Visscher, demeurant 15, rue Henri de Stein à L-7349 Heisdorf, et
- Monsieur Gaspard Chlecq, demeurant 7, rue Bechel à L-4970 Bettange-Mess
2.- Confirmation comme fondés de pouvoir pour une durée indéterminée de
Monsieur Otmar Adam, Martin-Luther-Strasse D-66280 Sulzbach
Monsieur Patrick Kieffer, 104, rue de Luxembourg, L-6210 Consdorf
Monsieur Charles Antoine De Theux, 30, route d’Uebersyren, L-6930 Mensdorf
3.- Démission avec décharge des fondés de pouvoir de Messieurs Georges Schiltz, Jean-Claude Speicher et Henri

Neiens.

4.- Confirmation de la nomination pour une durée indéterminée 
- du gérant Monsieur Wendelin Von Boch, D-66679 Losheim am See, Britten,
et
- de Monsieur Claude Peiffer comme co-gérant.

Les associés présent et représentés ont ensuite pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Sont nommés pour une durée indéterminée fondés de pouvoir à titre de
- directeur du personnel Monsieur Nuyt Visscher demeurant 15, rue Henri de Stein à L-7349 Heisdorf, et 
- directeur technique Monsieur Gaspard Chlecq demeurant 7, rue Bechel à L-4970 Bettange-Mess.

<i>Deuxième résolution

Sont confirmés comme fondés de pouvoir pour une durée indéterminée à titre de:
- directeurs financiers Monsieur Otmar Adam, Martin-Luther-Strasse D-66280 Sulzbach et Monsieur Patrick Kieffer,

104, rue de Luxembourg, L-6210 Consdorf,

- directeur commercial export Monsieur Charles Antoine De Theux, 30, route d’Uebersyren, L-6930 Mensdorf, qui

est confirmé pour le surplus en qualité de directeur commercial Export de la société.

Les fondés de pouvoir engageront la Société dans le cadre de leur compétence spécifique par signatures conjointes

avec le gérant ou le co-gérant. Ils représenteront par ces deux signatures conjointes la Société vis-à-vis des instances
judiciaires, des administrations et plus particulièrement des contributions, des douanes et des postes.

<i>Troisième résolution

Démission avec décharge est accordée aux fondés de pouvoir Messieurs Georges Schiltz, Jean-Claude Speicher et

Henri Neiens.

<i>Pour FRIDES, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
Signature

1.- VILLEROY &amp; BOCH A.G., société de droit allemand établie et ayant son siège social à Mettlach (D),

propriétaire de   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5.984 parts

ici représentée par:
- Monsieur Wendelin Von Boch, demeurant à D-66679 Losheim am See, Britten,
- Monsieur Rainer Kuhn, demeurant à D-66787 Wadgassen
2.- Monsieur Luitwin Gisbert Von Boch, demeurant à D-66693 Mettlach, propriétaire de   . . . . . . . . . 

16 parts

Total parts émises et représentées  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.000 parts

4032

<i>Quatrième résolution

Sont confirmés pour une durée indéterminée en qualité de 
- gérant Monsieur Wendelin Von Boch, prénommé, et
- co-gérant Monsieur Claude Peiffer, 27, rue Dr Peffer à L-2319 Howald.
Les deux gérants assurent collectivement la gestion de la société et auront les pouvoirs d’administration les plus éten-

dus.

Le gérant Monsieur Wendelin Von Boch, prénommé, engage et représente la Société par et sous sa seule signature.
Le cogérant Monsieur Claude Peiffer engage et représente la Société avec la signature conjointe du gérant ou du di-

recteur compétent vis-à-vis de tiers, des banques, des instances judiciaires tant en demandant qu’en défendant, des ad-
ministrations et plus particulièrement des contributions, des douanes et des postes. Ils signent la correspondance
journalière, engagent et licencient le personnel, fixent les dépenses générales d’administration, règlent les approvision-
nements et procèdent à la vente des produits de la Société.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour le présent procès-verbal a été clôturé. 

Enregistré à Luxembourg, le 9 décembre 2002, vol. 577, fol. 65, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(94945/206/67) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

VIENDER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.852. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(95020/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

VIENDER FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 64.852. 

<i>Extrait des Minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires qui s’est tenue le 29 novembre 2002

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de VIENDER FINANCE S.A. (la «Société»), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 2001;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 2001;
- prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 2001 est une perte de EUR 74.505,96

qui sera allouée dans le compte perte à reporter;

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes les opé-

rations effectuées jusqu’à la date du 31 décembre 2001.

Luxembourg, le 29 novembre 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2002, vol. 578, fol. 37, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(95021/710/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2002.

VILLEROY &amp; BOCH AG / R. Kuhn / L.-G. von Boch
W. von Boch

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
<i>Administrateur-délégué
Signatures

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Dexia Protected

Luxembourg Online S.A.

Amara, S.à r.l.

Amara, S.à r.l.

Dasolux S.A.

Dasolux S.A.

Arctotis S.A.

Avail Medical Products Europe, S.à r.l.

Ratanja S.A.

Aristée S.A.

Rodolphe S.A.

AOL Luxembourg, S.à r.l.

Prophète S.A.

Leopold Holding, S.à r.l.

Opson Holding S.A.

Sigma Capital Hospitality, Leisure and Tourism Holding Company S.A.

Comitalu S.A.

Happy Greens S.A.

Happy Greens S.A.

ABM Merchant S.A.

ABM Merchant S.A.

Gemex S.A.

Gemex S.A.

Gemex S.A.

Gemex S.A.

Norfin II S.A.

Promotra S.A.

Sigma Capital Investments S.A.

Jabe S.A.

Pradera Holdco, S.à r.l.

Pradera Holdco, S.à r.l.

Frides, S.à r.l.

Villeroy &amp; Boch

Viender Finance S.A.

Viender Finance S.A.