logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

65377

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1363

19 septembre 2002

S O M M A I R E

A.W.T.C. Holdings, African Wood Trading Com- 

HCEPP Management Company, S.à r.l., Luxem- 

pany Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .

65420

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65380

Agoranet Holding S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . .

65416

Industrial Properties S.A.H., Luxembourg  . . . . . . 

65418

Alavita S.A., Junglinster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65410

Intesa Luxembourg Fund, Sicav, Luxembourg  . . . 

65383

Am Generali FondsStrategie  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65378

Invesco European CDO I S.A., Luxembourg . . . . . 

65407

Aran International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .

65414

Invesco European CDO I S.A., Luxembourg . . . . . 

65409

Bond Select Trust  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65381

Invesco European Warrant Fund, Sicav, Luxem- 

Calim International Holding S.A., Luxembourg . . .

65417

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65420

Carval S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65413

Janus Global Life Sciences Fund  . . . . . . . . . . . . . . . 

65388

Chekiang  First  Bank (Luxembourg) S.A., Muns- 

Jurisfides S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

65418

bach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65424

Kortmann Bau, S.à r.l., Luxemburg  . . . . . . . . . . . . 

65393

Chenonceau S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

65416

Lemanik Private Equity Fund, Sicav, Luxembourg

65419

CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrète- 

Lift Luxembourg S.A., Peppange  . . . . . . . . . . . . . . 

65410

ments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65415

Luxicav, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65383

CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrète- 

Medea Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

65415

ments S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65415

Milan E-Ventures S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

65421

Cosma Finance International S.A., Luxembourg . .

65413

Monte  Carlo  International  Real  Estate S.A.H., 

Cosmos Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

65416

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65419

CRQ S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65422

Nomura Global Select Trust . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65386

Crédit Suisse Fund of Funds (Lux) . . . . . . . . . . . . . .

65386

Nomura Multi Currency MMF. . . . . . . . . . . . . . . . . 

65383

Deborah S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

65421

Obeche S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65423

DML Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

65422

One-Two-Three Holding, Luxembourg . . . . . . . . . 

65409

DSI International, S.à r.l. (Luxembourg), Luxem- 

Orcades Europe S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

65419

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65389

P.E.L.S.,  Propreté  Eclair  Luxembourgeoise de 

Eureko Sicav, Senningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65420

Services S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65388

Exicom-Azur, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

65415

Pizzaphone, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

65394

Fa & Ma Luxembourg, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . .

65409

Pizzaphone, S.à r.l., Esch-sur-Alzette . . . . . . . . . . . 

65395

Farina European Invest S.A.H., Luxembourg . . . . .

65416

Private Holdings of Investments Luxembourg S.A., 

Figest S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65417

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65414

Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65418

S.E.F. Société Européenne Financière S.A., Lu- 

Finarch, S.à r.l., Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65410

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65413

Finarom Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

65423

Sanpaolo  Gestion  Internationale  S.A.,  Luxem- 

Finropa S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65421

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65392

Flanders International S.A.H., Luxembourg . . . . . .

65418

Sinvar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

65409

Gamma S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65422

Sodevibois S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

65423

Gantro Invest, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

65401

Troy Investment S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . 

65403

Gardiners  Immobiliers  Conseils, S.à r.l., Luxem- 

Valona Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

65422

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65414

Welfort  International  Holding  S.A.H., Luxem- 

Glenville Holding S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . .

65410

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65395

Goldman  Sachs  Mezzanine  Partners II Luxem- 

Wolff International S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . 

65417

bourg, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65396

65378

AM GENERALI FONDSSTRATEGIE, Fonds Commun de Placement.

<i>Änderung des Verwaltungsreglements 

Infolge des Beschlusses von AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A. (die «Verwaltungsgesellschaft») in ihrer Ei-

genschaft als Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds AM GENERALI FONDSSTRATEGIE (der «Fonds»), wird das
Verwaltungsreglement des Fonds wie nachfolgend geändert:

1. Artikel 3 Absatz 5 wird wie folgend geändert:
«Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben handelt die Depotbank unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft und aus-

schliesslich im Interesse der Anteilinhaber. Die Depotbank wird entsprechend den Weisungen der Verwaltungsgesell-
schaft, vorausgesetzt, diese stehen in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsreglement, dem Depotbankvertrag, dem
jeweils gültigen Verkaufsprospekt und dem Gesetz.»

2. Artikel 3 Absatz 6, zweiter Gedankenstrich wird wie folgt geändert:
«- der Verkauf, die Ausgabe, der Umtausch, die Rücknahme, die Auszahlung und die Entwertung der Anteile, die für

Rechnung der jeweiligen Teilfonds vorgenommen werden, den gesetzlichen Vorschriften und dem Verwaltungsregle-
ment gemäss erfolgen.»

3. Artikel 3 Absatz 6 wird durch Einfügen eines neuen vierten Gedankenstrichs wie folgt geändert:
«- Investmentanteile höchstens zum Ausgabepreis gekauft und mindestens zum Rücknahmepreis verkauft werden.»
4. Artikel 3 Absatz 6 vierter Gedankenstrich (nach Änderung: fünfter Gedankenstrich) wird wie folgt umgeändert:
«sonstige börsennotierte Vermögenswerte höchstens zum Tageskurs gekauft und mindestens zum Tageskurs ver-

kauft werden sowie sonstige nicht an einer Börse notierte Vermögenswerte zu einem Preis gekauft bzw. verkauft wer-
den, der nicht in einem offensichtlichen Missverhältnis zu ihrem tatsächlichen Wert steht.»

5. Satz 1 des Artikels 5 Ziffer 5.5 (Flüssige Mittel) wird wie folgt geändert:
«Der jeweilige Teilfonds kann flüssige Mittel in Form von Bankguthaben und regelmässig gehandelten Geldmarktin-

strumenten in Höhe von bis zu maximal 49 % seines Netto-Teilfondsvermögens halten oder als Festgelder anlegen.»

6. Artikel 6 Absatz 2 und 3 werden wie folgt geändert:
«Die Anträge auf Ausgabe der Anteile können an jedem Tag, an dem die Banken in Luxemburg und München gewöhn-

lich geöffnet sind («Bewertungstag»), bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank oder allen Zahlstellen eingereicht
werden. Anteile werden an jedem Bewertungstag zu einem Ausgabepreis ausgegeben, welcher dem gemäss Artikel 9
berechneten Inventarwert pro Anteil zuzüglich eines etwaigen Ausgabeaufschlages, dessen maximale Höhe im Verkaufs-
prospekt festgelegt ist, entspricht. Für alle Zeichnungen, die bei einer der vorgenannten Stellen an einem Bewertungstag
eingehen, gilt der am nächsten Bewertungstag ermittelte Ausgabepreis.

Der Ausgabepreis ist innerhalb von drei Bewertungstagen nach Eingang des Zeichnungsantrages (unter Einschluss des

Tages des Eingangs des Zeichnungsantrages) in der Fondswährung des betreffenden Teilfonds, welche im Verkaufspro-
spekt festgelegt ist, zahlbar.»

Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
«Der Wert eines Anteils («Inventarwert pro Anteil») lautet auf die im Verkaufsprospekt festgelegte Währung, in wel-

cher der jeweilige Teilfonds aufgelegt wird («Teilfondswährung»).»

Artikel 9 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
«Die Berechnung erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens (Fondsvermögen abzüglich Verbindlichkeiten) ei-

nes Teilfonds durch die Zahl der sich zum Zeitpunkt der jeweiligen Berechnung im Umlauf befindlichen Anteile dieses
Teilfonds.»

9. Artikel 9 Absatz 3 Ziffer c) wird wie folgt geändert:
«c) Wertpapiere bzw. Geldmarktinstrumente, die weder an einer Börse amtlich notiert, noch an einem anderen ge-

regelten Markt gehandelt werden, werden zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach
Treu und Glauben und allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewer-
tet.»

10. Artikel 9 Absatz 3 Ziffer f) Satz 2 wird wie folgt umgeändert:
«Festgelder mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als 30 Tagen können zu dem jeweiligen Renditekurs bewertet wer-

den, vorausgesetzt, ein entsprechender Vertrag zwischen der Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor,
dass diese Festgelder zu jeder Zeit kündbar sind und dass im Falle einer Kündigung ihr Realisierungswert diesem Ren-
ditekurs entspricht.»

11. Artikel 10 Absatz 1 Ziffer a) wird wie folgt geändert:
«a) während der Zeit, in der die Rücknahmepreise eines erheblichen Teils der Investmentanteile im betreffenden Teil-

fonds nicht verfügbar sind.»

12. Artikel 11 Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
«Die Anteilinhaber sind berechtigt, an jedem Bewertungstag die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen.»
13. Artikel 11 Absatz 2 und 3 werden wie folgt geändert:
«Für Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen eingehen, gilt der am näch-

sten Bewertungstag ermittelte Rücknahmepreis je Anteil. Der Rücknahmepreis entspricht dem Inventarwert pro Anteil.

Die Zahlung des Rücknahmepreises erfolgt innerhalb von drei Bewertungstagen nach Eingang des Rücknahmeantrages

(unter Einbeziehung des Tages des Eingangs des Rücknahmeantrages). Die Zahlung des Rücknahmepreises und sonstige
Zahlungen erfolgen über die Depotbank oder die Zahlstellen.»

14. Artikel 11 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt geändert:
«In diesem Falle erfolgt die Rücknahme gemäss den Bestimmungen des letzten Absatzes von Artikel 9 des Verwal-

tungsreglements zum dann geltenden Inventarwert pro Anteil.»

15. Artikel 11 Absatz 8 wird wie folgt geändert:

65379

«Der Anteilinhaber kann an jedem Bewertungstag den Antrag auf vollständigen oder teilweisen Umtausch seiner An-

teile in solche eines anderes Teilfonds bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank sowie bei jeder Zahlstelle ein-
reichen. Für Umtauschanträge, die an einem Bewertungstag bei einer der vorgenannten Stellen eingehen, gelten die am
nächsten Bewertungstag ermittelten Inventarwerte pro Anteil der betreffenden Teilfonds.

Hierfür kann eine Umtauschgebühr, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, erhoben werden.»
16. Artikel 12 fünfter, siebter und neunter Gedankenstrich werden entfernt.
17. Artikel 12 wird durch Einfügen eines neuen Gedankenstrichs nach dem bisherigen zehnten Gedankenstrich und

Eingliederung des bisherigen elften Gedankenstrichs wie folgt geändert:

«- Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung dieses Verwaltungsregle-

ments sowie anderer Dokumente, die den Teilfonds betreffen, einschliesslich Anmeldungen zur Registrierung, Prospek-
te oder schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschliesslich örtlichen
Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Teilfonds oder dem Anbieten der Anteile vor-
genommen werden müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber
in allen notwendigen Sprachen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumen-
ten, welche gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind, die Ge-
bühren an die jeweiligen Repräsentanten im Ausland, sowie sämtliche Verwaltungsgebühren.»

18. Artikel 12 Absatz 4 wird wie folgt geändert:
«Die Gründungskosten, die sich auf ungefähr 75.000,- Euro beliefen, wurden zunächst von der Verwaltungsgesell-

schaft getragen und dann über einen Zeitraum, der sich über das erste Geschäftsjahr erstreckt, den jeweiligen Teilfonds-
vermögen anteilsmässig durch die Verwaltungsgesellschaft in Rechnung gestellt.»

19. Artikel 16 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
«Die Verwaltungsgesellschaft wird im Jahresbericht und Halbjahresbericht den Betrag der Ausgabeaufschläge und ggf.

der Rücknahmeabschläge angeben, die dem jeweiligen Teilfonds im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rückgabe
von Anteilen an anderen Investmentvermögen berechnet worden sind, sowie die Vergütung angeben, die dem jeweiligen
Teilfonds von einer anderen Kapitalanlagegesellschaft oder einer anderen Investmentgesellschaft einschliesslich ihrer
Verwaltungsgesellschaft als Verwaltungsvergütung für die im jeweiligen Teilfonds gehaltenen Anteile berechnet wurde.»

20. Der Abschnitt «Anlagepolitik», Ziffer 1. Satz 1 des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 1. AM GENERALI-

FondsStrategie Balance, wird wie folgt geändert:

«Der Teilfonds AM GENERALI FondsStrategie Balance strebt als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung ei-

nes möglichst hohen Wertzuwachses an, wobei Ausgewogenheit und Substanzerhalt hierbei im Vordergrund stehen.»

21. Der Abschnitt «Anlagepolitik», Ziffer 2. b), des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 1. AM GENERALI

FondsStrategie Balance, wird wie folgt geändert:

«b) offenen Investmentvermögen, die nach dem Auslandinvestment-Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland öf-

fentlich vertrieben werden dürfen und bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine
Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen, erworben.»

22. Der Abschnitt «Anlagepolitik», Ziffer 3., des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 1. AM GENERALI Fonds-

Strategie Balance, wird wie folgt geändert:

«Die Zielfonds müssen in einem Mitgliedstaat der EU, der Schweiz, Kanada, den USA, Japan, oder Hongkong aufgelegt

worden sein.»

23. Der Abschnitt «Anlagepolitik», Ziffer 4. Satz 5, des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 1. AM GENERALI

FondsStrategie Balance, wird wie folgt geändert:

«In Anteilen eines einzigen Zielfonds dürfen höchstens 20 % des Netto-Teilfondsvermögens angelegt werden.»
24. Der Abschnitt «Anlagepolitik», Ziffer 6., des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 1. AM GENERALI Fonds-

Strategie Balance, wird wie folgt geändert:

«Es ist beabsichtigt, die Erträge des Teilfondsvermögens am 15. März eines jeden Jahres, sofern dieser Tag ein Bewer-

tungstag ist, auszuschütten. Im Falle, wo der 15. März eines jenen Jahres kein Bewertungstag ist, erfolgt die Auszahlung
der Ausschüttung an dem nächstfolgenden Tag, der ein Bewertungstag ist.»

25. Der Abschnitt «Kosten» des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 1. AM Generali FondsStrategie Balance,

wird unter Ziffer 3. dritter Gedankenstrich wie folgt geändert:

«Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung dieses Verwaltungsregle-

ments sowie anderer Dokumente, die den Teilfonds betreffen, einschliesslich Anmeldungen zur Registrierung, Prospek-
te oder schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschliesslich örtlichen
Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Teilfonds oder dem Anbieten der Anteile vor-
genommen werden müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber
in allen notwendigen Sprachen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumen-
ten, welche gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind, die Ge-
bühren an die jeweiligen Repräsentanten im Ausland, sowie sämtliche Verwaltungsgebühren.»

26. Der Abschnitt «Anlagepolitik» des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 2. AM Generali FondsStrategie Dy-

namik, wird unter Ziffer 2. b) wie folgt geändert: 

«b) offenen Investmentvermögen, die nach dem Auslandinvestment-Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland öf-

fentlich vertrieben werden dürfen und bei denen die Anteilinhaber das Recht zur Rückgabe der Anteile haben, die keine
Spezialfonds sind und die in ihrem Sitzland einer funktionierenden Investmentaufsicht unterliegen, erworben.»

27. Der Abschnitt «Anlagepolitik» des Verwaltungsreglements - Besondere Teil, 2. AM Generali FondsStrategie Dy-

namik, wird unter Ziffer 3. wie folgt geändert:

«Die Zielfonds müssen in einem Mitgliedstaat der EU, der Schweiz, Kanada, den USA, Japan, oder Hongkong aufgelegt

worden sein.»

65380

28. Der Abschnitt «Anlagepolitik» des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 2. AM GENERALI FondsStrategie

Dynamik, wird unter Ziffer 4. Satz 5 wie folgt geändert:

«In Anteilen eines einzigen Zielfonds dürfen höchstens 20 % des Netto-Teilfondsvermögens angelegt werden.»
29. Der Abschnitt «Anlagepolitik» des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 2. AM GENERALI FondsStrategie

Dynamik, wird unter Ziffer 6. wie folgt geändert:

«Es ist beabsichtigt, die Erträge des Teilfondsvermögens am 15. März eines jeden Jahres, sofern dieser Tag ein Bewer-

tungstag ist, auszuschütten. Im Falle, wo der 15. März eines jenen Jahres kein Bewertungstag ist, erfolgt die Auszahlung
der Ausschüttung an dem nächstfolgenden Tag, der ein Bewertungstag ist.»

30. Der Abschnitt «Kosten» des Verwaltungsreglements - Besonderer Teil, 2. AM GENERALI FondsStrategie Dyna-

mik, wird unter Ziffer 3. dritter Gedankenstrich wie folgt geändert:

«Kosten der Vorbereitung und Erstellung sowie der Hinterlegung und Veröffentlichung dieses Verwaltungsregle-

ments sowie anderer Dokumente, die den Teilfonds betreffen, einschliesslich Anmeldungen zur Registrierung, Prospek-
te oder schriftliche Erläuterungen bei sämtlichen Aufsichtsbehörden und Börsen (einschliesslich örtlichen
Wertpapierhändlervereinigungen), welche im Zusammenhang mit dem Teilfonds oder dem Anbieten der Anteile vor-
genommen werden müssen, die Druck- und Vertriebskosten der Jahres- und Halbjahresberichte für die Anteilinhaber
in allen notwendigen Sprachen, sowie Druck- und Vertriebskosten von sämtlichen weiteren Berichten und Dokumen-
ten, welche gemäss den anwendbaren Gesetzen oder Verordnungen der genannten Behörden notwendig sind, die Ge-
bühren an die jeweiligen Repräsentanten im Ausland, sowie sämtliche Verwaltungsgebühren.»

Luxemburg, den 23. August 2002.  

Enregistré à Luxembourg, le 29 août 2002, vol. 573, fol. 74, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(64904/260/161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.

HCEPP MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered Office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 78.051. 

<i>Amendment agreement to the management regulations

Between:
1) HCEPP MANAGEMENT COMPANY, S.à r.l., a company incorporated on September 28, 2000, as a société à re-

sponsabilité limitée under the laws of Luxembourg, having its registered office at 69, route d’Esch, L-1470 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg (the «Management Company»); and

2) DEXIA BANQUE INTERNATIONAL A LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg Bank under the form of a public lim-

ited company with its registered office at 69, route d’Esch, L-2953 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the
«Custodian»);

Whereas:
a) Pursuant to the Management Regulations of the Heitman Central Europe Property Partners, a Luxembourg mutual

investment fund (the «Fund»), the Management Company may, with the approval of the Custodian and with the unani-
mous consent of the Investment Committee (except as provided in Section 27.1(b) of the Management Regulations),
amend the Management Regulations of the Fund, in whole or in part.

b) A meeting of the Investment Committee held on 6 March 2002 has unanimously approved the amendments pro-

posed to be made to the Management Regulations.

c) The Management Company and the Custodian are satisfied that the amendments proposed to be made to the Man-

agement Regulations are in the best interests of the holders of Units; the Amendment to the Management Regulations
as agreed below shall become effective at the date of the execution of the present agreement by the Custodian.

Now therefore it is agreed as follows:
The Custodian and the Management Company hereby agree to amend the Management Regulations as follows:

Art. 1. Definitions and Interpretation
The Definition of the Commitment Period in the Management Regulations as provided in Section 1.1 shall be amend-

ed as follows:

«Commitment Period. The Commitment Period shall mean twenty-four (24) months from the Closing Date.»

Art. 3. The management company
Amendment of section 3.4 (a) which shall henceforth read as follows:
«The Fund will pay the Management Company an annual management fee (the «Management Fee») equal to:
(i) 2.0% per annum of the aggregate Commitments, until March 31, 2002; or 
(ii) 2.0% per annum, of the sum of total Capital Contributions actually invested in Project Investments plus the total

Capital Contributions attributable to Project Investments approved by the Investment Committee (but not yet invested

AM GENERALI INVEST LUXEMBOURG S.A.
<i>Verwaltungsgesellschaft
Unterschriften

HVB BANQUE LUXEMBOURG S.A.
<i>Depotbank
Unterschriften

65381

in such Project Investments) after March 31, 2002. Any Project Investments disposed of shall not be taken into account
for purposes of determining the Management Fee as of the date of such disposition.»

Art. 5. The custodian and the administrative agent
Amendment of section 5.6 which shall henceforth read as follows:
«Agreement. The rights and duties of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., as Custodian (pursuant

to a Custodian Agreement), Domiciliary and Service Agent (pursuant to a Domiciliary and Service Agent Agreement),
Administrative and Paying Agent (pursuant to an Administrative and Paying Agent Agreement), and FETA as Registrar
and Transfer Agent (pursuant to a Registrar and Transfer Agent Agreement) are governed by agreements entered into
on September 28, 2000, for a period of four and one half (4.5) years after the end of the Commitment Period, but shall
be extended if the term of the Fund shall be extended. Each such agreement may be terminated at any time by the Man-
agement Company, subject to the voting requirements in Section 4.2 (e)(vii), or by the Custodian, or FETA, as applicable,
upon 90 days’ prior written notice. In case of termination by the Custodian, the Management Company shall appoint a
new custodian who shall assume the responsibilities and functions of the Custodian under these Management Regula-
tions. The Custodian is required to use its best endeavors to preserve the interests of Unitholders of the Fund until the
appointment of a new custodian which shall take place within two (2) months. The Custodian’s termination shall not
become effective pending (i) the appointment of a new custodian by the Management Company, and (ii) the complete
transfer of all assets of the Fund held by the Custodian to the new custodian.»

Art. 24. Duration of the fund - Liquidation
Amendment of section 24.1 which shall henceforth read as follows:
«Term of the Fund. The Fund will be close-ended and shall terminate four and one half (4.5) years from the termina-

tion of the Commitment Period, or upon the liquidation of all of the Fund’s investments or upon no successor manage-
ment company being appointed pursuant to Section 21.5, whichever is sooner.»

This Amendment Agreement is governed by Luxembourg law and the parties hereto accept the arbitration and the

jurisdiction as set forth in article 27 of the Management Regulations.

In Whitness whereof, the parties hereto have this instrument to be executed in three originals.
Dated as of July 8, 2002. 

Dated as of 29 July 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 6 août 2002, vol. 571, fol. 99, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(60481/250/70) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 août 2002.

BOND SELECT TRUST, Fonds Commun de Placement.

<i>Amendment to the management regulations

Upon decision of GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A., acting as Management Company to BOND SELECT

TRUST (the Trust») and with the approval of NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., acting, as custodian, the Man-
agement Regulations of the Trust shall be amended in a manner that:

1. In article 6 entitled «Investment Restrictions», the word «EEC» is replaced by «EU».
2. A new article entitled «Restriction on ownership of shares», which shall include paragraph 3 and following of article

7 entitled «Issue of shares», is created and the following articles are renumbered accordingly.

3. In the new article 8 entitled «Restriction on ownership of shares», the second paragraph is deleted and the follow-

ing wording is added at the end of the article:

«More specifically:
a) The Management Company will not promote the sale of the Trust’s shares to the public within the European Union

(«EU»), or any part of it.

b) None of the shares is registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the «1933 Act»).

Except as described below, none of the shares may be offered, sold, transferred or delivered, directly or indirectly, in
the United States of America or any of its territories or possessions or areas subject or its jurisdiction including the
Commonwealth of Puerto Rico (the «United States»), or to any citizen or resident thereof (including any corporation,
partnership or other entity created or organised in or under the laws of the United States or any political subdivision
thereof), or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which from sources outside the United
States (which is not effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States) is not in-
cluded in gross income for the purposes of computing United States federal income tax («U.S. Person»).

The Trust is not registered under the United States Investment Company Act of 1940 (the «Investment Company

Act»). The Management Company will not knowingly permit the number of holders of shares who are U.S. persons or
are in the United States to exceed 100. Subject to the foregoing prohibitions, private sales of a portion of the shares to
a limited number of sophisticated institutional investors in the United States or which are U.S. persons may from time
to time be arranged under restrictions and other circumstances designed to preclude a distribution that would other-
wise require registration of the shares under the 1933 Act or cause the Trust to become subject to the Investment

<i>The Management Company
Signature

DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, Société Anonyme
<i>The Custodian
Signatures

65382

Company Act or that would subject the Trust to U.S. taxation, including presentation by such investors, prior to the
delivery to them of shares, of a letter containing specified representations and agreements.

For the purpose of restricting or preventing the beneficial ownership of Trust shares by any U.S. person, as defined

above, except those U.S. Persons who purchase shares in a private placement, as provided above, the Management
Company or its agent may:

a) decline to issue any shares and decline to register any transfer of a share, where it appears to it that such registry

or transfer would or might result in beneficial ownership of such shares by a U.S. Person; and

b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of shares

on, the Register of shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider neces-
sary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such shareholder’s shares rests in a U.S.
Person, or whether such registry will result in beneficial ownership of such shares by a U.S. Person; and

c) where it appears to the Management Company that any U.S. person either alone or in conjunction with any other

person is a beneficial owner of shares, compulsorily repurchase or cause to be repurchased from any such shareholder
all shares held by such shareholder, in the following manner:

(i) the Management Company or its agent shall serve a notice (the «purchase notice») upon the shareholder appearing

in the Register of shareholders as the owner of the shares to be purchased, specifying the shares to be purchased as
aforesaid, the manner in which the purchase price will be calculated and the name of the purchaser. Any such notice
may be served upon such shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such share-
holder at his address appearing in the books of the Trust. The shareholder shall thereupon forthwith be obliged to de-
liver to the Management Company or its agent the share certificate or certificates (if any are issued) representing the
shares specified in the purchase notice. Immediately after the close of business on the date specified in the purchase
notice, such shareholder shall cease to be the owner of the shares specified in such notice and his name shall be removed
from the registration of such shares in the Register of shareholders;

(ii) the price at which each such share is to be purchased (the «purchase price») shall be an amount equal to the Net

Asset Value per share in a Fund as at the Valuation Day (as defined in Article 11) specified by the Management Company
or the Valuation Day following the surrender of the share certificate or certificates representing the shares specified in
such notice, whichever is lower, all as determined in accordance with Article 11 hereof;

(iii) payment of the purchase price will be made available to the former owner of such shares in U.S. Dollars or, in

the discretion of the Management Company, in any other freely convertible currency at the rate of exchange for U.S.
Dollars on the date of payment and will be deposited for payment to such owner with a bank in Luxembourg or else-
where (as specified in the purchase notice) upon final determination of the purchase price following surrender of the
share certificate or certificates specified in such notice. Upon service of the purchase notice as aforesaid such former
owner shall have no further interest in such shares or any of them, nor any claim against the Trust or its assets nor
against the Management Company, the Custodian or any other person in respect thereof, except the right to receive
the purchase price (without interest) from such bank following effective surrender of the share certificate or certificates
as aforesaid. Any funds receivable by a shareholder under this paragraph, but not collected within a period of notice,
may not thereafter be claimed and shall revert to the Trust. The Management Company shall have power from time to
time to take all steps necessary and to authorise such action on behalf of the Trust to perfect such reversion,

(iv) the exercise by the Management Company of the power conferred by this Article shall not be questioned or

invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of shares by any person or that
the true ownership of any shares otherwise than appeared to the Management Company at the date of any purchase
notice, provided in such case the said powers were exercised by the Management Company in good faith.»

4. In article 15 and Appendices I to V, the word «Agent Securities Company» is replaced by «Agent Company».
5. In the renumbered article 16 entitled «Accounting Year, Audit», the first paragraph is amended so as to read as

follows:

«The accounts of the Trust are closed each year on 31st December.»
6. In the renumbered article 17 entitled «Dividends», the following wording is added as second paragraph:

«The Management Company may determine a minimum distribution amount below which no distribution will be paid

to the shareholders, subject however to any condition provided for by the Management Company from time to time.»

In the renumbered paragraph 3, the wording «Luxembourg francs 50,000,000.-» is replaced by «EUR 1,239,467.62».
7. In Appendices I to V relating to the sub-funds of the Trust, the last sentence is deleted.
In section 6 «Valuation Day», the following wording is added at the end of the paragraph:
«(except December 24 in each year)».
8. In section 2 «Investment Policy» of Appendix V relating to BOND SELECT TRUST - EURO FUND, the wording

«(ECU until and excluding 1st January, 1999)», the second sentence of the second paragraph and the last paragraph of
the section are deleted.

9. The wording under section 7 «Denomination of the Fund» is replaced by «Euro».

Luxembourg, 5th September, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66491/260/93) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. / NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i>as Management company / as Custodian
Signatures / Signatures

65383

NOMURA MULTI CURRENCY MMF, Fonds Commun de Placement.

<i>Amendment to the Management Regulations

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. (the «Management Company») acting as management company to Nomura

Multi Currency MMF (the «Trust») with the approval of NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., as custodian of the
Trust, has decided:

1. To amend in paragraph 2 of article 17 the amount of «Luxembourg francs 50,000,000» to «Euro 1,239,467.62».
2. To amend Section 8. of Appendix I, so as to include the following before «(a «Dealing Day»)»:
«(except December 24th in each year)».
3. To amend Section 8. of Appendix II, so as to include the following before «(a «Dealing Day»)»:
«(except December 24th in each year)».
4. To amend Section 8. of Appendix III, so as to include the following before «(a «Dealing Day»)»:
«(except December 24th in each year)».
5. To amend Section 8. of Appendix IV, so as to include the following before «(a «Dealing Day»)»:
«(except December 24th in each year)».
This amendment to the Management Regulations shall become effective on 24th September, 2002.

Luxembourg, 5th September, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66488/260/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 77.033. 

LUXICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 30.337. 

PROJET DE FUSION

L’an deux mille deux, le dix septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

Ont comparu:

I) INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV une Société d’Investissement à Capital Variable, (la «SICAV») inscrite au

registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 77.033, constituée par acte reçu par le
notaire Paul Frieders, préqualifié en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial C et ayant son siège social à Luxembourg,
19-21, boulevard du Prince Henri, 

représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE (la «Mandataire») ayant son siège social

à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 13.859,

elle-même représentée par Madame Solange Velter et Monsieur Guy Nimax, tous deux employés privés, demeurant

professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, 

aux termes d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur

par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

ci-après désignée «la société absorbée»;
II) LUXICAV, une Société d’Investissement à Capital Variable, (la «Société») inscrite au registre de commerce et des

sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 30.337, constituée par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, pré-
qualifié en date du 17 avril 1989, publié au Mémorial C du 11 juillet dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu
par le notaire soussigné en date du 12 mai 1993, publié au Mémorial C et pour la dernière fois le 26 août 2002 et publié
au Mémorial C et ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, 

représentée par la société anonyme SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE (la «Mandataire») ayant son siège social

à Luxembourg, 19-21 boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg, sec-
tion B sous le numéro 13.859, 

elle-même représentée par Madame Solange Velter et Monsieur Guy Nimax, tous deux employés privés, demeurant

professionnellement à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, 

aux termes d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur

par la mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui,

ci-après désignée «la société absorbante»;
Lesquels sociétés comparantes ont demandé au notaire soussigné d’acter comme suit le projet de fusion sur lequel

se sont mis d’accord le Conseil d’administration de INTESA LUXEMBOURG FUND et le Conseil d’administration de
LUXICAV afin de réaliser la fusion entre les deux Sociétés, lequel projet de fusion est conçu comme suit:

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.

NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.

<i>as Management Company

<i>as Custodian

Signatures

Signatures

65384

I. Désignation des Sociétés qui fusionnent

INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV est une société anonyme établie sous le régime d’une société d’investisse-

ment à capital variable («Sicav») avec son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au re-
gistre de commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 77.033, 

constituée par acte reçu par le notaire Paul Frieders en date du 20 juillet 2000, publié au Mémorial C de 2000, page

28392.

LUXICAV est une société anonyme établie sous le régime d’une société d’investissement à capital variable («Sicav»)

avec son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de commerce et des sociétés
à Luxembourg, section B sous le numéro 30.337, 

constituée par acte reçu par le notaire Jacques Delvaux, préqualifié en date du 17 avril 1989, publié au Mémorial C

du 11 juillet dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 12 mai 1993, publié
au Mémorial C et pour la dernière fois le 26 août 2002, en voie de publication au Mémorial C.

Les deux Sociétés ont la même Administration centrale, la même Banque dépositaire et le même Service financier.

II. Structure des Sociétés avant la fusion

Les compartiments de INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV sont établis sous les dénominations suivantes:
1) INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-BREVE TERMINE
2) INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-OBBLIGAZIONARIO
3) INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-AZIONARIO
4) INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-AZIONARIO ITALIA
Les compartiments de LUXICAV sont établis sous les dénominations suivantes:
1) LUXICAV-MIXED 
2) LUXICAV-CROISSANCE PLUS
3) LUXICAV-EQUILIBRE
4) LUXICAV-CONSERVATEUR 

III. Structure de la Société absorbante après l’absorption

Les actions en circulation des compartiments de la société absorbée (INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV) seront

annulées à la suite de la réalisation de la fusion par absorption par les compartiments de la société absorbante (LUXI-
CAV). Ces derniers, ayant chacun des actions de distribution (catégorie A) et des actions de capitalisation (catégorie
B), accueilleront les compartiments absorbés comme suit: 

Les deux compartiments absorbants changeront de dénomination en LUXICAV-AZIONARIO et LUXICAV-OBBLI-

GAZIONARIO.

Par ailleurs, les compartiments INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-BREVE TERMINE et INTESA LUXEM-

BOURG FUND, SICAV-AZIONARIO ITALIA seront transférés tels quels dans les compartiments LUXICAV-BREVE
TERMINE et LUXICAV-AZIONARIO ITALIA, spécialement créés à cet effet.

De plus, les compartiments suivants LUXICAV-MIXED et LUXICAV-EQUILIBRE fusionneront pour donner le nou-

veau compartiment: LUXICAV-EQUILIBRIO.

Au terme de l’opération de fusion entre les deux Sicav, au transfert des deux compartiments de INTESA LUXEM-

BOURG FUND, SICAV et suite à la fusion des deux compartiments à l’intérieur de LUXICAV, la Société sera donc
composée des compartiments suivants:

- LUXICAV-BREVE TERMINE
- LUXICAV-AZIONARIO ITALIA
- LUXICAV-AZIONARIO
- LUXICAV-OBBLIGAZIONARIO
- LUXICAV-EQUILIBRIO 

IV. Rapport d’échange et transfert des avoirs

A) Les valeurs nettes d’inventaire des compartiments de INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV (la «société absor-

bée») et de LUXICAV (la «société absorbante»), calculées le 18 novembre 2002, serviront de base à l’établissement du
rapport d’échange des actions.

B) Le transfert des avoirs s’opérera comme suit, conformément aux articles 257 et suivants de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée par la loi du 7 septembre 1987:

1. L’actif et le passif du compartiment INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-OBBLIGAZIONARIO seront trans-

férés dans le compartiment LUXICAV-OBBLIGAZIONARIO (anciennement LUXICAV-CONSERVATEUR) en échange
d’actions et au prorata de la valeur nette d’inventaire de ce compartiment;

2. L’actif et le passif du compartiment INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-AZIONARIO seront transférés dans

le compartiment LUXICAV-AZIONARIO (anciennement LUXICAV-CROISSANCE PLUS) en échange d’actions et au
prorata de la valeur nette d’inventaire de ce compartiment;

3. Le transfert de l’actif et du passif des compartiments INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-BREVE TERMINE et

INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-AZIONARIO ITALIA dans les compartiments respectifs LUXICAV-BREVE
TERMINE et LUXICAV-AZIONARIO ITALIA s’effectuera sur base d’un rapport d’échange égal (1/1);

Compartiments absorbés

 Compartiments absorbants

INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-AZIONARIO . . . . . .

>>>

LUXICAV-CROISSANCE PLUS

INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-OBBLIGAZIONA-

RIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

>>>

LUXICAV-CONSERVATEUR

65385

4. L’actif et le passif du compartiment LUXICAV-MIXED seront transférés dans le compartiment LUXICAV-EQUI-

LIBRIO (anciennement LUXICAV-EQUILIBRE) en échange d’actions et au prorata de la valeur nette d’inventaire de ce
compartiment.

En contrepartie de la transmission universelle des avoirs de la société absorbée (INTESA LUXEMBOURG FUND,

SICAV) ainsi que du compartiment fusionnant LUXICAV-MIXED de la société absorbante, la société absorbante (LUXI-
CAV)  émettra et attribuera aux actionnaires des compartiments de la société absorbée (INTESA LUXEMBOURG
FUND, SICAV), ainsi qu’aux actionnaires du compartiment fusionnant LUXICAV-MIXED de la société absorbante un
nombre d’actions au sein des compartiments correspondants de la société absorbante (LUXICAV) proportionnel aux
actifs nets apportés à ces compartiments.

Des fractions d’actions (au millième) pourront être émises.
Tout actionnaire d’actions de capitalisation aura la possibilité de les échanger contre des actions de capitalisation ou

de distribution; ce choix sera également possible pour les actionnaires des compartiments INTESA LUXEMBOURG
FUND, SICAV-BREVE TERMINE et INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV-AZIONARIO ITALIA.

Aucun actionnaire de la société absorbée ne bénéficiera de droits spéciaux et aucun titre autre que des actions ne

sera émis.

A la suite de l’opération qui précède, la société absorbée (INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV) sera dissoute.
C) La date d’effet de la fusion est fixée au 18 novembre 2002 (ci-après la «Date d’effet»), date à laquelle la fusion

deviendra effective.

D) La fusion sera du point de vue comptable considérée comme accomplie le 18 novembre 2002; à partir de cette

date, les opérations seront accomplies pour compte de la société absorbante.

A l’exception d’une rémunération normale due aux experts indépendants et aux réviseurs d’entreprises des sociétés

participant à la fusion pour leurs prestations, aucun avantage particulier ne sera attribué ni aux experts indépendants ni
aux membres du Conseil d’administration et aux réviseurs d’entreprises des sociétés participant à la fusion.

E) Les actions des compartiments de LUXICAV nouvellement émises, suite à la fusion, bénéficieront des mêmes

droits à tous les égards que les actions existantes (actions de distribution/actions de capitalisation) et participeront à ce
titre aux bénéfices à partir du 18 novembre 2002.

V. Convocation d’une assemblée générale extraordinaire délibérant et approuvant le projet de fusion

Une assemblée générale extraordinaire de INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV sera convoquée le 14 octobre

2002 afin de délibérer et d’approuver le projet de fusion. A moins que les actionnaires de LUXICAV disposant d’au
moins 5% des actions en circulation ne le requièrent jusqu’au lendemain de la tenue de l’Assemblée générale de INTESA
LUXEMBOURG FUND, SICAV, la fusion sera réalisée sans décision d’une Assemblée générale extraordinaire des ac-
tionnaires de LUXICAV.

L’(les) assemblée(s) générale(s) extraordinaire(s) ne délibérera(ont) valablement que si les conditions de quorum et

de présence requises par la loi du 10 août 1915 (art. 67-1 et 2) sont remplies.

A partir du 13 septembre 2002, tout actionnaire pourra prendre connaissance ou obtenir sans frais ou sur simple

demande, au siège social, une copie des documents énumérés ci-après:

a) projet de fusion; 
b) comptes annuels ainsi que rapports de gestion des exercices 1998, 1999 et 2000 de LUXICAV et des exercices

2000 et 2001 de INTESA LUXEMBOURG FUND, SICAV; 

c) les états comptables respectivement arrêtés au 6 août 2002 pour LUXICAV et au 5 août 2002 pour INTESA

LUXEMBOURG FUND, SICAV; 

d) rapports des conseils d’administration des sociétés qui fusionnent; 
e) rapport d’examen du projet de fusion établi par le réviseur d’entreprises des sociétés qui fusionnent. 

VI. Répartition des frais inhérents à la fusion

Les frais sont estimés à EUR 20.000,- et seront payables par LUXICAV proportionnellement aux actifs nets de chaque

compartiment. Ces frais seront amortis sur une période d’un an à dater du 18 novembre 2002.

Ce projet de fusion a été approuvé séparément par les conseils d’administration de INTESA LUXEMBOURG FUND,

SICAV et de LUXICAV le 3 septembre 2002.

Un rapport de fusion examinant le projet de fusion sera rédigé par ERNST &amp; YOUNG S.A. qui évaluera l’apport des

portefeuilles-titres absorbés, de même que la pertinence du rapport d’échange.

Des photocopies de ces procès-verbaux resteront annexées aux présentes.
Le notaire soussigné certifie la légalité du projet de fusion.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite aux comparants et interprétation leur donnée en langue française, les comparants, tous connus

du notaire instrumentant par noms, prénoms états et demeures, ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé. S. Velter, G. Nimax, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 136S, fol. 32, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

 Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(68680/208/165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

Luxembourg, le 16 septembre 2002.

J. Delvaux.

65386

CREDIT SUISSE FUND OF FUNDS (LUX), Fonds Commun de Placement.

<i>Liquidationserlös

Die Anteilinhaber des Credit Suisse Fund of Funds (Lux) werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, daß per Be-

schluß vom 11. September 2002 der CREDIT SUISSE FUND OF FUNDS MANAGEMENT COMPANY, in ihrer Eigen-
schaft als Verwaltungsgesellschaft des Credit Suisse Fund of Funds (Lux), mit Zustimmung der BROWN BROTHERS
HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A., in ihrer Eigenschaft als Depotbank, der Fonds bzw. die Teilfonds Credit Suisse
Fund of Funds (Lux) Global Equity, Credit Suisse Fund of Funds (Lux) Global Growth und Credit Suisse Fund of Funds
(Lux) Global Balanced mit Wirkung zum 13. September 2002 aufgelöst und in Liquidation gesetzt wurden.

Die Ausgabe von Anteilen des Fonds wurde per Beschluß der Verwaltungsgesellschaft vom 11. September 2002 zum

12. September 2002 eingestellt. Die Rücknahme von Anteilen des Fonds wurde zum 13. September 2002 eingestellt und
kein Nettoinventarwert mehr berechnet.

Der an die Anteilinhaber auszuzahlende Liquidationserlös, nach Abzug aller Kosten zu Lasten des Anlagefonds be-

trägt:

Für den Subfund CS Fund of Funds (Lux) Global Equity: EUR 6,60
Für den Subfund CS Fund of Funds (Lux) Global Growth: EUR 5,72
Für den Subfund CS Fund of Funds (Lux) Global Balance: EUR 8,11
Am Tag der Publikation dieser Anzeige waren bereits alle ausstehenden Forderungen sowie etwaige Forderungen,

welche im Rahmen der Liquidation entstehen, zurückgestellt.

Anteile, die sich am Tage der Liquidation noch im Umlauf befanden, sind ab dem 19. September 2002 bei den Zahl-

stellen einlösbar. Der Liquidationserlös, abzüglich der Liquidationskosten und Honorare, der sich im Depot befindlichen
oder dematerialisiert verbuchten Anteile wird den jeweiligen Kontoinhabern mit Valuta 19. September 2002 gutge-
schrieben.

Nettoliquidationserlöse, die nicht zum Abschluß des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden

sind, werden von der Depotbank nach 6 Monaten für Rechnung der berechtigten Anteilinhaber bei der Caisse des Con-
signations in Luxemburg hinterlegt, bei der diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort
angefordert werden.

Die Konten und Geschäftsbücher des Anlagefonds werden für die Dauer von fünf Jahren bei der früheren Verwal-

tungsgesellschaft des Anlagefonds, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.,
hinterlegt.

Luxemburg, den 19. September 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2002, vol. 574, fol. 34, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68792/736/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 septembre 2002.

NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, Fonds Commun de Placement.

<i>Amendment to the management regulations

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. (the «Management Company») acting as management company to NOMU-

RA GLOBAL SELECT TRUST (the «Trust») with the approval of NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A., as custodian
of the Trust, has decided to create a new subfund under the name of «NOMURA GLOBAL SELECT TRUST - EURO
MONEY MARKET FUND» and to amend the Management Regulations of the Trust as follows:

1. Amendment of the first sentence of Article 1 to refer to «... transferable securities and other assets...»
2. Amendment of paragraph c) (iii) of Article 7 to read as follows: «payment of the purchase price will be made avail-

able to the former owner of such shares in the reference currency of the relevant Fund or in the discretion of the Man-
agement Company, in any other freely convertible currency at the rate of exchange for such reference currency of the
relevant Fund on the date of payment...»

3. Replacing the reference to «net asset value» by «Net Asset Value» in Articles 8, 10, 11, 12, 14, 18 and 19.
4. Amendment of the first sentence of Article 10 to read the «The Net Asset Value per share of each Fund expressed

in the reference currency of such Fund is determined on every Dealing Day immediately after the daily declaration of
dividends.»

Amendment of d) of Article 10 to read: «in the case where any asset or liability of the Trust cannot be considered

as being attributable to a particular pool, such asset or liability shall be allocated to all the pools pro rata to the total
Net Asset Values of the relevant Fund;»

5. Amendment of the third to last paragraph of Article 12 to read «Payment of the repurchase price and the dividends

as aforesaid shall be made in the reference currency of the Fund on the...»

6. Amendment of paragraph 3 of Article 14 by replacing the reference to «Agent Securities Company» by «Agent

Company.»

7. Amendment of the first paragraph of Article 16 by replacing the word «amount specified in its investment policy»

by «Fixed NAV amount».

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUND SERVICE (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Der Liquidator
Unterschriften

65387

Amendment of the second paragraph of Article 16 by replacing «Luxembourg Francs 50,000,000.-» by «Euro

1,239,467.62».

8. Appendix I is amended as follows:
«Under «3. Dividend Policy», the reference to «daily distribution of dividends» is replaced by «daily declaration of

dividends».

The reference to «Net Asset Value per share determined on the Dealing Day» is replaced by «Net Asset Value per

share of the Fund determined on the Dealing Day».

The reference to «the next Dealing Day following that last Dealing Day» is replaced by «the next Dealing Day fol-

lowing that aforesaid last Dealing Day».

Under «5. Fees of the Management Company», the text is amended to read «The Management Company is entitled

to receive a management fee payable quarterly in arrears, out of the assets of the Fund, at an annual rate of 0.01% of
the average daily Net Asset Values of such Fund during the relevant quarter.»

In sections 7 and 9, the reference to «Agent Securities Company» is replaced by «Agent Company».
In section 7, the following is added as last sentence:
«Any reasonable disbursement and out of pocket expenses incurred by the Agent Company will be borne by such

Fund.»

9. An Appendix II relating to «Euro Money Market Fund» is added to the Management Regulations.

<i>Appendix II to the management regulations of NOMURA GLOBAL SELECT TRUST

<i>Relating to the Fund

<i>EURO MONEY MARKET FUND

1. Name of the Fund:
EURO MONEY MARKET FUND (the «Fund»).
2. Investment Policy:
The investment objective of the Fund is to seek a stable rate of income while seeking preservation of capital and main-

tenance of liquidity. The Fund seeks to achieve this objective through investment in a diversified portfolio comprising
primarily Euro denominated money market instruments of high credit quality and liquidity.

The type of money market instruments in which the Fund may invest includes securities of the Member States of the

European Union («EU») and their agencies and instrumentalities, non-EU governments and their agencies and instru-
mentalities, and supranational entities, obligations of European and non-European banks (including bank deposits), com-
mercial paper and other short-term obligations of European and non-European companies and other entities, and other
investments deemed by the Management Company, appropriate and consistent with the Fund’s investment objective.

The Fund may also enter into repurchase agreements fully collateralised by securities of high credit quality with highly

rated financial institutions. In the context of such transactions, the Fund will mainly act as purchaser and will not sell the
securities and instruments which are the object of the agreement either before the repurchase of the securities by the
counterpart has been carried out or the repurchase period has expired.

Any investment made by the Fund shall have an effective maturity or term of twelve months or less at the time of

investment; provided that the Fund may invest in adjustable rate instruments of one year or longer of which interest
rate shall be adjusted at least annually based on the market rate; provided further that investment in such instrument is
deemed by the Management Company, appropriate and consistent with the Fund’s investment objective.

Under normal circumstances, the Fund’s weighted average maturity shall be kept within 90 days or less.
Any investment made by the Fund shall be rated A-1 or higher by STANDARD &amp; POOR’S, P-1 by MOODY’S or

similarly by any other internationally recognised statistical rating organisations or, if not rated, shall be one of which
credit quality is deemed by the Management Company, equivalent at the time of investment.

More than 50% of the Fund’s assets shall be invested in securities which fall within the definition of securities under

the Securities and Exchange Law of Japan.

3. Dividend Policy:
It is the intention of the Management Company to proceed to a daily declaration of dividends in an amount necessary

to maintain the Fund’s Net Asset Value per share at Euro 0.01. The dividends in respect of the shares of the Fund issued
will accrue during the period from (and including) the payment date (as defined in Article 8) hereof) of the shares up to
(but excluding) the repayment date (as defined in Article 12) hereof) of such shares. On the last Dealing Day in each
month, all dividends declared, accrued (up to and including the day immediately preceding the last Dealing Day) and not
yet paid (after deducting withholding and other taxes required to be paid (if any) in Luxembourg and/or countries of
shareholders in respect of dividends), are automatically reinvested against issue of further shares of the Fund at the Net
Asset Value per share of the Fund determined on the Dealing Day preceding the aforesaid last Dealing Day. If the Dis-
tributor or Selling Dealer, on behalf of the shareholder, has so indicated to the Transfer Agent of the Trust, dividends
will instead be paid in cash on the next Dealing Day following the aforesaid last Dealing Day by check or bank transfer,
subject to applicable foreign exchange regulations applicable in the country where the payment has been requested to
be made.

The Fund shall seek to maintain, to the extent reasonably possible, the Fund’s Net Asset Value per share at Euro 0.01.
4. Repurchase of Shares:
Shareholders may request the repurchase of their shares of the Fund on any Dealing Day.
5. Fees of the Management Company:
The Management Company is entitled to receive a management fee payable quarterly in arrears, out of the assets of

the Fund at an annual rate of 0.01% of the average of the daily Net Asset Values of such Fund during the relevant quarter.

6. Fees of the Investment Adviser:

65388

The investment adviser is entitled to an advisory fee payable quarterly in arrears, out of the assets of the Fund at an

annual rate of 0.15% of the average of the daily Net Asset Values of the Fund during the relevant quarter.

7. Fees of the Agent Company in Japan:
The Agent Company in Japan will charge to the Fund a fee at an annual rate of 0.08% of the average of the daily Net

Asset Values of the Fund, such fee to be paid quarterly, in arrears. Any reasonable disbursements and out-of-pocket
expenses incurred by the Agent Company will be borne by such Fund.

8. Fees of Distributor(s) in Japan:
Each of the Distributors in Japan is entitled to a fee payable quarterly, in arrears, out of the assets of each Fund, at

an annual rate of 0.35% of the average of the daily Net Asset Values of the Fund during the relevant quarter attributable
to the shares sold by the relevant Distributor in Japan.

9. Temporary waiver of fees:
The Investment Adviser, the Agent Company and the Distributors in Japan may choose to waive all of their fee or

any portion thereof at their absolute discretion for an indefinite period, in order to reduce the impact such fee may have
on the performance of the Fund in instances where the Fund’s net assets are of insufficient size. The fees effectively
charged during any semi-annual period will be disclosed in the periodical reports.

10. Duration of the Fund:
The Fund is established for an undetermined period.
11. Dealing Day:
Dealing Day means each day i) which is a bank business day in Luxembourg, London and Frankfurt, ii) on which the

Frankfurt Stock Exchange is open for business, and iii) which is a business day in Japan, except December 24th in each
year.

12. Reference Currency of the Fund: Euro.
This amendment to the Management Regulations shall become effective on 24th September, 2002.

Luxembourg, 5th September, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66489/260/121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, Fonds Commun de Placement.

<i>Amendment to the management regulations

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. (the «Management Company»), acting as Management Company to JANUS

GLOBAL LIFE SCIENCES FUND (the «Fund») and with the approval of NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. as
Custodian of the Fund, has decided to amend the Management Regulations of the Fund as follows:

- In article 7 - Issue Price - the words «except December 24th in each year» are added at the end of the third para-

graph.

- In article 15 - Dividends - the reference to «Luxembourg Francs 50,000,000.-» shall be to «EUR 1,239,467.62».
This amendment shall become effective five days after its publication in the Mémorial.

Luxembourg, 5th September, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 5 septembre 2002, vol. 573, fol. 98, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(66490/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 septembre 2002.

P.E.L.S., PROPRETE ECLAIR LUXEMBOURGEOISE DE SERVICES S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 36.810. 

La société INVEST GESTION INTERNATIONALE S.A., 11, rue Pierre d’Aspelt, L-1142 Luxembourg, dénonce, avec

effet immédiat, le siège social de la société P.E.L.S., PROPRETE ECLAIR LUXEMBOURGEOISE DE SERVICES S.A., R. C.
S. section B, n

°

 36.810.

Luxembourg, le 10 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 6. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56037/576/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A. / NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.
<i>as Management company / as Custodian
Signatures / Signatures

GLOBAL FUNDS MANAGEMENT S.A.

NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A.

<i>as Management Company

<i>as Custodian

Signatures

Signatures

EURO ASSOCIATES
Signature

65389

DSI INTERNATIONAL, S.à r.l. (LUXEMBOURG), Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

STATUTES

In the year two thousand and two, on the 8th of July
 Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven,

There appeared:

DISPLAY SPECIALTIES, INC., with registered office in 9, Beacon Drive, Wilder, Kentucky 41076, United States of

America

represented by Maître Emmanuelle Adam, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

Said proxy initialled ne varietur by the appearing party and the undersigned notary shall be annexed to the present

deed.

 The above named person in the capacity in which they act, have declared their intention to constitute by the present

deed a «société à responsabilité limitée» and to draw up the Articles of Association of it as follows:

 Art. 1. There is hereby established a «société a responsabilité limitée» which will be governed by the laws in effect

and especially by those of August 10th, 1915 referring to commercial companies as amended from time to time, as well
as by the present statutes.

Art. 2. The denomination of the corporation is:
DSI INTERNATIONAL, S.à r.l. (LUXEMBOURG) 

Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It can be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg according to an agreement of the par-

ticipants.

Art. 4. The object of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-

embourg or foreign companies and any other forms of investments, to acquire by way of purchase, subscription or oth-
erwise and to realize by sale, exchange or otherwise all types of transferable securities, the management control and
development of such interests the corporation may participate at the foundation and development of any industrial or
commercial enterprise and may borrow and grant any assistance to such enterprises by loans, guaranties or otherwise.

The corporation may lend or borrow with or without interests, issue bonds and other acknowledgements of debts.
The corporation may realize all personal real estate, financial or industrial, commercial or civil transactions, which

are directly or indirectly in connection to its object.

The corporation may realize its object directly or indirectly in its own name or on behalf of third parties, alone or in

association, by way or any kind of operations which may favour its object or the object of companies in which it has
interests.

In general the corporation may take any measures of control and supervision and carry out all operations which deem

to be useful to the accomplishment of its object and purpose. 

Art. 5. The corporation is established for an unlimited period.

Art. 6. The capital of the corporation is fixed at EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) divided into 125 

(one hundred and twenty-five) parts of EUR 100.- (one hundred Euro) each.

Art. 7. Parts may be freely transferred between participants.
 Transfer of parts inter vivos to non-participants may only be made with the agreement of participants representing

at least seventy-five per cent (75%) of the capital.

 For all other matters reference is being made to Articles 189 and 190 of the law referring to commercial companies.

Art. 8. A participant as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a participant cannot, 

under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the company, nor become involved
in any way in its administration.

 In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general

meetings.

 Art. 9. The death, the suspension of civil rights, the bankruptcy or the failure of one of the participants do not put

an end to the company. 

Art. 10. The company is administrated by one or more managers (gérants), who need not be participants. They are 

appointed by the general meeting of participants for an undefined period and they can be removed at any time.

 The powers of the managers (gérants) will be determined in their nomination deed.

Art. 11. Decisions of participants are being taken in a general meeting or by written consultation at the instigation

of the management.

 No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the participants representing more than fifty per

cent (50%) of the capital.

 As long as the company has only one participant the sole participant will exercise the powers reserved by law or by

the present statutes to the general meeting of participants.

 The resolutions taken by the sole participant will be set down in the form of minutes. 

65390

Art. 12. The accounting year of the corporation starts on the first (1st) of January and ends on the last day of De-

cember each year. However, the first financial year starts on the day of the incorporation of the corporation and shall
end on December 31st, 2002.

 Art. 13. Each year on the last day of December an inventory of the assets and the liabilities of the corporation as

well as a balance sheet and a profit and loss account shall be drawn up.

 The revenues of the corporation, deduction made of the general expenses and the charges, the depreciations and

the provisions constitute the net profit.

 Five per cent (5%) of this net profit shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compul-

sory as soon as the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation, but it must be resumed
until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.  The balance
is at the disposal of the general meeting of participants.

Art. 14. In case of dissolution of the corporation each participant will draw, before any distribution, the nominal

amount of his parts in the capital; the surplus shall be divided in proportion to the invested capital of the participants.
Should the net assets not allow the reimbursement of the capital, the distribution will take place in proportion to the
initial investments.

Art. 15. In case of dissolution of the corporation the liquidation will be carried out by one or more liquidators who 

need not to be participants, designated by the meeting of participants at the majority defined by Article 142 of the Law
of August 10th 1915 and of its modifying laws. The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the re-
alization of the assets and payment of the liabilities.

 Art. 16. The parties will refer to the existing regulations for all matters not mentioned in the present statutes.

<i>Subscription

 The statutes having thus been established; the party appearing declares to subscribe the whole capital as follows: 

 All the parts have been paid up of one hundred per cent (100%), whereof the sole participant gives himself receipt

and discharge.

 The notary executing this deed specifically acknowledges that the Company has, as of now, the amount of twelve

thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) at its disposal, proof of which is furnished.

<i> Estimation - Expenses

 The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of its formation, are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (1,500.-EUR).

<i>Extraordinary general meeting

 After the Articles of Association have thus been drawn up, the above named participant exercising the powers of

the general meeting has passed the following resolutions:

1) Have been elected managers (gérants) of the company for an undetermined period: 
- Mr Doug Bray, (general business person) residing at 5, Colonel Pointe Drive, Wilder, Kentucky 41076, United States

of America;

He is invested with the broadest powers to act in the name of the company by his sole signature;
- Mr Thomas K. Frickman, (general business person) residing at 3233, High Ridge Drive, Taylor Mill, Kentucky 41015,

United States of America; 

He is invested with the broadest powers to act in the name of the company by his sole signature.
- Mr Robert Zeisloft, (general business person) residing at 615, Loveland Miamiville Road, Loveland, Ohio 45140,

United States;

He is invested with the broadest powers to act in the name of the company when his signature is accompanied by

either that of Mr Doug Bray or Mr Thomas Frickman.

 2) The registered office of the company is fixed at L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
 The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English followed by a French version; on the request of the same
appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be pre-
vailing.

 Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

 The document having been read to the person appearing, known to the notary by its name, first name, civil statute

and residence, the said person appearing signed together with the notary the present original deed.

 Follows the French version: 

 L’an deux mille deux, le huit juillet.
 Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven,

A comparu:

 La société DISPLAY SPECIALTIES, INC., établie et ayant son siège social au 9, Beacon Drive, Wilder, Kentucky

41076, Etats-Unis d’Amérique,

DISPLAY SPECIALTIES, INC., prenamed, one hundred and twenty-five   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 parts

Total: one hundred and twenty-five  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125 parts

65391

représentée par Maître Emmanuelle Adam, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé.

Laquelle procuration, après avoir été signée par le comparant et le notaire instrumentaire restera annexée au présent

acte.

 Lequel comparant, ès-qualités qu’il agit, a déclaré avoir constitué une société à responsabilité limitée dont il a arrêté

les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et

notamment par celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle qu’amendée ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de:
DSI INTERNATIONAL, S.à r.l. (LUXEMBOURG)

Art. 3. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg de l’accord des associés.

Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes es-
pèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. 

La société pourra prendre part à l’établissement et au développement de toute entreprise industrielle ou commer-

ciale et pourra prêter son assistance à pareille entreprise au moyen de prêts, de garantie ou autrement. 

Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêt, émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, immobilières, financières ou industrielles, commerciales ou ci-

viles, liées directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou en as-

sociation en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient
des intérêts.

D’une façon générale, la société pourra exercer toutes activités généralement quelconques qui pourraient paraître

nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet social. 

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-), représenté par cent vingt-cinq parts

sociales (125) de cent Euro (EUR 100,-) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
 Des transferts de parts sociales inter vivos à des non-associés ne peuvent se faire que moyennant l’agrément des

associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.

 Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

 Art. 8. Un associé ainsi que les héritiers et représentants ou ayants-droit et créanciers d’un associé ne peuvent,

sous aucun prétexte, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer en aucune
manière dans les actes de son administration.

 Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées

générales.

 Art. 9. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la société.

 Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés par l’assemblée

générale des associés pour une durée indéterminée et peuvent à tout moment être révoqués.

 Les pouvoirs des gérants seront déterminés dans leur acte de nomination. 

Art. 11. Les décisions des associés sont prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la diligence de la

gérance.

 Une décision n’est valablement prise qu’après avoir été adoptée par des associés représentant plus de cinquante

pour cent (50%) du capital social.

 Aussi longtemps que la société n’a qu’un seul associé, il exercera tous les pouvoirs réservés à l’assemblée générale

des associés par la loi ou par les présents statuts.

 Les résolutions prises par l’associé unique seront inscrites sous forme de procès-verbaux.

Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le dernier jour du mois de décembre de chaque année. 

Par dérogation, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et finira le 31 décembre
2002.

 Art. 13. Chaque année au dernier jour de décembre il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte de profits et pertes.

 Les produits de la société, déduction faite des frais généraux, charges, amortissements et provisions, constituent le

bénéfice net.

 Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve; ce prélèvement

cesse d’être obligatoire, dès que le fonds de réserve a atteint le dixième du capital, mais devrait toutefois être repris
jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été
entamé. Le solde est à la disposition de l’assemblée générale des associés.

65392

 Art. 14. En cas de dissolution de la société, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa

part dans le capital; le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le rembourse-
ment du capital social, le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

 Art. 15. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modifi-
catives.

 Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 16. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions des lois 

afférentes.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi établis, le comparant souscrit l’intégralité du capital comme suit: 

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, ce dont l’associé unique se donne quittance et décharge:
 Le notaire instrumentaire constate expressément que dès à présent la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR

12.500,-) se trouve à la disposition de la société ainsi qu’il lui en a été justifié.

<i>Evaluation - Frais

 Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève approximativement à mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les statuts de la société ayant été arrêtés ainsi, l’associé préqualifié, exerçant les pouvoirs de l’assemblée générale,

a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants de la société pour une durée indéterminée: 
- M. Doug Bray, (administrateur de sociétés) demeurant 5, Colonel Pointe Drive, Wilder, Kentucky 41076, Les Etats-

Unis d’Amérique;

La société est valablement engagée par la signature unique de M. Doug Bray;
- M. Thomas K. Frickman, (administrateur de sociétés) demeurant 3233, High Ridge Drive, Taylor Mill, Kentucky

41015, Les Etats-Unis d’Amérique;

La société est valablement engagée par la signature unique de M. Thomas Frickman;
- M. Robert Zeisloft, (administrateur de sociétés) demeurant 615, Loveland Miamiville Road, Loveland, Ohio 45140,

Les Etats-Unis d’Amérique.

La société est valablement engagée par la signature conjointe de M. Robert Zeisloft avec celles de M. Doug Bray et/

ou M. Thomas Frickman.

2) Le siège social est établi à L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
 Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur la demande du comparant, le présent

acte de société est rédigé en langue anglaise suivi d’une version en langue française et qu’en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

 Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
 Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: E. Adam, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 11 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 45, case 5. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55980/202/227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

SANPAOLO GESTION INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 28.536. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 22 avril 2002, actée sous le n

°

 280/

2002 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55992/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

 La société DISPLAY SPECIALTIES, INC., prénommée, cent vingt-cinq  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 125 parts

Total: cent vingt-cinq  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 125 parts

Senningerberg, le 19 juillet 2002.

P. Bettingen.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

65393

KORTMANN BAU, S.à r.l., Unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-2222 Luxemburg, 84, rue de Neudorf.

Im Jahre zweitausendzwei, den fünften Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Ist erschienen:

Herr Suat Dedeic, Eisenflechter, wohnhaft zu L-2222 Luxemburg, 84, rue de Neudorf.
Welcher Komparent, den instrumentierenden Notar ersucht, die Satzungen einer von ihm zu gründenden uniperso-

nalen Gesellschaft mit beschränkter Haftung wie folgt zu beurkunden:

Art. 1. Der vorbenannte Komparent, errichtet hiermit eine unipersonale Gesellschaft mit beschränkter Haftung un-

ter der Bezeichnung: 

KORTMANN BAU, S.à r.l.
Der einzige Gesellschafter kann sich jederzeit mit einem oder mehreren Gesellschaftern zusammenschliessen und die

zukünftigen Gesellschafter können ebenso die geeigneten Maßnahmen treffen, um die unipersonale Eigentümlichkeit der
Gesellschaft wieder herzustellen.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluß der Gesellschafter an jeden anderen Ort in der Gemeinde des Gesell-

schaftssitzes verlegt werden.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft sind Beton- und Stahlbetonarbeiten aller Arten sowie der Handel mit jeglicher Art

von Baumaterial.

Die Gesellschaft ist berechtigt bewegliche und unbewegliche Güter zu erwerben, alle Geschäfte und Tätigkeiten vor-

zunehmen und alle Maßnahmen zu treffen welche mit dem Gegenstand der Gesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu-
sammenhängen oder ihm zu dienen geeignet erscheinen; in diesem Sinne kann sie sich in anderen Gesellschaften oder
Firmen im In- und Ausland beteiligen, mit besagten Rechtspersonen zusammenarbeiten sowie selbst Zweigniederlassun-
gen errichten, sowie jede Art von Tätigkeit, welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt
oder denselben fördern kann, im In- und Ausland, ausüben.

Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer errichtet.

Art. 5. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres. Ausnahmsweise be-

ginnt das erste Geschäftsjahr am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2002.

Art. 6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und ist eingeteilt in

hundert (100) Geschäftsanteile zu je hundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-).

Alle einhundert (100) Anteile wurden von Herrn Suat Dedeic, vorbenannt, gezeichnet. 
Der alleinige Gesellschafter erklärt, dass die Gesellschaftsanteile voll in barem Gelde eingezahlt wurden, so dass ab

heute der Gesellschaft die Summe von zwölf tausend fünfhundert Euro (EUR 12.500,-) zur Verfügung steht, so wie dies
dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil berechtigt zur proportionalen Beteiligung an den Nettoaktiva sowie an den Gewin-

nen und Verlusten der Gesellschaft.

Art. 8. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den einzigen Gesellschafter sowie die Übertragung von

Anteilen durch Erbschaft oder durch Liquidation einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.

Im Todesfalle des einzigen Gesellschafters wird die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.
Wenn es mehrere Gesellschafter gibt, sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen

unter Lebenden an Nichtgesellschafter sind nur mit dem vorbedingten Einverständnis der Gesellschafter, welche wenig-
stens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, möglich.

Bei Todesfall können die Anteile an Nichtsgesellschafter nur mit der Zustimmung der Anteilsbesitzer, welche minde-

stens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden Anteile vertreten, übertragen werden.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen,

verwaltet.

Sie werden vom einzigen Gesellschafter oder, je nachdem, von den Gesellschaftern, ernannt und abberufen.
Die Gesellschafter bestimmen die Befugnisse der Geschäftsführer.
Falls die Gesellschafter nicht anders bestimmen, haben die Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, um unter allen Um-

ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln.

Der Geschäftsführer kann Spezialvollmachten erteilen, auch an Nichtgesellschafter, um für ihn und in seinem Namen

für die Gesellschaft zu handeln. 

Art. 10. Bezüglich der Verbindlichkeit der Gesellschaft sind die Geschäftsführer als Beauftragte nur für die Ausfüh-

rung ihres Mandates verantwortlich.

Art. 11. Tod, Verlust der Geschäftsfähigkeit, Konkurs oder Zahlungsunfähigkeit eines Gesellschafters lösen die Ge-

sellschaft nicht auf.

Gläubiger, Berechtigte und Erben eines verstorbenen Gesellschafters können nie einen Antrag auf Siegelanlegung am

Gesellschaftseigentum oder an den Gesellschaftsschriftstücken stellen.

65394

Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich an die Satzung der Gesellschaft, an die von der Gesellschaft aufgestellten

Werte und Bilanzen, sowie an die Entscheidungen halten, welche von den Gesellschafterversammlungen getroffen wer-
den.

Art. 12. Am 31. Dezember eines jeden Jahres werden die Konten abgeschlossen und die Gesellschaftsführer erstel-

len den Jahresabschluss in Form einer Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung.

Der nach Abzug der Kosten, Abschreibung und sonstigen Lasten verbleibende Betrag stellt den Nettogewinn dar.
Dieser Nettogewinn wird wie folgt verteilt:
- fünf Prozent (5,00%) des Gewinnes werden der gesetzlichen Reserve zugeführt, gemäß den gesetzlichen Bestimmun-

gen,

- der verbleibende Betrag steht den Gesellschaftern zur Verfügung.

Art. 13. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren, von den Gesell-

schaftern ernannten Liquidatoren, welche keine Gesellschafter sein müssen, durchgeführt.

Die Gesellschafter bestimmen über die Befugnisse und Bezüge der Liquidatoren.

Art. 14. Für alle Punkte, welche nicht in diesen Satzungen festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die gesetzlichen

Bestimmungen.

<i> Schätzung der Gründungskosten

Die Kosten und Gebühren, in irgendwelcher Form, welche der Gesellschaft wegen ihrer Gründung obliegen oder zur

Last gelegt werden, werden auf ein tausend Euro (EUR 1.000,-) abgeschätzt.

<i> Ausserordentliche Generalversammlung

Anschliessend an die Gründung hat der einzige Gesellschafter, welcher das Gesamtkapital vertritt, sich zu einer aus-

serordentlichen Generalversammlung zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

Zu Geschäftsführern werden ernannt für eine unbestimmte Dauer:
a) Herr Gildo Kortmann, Stahl- und Betonbauer, mit Wohnsitz in L-2222 Luxemburg, 84, rue de Neudorf, als tech-

nischer Geschäftsführer.

b) Herr Suat Dedeic, Eisenflechter, wohnhaft zu L-2222 Luxemburg, 84, rue de Neudorf, als administrativer Ge-

schäftsführer.

Die Gesellschaft wird rechtskräftig verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift der beiden Geschäftsführer.
Sie können ausserdem Vollmacht an Drittpersonen erteilen. 
Der Sitz der Gesellschaft befindet sich auf folgender Adresse:
L-2222 Luxemburg, 84, rue de Neudorf. 
Der Notar hat den Komparenten darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-

sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor der Aufnahme jeder kommerziellen Tätigkeit er-
forderlich ist, was der Komparent ausdrücklich anerkennt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort

bekannt, hat der Erschienene gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: S. Dedeic, P. Bettingen
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 40, case 12. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, er-

teilt.

(55981/202/103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

PIZZAPHONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4943 Esch-sur-Alzette, 1, rue J.P. Michels.

R. C. Luxembourg B 62.628. 

L’an deux mille deux, le dix juillet.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Madame Véronique Giorgi, maître d’hôtel, demeurant à Esch-sur-Alzette, 134, boulevard J.-F. Kennedy.
Laquelle comparante déclare être la seule associée de la société à responsabilité limitée PIZZAPHONE, S.à r.l., avec

siège social à L-4940 Bascharage, 124, route de Luxembourg.

inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg section B numéro 62.628,
constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire instrumentant en date du 23 décembre 1997, publié au Mémorial

C numéro 261 du 21 août 1998,

dont le capital social est de cinq cent mille francs (500.000,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d’une

valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune, est reparti comme suit: 

Senningerberg, den 18. Juli 2002.

P. Bettingen.

Madame Véronique Giorgi, prénommée, cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

Total: cinq cent parts sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500

65395

La comparante prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
1.- La comparante décide de convertir le capital social en Euros de sorte que le capital représente maintenant douze

mille trois cent quatre-vingt-quatorze euros et soixante-huit cents (EUR 12.394,68). Pour arrondir ce capital et pour
disposer de parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-), la comparante déclare qu’elle a versé
à la caisse de la société le montant de cent cinq euros et trente-deux cents (EUR 105,32) pour pouvoir disposer d’un
capital de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Suite à la décision qui précède l’article quatre (4) des statuts à dorénavant la teneur suivante.

 Art. 4. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.»

2.- La comparante décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle L-4940 Bascharage, 124,

route de Luxembourg à L-4943 Esch-sur-Alzette, 1, rue J.-P. Michels de sorte que l’article trois (3) des statuts a doré-
navant la teneur suivante.

 Art. 3. Le siège social est établie à Esch-sur-Alzette.
3.- Madame Maria Antonia Devillanova, demeurant à Esch-sur-Alzette, 134, boulevard J.-F. Kennedy, a déclaré démis-

sionner en tant que gérant technique. Il lui est accordé pleine et entière décharge pour l’exercice de son mandat.

Madame Véronique Giorgi, prénommée, exerçant actuellement la fonction de gérant administratif, est nommée pour

le futur gérant de la société, laquelle peut engager la société par sa seule signature.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, à l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. Giorgi, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 12 juillet 2002, vol. 880, fol. 13, case 6. – Reçu 12 euros. 

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de la publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

(55878/219/44) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

PIZZAPHONE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4943 Esch-sur-Alzette, 1, rue J.P. Michels.

R. C. Luxembourg B 62.628. 

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 10

juillet 2002, déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55879/219/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

WELFORT INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 63.210. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 2 juillet 2002, Monsieur Cavalli Ferdinando, Employé

Privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55998/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Esch-sur-Alzette, le 17 juillet 2002.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 19 juillet 2002.

F. Kesseler.

<i>Pour WELFORT INTERNATIONAL HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme 
<i>Banque domiciliataire
Signatures

65396

GOLDMAN SACHS MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à r.l., 

Société à responsabilité limitée.

Registered office: Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

STATUTES

In the year two thousand two, on the eleventh of June.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven. 

There appeared:

(1) The company GS MEZZANINE PARTNERS II OFFSHORE, L.P., having its registered office in 85 Broad Street,

New York, New York 10004, represented by Alain Steichen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on June 10, 2002.

Which proxy shall be signed ne varietur by the representative of the above named person and the undersigned notary

and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

(2) The company GS MEZZANINE PARTNERS II, L.P., having its registered office in 85 Broad Street, New York, New

York 10004, represented by Alain Steichen, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given on June 10, 2002.

Which proxy shall be signed ne varietur by the appearing parties and the undersigned notary and shall be attached to

the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties has requested the notary to draw up the following articles of incorporation of a company with

limited liability, («société à responsabilité limitée») which they declared to form: 

Art. 1. There is hereby formed a Company with limited liability («société à responsabilité limitée») governed by ac-

tual laws, especially the laws of August 10th, 1915 on commercial companies and of September 18th, 1933 on limited
liability companies, as amended, and the present articles of incorporation. 

Art. 2. The Company is incorporated under the name of GOLDMAN SACHS MEZZANINE PARTNERS II LUXEM-

BOURG, S.à r.l.

Art. 3. The business purpose of the Company is to manage and to carry out financial, property and holding activities,

especially for example

- to lend and borrow money;
- to supply or procure the supply of money loans to bodies corporate and companies as well as to draw or to procure

the drawing of money loans;

- to enter into agreements whereby the Company commits itself as guarantor or severally liable co-debtor, or grants

security or declares itself jointly or severally liable with or for others, to the benefit of bodies corporate and companies;

- either alone or jointly with others to acquire and dispose of participations or other interests in bodies corporate,

companies and enterprises, to collaborate with and to manage such bodies corporate, companies or enterprises;

- to acquire, manage, turn to account, encumber and dispose of any property -including intellectual property rights-

and to invest capital; and

- to do all such things as are incidental or conducive to the above objects or any of them, or otherwise permitted by

law. 

Art. 4. The Company has its registered office and its place of effective management in the City of Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg. The registered office and place of effective management may be transferred to any other place
within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners. 

Art. 5. The Company is formed for an unlimited period. 
Art. 6. The subscribed capital is set at fifteen thousand Euro (EUR 15,000.-), represented by six hundred (600) shares

with a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.- ) each, entirely subscribed and fully paid up. 

Art. 7. Shares are freely transferable among partners. Transfer of shares inter vivos to non partners may only be

made with the prior approval of partners representing at least three quarters of the capital.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the law on commercial companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them. 

Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-

vency of any partner. 

Art. 9. A partner as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a partner cannot, under

any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become involved in
any way in its administration.

In order to exercise their rights they have to refer to financial statements and to the decisions of the general meetings. 

Art. 10. The Company is managed by a Board of Managers which will be composed of at least three members, who

need not be partners.

The managers will be appointed by the general meeting of partners with or without limitation of their period of office.
The Board of Managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may

preside over the meeting.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the

Board to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the Board of Managers who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Managers

by means of a communications device including a telephone or a video conference which allows all the other members
of the Board of Managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications

65397

device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such
meeting, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Members of the Board of Managers who participate in the proceedings of a meeting of the Board of Managers
by means of such a communications device shall ratify their votes so cast by signing one copy of the minutes of the meet-
ing.

The Board of Managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, as often as the in-

terest of the Company so requires.

The board can validly deliberate and act only if the majority of Managers is present or represented.
Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of Managers present or represented.
Circular resolutions signed by all members of the Board of Managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

The resolutions of the Board will be recorded in minutes signed by all of the members who took part at the deliber-

ation.

Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the

chairman of the meeting or any two managers. 

Art. 11. The Board of Managers is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-

position in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of partners

fall within the competence of the Board of Managers.

The Board of Managers may pay interim dividends.
In the event of a vacancy on the Board of Managers, the remaining managers have the right to provisionally fill the

vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of

the first managers will be determined in the act of nomination. 

Art. 12. The Board of Managers may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one

or more managers, who will be called Managing Director. 

Art. 13. The Company is committed by the sole signature of the Managing Director for decisions having a value of

an amount of up to EUR 1,000.-.

For decisions having a value of an amount over EUR 1,000.-, the Company is committed by the joint signature of at

least two Managers. 

Art. 14. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-

larly taken by him in the name of the Company; as a proxyholder he is only responsible for the execution of his mandate. 

Art. 15. Decisions of partners shall be taken in a general meeting or by written consultation at the instigation of the

management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the partners representing more than fifty
percent (50%) of the capital. 

Art. 16. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December. Exceptionally

the first financial year shall begin today and close on the 31th of December 2002. 

Art. 17. Each year, as of the thirty-first of December, the management will draw up the balance sheet which will

contain a record of the property of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex
containing a summary of all the commitments and debts of the manager(s) to the Company.

At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-

ing of partners together with the balance sheet. 

Art. 18. Each partner may inspect at the registered office the inventory, the balance sheet and the profit and loss

account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations,

charges and provisions represents the net profit of the Company.

Each year, five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve. This deduction ceases to be com-

pulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the subscribed capital but must be resumed until the re-
serve fund is entirely reconstituted if, any time and for any reason whatever, it has been touched. The balance is at the
disposition of the general meeting of partners. 

Art. 20. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators

who need not to be partners, designated by the meeting of partners at the majority defined by article 142 of the law of
August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The liquidator(s) shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payment of the debts. 

Art. 21. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the parties refer to the existing

laws.

<i>Subscription

The shares have been subscribed as follows: 
(1) GS MEZZANINE PARTNERS II OFFSHORE, L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

140 shares

(2) GS MEZZANINE PARTNERS II, L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

460 shares

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

600 shares

65398

All the shares have been totally paid up so that the amount of fifteen thousand euros (15,000.- EUR) is from this on

at free disposal of the corporation and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests
thereto.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand five hundred Euro (EUR
1,500.-).

<i>Decision of the shareholders

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named partners took the following resolutions:
1) The number of managers is fixed at three.
2) Are appointed as managers for an unlimited period:
- Alain Steichen, avocat à la Cour, 44, rue de la Vallée, B.P. 522, L-2015 Luxembourg
- Robin Doumar, Managing Director, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, GOLDMAN SACHS INTERNA-

TIONAL, Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB

- Dr. Martin Hintze, Associate, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL,

Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 21313

3) Is appointed as Managing Director for an unlimited period:
- Alain Steichen, avocat à la Cour, 44, rue de la Vallée, B.P. 522, L-2015 Luxembourg
4) The Company shall have its registered office in 44, rue de la Vallée, B.P. 522, L-2015 Luxembourg
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

persons, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the persons appearing, said persons signed with us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède

L’an deux mille deux, le onze juin.
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven. 

Ont comparu:

(1)GS MEZZANINE PARTNERS II OFFSHORE, L.P, avec siège social à 85 Broad Street, New York, New York 10004,

ici représentée par M

e

 Alain Steichen, avocat à la cour, demeurant à 44, rue de la Vallée, L-2015 Luxembourg, en vertu

d’une procuration sous seing privé en date du 10 juin 2002.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée avec lui.

(2) GS MEZZANINE PARTNERS II, L.P, avec siège social à 85 Broad Street, New York, New York 10004, ici repré-

senté par M

e

 Alain Steichen, avocat à la cour, demeurant à 44, rue de la Vallée, L-2015 Luxembourg, en vertu d’une

procuration sous seing privé en date du 10 juin 2002.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent

acte pour être enregistrée avec lui. 

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société à responsabilité

limitée qu’ils déclarent constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois actuellement en

vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée, telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts. 

Art. 2. La société prend la dénomination de GOLDMAN SACHS MEZZANINE PARTNERS II LUXEMBOURG, S.à

r.l.

Art. 3. L’objet de la Société est de gérer et d’opérer des activités financières, de propriété et de participation, et

essentiellement:

- de prêter et d’emprunter de l’argent;
- de fournir ou de faire fournir des crédits en espèces à des personnes morales et sociétés, ainsi que de retirer ou

de faire retirer des crédits en espèces;

- de conclure des conventions par lesquelles la Société s’engage en tant que garant ou débiteur solidaire, ou octroie

des garanties ou se déclare solidairement responsable avec ou pour d’autres, au profit d’entités et sociétés dont il est
fait référence au point a);

- d’acquérir soit seule ou solidairement avec d’autres et disposer de participations ou d’autres intérêts dans des en-

tités, sociétés et entreprises, de collaborer avec et gérer ces entités, sociétés ou entreprises;

- d’acquérir, gérer, développer, grever et disposer de toute propriété -y compris des droits intellectuels- et d’investir

du capital; et

- faire tout ce qui est accessoire ou se rattache aux objets ci-dessus ou chacun d’eux, ou autrement autorisé par la loi. 

Art. 4. Le siège social et le siège effectif de direction est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège

social et le siège effectif de direction pourront être transférés en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par
simple décision des associés. 

65399

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée. 

Art. 6. Le capital social est fixé à quinze mille Euro (15.000,- EUR), représenté par six cents (600) parts sociales,

d’une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune. 

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Aucune cession de parts sociales entre vifs à un

tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres associés représentant au moins les trois quarts
du capital. 

Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi sur les sociétés commerciales.
Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle. 

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne met pas fin à la société. 

Art. 9. Un associé ainsi que les héritiers, les représentants ou ayants-droit et les créanciers d’un associé ne pourront,

pour quelque motif que ce soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent pour l’exercice de leurs droits se rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées. 

Art. 10. La société est administrée par un Conseil de Gérance qui sera composé de trois membres au moins, associés

ou non.

Les gérants sont nommés par l’assemblée générale des associés, pour une durée limitée ou sans limitation de durée.
Le conseil désigne parmi ses membres un président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion peut

être conférée à un autre gérant présent. 

Chaque gérant de la société peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par câble,

télégramme, télex, téléfax ou tous autres moyens de communication électronique, un autre membre du Conseil de Gé-
rance comme son mandataire.

Tout membre du Conseil de Gérance qui participe à une réunion du Conseil de Gérance via un moyen de commu-

nication (incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du Conseil de Gérance pré-
sents à cette réunion (soit en personne soit par mandataire ou au moyen de ce type de communication) d’entendre à
tout moment ce membre et permettant à ce membre d’entendre à tout moment les autres membres sera considéré
comme étant présent en personne à cette réunion et sera pris en compte pour le calcul du quorum et autorisé à voter
sur les matières traitées à cette réunion. Les membres du Conseil de Gérance qui participent à une réunion du Conseil
de Gérance via un tel moyen de communication ratifieront leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du
procès-verbal de cette réunion.

Le Conseil de Gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, aussi souvent que

l’intérêt de la société l’exige.

Le Conseil ne peut délibérer et agir que si une majorité de gérants sont présents ou représentés.
Les résolutions seront adoptées si elles ont été prises à la majorité des votes des membres présents soit en personne

soit par mandataire à telle réunion.

Les résolutions circulaires signées par tous les membres du Conseil de Gérance seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d’une résolution identique. 

Les résolutions du Conseil de Gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par tous les membres qui ont

participé à la réunion.

Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d’une procédure judiciaire ou ailleurs seront valablement

singées par le Président de la réunion ou par deux gérants. 

Art. 11. Le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration et de

disposition qui rentrent dans l’objet social.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l’assemblée

générale.

Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes.
En cas de vacance d’une place au conseil, les gérants restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement; dans ce cas

l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement

des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination. 

Art. 12. Le Conseil de Gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs gérants qui pren-

dront la dénomination de gérants-délégués. 

Art. 13. La société est engagée par la seule signature du gérant-délégué pour toute décision ayant une valeur jusqu’à

un montant de EUR 1.000,-.

Concernant les décisions ayant une valeur supérieure à EUR 1.000,-, la société est engagée par les signatures con-

jointes d’au moins deux gérants. 

Art. 14. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat. 

Art. 15. Les décisions seront prises en assemblée générale ou par voie de consultation écrite à la demande de la

gérance. Les décisions ne sont valablement adoptées que par les associés représentant plus de la moitié (50%) du capital
social. 

65400

Art. 16. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Exceptionnellement

le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2002. 

Art. 17. Chaque année, avec effet au trente et un décembre, la gérance établit le bilan qui contiendra l’inventaire des

avoirs de la société et de toutes les dettes actives et passives, ensemble avec une annexe contenant un résumé de tous
les engagements ainsi que les dettes du ou des gérants à l’égard de la société.

A la même date la gérance préparera un compte de profits et pertes qu’elle soumettra, avec le bilan, à l’assemblée

générale des associés. 

Art. 18. Tout associé peut prendre inspection au siège social de la société de l’inventaire, du bilan et du compte de

profits et pertes. 

Art. 19. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements

et provisions, constitue le bénéfice net de la société. 

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale. 
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital souscrit,

mais devront être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, la
réserve légale a été entamée. Le solde est à la disposition de l’assemblée des associés. 

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne doivent

pas être associés, désignés par l’assemblée des associés statuant à la majorité prévus à l’article 142 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

Art. 21. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se référent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Souscription

Les parts sociales ont été souscrites de la façon suivante: 

Toutes les parts ont été entièrement souscrites et intégralement libérées de sorte que la somme de quinze mille

euros (15.000,- EUR) est dès maintenant à la disposition de la société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ mille cinq cents Euro (EUR 1.500).

<i>Décisions des associés

Immédiatement après la constitution de la société, les associés ont pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre des gérants est fixé à trois.
2) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Alain Steichen, avocat à la Cour, 44, rue de la Vallée, B.P. 522, L-2015 Luxembourg
- Robin Doumar, Managing Director, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, GOLDMAN SACHS INTERNATIO-

NAL, Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB

- Dr. Martin Hintze, Associate, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL,

Principal Investment Area, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB 

3) Est nommé gérant-délégué pour une durée indéterminée:
- Alain Steichen, avocat à la Cour, 44, rue de la Vallée, B.P. 522, L-2015 Luxembourg
4) Le siège social de la société est établi à 44, rue de la Vallée, B.P. 522, L-2015 Luxembourg
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête des comparants les pré-

sents statuts sont rédigés en anglais suivis d’une version française, à la requête des mêmes comparants et en cas de di-
vergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: A. Steichen, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 12CS, fol. 96, case 11. – Reçu 150 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

(55982/202/305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(1) GS MEZZANINE PARTNERS II OFFSHORE, L.P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 140 parts

(2) GS MEZZANINE PARTNERS II, L.P  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

460 parts

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 600 parts

Senningerberg, le 1

er

 juillet 2002.

P. Bettingen.

65401

GANTRO INVEST, Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

STATUTES

In the year two thousand two, on the fifth of July.
Before Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich. 

There appeared the following:

Mr Jan Roland Persson, managing director, residing in SE-236 37 Höllviken, 17, Domkyrkovägen (Sweden),
here represented by Mr Sidney Bouvier, legal advisor, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given in Höllviken, on May 16th, 2002,
Said proxy, after signature ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached to the

present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said party, represented as aforesaid, has declared forming a private limited liability company on the basis of the

Articles of Incorporation of which they have agreed as follows:

Art. 1. There is hereby formed a corporation in the form of a private limited liability company under the name of

GANTRO INVEST.

Art. 2. The registered office of the corporation is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

Art. 3. The corporation is established for an unlimited period from the date hereof.

Art. 4. The company has as object all activities relating directly or indirectly to the taking of participating interests

in whatsoever form, in any enterprise in the form of a company limited by shares or of a private company, as well as the
administration, management, control and development of such participations without having to remain within the limits
established by the Law of July 31, 1929, concerning holding Companies.

In particular the company may use its funds for the creation, management, development and the realisation of a port-

folio comprising all types of transferable securities, take part in the creation, development and control of all enterprises,
acquire all securities, either by way of contribution, subscription, purchase option or otherwise, as well as realise them
by sale, transfer, exchange. The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to any
company in which it has a direct or indirect substantial interest.

The company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money.

In general, the company may carry out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial ac-

tivity as well as all transactions and operations which it may deem useful to promote and facilitate directly or indirectly
the accomplishment and development of its purpose.

Art. 5. The corporate capital is fixed at twelve thousand and five hundred Euros (12,500.- EUR) divided into five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five Euros (25.- EUR) each, all subscribed by Mr Jan Roland Persson,
managing director, residing in SE-236 37 Höllviken, 17, Domkyrkovägen (Suede).

The capital of 12,500.- EUR has been fully paid in by contribution in cash and is at the disposal of the company, wher-

eover proof has been given to the undersigned notary.

Art. 6. The management of the corporation shall be assumed by one or more directors, who needs not be share-

holder. The director, in accordance with the shareholders, may appoint a manager, whose power shall be defined by
the general meeting.

Art. 7. The management has full power to perform such acts as shall be necessary or useful to the corporation’s

object. All matters not expressly reserved to the general meeting by law or by the present articles of incorporation are
within the competence of the management.

The corporation is committed either by the signature of the director or by the signature of a manager in accordance

with his delegated power.

Art. 8. The corporation’s financial year shall begin on the first of January and shall end on the 31st of December.

Art. 9. In the event of incapacitation or death of a shareholder the corporation will not be dissolved. The shares of

the disabled or dead shareholder will be taken over by application of the law.

Art. 10. The law of August 1915 on commercial companies, as amended, shall apply in so far as these articles of

incorporation do not provide for the contrary. 

<i>Transitory provisions

The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and end on the 31st of December

2003.

<i>Statement

The notary drawing up the present deed declares that the conditions set forth in Article 26 of the law on commercial

companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

65402

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at 1,150.- EUR. 

<i>Extraordinary General Meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital, has immediately proceeded to hold an Extraor-

dinary General Meeting and has passed the following resolutions:

1.- The registered office is established in L- 2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
2.- The number of managers is fixed at two.
Are appointed managers for an unlimited period:
- Mr Jan Roland Persson, prenamed, technical manager,
- Mrs. Lena Kristin Persson, director, residing in SE-236 37 Höllviken, 17, Domkyrkovägen (Sweden), administrative

manager,

3.- The Company will be bound by the sole signature of the technical director or by the joint signature of the technical

and the administrative director.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed and the Articles of Incorporation contained therein, is worded in English, followed by a French
version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French texts,
the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary, have set our hand and seal in Luxembourg on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read and translated to appearing person known to the undersigned notary by their names,

usual surnames, civil status and residences, said appearing person signed with us, the notary, the present original deed. 

Suit la traduction française

L’an deux mille deux, le cinq juillet. 
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

A comparu:

Monsieur Jan Roland Persson, managing director, demeurant à SE-236 37 Höllviken, 17, Domkyrkovägen (Suede),
ici représentée par Monsieur Sidney Bouvier, juriste, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donné à Höllviken, le 16 mai 2002,
Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant demeurera annexée

au présent acte pour être enregistrée en même temps.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a déclaré constituer une société à responsabilité limitée dont il a

arrêté les statuts comme suit: 

Art. 1

er

. Par les présentes il est formé une société à responsabilité limitée sous le dénomination de GANTRO IN-

VEST. 

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée gé-

nérale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts. 

Art. 3. La société est établie pour une durée indéterminée à partir de ce jour. 

Art. 4. La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de partici-

pations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise luxembourgeoise ou étrangère se présentant sous forme
de société de capitaux ou de société de personnes, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement
de ces participations sans avoir à respecter les limites de la loi du 31 juillet 1929, sur les sociétés holding.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres, participer à la création, au développement et au contrôle de toutes entreprises,
acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres,
les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange, accorder tous concours, prêts, avances ou garanties à toute société
dans laquelle elle dispose d’un intérêt direct ou indirect.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

En général, la société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial, mobilières, immobilières, commerciales,

industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature à promouvoir et à faciliter directement
ou indirectement la réalisation de l’objet social ou son extension. 

Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) divisé en cinq cents (500) parts sociales

de vingt-cinq Euros (25,- EUR) chacune, toutes attribuées à Monsieur Jan Roland Persson, managing director, demeurant
à SE-236 37 Höllviken, 17, Domkyrkovägen (Suede).

Le prédit capital de 12.500,- EUR a été libéré entièrement par un versement en espèces et se trouve dès-à-présent

à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.

Art. 6. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être

associé. Le gérant pourra, avec l’accord de l’associé, nommer un directeur. Les pouvoirs du directeur seront définis par
l’assemblée générale. 

65403

Art. 7. La gérance a tout pouvoir pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social.

Tout ce qui n’est pas expressément réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts relève de sa com-
pétence.

La société se trouve valablement engagée soit par la signature du gérant, soit par la signature du directeur en confor-

mité avec ses pouvoirs. 

Art. 8. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. 

Art. 9. La société n’est pas dissoute par l’incapacité ou le décès d’un associé. Les parts de l’associé incapable ou dé-

cédé seront reprises par application à la loi. 

Art. 10. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, est applicable, pour autant qu’il

n’est pas autrement décidé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 2003.

<i>Déclaration

Le notaire rédacteur du présent acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi

du 10 août,1915 sur les sociétés commerciales et en affirme expressément l’accomplissement.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa constitu-

tion sont estimés à environ 1.150,- EUR

<i>Assemblée générale extraordinaire

La partie précitée, représentant l’entièreté du capital souscrit a immédiatement tenu une Assemblée Générale Extra-

ordinaire et a pris les décisions suivantes:

1.- Le siège de la société est établi à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy. 
2.- Le nombre des gérants est fixé à deux.
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jan Roland Persson, prénommé, gérant technique,
- Madame Lena Kristin Persson, administrateur, demeurant à SE-236 37 Höllviken, 17, Domkyrkovägen (Suede), gé-

rant administratif,

3.- La société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant technique ou par la signature conjointe

du gérant technique et du gérant administratif.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une version française, sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. Bouvier, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 17, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(55983/206/163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

TROY INVESTMENT, Aktiengesellschaft.

Siège social: L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendzwei, den sechsundzwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.

Sind erschienen:

1.- Herr Ronald Weber, Revisor, wohnhaft in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
2.- Die Aktiengesellschaft Holding LUXLUCE S.A. mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, eingetragen im

Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 37.761,

hier vertreten durch Herrn Ronald Weber, vorbenannt, handelnd aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift gege-

ben in Luxemburg am 26. Juni 2002,

welche Vollmacht, nach gehöriger ne varietur Paraphierung durch den Komparenten und den amtierenden Notar,

gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Welche Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt, beschlossen haben zwischen ihnen eine Ak-

tiengesellschaft zu gründen mit folgenden Statuten:

Luxembourg-Eich, le 19 juillet 2002.

P. Decker.

65404

Kapitel 1. Form - Name - Sitz - Zweck - Dauer der Gesellschaft

Art. 1. Form, Name der Gesellschaft. Zwischen den obengenannten Komparenten und all jenen Personen, wel-

che Inhaber der Anteile werden, welche hiermit geschaffen werden, wird andurch eine Gesellschaft in der Form einer
Aktiengesellschaft (die «Gesellschaft») gegründet. Diese Aktiengesellschaft unterliegt der Gesetzgebung des Grossher-
zogtums Luxemburg («Luxemburg») und den Bestimmungen dieser Satzung.

Die Gesellschaft trägt den Namen TROY INVESTMENT

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er kann durch Beschluss des Verwaltungsrates an jeden anderen Ort innerhalb des Grossherzogtums Luxemburg ver-

legt werden.

Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art

eingetreten sind oder bevorstehen, die die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder die Verbindung zwi-
schen dem Gesellschaftssitz und dem Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschafts-
sitz vorübergehend ins Ausland verlegen. Diese provisorischen Massnahmen haben keinen Einfluss auf die
Staatszugehörigkeit der Gesellschaft, welche, unbeschadet dieser provisorischen Verlegung des Gesellschaftssitzes, die
Luxemburger Staatszugehörigkeit beibehält.

Die Anordnung der Verlegung des Gesellschaftssitzes ist von einer der Personen, die mit der täglichen Geschäftsfüh-

rung betraut sind, auszuführen und bekanntzugeben.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung in jedmöglicher Form an anderen lu-

xemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung dieser Beteiligun-
gen.

Sie kann vor allem auf dem Wege von Einlagen, Zeichnungen, Optionen, Kauf und jeder anderen Weise Werte je-

derzeit erwerben und diese durch Verkauf, Abtretung, Tausch oder anders realisieren und verwerten.

Die Gesellschaft kann Patente und alle mit diesen Patenten verbundenen Rechte erwerben und verwalten.
Die Gesellschaft kann den Unternehmen an denen ein direktes und substantielles Interesse besteht, jeder Zeit jede

Hilfeleistung, Darlehn, Vorauszahlungen oder Garantien gewähren.

Sie kann alle Massnahmen vornehmen um ihre Rechte zu garantieren, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhän-

gen oder ihn fördern, alles im Rahmen von Artikel 209 des abgeänderten Gesetzes über die Handelsgesellschaften.

Art. 4. Dauer der Gesellschaft. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung gemäss den gesetzli-

chen Bestimmungen aufgelöst werden.

Kapitel II. Kapital - Aktien

Art. 5. Kapital. Das Gesellschaftskapital wird festgesetzt auf vierzigtausend Euro (40.000,-) eingeteilt in vierhundert

(400) Aktien mit einem Nennwert von je einhundert Euro (100,-).

Art. 6. Form der Aktien. Die Aktien sind je nach Belieben des Aktionärs entweder Namens- oder Inhaberaktien.

Kapitel III. Verwaltungsrat

Art. 7. Verwaltungsrat. Die Verwaltung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat von mindestens drei Mit-

gliedern, welche nicht Gesellschafter sein müssen. Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Gesellschafterver-
sammlung gewählt, die die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder festlegt. Die Verwaltungsratsmitglieder werden auf eine
Höchstdauer von sechs Jahren ernannt und bleiben im Amt bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Verwaltungsratsmitglieder
sind wiederwählbar und können jederzeit von der Gesellschafterversammlung mit oder ohne Grund abberufen werden.

Art. 8. Verwaltungsratssitzungen. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestimmen.
Er kann ebenfalls einen Sekretär bestimmen, der nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein muss und der für die Sit-

zungsprotokolle der Gesellschafterversammlung und der Verwaltungsratssitzungen zuständig ist.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen durch Einberufung des Vorsitzenden und ebenso jedesmal dann, wenn zwei Ver-

waltungsratsmitglieder die Einberufung verlangen.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz der Gesellschafterversammlungen und der Verwaltungsratssitzun-

gen; in seiner Abwesenheit wird die Gesellschafterversammlung oder der Verwaltungsrat mit einer Mehrheit der Stim-
men ein anderes Verwaltungsratsmitglied bestimmen, welches den Vorsitz der Versammlung führen wird.

Die schriftliche Einberufung aller Verwaltungsratssitzungen muss mindestens eine Woche vor der Sitzung an alle Ver-

waltungsratsmitglieder verschickt werden, mit Ausnahme von Dringlichkeitsfällen oder im Falle des Einverständnisses
aller Personen, die an der Sitzung teilnehmen können.

Die Einberufung gibt den Ort, die Zeit und die Tagesordnung der Sitzung an.
Durch schriftliches Einverständnis aller Verwaltungsratsmitglieder per Telekopie oder durch jede Art von Fernmel-

detechnik kann auf die Einberufung verzichtet werden.

Es bedingt keiner speziellen Einberufung für Sitzungen, für welche das Datum und der Sitzungsart im voraus durch

Beschluss des Verwaltungsrates festgelegt worden sind.

Jede Verwaltungsratssitzung findet in Luxemburg statt oder an einem anderen Ort, welcher von Zeit zu Zeit vom

Verwaltungsrat bestimmt werden kann.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann einem anderen Mitglied durch Telefax oder durch jede Art von Fernmeldetechnik

Vollmacht zur Vertretung und zur Abstimmung bei Einer Verwaltungsratssitzung erteilen.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig beraten und ist nur dann beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Verwaltungsrats-

mitglieder erschienen oder vertreten ist.

Jeder Beschluss wird durch die Mehrheit der abstimmenden erschienenen oder vertretenen Mitglieder gefasst.

65405

In Dringlichkeitsfällen ist ein schriftlicher Beschluss, welcher von allen Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben ist,

gültig und rechtsverbindlich, als wäre er während einer rechtmässig einberufenen Verwaltungsratssitzung, die gültig be-
raten hat, gefasst worden.

Ein solcher Beschluss kann in einem oder mehreren getrennten Dokumenten mit gleichem Inhalt beurkundet werden.

Jedes dieser Dokumente ist von einem oder mehreren Verwaltungsratsmitglieder unterschrieben.

Art. 9. Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzungen. Die Sitzungsprotokolle der Verwaltungsratssitzun-

gen werden vom Vorsitzenden der Versammlung unterschrieben. Die Vollmachten sind den Protokollen beizufügen. Die
Abschriften und Auszüge von Protokollen, welche vor Gericht oder anderswo vorzulegen sind, werden vom Verwal-
tungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben.

Art. 10. Befugnisse des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat ist befugt, jedwede Handlung vorzunehmen, wel-

che zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig oder zweckdienlich ist. 

Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbe-

halten sind, fallen in den Kompetenzbereich des Verwaltungsrates.

Art. 11. Übertragung von Vollmachten. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesell-

schaft sowie die Vertretung derselben in Bezug auf die tägliche Geschäftsführung an ein oder mehrere Verwaltungsrats-
mitglieder sowie an geschäftsführende Direktoren, Bevollmächtigte, Angestellte oder andere Beauftragte übertragen,
welche nicht Gesellschafter sein müssen aber Gesellschafter sein können. Der Verwaltungsrat kann auch Spezialvoll-
machten oder Vollmachten erteilen oder fortdauernde oder vorübergehende Funktionen an Personen oder Beauftragte
seiner Wahl übergeben.

Falls die tägliche Geschäftsführung an ein Mitglied des Verwaltungsrates übertragen wird, ist hierzu die vorherige Ge-

nehmigung der Gesellschafterversammlung nötig.

Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist gegenüber Dritten rechtsverbindlich verpflichtet durch

die gemeinsame Unterschrift von je zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch die einzelne Unterschrift der
Person, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt wurde, im Rahmen dieser täglichen Geschäftsführung, oder
durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift von allen Personen, auf die der Verwaltungsrat solche Unterschrifts-
befugnisse übertragen hat, aber nur im Rahmen dieser Unterschriftsbefugnisse.

Art. 13. Kommissare. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, Gesellschafter

oder Nichtgesellschafter.

Die Kommissare werden durch die Gesellschafterversammlung, welche ihre Zahl bestimmt, für eine Höchstdauer von

sechs Jahren ernannt und bleiben auf ihrem Posten bis zur Wahl ihres Nachfolgers. Sie sind wiederwählbar; die Gesell-
schafterversammlung kann ihr Mandat zu jeder Zeit mit oder ohne Grund widerrufen.

Kapitel IV. Gesellschafterversammlung

Art. 14.  Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung, welche ordnungsge-

mäss zusammengekommen ist, vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Sie hat sämtliche Befugnisse, welche das Gesetz und gegenwärtige Satzung ihr erteilen.

Art. 15. Jährliche Gesellschafterversammlung. Die jährliche Gesellschafterversammlung tritt ein am ersten

Dienstag des Monats Mai eines jeden Jahres um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen Ort, welcher in
der Einberufung angegeben ist.

Ist dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag, so wird die jährliche Gesellschafterversammlung am darauffolgenden Werktag

abgehalten.

Art. 16. Andere Gesellschafterversammlungen. Der Verwaltungsrat kann andere Gesellschafterversammlun-

gen einberufen. Diese Versammlungen müssen auf Anfrage von Aktionären abgehalten werden, die mindestens ein Fünf-
tel des Gesellschaftskapitals vertreten.

Wenn Fälle von höherer Gewalt eintreten sollten, welche souverän vom Verwaltungsrat abgewägt werden, können

die Gesellschafterversammlungen, inbegriffen auch die jährliche Gesellschafterversammlung, im Ausland abgehalten wer-
den.

Art. 17. Prozedur, Wahl. Die Gesellschafterversammlungen werden vom Verwaltungsrat oder von den Kommis-

saren in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form einberufen.

Die Einberufung beinhaltet die Tagesordnung der Gesellschafterversammlung.
Falls sämtliche Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und erklären, die der Versammlung vorgelegte Tages-

ordnung zu kennen, kann eine Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Einberufung rechtsgültig abgehalten
werden.

Jeder Gesellschafter kann einen Bevollmächtigten, Gesellschafter oder Nichtgesellschafter, durch Telekopie oder

durch jede Art von Fernmeldetechnik zu seiner Vertretung und zur Abstimmung bei einer Gesellschafterversammlung
ernennen.

Der Verwaltungsrat ist befugt, alle anderen Bedingungen zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung festzule-

gen.

Ausser im Falle einer gegensätzlichen Bestimmung des Gesetzes werden die Beschlüsse, unbeschadet der Zahl der

auf der Gesellschafterversammlung vertretenen Aktien, mit einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst.

Die Änderung der Satzung verlangt die Präsenz oder die Vertretung von fünfzig Prozent des Gesellschaftskapitals und

eine Zweidrittelmehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Gesellschafter.

Jede Aktie gibt Recht auf ein Stimmrecht.

65406

Die Abschriften oder Auszüge der Versammlungsprotokolle, welche bei Gericht oder anderswo vorzulegen sind,

werden vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Kapitel V. Geschäftsjahr - Gewinnausschüttung

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem ersten Tag des Monats Januar und endet mit dem letz-

ten Tag des Monats Dezember.

Der Verwaltungsrat bereitet die Jahresrechnung entsprechend den luxemburgischen Rechtsvorschriften und den

Buchhaltungsregeln vor.

Art. 19. Gewinnausschüttung. Von denn durch die Bilanz ausgewiesenen Reingewinn sind 5% abzuziehen zur

Speisung des gesetzlichen Reservefonds. Die Verpflichtung dieses Abzuges entfällt, sobald und solange der Reservefonds
ein Zehntel des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Auf Empfehlung des Verwaltungsrates wird die Gesellschafterversammlung über die Ausschüttung des Saldos des

Reingewinnes entscheiden. 

Die Gesellschafterversammlung kann beschliessen, den restlichen Gewinn oder einen Teil davon einem Reserve-

oder Provisionsfonds zukommen zu lassen, ihn zu übertragen oder an die Gesellschafter als Dividende zu verteilen. 

Der Verwaltungsrat kann unter den gesetzlich festgelegten Bedingungen eine Anzahlung auf Dividende vornehmen.
Der Verwaltungsrat beschliesst den Betrag und das Datum, an welchem eine solche Anzahlung vorgenommen wird.
Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der vom Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen, ihre eigenen Aktien zurück-

kaufen.

Kapitel Vl. Auflösung - Liquidation

Art. 20. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschafterversammlung kann zu jeder Zeit unter denselben Bedingungen

hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der Mehrheit wie die, die für eine Satzungsänderung erforderlich sind, die Auflö-
sung der Gesellschaft entscheiden, ausser bei anderslautenden Gesetzesbestimmungen.

Bei Auflösung der Gesellschaft werden ein oder mehrere Liquidatoren ernannt. Ihre Ernennung erfolgt durch die Ge-

sellschafterversammlung, welche ihre Befugnisse und Bezüge festsetzt.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 21. Geltendes Recht. Für alle Punkte, welche nicht durch die gegenwärtige Satzung bestimmt werden, bezie-

hen sich die Parteien auf das Gesetz vom 15. August 1915 betreffend die Handelsgesellschaften sowie dessen Abände-
rungsgesetze. 

<i>Zeichnung und Zahlung der Aktien

Nachdem erfolgter Festlegung der Statuten durch die Komparenten, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt,

werden die Aktien wie folgt gezeichnet: 

Das Kapital wurde vollständig in bar einbezahlt und steht der Gesellschaft zur Verfügung, worüber dem unterzeich-

neten Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Erklärung

Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Han-

delsgesellschaften vorgesehenen Bestimmungen erfüllt sind.

<i>Übergangsbestimmungen

1.- Die erste Generalversammlung wird im Jahre 2003 stattfinden.
2.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und wird am letzten Tag des Monats

Dezember 2002 enden.

<i>Kosten

Die Auslagen, Kosten und Honorare jedweder Art welche der Gesellschaft aufgrund gegenwärtiger Gründung er-

wachsen, werden abgeschätzt auf 1.530,-  .

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Und sofort nach der Gründung der Gesellschaft haben die Aktionäre, anwesend oder vertreten wie eingangs erwähnt,

welche das gesamte Kapital vertreten und sich als rechtsgültig einberufen erklären, zu einer ausserordentlichen Haupt-
versammlung zusammenfunden und haben einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1) Der Sitz der Gesellschaft ist in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy.
2) Zu Mitgliedern des Verwaltungsrates werden ernannt, ihr Mandat erlöscht bei der ordentlichen Generalversamm-

lung welche über das Geschäftsjahr 2005 befindet.

- Herr Franz Bondy, Direktor, wohnhaft in L-7456 Lintgen, 9, place Roschthen.
- Herr Marc Kipfer, Jurist, wohnhaft in CH-8700 Küsnacht, 2, Bungertweg.
- Herr Roland Bonnici, Direktor, wohnhaft in L-8017 Strassen, rue de la Chapelle.

1.- Herr Ronald Weber, Revisor, wohnhaft in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, zwanzig Aktien . . . . . . . . .  20
2.- Die Aktiengesellschaft Holding LUXLUCE S.A. mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place de Nancy, eingetragen

im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer 37.761, drei-
hundertachtzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Total: vierhundert Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

65407

3) Zum Kommissar wird ernannt: Die Aktiengesellschaft PKF LUXEMBOURG mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, place

de Nancy, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg Sektion B unter Num-
mer 48.951.

Das Mandat erlöscht bei der ordentlichen Generalversammlung welche über das Geschäftsjahr 2005 befindet.
4) Gemäß den Bestimmungen der gegenwärtigen Statuten und des Gesetzes ermächtigt die Generalversammlung den

Verwaltungsrat die tägliche Geschäftsführung sowie die Vertretung der Gesellschaft im Rahmen dieser Geschäftsführung
einem oder mehreren seiner Mitglieder zu übertragen oder an jede andere durch den Verwaltungsrat bestimmte Per-
son.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Da-

tum wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem unterzeichneten Notar nach Na-

men, gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, hat der Komparent mit dem Notar gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: R. Weber, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 2 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 11, case 1. – Reçu 400 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations.

(55984/206/222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

INVESCO EUROPEAN CDO I S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 86.409. 

In the year two thousand two, on the twentieth day of June.
Before Us, Maître Paul Decker, notary, residing in Luxembourg-Eich. 

Was held the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the public limited liability company INVESCO

EUROPEAN CDO I S.A. a «Société anonyme» under Luxembourg law having its registered office at L-2320 Luxem-
bourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

incorporated pursuant to a deed of Maître Paul Decker, notary residing in Luxembourg-Eich, on March 6th, 2002,

published in the Recueil du Mémorial C, Number 540 of April 6th, 2002,

filed in the register of commerce at Luxembourg RCS Number B 86.409, 
The meeting is opened at 9.30 a.m. and is presided by Mr Régis Galiotto, private employee, residing in Luxembourg-

Eich,

The Chairman appoints as secretary Mrs. Céline Fournier, private employee, residing in Luxembourg-Eich,
The meeting elects as scrutineer Mr Eric Biren, company director, residing in Luxembourg,
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1.- To change the financial year end of the Company so that the financial year of the company shall forthwith start on

July 1st of each calendar year and end on June 30th of the following calendar year, the current financial year ending on
June 30th, 2003.

2.- Amendment of the Article 18, first paragraph of the Articles of Incorporation as follows:

«Art. 18. First paragraph. The accounting year of the company shall begin on the first of July of each year and shall

terminate on the thirtieth of June of the following year.»

II) The shareholders represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are

shown on an attendance list, which, signed by the proxies of the represented shareholders, the members of the bureau
of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by
the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been initialled ne varietur, by the proxies of the rep-

resented shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain an-
nexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole capital of the Company is represented at the present extraordinary gen-

eral meeting, the notice of which has been duly waived by all the shareholders present or represented.

IV) The chairman states that the present meeting is regularly constituted and may validly decide on its agenda.
The chairman then submits to the vote of the members of the meeting the following resolutions which, after delib-

eration, were all adopted by unanimous vote.

<i>First resolution

The General Meeting resolves to change the financial year end of the company so that the financial year of the com-

pany shall forthwith start on July 1st of each calendar year and end on June 30th of the following calendar year, the
current financial year ending on June 30th, 2003.

Luxemburg-Eich, den 19 Juli 2002.

P. Decker.

65408

<i>Second resolution

The General Meeting resolves to amend the article 18, first paragraph of the Articles of Incorporation as follows:

«Art. 18. First paragraph. The accounting year of the company shall begin on the first of July of each year and shall

terminate on the thirtieth of June of the following year.»

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned at 9.45 a.m.

<i>Valuation, Expenses, Costs

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are es-

timated at 870.- EUR. 

Whereover the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this doc-

ument, followed by a translation in French. In case of divergences between the two texts the english version shall prevail.

The document having been read to the appearing persons, all of them known to the notary by their names, Christian

names, civil status and domiciles, said appearing persons, signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français.

L’an deux mille deux, le vingt juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme INVESCO EUROPEAN CDO

I S.A. une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la
Pétrusse,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich le 6 mars 2002, publié

au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations N° 540 du 6 avril 2002,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 86.409,
L’assemblée générale extraordinaire est ouverte à 9.30 heures sous la présidence de Régis Galiotto, employé privé,

demeurant professionnellement à Luxembourg-Eich,

Le président nomme secrétaire Madame Céline Fournier, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg-Eich,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Eric Biren, company director, demeurant à Luxembourg,
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d’acter que:
I) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1.- Changement de la fin de l’exercice social de la société en sorte que l’exercice social dorénavant commence le 1

er

juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante, l’exercice actuel se terminant le 30 juin 2003.

2.- Modification du 1

er

 alinéa de l’article 18 des statuts comme suit:

«Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale de la société commencera le 1

er

 jour du mois de juillet de chaque année

et se terminera le 30 juin de l’année suivante.»

II) Les actionnaires représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions des actionnaires,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les mandataires des actionnaires représentés au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées ne varietur par les mandataires des actionnaires représentés,

les membres du bureau et le notaire instrumentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée gé-

nérale extraordinaire, qui a été dûment approuvé par tous les actionnaires présents ou représentés.

IV) Le président constate que la présente assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur

les points de l’ordre du jour.

Le président soumet ensuite au vote des membres de l’assemblée les résolutions suivantes qui ont été, après délibé-

ration, toutes prises à l’unanimité des voix.

<i>Première résolution

L’Assemblée Générale décide de changer la fin de l’exercice social de la société en sorte que l’exercice social com-

mence dorénavant le 1

er

 juillet de chaque année et se termine le 30 juin de l’année suivante, l’exercice social actuel se

terminant le 30 juin 2003.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée Générale décide de modifier l’article 18, premier alinéa des statuts de la société pour lui donner la te-

neur suivante:

«Art. 18. Premier alinéa. L’année sociale de la société commencera le 1

er

 jour du mois de juillet de chaque année

et se terminera le 30 juin de l’année suivante.»

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée à 9.45 heures.

<i>Evaluation, Dépenses, Frais

Les frais, dépenses, rémunération et charges qui incombent à la société en raison du présent acte, sont évalués à 870,-

EUR.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes, avec la traduction en langue française qui suit.

En cas de divergences d’interprétation entre les deux textes, la version anglaise prévaudra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus par le notaire instrumentaire par noms, pré-

noms usuels, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: C. Fournier, R. Galiotto, E. Biren, P. Decker.

65409

Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 13CS, fol. 19, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(55985/206/109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

INVESCO EUROPEAN CDO I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 86.409. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 juillet 2002.

(55986/206/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

ONE-TWO-THREE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 84.169. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55994/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

FA &amp; MA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4205 Esch-sur-Alzette, 10, rue Lankelz.

R. C. Luxembourg B 82.269. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55995/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

SINVAR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.383. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 2 juillet 2002, Monsieur Cavalli Ferdinando, Employé

Privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56000/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Luxembourg-Eich, le 19 juillet 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker

Senningerberg, le 20 juillet 2002.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 19 juillet 2002.

Signature.

<i>Pour SINVAR HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

65410

FINARCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5326 Contern, 22, rue Edmond Reuter.

R. C. Luxembourg B 78.384. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55996/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

ALAVITA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6117 Junglinster, 13A, rue de la Gare.

R. C. Luxembourg B 71.230. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55997/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

GLENVILLE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 83.522. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction de Président du con-

seil d’administration, prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouveau Président du conseil d’administration avec effet au 2 juillet 2002, Madame Brero

Emanuela, Employée Privée, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédéces-
seur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55999/024/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

LIFT LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3390 Peppange, 64, route de Crauthem.

STATUTS

L’an deux mille deux, le treize juin.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu:

 1. Monsieur Jean-Pierre Schellings, administrateur de sociétés, demeurant à B-4654 Charneux, 112, Rue Beauregard.
 2. Madame Marie Cécile Geron, administrateur de sociétés, demeurant à B-4654 Charneux, 112, Rue Beauregard,
 ici représentée par Monsieur Livius Gorecka, économiste-juriste, demeurant à Luxembourg,
 en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 13 juin 2002.
 Ladite procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

 3. Monsieur Guy Feltus, administrateur de sociétés, demeurant à B-6720 Habay, 16, rue de l’Hôtel de Ville.
 Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d’une société anonyme qu’ils

déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de LIFT LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Peppange dans la commune de Roeser.

Senningerberg, le 20 juillet 2002.

P. Bettingen.

Senningerberg, le 19 juillet 2002.

P. Bettingen.

<i>Pour GLENVILLE HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

65411

Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d’administration.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Une telle décision n’aura d’effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l’organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet la commercialisation, la construction, l’installation et la maintenance de monte-char-

ges, d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques, de matériel de manutention et de levage et de tout matériel nécessaire ou
connexe, ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se ratta-
chant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développe-
ment.

Titre II: Capital, Actions

 Art. 5. Le capital social est fixé à quatre-vingt-six mille Euros (86.000,- EUR) représenté par cent (100) actions sans

valeur nominale.

 Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représen-

tatifs de plusieurs actions.

 Les titres peuvent aussi être nominatifs ou au porteur, au gré de l’actionnaire.
 La société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
 Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Titre III: Administration

 Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six années, par l’assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle.

 Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l’assemblée

générale de la société.

Art. 7. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président.
 Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

 Art. 8. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale. Il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions
prévues par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs dont 

celle de l’administrateur-délégué, ou par la signature d’un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à prendre
quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d’administration en vertu
de l’article 10 des statuts.

 Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administra-

teurs qui prendront la dénomination d’administrateurs-délégués.

 Il peut aussi confier la direction de l’ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pou-
voirs, choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

 Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d’administration, poursuites et diligences de son président ou d’un administrateur délégué à ces fins.

Titre IV: Surveillance

 Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six années.

Titre V: Assemblée générale

 Art. 13. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans les con-

vocations, le 2 mai à 15.00 heures et pour la première fois en 2003.

 Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI: Année sociale, Répartition des bénéfices

 Art. 14. L’année sociale commence le 1

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

 Exceptionnellement, le premier exercice social comprendra tout le temps à courir de la constitution de la société

jusqu’au 31 décembre 2002.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice 

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois

65412

être repris jusqu’à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

 Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII: Dissolution, Liquidation

 Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale.
 Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII: Dispositions générales

 Art. 17. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Souscription

 Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit: 

 Les actions ont été libérées à concurrence de 100%, de sorte que la somme de quatre-vingt-six mille Euros (86.000,-

EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire. 

<i>Constatation

 Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Evaluation des Frais

 Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, à environ deux mille Euros (2.000,- EUR).

<i>Assemblée générale extraordinaire

 Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,

se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

 Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les

résolutions suivantes:

 1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
 2. Sont nommés administrateurs:
 a) Monsieur Jean-Pierre Schellings, prénommé,
 b) Madame Marie Cécile Geron, prénommée,
 c) Monsieur Guy Feltus, prénommé.
 3. Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:
 ELIOLUX S.A., ayant son siège social à L-1853 Luxembourg-Cents, 24, rue Léon Kauffman.
 4. Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l’issue de l’assemblée générale or-

dinaire statutaire de l’année 2007.

 5. Le siège social de la société est fixé à L-3390 Peppange, 64, route de Crauthem.
 6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière ainsi que la représentation

de la société concernant cette gestion à un ou plusieurs de ses membres.

<i>Réunion du Conseil d’Administration

 Ensuite les membres du conseil d’administration, tous présents ou représentés, et acceptant leur nomination, ont

désigné à l’unanimité en conformité des pouvoirs leur conférés par les actionnaires, Monsieur Jean-Pierre Schellings, pré-
nommé, comme administrateur-délégué pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature pour les
matières de gestion journalière; pour les autres matières, la co-signature de l’administrateur-délégué et de l’un des deux
autres administrateurs sera requise.

 Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes. 
 Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J.-P. Schellings, L. Gorecka, G. Feltus, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 juin 2002, vol. 13CS, fol. 9, case 12. – Reçu 860 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56066/220/134) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

 1. Monsieur Jean-Pierre Schellings, prénommé, quatre-vingt-cinq actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

 2. Madame Marie Cécile Geron, prénommée, deux actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

 3. Monsieur Guy Feltus, prénommé, treize actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

 Total: cent actions   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

Hesperange, le 15 juillet 2002.

G. Lecuit.

65413

COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.781. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 2 juillet 2002, Madame Brero Emanuela, Employée Pri-

vé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56003/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

CARVAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.154. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 2 juillet 2002, Madame Brero Emanuela, Employée Pri-

vé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56004/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

S.E.F. SOCIETE EUROPEENNE FINANCIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 85.220. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 2 juillet 2002, Monsieur Cavalli Ferdinando, Employé

Privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

<i>Pour COSMA FINANCE INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme 
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour CARVAL S.A.
Société Anonyme 
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour S.E.F. SOCIETE EUROPEENNE FINANCIERE S.A.
Société Anonyme 
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

65414

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56005/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

ARAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.174. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 2 juillet 2002, Madame Brero Emanuela, Employée Pri-

vé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56006/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.358. 

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue au siège social le 2 juillet 2002

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de Monsieur Longoni Massimo de sa fonction d’administrateur,

prend acte de cette démission.

Le conseil coopte comme nouvel Administrateur avec effet au 2 juillet 2002, Monsieur Cavalli Ferdinando, Employé

Privé, demeurant à Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

Cette cooptation sera ratifiée par la prochaine assemblée générale des actionnaires de la société, conformément à la

loi et aux statuts.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 8, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56007/024/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

GARDINERS IMMOBILIERS CONSEILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 60.718. 

Les comptes annuels aux 31 décembre 2001 et 2000, enregistrés à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 31,

case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56028/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

<i>Pour ARAN INTERNATIONAL S.A.
Société Anonyme 
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

<i>Pour PRIVATE HOLDINGS OF INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
Société Anonyme 
SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE
Société Anonyme
<i>Banque domiciliataire
Signatures

F. Mangen.

65415

EXICOM-AZUR, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 60.813. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 31, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(56048/592/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

CLD’A, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETEMENTS S.A., Société Anonyme. 

Siège social: L-1811 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 55.803. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui aura lieu le <i>7 octobre 2002 à 10.00 heures en l’étude de Maître Blanche Moutrier, Notaire de résidence à Esch-sur-
Alzette, 19, rue de l’Eau avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 4 des statuts par suppression des 6 derniers paragraphes et ne garder que le 1

er

 pour qu’il

ait la teneur suivante:

«La société a pour objet l’achat, la vente, l’affrètement coque nue, l’affrètement, le frètement, l’exploitation et la
gestion de navires de mer, ainsi que toutes les opérations financières et commerciales s’y rattachant directement
ou indirectement.»

(04244/000/19) .

MEDEA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 7, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 41.158. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>3 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social avec l’ordre du jour

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 19 septembre 2002 avec le même ordre du

jour, n’a pu délibérer valablement sur les points figurants à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les déci-
sions à la majorité des actions présentes ou représentées.
(04258/000/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CLD’A, COMPAGNIE LUXEMBOURGEOISE D’AFFRETEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1811 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.

R. C. Luxembourg B 55.803. 

RECTIFICATIF

La société sous rubrique avait bien demandé 2 dates de publication, à savoir le 4 septembre 2002 et le 19 septembre

2002 pour l’assemblée du 7 octobre 2002, mais erronément la convocation n’a pas été publiée le 4 septembre 2002.
(04325/XXX/9) .

<i>Pour la société
FIDUCIAIRE WEBER &amp; BONTEMPS, S.à r.l.
Experts Comptables et Fiscaux
Réviseur d’Entreprises

<i>Pour le Conseil d’Administration
F. Bracke
<i>Administrateur-délégué

65416

CHENONCEAU S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 43.571. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>11 octobre 2002 à 10.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des Administrateurs et du Commissaire.
5. Divers.

I (03953/660/15) 

<i>Pour le Conseil d’administration.

AGORANET HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 72.913. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 octobre 2002 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Décision à prendre conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
8. Divers

I (04234/029/20) 

<i>Le Conseil d’administration.

COSMOS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.539. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 octobre 2002 à 16.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

I (04250/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FARINA EUROPEAN INVEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 31.647. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le mardi <i>15 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001 et affectation des résultats,

65417

– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Décision à prendre quant à la poursuite de l’activité de la société malgré la perte reportée.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04237/755/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

WOLFF INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 30.804. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social en date du mardi <i>8 octobre 2002 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 mai 2001.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Décision à prendre quant à l’article 100 de la loi sur les sociétés.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (04242/783/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

CALIM INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 16.181. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 octobre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

6. Divers

I (04247/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIGEST S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 17.923. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>7 octobre 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

I (04248/795/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

65418

FLANDERS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 22.684. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 octobre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (04249/795/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INDUSTRIAL PROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 11.522. 

Messrs Shareholders are hereby convened to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

which will be held on <i>October, 9 2002 at 10.00 a.m. at the registered office, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Submission of the management report of the Board of Directors and the report of the Statutory Auditor
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at December 31, 1999, 2000 and 2001
3. Discharge of the Directors and Statutory Auditor
4. Statutory Appointments
5. Action on a motion relating to the possible winding-up of the company as provided by Article 100 of the Luxem-

bourg law on commercial companies of August 10, 1915

6. Miscellaneous

I (04251/795/17) 

<i>The Board of Directors.

JURISFIDES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 21.972. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>8 octobre 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d’un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Divers

I (04252/795/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 34.037. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>9 octobre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002.
3. Ratification de la cooptation d’un Administrateur.

65419

4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

I (04254/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ORCADES EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.507. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>7 octobre 2002 à 15.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation et approbation du rapport du liquidateur
2. Nomination d’un commissaire-vérificateur
3. Divers

I (04295/029/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MONTE CARLO INTERNATIONAL REAL ESTATE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 52.460. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 octobre 2002 à 10.00 heures au siège de la société.

<i>Ordre du jour:

1. Révocation du mandat d’administrateur de Monsieur Stefano Mugnai sans lui accorder de décharge.
2. Ratification de la nomination de Madame Evelyne Pastor, sans profession, résidant à Monaco, aux fonctions d’ad-

ministrateur de la société.

3. Divers.

I (04300/806/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 77.352. 

Notice is hereby given that the

STATUTORY GENERAL MEETING

of Shareholders will be held at the registered office of the Company on <i>October 3, 2002 at 11.00 a.m. with the following
agenda:

<i>Agenda:

1. Approval of the reports of the Board of Directors and of the Authorised Auditor.
2. Approval of the annual accounts, appendices and allocation of the results as at 31 May 2002.
3. Discharge to the Directors for the past financial year.
4. Re-election of the Directors for the ensuing year.
5. Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items of the agenda and that the decisions will be

taken at the simple majority of the shares present or represented at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.
Every bearer shareholder who wants to be present or to be represented at the Annual General Meeting has to de-

posit its shares for September 21, 2002 the latest at the domicile of the Fund or at the following address in Luxembourg:
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
I (04331/755/22) 

<i>By order of the Board of Directors.

<i>Pour GRANT THORNTON FIDUCIAIRE S.A.
M.-C. Haas

65420

EUREKO SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 71.571. 

Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>4 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social de EUREKO SICAV avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l’article 5 de façon à remplacer toute référence au Francs Luxembourgeois par une référence à

l’EURO modification du troisième paragraphe de cet article en vue de le corriger.

2. Modification des articles 5, 8, 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 de façon à donner au conseil d’administration la possibilité

d’ouvrir à l’intérieur de chaque catégorie deux ou plusieurs classes d’action.

3. Modification de l’article 8 en vue de remplacer la référence à la première année sociale.
4. Modification de l’article 12 point (iii) en vue de remplacer la référence à un pays des Amériques par une référence

à un pays des continents Américain.

5. Modification de l’article 19 (A) point 2 en vue de spécifier que l’évaluation de valeurs mobilières qui sont négociées

ou cotées sur une bourse de valeurs, dite cote officielle, sera déterminée suivant le cours de clôture du jour ban-
caire précédent tel que délivré par des systèmes d’informations telles que Telekurs, Reuters AG Zürich ou Bloom-
berg;

6. Modification de l’article 19 (B) point d) en vue de biffer la provision que tous les engagements peuvent engager la

Société toute entière;

7. Modification de l’article 26 premier tiret en vue de remplacer le terme sous-conseiller par le terme gestionnaiare

Pour assister à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours

francs avant l’Assemblée au siège social.

Une première assemblée extraordinaire ayant eu le même ordre du jour que la présente assemblée a été tenue le 23

août 2002. Cette assemblée n’a cependant pas pu délibérer valablement sur l’ordre du jour, puisque le quorum de pré-
sence d’au moins 50% des actions émises de la société n’a pas été atteint. Cette seconde assemblée peut, sans quorum
de présence, délibérer sur tous les points à l’ordre du jour et les résolutions pour être valables devront être prises par
les deux tiers des actionnaires présents ou représentés.
II (04106/755/31) 

<i>Le Conseil d’Administration.

A.W.T.C. HOLDINGS, AFRICAN WOOD TRADING COMPANY HOLDINGS, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 30.131. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>27 septembre 2002 à 17.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (04195/546/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 32.805. 

Notice is hereby given that the 

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders of INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, SICAV, will be held at the Registered Office in Luxem-
bourg, 69, route d’Esch, on Friday <i>September 27, 2002 at 11.30 a.m., with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To hear and accept:

a. the Management Report of the Directors,
b. The Report of the Auditors.

65421

2. To approve the Statement of Net Assets and the Statement of Changes in Net Assets for the year ended May 31,

2002; and to approve the allocation of the net result of the year.

3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended May 31, 2002.
4. To elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
5. To elect the Auditors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
6. Any other business.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and that decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the Meeting.
II (04192/584/22) 

<i>The Board of the Directors.

DEBORAH, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 47.748. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>27 septembre 2002 à 11.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

II (04194/546/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MILAN E-VENTURES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 78.478. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société, le vendredi <i>27 septembre 2002 à 15.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilans, comptes de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2000 et au 31

décembre 2001.

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Ratification de la décision du Conseil d’Administration prise en date du 20 juin 2002.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (04205/793/17) 

<i>La société.

FINROPA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.157. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 septembre 2002 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 30

juin 2002.

4. Divers.

II (04219/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

65422

CRQ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2419 Luxembourg, 3, rue du Fort Rheinsheim.

R. C. Luxembourg B 80.865. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social de la société, le <i>28 septembre 2002 à 18.00 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation des bilan, compte de profits et pertes et affectation des résultats au 31 décembre 2000 et au 31 dé-

cembre 2001.

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes.
4. Ratification de la décision prise lors de la réunion du Conseil d’administration qui s’est tenue en date du 22 mars

2002.

5. Nominations statutaires.
6. Divers.

II (04206/793/18) 

<i>La société.

DML HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 36.021. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>27 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mars 2002, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mars 2002.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (04220/005/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GAMMA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 82.718. 

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra exceptionnellement le <i>26 septembre 2002 à 10.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2001;
b. rapport du Commissaire de Surveillance;
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 31 décembre 2001;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et aux Commissaires;
f. divers.

II (04231/045/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

VALONA FINANCE S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 21.796. 

The Shareholders are hereby convened to attend the

STATUTORY GENERAL MEETING

to be held at Luxembourg, extraordinarily on <i>September 27th, 2002 at 9.30 o’clock with the following agenda:

<i>Agenda:

1. Report of the Board of Directors.
2. Report of the Statutory Auditor.

65423

3. Approval of the audited annual accounts at 31st December 2001.
4. Allocation of net results.
5. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
6. Election or re-election of directors and of an auditor.
7. Miscellaneous.

II (04233/799/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

OBECHE, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 47.475. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le vendredi <i>27 septembre 2002 à 10.00 heu-
res, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant: 

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

II (04196/546/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SODEVIBOIS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 24-28, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 29.972. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 24-28, rue Goethe, le vendredi <i>27 septembre 2002 à 18.00
heures, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice clôturé au 31 décembre 2001;
2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Décisions à prendre en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales;
7. Divers.

II (04197/546/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINAROM HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 25, avenue de la Liberté.

R. C. Luxembourg B 82.783. 

EXTRAIT

Il résulte d’une résolution du Conseil d’Administration prise en date du 17 juillet 2002 que Monsieur Gérald J. Meyer,

demeurant à Monaco, a été élu Président du Conseil d’Administration.

Luxembourg, le 17 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 25, case 11. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(56074/802/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

Pour extrait conforme
Signature

65424

CHEKIANG FIRST BANK (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme. 

Registered office: L-5365 Munsbach, 1B, Parc d’Activité Syrdall.

R. C. Luxembourg B 55.154. 

The balance sheet as per December 31st 2001, and the profit and loss Account registered in Luxembourg on 22 July

2002, vol. 571, fol. 32, case 12, has been deposited at the record on the registre de commerce et des sociétés de Lux-
embourg, on 23 July 2002.

Mention for publication in the Memorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Company incorporated on June 18th, 1996 by mean of a deed made before M

e

 Jean-Paul Hencks, notary residing in

Luxembourg published in the Mémorial C N

°

 355 dated July 24th 1996.

By-laws modified by mean of an Extraordinary General Meeting held before the same notary on April 4th, 2002.
The Annual General Meeting of shareholders of the Company held in Luxembourg on April 2nd, 2002, resolved to

carry forward the profit for the past business year amounting to USD 317,661.11 and on the following allocation of the
aggregate net results: 

As at December 31st, 2001, the members of the Board of Directors are as follows: 

Strassen, July 19th, 2002.

(56192/799/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 juillet 2002.

- Profit brought forward  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,341,975.30 USD

- Profit of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

317,661.11 USD

- Profit to be allocated. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,659,636.41 USD

- Legal reserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,883.00 USD

- Dividend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0.00 USD

- Profit to be carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,643,753.41 USD

- Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,659,636.41 USD

Mr James Zian-Mien Kung  Chairman of the Board of CHEKIANG FIRST BANK LTD.

Hong Kong
1, Duddell Street, Central, Hong Kong

Mr Takaaki Ohya 

Vice Chairman and Deputy Chief Manager of CHEKIANG FIRST BANK LTD.
Hong Kong
1, Dudell Street, Central, Hong Kong

Mr Yuzo Shibata 

Vice Chairman and Deputy Chief Manager of Chekiang
FIRST BANK LTD, Hong Kong
1, Duddell Street, Central, Hong Kong

 Mr Hideyuki Sasaki 

Managing Director and Co-CEO of MIZUHO TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG S.A.)
1B Parc d’Activités Syrdall, L-5365 Munsbach
Luxembourg (appointed on November 29, 2001)

Mr Takashi Katono 

Managing Director of DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
1B, Parc d’Activité Syrdall, L-5364 Munsbach 
Luxembourg (resigned on November 29, 2001)

Mr Fumihiko Yuda 

Executive Vice President of MIZUHO TRUST &amp; BANKING (LUXEMBOURG) S.A.
1B Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
Luxembourg (appointed on April 23, 2002)

Mr Nobuo Takahara 

Deputy General Manager of DAI-ICHI KANGYO BANK (LUXEMBOURG) S.A.
1B Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
Luxembourg (resigned on April 23, 2001)

Mr Sun-Man Wong 

Managing Director
2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
1B Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach
Luxembourg

DELOITTE &amp; TOUCHE S.A.
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Am Generali FondsStrategie

HCEPP Management Company, S.à r.l.

Bond Select Trust

Nomura Multi Currency MMF

Intesa Luxembourg Fund, Sicav

Crédit Suisse Fund of Funds (Lux)

Nomura Global Select Trust

Janus Global Life Sciences Fund

P.E.L.S., Propreté Eclair Luxembourgeoise de Services S.A.

DSI International, S.à r.l. (Luxembourg)

Sanpaolo Gestion Internationale S.A.

Kortmann Bau, S.à r.l.

Pizzaphone, S.à r.l.

Pizzaphone, S.à r.l.

Welfort International Holding S.A.

Goldman Sachs Mezzanine Partners II Luxembourg, S.à r.l.

Gantro Invest

Troy Investment

Invesco European CDO I S.A.

Invesco European CDO I S.A.

One-Two-Three Holding

Fa &amp; Ma Luxembourg, S.à r.l.

Sinvar Holding S.A.

Finarch, S.à r.l.

Alavita S.A.

Glenville Holding S.A.

Lift Luxembourg S.A.

Cosma Finance International S.A.

Carval S.A.

S.E.F. Société Européenne Financière S.A.

Aran International S.A.

Private Holdings of Investments Luxembourg S.A.

Gardiners Immobiliers Conseils, S.à r.l.

Exicom-Azur, S.à r.l.

CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrètements S.A.

Medea Holding S.A.

CLd’A, Compagnie Luxembourgeoise d’Affrètements S.A.

Chenonceau S.A.

Agoranet Holding S.A.

Cosmos Holding S.A.

Farina European Invest S.A.

Wolff International S.A.

Calim International Holding S.A.

Figest S.A.

Flanders International S.A.

Industrial Properties S.A.

Jurisfides S.A.

Finance S.A.

Orcades Europe S.A.

Monte Carlo International Real Estate S.A.

Lemanik Private Equity Fund

Eureko Sicav

A.W.T.C. Holdings, African Wood Trading Company Holdings

Invesco European Warrant Fund

Deborah

Milan E-Ventures S.A.

Finropa S.A.

C.R.Q. S.A.

DML Holding S.A.

Gamma S.A.

Valona Finance S.A.

Obeche

Sodevibois

Finarom Holding S.A.

Chekiang First Bank (Luxembourg) S.A.