logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

65041

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1356

18 septembre 2002

S O M M A I R E

Alexa International S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . .

65050

Land’s End S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

65088

Allied Arthur Pierre S.A., Strassen  . . . . . . . . . . . . .

65055

Ludovica S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

65085

Alumex Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

65083

Map Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65080

Annibal Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

65083

Map Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65080

Argenta Life Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . .

65055

Mobiltec, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

65081

Austrian Financial and Futures Trust, Sicav, Lu- 

Naja Investment S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . 

65086

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65087

Natural Global Resources Holding S.A., Luxem- 

Blaze Holdings, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

65076

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65069

Bogazzi International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

65048

Natural Global Resources S.A., Luxembourg  . . . . 

65063

Bogazzi International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

65048

NCI Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . 

65055

Bogazzi International S.A., Luxembourg. . . . . . . . .

65048

Next, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65049

Bogazzi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65051

Odysset S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65088

Bogazzi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65051

Odyssey Asset Management Systems S.A.  . . . . . . 

65052

Building Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .

65085

Odyssey Asset Management Systems S.A.  . . . . . . 

65052

C.B.R. Finance S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . .

65049

Pasie S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65048

Cerep Finance, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

65055

Patmark S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65051

Cerep, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65054

Performance International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . 

65052

CGS International Holdings (Luxembourg), S.à r.l., 

PI-S.A. - Soparfi, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

65061

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65054

PI-S.A. - Soparfi, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

65062

COREVEST  - Compagnie de Recherches et d’Inves- 

Polichem S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65046

tissements S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .

65085

Portunus Investment Holding S.A., Luxembourg . 

65085

Credit Suisse Commodity Fund (Lux) . . . . . . . . . . .

65047

Premium Invest Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65042

Credit Suisse Euro Bond Express . . . . . . . . . . . . . . .

65042

Premium Invest Fund. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65042

Eli, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65082

Publicis  Graphics  Group  Holding  S.A., Luxem- 

Energy Systems International S.A., Luxembourg . .

65049

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65049

Europe Property S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . .

65049

Ratio Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . 

65056

European Marketing Holding S.A., Luxembourg  . .

65086

SEB Invest Select America  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65083

ExxonMobil Luxembourg et Cie S.C.A., Bertrange

65053

Sefipar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65084

ExxonMobil Luxembourg, S.à r.l., Bertrange  . . . . .

65053

Siewit S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65047

FinanzInvest, GmbH, Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . .

65054

SNA & Associés S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

65088

Fricky S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65053

Société Internationale de Publicité S.A.H., Lu- 

Fricky S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65053

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65087

Fricky S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65054

Stora Enso, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

65047

Fricky S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65054

Stora Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . 

65043

Garage Muller-Locations, S.à r.l., Luxembourg  . . .

65046

T.F.M. International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

65084

Gourmet Trade S.A., Livange. . . . . . . . . . . . . . . . . .

65043

Takolux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65056

Grand Garage Jean Muller, S.à r.l., Luxembourg  . .

65046

Threeland Hôtels S.A., Pétange . . . . . . . . . . . . . . . 

65050

Hervain Investissements S.A., Luxembourg . . . . . .

65050

Trascania Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

65050

I.Q. Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . .

65083

TSM, Tuyauterie Soudure Maintenance S.A., Bas- 

KB  Lux  Special  Opportunities  Fund, Sicav, Lu- 

charage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

65056

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65087

Unio Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

65086

Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

65044

Vavisto Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

65056

Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l., Luxembourg  . . . .

65046

Walfra Investments S.A., Luxembourg . . . . . . . . . 

65084

Ladino S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65057

Zipa Food Trading S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

65082

65042

PREMIUM INVEST FUND, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der PREMIUM INVEST LUX MANAGEMENT S.A. hat mit Zustimmung der Depotbank beschlos-
sen, das Verwaltungsreglement des PREMIUM INVEST FUND wie folgt zu ändern:

Art. 18. Ausgabe, Rücknahme und Konversion von Anteilen
Der letzte Satz am Ende von Absatz (3) wird wie folgt neu gefasst:
«Der erste Bericht wird ein geprüfter Jahresbericht zum 31. März 2002 sein.»
Diese Änderungen treten am 23. August 2002 in Kraft.

Luxemburg, den 21. August 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 28 août 2002, vol. 573, fol. 70, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(64929/267/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.

PREMIUM INVEST FUND, Fonds Commun de Placement.

Règlement de gestion coordonné déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002. 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 août 2002.

(64930/267/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2002.

CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, Fonds Commun de Placement.

By decision of CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANAGEMENT COMPANY in its capacity as Management

Company, with the consent of BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A. in its capacity as Custodian
Bank, the Management Regulations of CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS shall be amended as follows:

1. Any reference made in the Management Regulations to «shares», «shareholders» or «shareholding» in the Fund

shall be replaced respectively by «units», «unitholders» or «holding of units» in the Fund.

2. Any reference made in the Management Regulations to the «ECU» shall be replaced by the «Euro».
3. At page 5, the last sentence of the eighth paragraph of Chapter 4) Investment Objective and Investment Policies

shall be deleted. This paragraph shall now read as follows: «The currency in which assets of the Fund shall be denomi-
nated principally will be the Euro, European currencies (including Eastern European currencies) and USD: Investments
in assets denominated in currencies other than the Euro will in principle be hedged against the Euro.»

4. At page 5, the last sentence of the ninth paragraph of Chapter 4) Investment Objective and Investment Policies

shall be amended to read as follows: «The Management Company intends that the Fund’s liquid assets will be held in
Euro».

5. At page 5, in the last paragraph of Chapter 4) Investment Objective and Investment Policies, reference made to

paragraphs «11» and «13» under «Investment Restrictions» below shall be replaced by paragraphs «12» and «14» under
«Investment Restrictions» below.

6. At page 7, below section (7) of Chapter 5) Investment Restrictions, a new paragraph shall be added:
«(8) Except in relation to borrowing conducted within the limitations set out under the Management Regulations, the

Management Company may not pledge the assets of the Fund or assign them as collateral. In such cases, not more than
10% of the assets of the Fund shall be pledged or assigned. The collateral that must normally be made available to rec-
ognised securities settlement systems or payment systems in accordance with their respective regulations for the pur-
pose of guaranteeing settlement within these systems, and the usual margin deposits in options, futures and forward
transactions, shall not be regarded as being a pledge in the sense of this regulation.»

Thereafter, the numeration of the following sections shall be adapted accordingly.
7. At page 7, the newly denominated section (9) of Chapter 5) Investment Restrictions shall be amended as follows:

«The Management Company may not mortgage, hypothecate or in any manner transfer as security for indebtedness,
any securities owned or held on behalf of the Fund, except as may be necessary in connection with borrowings men-
tioned in (7) and (8) above».

8. At page 11, the second last paragraph of Chapter 5) Investment Restrictions is amended as follows: «Except by the

acquisition of debt securities or instruments in accordance with restrictions 12), 13), 14) and 15) above, the Manage-
ment Company may not grant loans or act as guarantor on behalf of third parties.»

9. At page 12, the first paragraph shall now read as follows: «The terms of the initial offering will be determined by

the Management Company».

<i>Für den Verwaltungsrat
S. Jaffer / L. Hilger

<i>Für die Depotbank
M.-A. Bechet / G. Reiter
<i>Directeurs adjoints

<i>Pour la société
Signature

65043

10. At page 12, the second paragraph of Chapter 7) Issue Price shall be amended as follows: «Following the initial

offering period, the issue price per Unit will be the net asset value per Unit as determined in accordance with the pro-
visions of Article 9 hereof on the Valuation Day on which the application for purchase of Units is received by the Man-
agement Company (provided that such application is received prior to 12 noon, Luxembourg time, on that day), plus
the applicable sales charge not exceeding 2.50% of the net asset value of the units subscribed for, in favour of banks and
financial institutions acting in connection with the placing of the Units. The sales charge shall in no case exceed the max-
imum permitted by the laws, regulations and practice of any country where the Units are sold.»

11. At page 12, the first paragraph of Chapter 9) Determination of the Net Asset Value shall be amended as follows:

«The Net Asset Value of Units in the Fund shall be expressed in Euro as per unit figure and determined on each Valu-
ation Day.»

12. At page 18, the first paragraph of Chapter 13) Accounting Year, Audit is amended as follows: «The accounts of

the Fund are closed each year on 31st March. They were closed for the first on 31st March, 1999.»

13. At page 19, in the second paragraph of Chapter 14) Distributions, 50,000,000.- Luxembourg francs shall be re-

placed by Euro 1,239,468.-

These amendments shall become effective five days after publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations of Luxembourg.

Dated as of 10 September, 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 13 septembre 2002, vol. 574, fol. 27, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68284/736/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 septembre 2002.

GOURMET TRADE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3378 Livange, Z.I., rue de Bettembourg.

R. C. Luxembourg B 50.780. 

EXTRAIT

Suite à la démission de Maître Charles Kaufhold en tant qu’administrateur de la société GOURMET TRADE S.A., le

nouveau conseil d’administration se compose comme suit:

- Monsieur Alinaghi Naderi Tabrizi, commerçant, demeurant à Téhéran, Iran, administrateur-délégué
- Monsieur Ali Mir Motahari, employé privé, demeurant à Crauthem
- Monsieur Mehdi Raouf, commerçant, demeurant à Téhéran (Iran)

Luxembourg, le 20 juin 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 27 juin 2002, vol. 570, fol. 17, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55500/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

STORA LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle,

au capital social de 1.087.108.000,- EUR.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.879. 

Il résulte des résolutions écrites prises par l’associé unique en date du 28 juin 2002 que:
«Le capital social est fixé à un milliard quatre-vingt-sept millions cent huit mille Euro (EUR 1.087.108.000), représenté

par quarante-trois millions huit cent trente-cinq mille (43.835.000) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre
Euro quatre-vingts cents (EUR 24,80) chacune.»

Luxembourg, le 17 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55542/805/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS MANAGEMENT COMPANY
Signatures
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Signature

Pour copie conforme 
M

e

 T. Reisch

Pour avis conforme
<i>Pour la société
M. Kohl
<i>Gérant

65044

KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EUROPA PCP, S.à r.l.).

Registered office: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.198. 

In the year two thousand two, on the twenty-second day of August. 
Before Us, Maître Robert Schuman, notary residing in Differdange (Grand Duchy of Luxembourg), acting in replace-

ment of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), who will be the depos-
itary of the present original deed. 

There appeared:

EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l. a «société à responsabilité limitée», existing under Luxembourg law, established and

having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

represented by Mrs. Carol Collin, private employee, with professional address in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard

de la Pétrusse,

acting by virtue of a proxy given in Luxembourg on August 20, 2002. 
I.- The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
II.- The appearing party, acting in its capacity as sole shareholder of the société à responsabilité limitée, EUROPA

PCP, S.à r.l., having its registered office in L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse (the «Company»), has re-
quested the undersigned notary to document the following:

The appearing party is the sole shareholder of the Company, incorporated by a deed of the notary Jean-Joseph Wag-

ner of July 5, 2002, not yet published, and entered in the Register of Commerce and Companies in Luxembourg, Section
B, under the number B 88.198.

III.- The appearing party, represented as above mentioned, recognise to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Modification of the Company’s name from EUROPA PCP, S.à r.l. to KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l.
2. Subsequent amendment of article 2 of the Articles of Incorporation of the Company.
3. To amend the article 3 (Object) of the Articles of Incorporation which forthwith read as follows:

«Art. 3. Object.
The main purpose of the Company is to hold interest as a general partner in KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à

r.l. &amp; Co KG, a limited partnership which is to be set up under the German law, to act as the legal representative of
KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l. &amp; Co KG, and to manage it. The Company may also carry out all transactions
relating directly or indirectly to the main purpose.»

4. To abolish the last paragraph of article 5 of the Articles of incorporation.
The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder decides to modify the Company’s name from EUROPA PCP, S.à r.l. to KRONPRINZBAU

STUTTGART, S.à r.l.

<i> Second resolution

The sole shareholder decides to amend article 2 of the Articles of Incorporation as follows:

«Art. 2. Denomination.
The Company will exist under the denomination of KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l.»

<i>Third resolution

The sole shareholder decides to amend the article 3 (Object) of the Articles of Incorporation which forthwith read

as follows:

«Art. 3. Object.
The main purpose of the Company is to hold interest as a general partner in KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à

r.l. &amp; Co KG, a limited partnership which is to be set up under the German law, to act as the legal representative of
KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l. &amp; Co KG, and to manage it. The Company may also carry out all transactions
relating directly or indirectly to the main purpose.»

<i>Fourth resolution

The sole shareholder decides to delete the last paragraph of article 5 of the Articles of Incorporation and to give it

henceforth the following wording:

«Art. 5. Registered Office.
The registered office is established in the municipality of Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by decision of the

management.»

<i> Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the corporation as a result of

this document are estimated at approximately seven hundred forty euro.

65045

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of any dif-
ferences between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name,

civil status and residence, the said person signed together with us the notary this original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le vingt-deux août.
Par-devant Nous, Maître Robert Schuman, notaire de résidence à Differdange (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de son collègue dûment empêché Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem
(Grand-Duché de Luxembourg), ce dernier restant dépositaire de la présente minute.

A comparu:

 EUROPA REAL ESTATE, S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant sous le droit luxembourgeois, établie

et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse,

représentée par Madame Carol Collin, employée privée, avec adresse professionnelle à L-2320 Luxembourg, 43, bou-

levard de la Pétrusse,

agissant en vertu d’une procuration lui délivrée à Luxembourg le 20 août 2002.
I.- La prédite procuration restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
II.- Lequel comparant, agissant en sa qualité d’associé unique de la société à responsabilité limitée EUROPA PCP, S.à

r.l., ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse, (la «Société»), a requis le notaire instru-
mentant d’acter ce qui suit:

Le comparant est le seul associé de la Société, constituée suivant acte du notaire Jean-Joseph Wagner, le 5 juillet 2002,

non encore publié, et inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro B
88.198.

III.- Le comparant, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaît être parfaitement au courant des décisions à inter-

venir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de la dénomination sociale de la Société de EUROPA PCP, S.à r.l. en KRONPRINZBAU STUTTGART,

S.à r.l.

2. Modification subséquente de l’article 2 des Statuts de la Société. 
3. Modification de l’article 3 (Objet) des Statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 3. Objet.
L’objet principal de la Société est de détenir une participation en qualité d’associé commandité, dans la société

KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l. &amp; Co KG, société en commandite de droit allemand à créer, d’agir en tant que
son représentant légal et d’en assurer la gestion. La Société peut également effectuer toutes transactions liées directe-
ment ou indirectement à son objet principal.»

4. Suppression du dernier alinéa de l’article 5 des Statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Siège social.
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.»
Le comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de modifier la dénomination sociale de la Société de EUROPA PCP, S.à r.l. en KRONPRINZ-

BAU STUTTGART, S.à r.l.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 2 des Statuts de la façon suivante: 

«Art. 2. Dénomination.
La Société prend la dénomination sociale de KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 3 (Objet) des Statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur

suivante:

«Art. 3. Objet.
L’objet principal de la Société est de détenir une participation en qualité d’associé commandité, dans la société

KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l. &amp; Co KG, société en commandite de droit allemand à créer, d’agir en tant que
son représentant légal et d’en assurer la gestion. La Société peut également effectuer toutes transactions liées directe-
ment ou indirectement à son objet principal.»

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de supprimer le dernier paragraphe de l’article 5 des statuts lequel aura désormais la teneur

suivante:

«Art. 5. Siège social.
Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg.

65046

II pourra être transféré en tout autre lieu dans la commune de Luxembourg en vertu d’une décision du gérant.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la société des suites de ce document sont

estimés à sept cent quarante euros.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande du comparant ci-avant,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande du même
comparant, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Collin, R. Schuman.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 28 août 2002, vol. 871, fol. 37, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur ff.(signé): Oehmen

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations par

Maître Aloyse Biel, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire
de résidence à Sanem.

(65553/239/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

KRONPRINZBAU STUTTGART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. EUROPA PCP, S.à r.l.).

Siège social: L-2320 Luxembourg, 43, boulevard de la Pétrusse.

R. C. Luxembourg B 88.198. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(65554/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2002.

GRAND GARAGE JEAN MULLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 19.463. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55504/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

GARAGE MULLER-LOCATIONS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 23.620. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 20, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55505/799/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

POLICHEM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 57.059. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 19 juillet 2002, vol. 571, fol. 21, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55552/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Esch-sur-Alzette, le 30 août 2002.

A. Biel.

Esch-sur-Alzette, le 30 août 2002.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 15 juillet 2002.

Signature.

Luxembourg, le 9 juillet 2002.

Signature.

65047

CREDIT SUISSE COMMODITY FUND (LUX), Fonds Commun de Placement.

<i>Änderungen der Vertragsbedingungen und des Verkaufsprospektes des Anlagefonds

Die CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY, in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsgesell-

schaft des oben genannten Fonds, hat mit Zustimmung der BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG)
S.C.A., in ihrer Eigenschaft als Depotbank, beschlossen, die Vertragsbedingungen des CREDIT SUISSE COMMODITY
FUND (LUX) dahingehend zu ergänzen, dass der Wortlaut des Artikel 4 N

°

 2 Buchstabe r) S. 1 der Vertragsbedingungen

gestrichen und durch folgenden Wortlaut ersetzt wird:

«Irgendwelche Vermögenswerte des Fonds verpfänden oder anderweitig belasten, sowie zum Zwecke der Schulden-

absicherung übertragen oder abtreten, ausser in Zusammenhang mit Kreditaufnahmen, die innerhalb der von den Ver-
tragsbedingungen vorgesehenen Begrenzungen getätigt werden. Dabei dürfen in solchen Fällen nicht mehr als 10% des
Vermögens des Fonds verpfändet oder abgetreten werden. Die Sicherheiten, die üblicherweise anerkannten Wertpa-
pierabwicklungssystemen oder Zahlungssystemen gemäss deren jeweiligen Regelungen geleistet werden müssen, um die
Abwicklungen innerhalb dieser Systeme sicherzustellen, sind nicht im Sinne dieser Bestimmung als Verpfändung anzuse-
hen.»

Diese Änderung der Vertragsbedingungen tritt fünfzehn Tage nach ihrer Veröffentlichung im «Mémorial, Recueil des

Sociétés et Associations» in Kraft.

Luxemburg, den 10. September 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 16 septembre 2002, vol. 574, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(68564/736/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2002.

SIEWIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.492. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55508/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

STORA ENSO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. STORA TREASURY, S.à r.l.),

au capital de: 1.090.767.984,- EUR.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 67.934. 

Il résulte des résolutions écrites prises par l’associé unique en date du 28 juin 2002 que:
«Le capital social est fixé à un milliard quatre-vingt-dix millions sept cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-

quatre Euro (EUR 1.090.767.984), représenté par quarante-trois millions neuf cent quatre-vingt-deux mille cinq cent
quatre-vingts (43.982.580) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-quatre Euro quatre-vingts cents (EUR 24,80)
chacune.»

Luxembourg, le 17 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 25, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55544/805/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CREDIT SUISSE COMMODITY FUND MANAGEMENT COMPANY
Unterschriften
BROWN BROTHERS HARRIMAN (LUXEMBOURG) S.C.A.
Unterschrift

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour avis conforme
<i>Pour la société
M. Kohl
<i>Gérant

65048

PASIE S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 35.490. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55509/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

BOGAZZI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.506. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571,

fol. 13, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55536/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

BOGAZZI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.506. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571,

fol. 13, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55537/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

BOGAZZI INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.506. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571,

fol. 13, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55538/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 237.323.972,00 ITL
Perte de l’exercice 1999  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 88.561.454,00 ITL

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 325.885.426,00 ITL

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 168.305,78 EUR

Perte de l’exercice 2000  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 36.160,40 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 204.466,18 EUR

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 204.466,18 EUR

Perte de l’exercice 2001  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 57.703,09 EUR

Report à nouveau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 262.169,27 EUR

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

65049

EUROPE PROPERTY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 27.742. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55510/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

PUBLICIS GRAPHICS GROUP HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 32.500. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 15 juillet 2002, vol. 570, fol. 100, case 12, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 juillet 2002.

(55511/549/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ENERGY SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 45.188. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55525/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

C.B.R. FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.657. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55527/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

NEXT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 62.332. 

Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571,

fol. 13, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(55545/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.A.
Signature

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 83.644.159,- ITL

Perte de l’exercice 1999   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 - 52.024.145,- ITL

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 134.668.304,- ITL

Signature
<i>Le Gérant

65050

ALEXA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 47.321. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55528/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TRASCANIA HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 61.986. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55529/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

THREELAND HÔTELS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Pétange, rue Pierre Hamer.

R. C. Luxembourg B 36.321. 

<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 28 juin 2002

L’Assemblée Générale est ouverte à 9.00 heures sous la Présidence de Mme Josée Quintus
qui désigne comme secrétaire Mme Anne-Marie Hoscheit
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsiuer Georges d’Huart
Monsieur le Président constate que toutes les actions étant présentes ou représentées, il a pu être fait abstraction

des convocations d’usage, tous les actionnaires se reconnaissent valablement convoqués et ayant connaissance de l’or-
dre du jour. L’assemblée étant dûment constituée, elle peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

1. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion du capital social en Euro avec effet rétroactif au 1

er

janvier 2002 suivant la procédure prévue par la loi du 10 décembre 1998.

2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts.
Après en avoir délibéré, l’assemblée prend, chacune à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
La désignation de la valeur nominale des vingt-six mille six cents (26.600) actions est supprimée.
La conversion de la devise d’expression du capital socila de la société actuellement en francs luxembourgeois, pour

l’exprimer dorénavant en Euro (au cour de 1 Euro=40,3399 LUF) est décidée. Le capital de la société devient donc six
cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize virgule soixante-dix-huit Euro (659.396,78).

Afin de mettre les statuts en concordance avec ce qui précède il est décidé de modifier l’article 3 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«Art. 3. Le capital social souscrit est fixé à six cent cinquante-neuf mille trois cent quatre-vingt-seize virgule soixante-

dix-huit Euro (659.396,78), représenté par vingt-six mille six cents (26.600) actions sans valeur nominale.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance à 9.10

heures. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 1

er

 juillet 2002, vol. 324, fol. 47, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(55530/207/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

HERVAIN INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 85.038. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571,

fol. 13, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55543/693/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature / Signature / Signature
<i>Président / Scrutateur / Secrétaire

Report à nouveau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 13.089,53 EUR

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

65051

BOGAZZI S.A., Société Anonyme,

(anc. BOGAZZI HOLDING S.A.). 

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.505. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571,

fol. 13, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55539/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

BOGAZZI S.A., Société Anonyme,

(anc. BOGAZZI HOLDING S.A.).

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.

R. C. Luxembourg B 56.505. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571,

fol. 13, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

AFFECTATION DU RESULTAT 

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55540/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

PATMARK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R. C. Luxembourg B 55.896. 

EXTRAIT

Il résultede l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 1

er

 septembre 2000 que FIDEI REVISION, Société

à responsabilité limitée ayant son siège social 50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg a été élue commissaire aux comptes
en remplacement de FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI, démissionnaire.

Par ailleurs, il résulte de la même Assemblée que Monsieur Alain Lam, Réviseur d’entreprises, demeurant à Strassen

(Luxembourg) a été élu administrateur en remplacement de Monsieur Frank Bauler, démissionnaire.

Luxembourg, le 15 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 21, case 10. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55553/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Résultats reportés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.337.841,22 EUR

Bénéfice de l’exercice   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16.437.209,39 EUR

./. Affectation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . 

- 258.353,38 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

17.516.697,23 EUR

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.659.062.676,00 ITL
Augmentation du capital social avec effet au 27 dé-

cembre 2000 par incorporation de réserves . . . . . . . - 5.000.000.000,00 ITL

2.659.062.676,00 ITL

Changement de la devise en euros au cours de 1

euro pour ITL 1.936,27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.373.291,27 EUR

Augmentation du capital social par incorporation

de réserves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 1.249,30 EUR

Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.372.041,97 EUR

Perte de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- 34.200,75 EUR

Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.337.841,22 EUR

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

65052

ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme. 

<i>Minutes of the Board Meeting held in Luxembourg on the 3rd July 2002

Attendees:
Antoine Duchateau (Président)
Guy Eggermont
Didier Vankeerberghen
Apologies:
Charlie Barrass

<i>Unique resolution: Power of Attorney

The board of directors hereby gives a power of attorney to the following mandatories for the daily administration of

the company:

Michel Mathys
Michel Jongen
Roland Jones
Thierry Divenot
Kenneth Watson
Hugues Vandepeutte
Monika Metler
The above mandatories have signature jointly with any of the directors. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55546/000/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ODYSSEY ASSET MANAGEMENT SYSTEMS S.A., Société Anonyme. 

<i>Procès-verbal d’une Assemblée Générale Extraordinaire tenue à Luxembourg le 3 juillet 2002

Présents:
Antoine Duchateau, Président
Guy Eggermont, Secrétaire
Sandrine Sancan, Scrutateur
Le président constate que l’unanimité des actionnaires est présente ou représentée et que l’assemblée est ainsi dû-

ment constituée.

L’assemblée nomme un nouveau Conseil d’Administration, constitué comme suit:
Antoine Duchateau (Président)
Charlie Barrass (Administrateur)
Didier Vankeerberghen (Administrateur)
Guy Eggermont (Administrateur)
Leur mandat viendra à expiration lors de l’Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes se clôturant au 31

décembre 2007. 

Enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 6, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55548/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

PERFORMANCE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

R. C. Luxembourg B 82.187. 

Le siège social de la société au 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg a été dénoncé avec effet au 31 juillet 2002.
La société LIGHTHOUSE SERVICES, S.à r.l. a déclaré sa démission de sa fonction de commissaire aux comptes de la

société avec effet au 31 juillet 2002.

Luxembourg, le 17 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55547/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

<i>For the Board
G. Eggermont / A. Duchateau
<i>Secretary / Chairman

A. Duchateau / G. Eggermont / S. Sancan
<i>Chairman / Secrétaire / Scrutateur

<i>Pour PERFORMANCE INTERNATIONAL S.A.
Signature

65053

ExxonMobil LUXEMBOURG ET CIE S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.560. 

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 22, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55554/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ExxonMobil Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: 367.015,20 EUR.

Registered office: L-8069 Bertrange, 20, rue de l’Industrie.

R. C. Luxembourg B 72.559. 

<i>Extract of the minutes of the Annual General Meeting of shareholders held in Bertrange on June 28, 2002

The General Meeting resolves
- To discharge the directors for their mandate through December 31, 2001.
- That no remuneration is paid to the directors for their mandate for the current year. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 22, case 9. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55555/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FRICKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 48.861. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société

<i>qui s’est tenue en date du 19 avril 2000 au siège social

L’Assemblée décide de renconduire les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une nou-

velle période statutaire de six ans.

Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes prendront fin à l’issue de l’assemblée générale an-

nuelle de l’an 2006.

Le Conseil d’Administration se compose de:
- Madame Véronique Wauthier, licenciée en droit, demeurant à Schweich,
- Monsieur Patrick Haller, employé privé, demeurant à Imbringen,
- Monsieur Guido Modiano, entrepreneur, demeurant à Milan (I)
Le Commissaire aux Comptes est:
GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxem-

bourg. 

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 14, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55541/806/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FRICKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 48.861. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 14, case 5, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55549/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

True copy
R. Kremer

Pour extrait conforme
Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

65054

FRICKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 48.861. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 14, case 5, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55550/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FRICKY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 7, rue Pierre d’Aspelt.

R. C. Luxembourg B 48.861. 

Le bilan abrégé au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 14, case 5, a été dé-

posé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55551/806/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

FinanzInvest, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-1542 Luxemburg.

<i>Gesellschafterbeschluss

Johann Kirchmair, Herbert Noichl und Johanna Thaler als Gesellschafter der FinanzInvest, GmbH mit dem Sitz in

L-1542 Luxemburg fassen hiermit folgenden:

<i>Beschluss 

Herbert Noichl geb. 26. Dezember 1965 wird zum 30. April 2002 seiner Funktion als Geschäftsführer enthoben.
Johan Kirchmair geb. 28. Juni 1966 ist mit Rechtswirksamkeit zum 1. Mai 2002 als allein zeichnungsberechtigter Ge-

schäftsführer zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt.  

Enregistré à Luxembourg, le 17 juillet 2002, vol. 571, fol. 14, case 7. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55556/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CEREP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 83.245. 

Acte Constitutif publié aux pages 4280-4284 du Mémorial C n

°

 90 du 17 janvier 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(55557/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CGS INTERNATIONAL HOLDINGS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 42.570. 

Le bilan au 31 août 2001, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 7, case 4, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55622/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signatures
<i>Administrateurs

Signatures
<i>Administrateurs

25. April 2002.

Unterschriften.

PricewaterhouseCoopers
Signature

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Signature.

65055

NCI LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 18-20, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 79.945. 

Suite à la réunion du Conseil d’administation tenue le 5 juillet 2002, il résulte que:
- La nomination de Monsieur Dominique Verlinde, résidant à Wicres (F-59134), 320, rue de l’Eglise, au poste d’admi-

nistrateur-délégué telle que décidée par l’assemblée générale des actionnaires du 21 novembre 2001 est confirmée par
le Conseil.

- Monsieur Dominique Verlinde est la personne habilitée à engager la Société pour tous les actes commerciaux par

sa signature individuelle ou sa co-signature obligatoire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 2. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55558/581/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

CEREP FINANCE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 83.244. 

Acte Constitutif publié aux pages 4241-4245 du Mémorial C n

°

 89 du 17 janvier 2002.

Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 juin 2002.

(55559/581/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ALLIED ARTHUR PIERRE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 112-114, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 24.402. 

Acte constitutif publié à la page 11085 du Mémorial C n

°

 233 du 14 août 1986.

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 24, case 2, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55560/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ARGENTA LIFE LUXEMBOURG, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 27, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 36.509. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 14 décembre 2001

1. «L’assemblée accepte la démission de Messieurs Van Rompuy Karel et Bart avec effet immédiat de leur poste d’ad-

ministrateur et leur donne entière décharge.

L’assemblée remercie vivement Messieurs Van Rompuy Karel et Bart pour l’intérêt qu’ils ont porté au développement

des affaires de la société.

2. L’assemblée nomme Monsieur Bruno Gilis en tant qu’administrateur à effet immédiat.
Son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.»

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 25, case 5. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55586/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

PricewaterhouseCoopers
Signature

PricewaterhouseCoopers
Signature

Signature.

<i>Pour la société
A. Mechanicus
<i>Directeur

65056

RATIO HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 54.028. 

Les statuts coordonnés du 26 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(55561/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

VAVISTO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 67.615. 

Les statuts coordonnés du 12 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(55562/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TAKOLUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 28.117. 

Les statuts coordonnés du 28 novembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 1,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(55563/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

TSM, TUYAUTERIE SOUDURE MAINTENANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4917 Bascharage, rue de la Continentale.

R. C. Luxembourg B 68.511. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 juin 2002

1) L’assemblée décide à l’unanimité de modifier le régime de signature comme suit:
La société sera dorénavant valablement engagée en toutes circonstances par la signature exclusive ou par la cosigna-

ture obligatoire de Monsieur Raphaël Bouchy, administrateur délégué de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité.
2) L’assemblée constatant la vacance d’un poste d’administrateur, décide de nommer Monsieur Fabrice Marzielli, chef

de chantier, demeurant à F-54700 Pont-à-Mousson, Le Pré Latour Allée Beethoven au poste d’administrateur.

Ce dernier terminera le mandat de son prédécesseur, lequel prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de

l’an 2004.

Pour extrait conforme, délivré aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 15 juillet 2002, vol. 324, fol. 61, case 3. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(55602/597/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

RATIO HOLDINGS S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

VAVISTO HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

TAKOLUX S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

Bascharage, le 28 juin 2002

Signatures.

65057

LADINO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse.

STATUTES

In the year two thousand two, on the twentieth of June.
Before Us, Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared:

1) The company under Spanish law SOCIEDAD ESPANOLA INMUEBLOS Y LOCALES S.L. with registered office in

Spain, Madrid, Zenit, 21, represented by Mr André Harpes under the terms and conditions of a power of attorney dated
and signed by the appearing party ne varietur and attached to the present public notary’s act.

2) Mr André Harpes, lawyer, resident in Luxembourg.
Such appearing parties, have drawn up the following articles of a joint stock company which they intend to organise

among themselves.

Name - Registered offices - Duration - Object - Capital

Art. 1. Between the above-mentioned persons and all those that may become owners of the shares created hereaf-

ter, a joint stock company (société anonyme) is herewith organized under the name of LADINO S.A.

Art. 2. The registered offices are in Luxembourg.
The company may establish branch offices, subsidiaries, agencies or administrative offices in the Grand Duchy of Lux-

embourg as well as in foreign countries by a simple decision of the board of directors.

Without prejudice of the general rules of law governing the termination of contracts in case the registered office of

the company has been determined by contract with third parties, the registered offices may be transferred to any other
place within the Municipality of the registered offices by a simple decision of the board of directors. If extraordinary
events either political, economic or social that might create an obstacle to the normal activities at the registered offices
or to easy communications of these offices with foreign countries should arise or be imminent, the registered offices
may be transferred to another country till the complete cessation of these abnormal circumstances. This measure, how-
ever, shall not affect the nationality of the company, which will keep its Luxembourg nationality, notwithstanding the
provisional transfer of its registered offices. One of the executive organs of the company, which has powers to commit
the company for acts of daily management, shall make this declaration of transfer of the registered offices and inform
third persons.

Art. 3. The company is established for an unlimited period.

Art. 4. The purposes for which the company is formed are the buying and selling, the chartering in and the chartering

out, and the management of seagoing ships, as well as the financial and commercial transactions that relate directly or
indirectly to such activities.

Art. 5. The subscribed capital is fixed at one hundred thousand euro (EUR 100,000.-), divided into one hundred (100)

shares with a par value of one thousand euro (EUR 1,000.-) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.

Management - Supervision

Art. 6. The company is administered by a board of not less than three members, shareholders or not, who are elect-

ed for a term which may not exceed six years by the General Meeting of shareholders and who can be dismissed at any
time. In the event of a vacancy on the board of Directors elected by a meeting of shareholders, the remaining directors
so elected have the right to provisionally fill the vacancy, such decision to be ratified by the next general meeting.

Art. 7. The board of directors chooses among its members a Chairman. The first chairman shall be appointed by the

General Meeting. In the case the chairman is unable to carry out his duties, he is replaced by the director designated to
this effect by the board. The meetings of the board of directors are convened by the chairman or by any two directors.
The board can only validly debate and take decisions, if the majority of its members are present of represented, proxies
between directors being permitted with the restriction that every director can represent only one of his colleagues.
The directors may cast their vote on the points of the agenda by letter, cable, telex or telefax, these last three to be
confirmed by letter. Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions
voted at the directors’ meetings.

Art. 8. All decisions by the board shall require an absolute majority. In case of an equality of votes, the chairman of

the meeting carries the decision.

Art. 9. The minutes of the meetings of the board of directors shall be signed by all the directors having assisted at

the debates. The copies or extracts shall be certified true by one director or by a proxy.

Art. 10. Full and exclusive powers for the administration and management of the company are vested in the board

of directors, which alone is competent to determine all matters not reserved for the General Meeting by law or by the
present articles.

Art. 11. The board of directors may delegate the daily management to directors or to third persons who need not

be shareholders of the company. Delegation of daily management to a member of the board is subject to previous au-
thorisation by the General Meeting of shareholders.The first managing director will be nominated by the first general
meeting of the shareholders.

65058

Art. 12. Towards third parties the company is in all circumstances committed by the joint signatures of two directors

or by the single signature of a delegate of the board acting within the limits of his powers. In their current relations with
the public administrations, the company is validly represented by one director, whose signature legally commits the com-
pany.

Art. 13. The company is supervised by one or several statutory auditors, who are appointed by the General Meeting

which fixes their number and their remuneration. The duration of the term of office of an auditor is fixed by the General
Meeting. It may not, however, exceed six years.

General meeting

Art. 14. The General Meeting represents the whole body of the shareholders. It has the most extensive powers to

decide of the affairs of the company. The convening notices are made in the form and delay prescribed by law.

Art. 15. The annual General Meeting is held in the commune of the registered office at the place specified in the

notice convening the meeting on the first Wednesday of May each year at 2.00 p.m. the first time in the year 2003. If
such a day is a holiday, the General Meeting will be held on the next following business day.

Art. 16. The directors or the auditor(s) may convene an extraordinary General Meeting. It must be convened at the

request of shareholders representing one fifth of the company’s capital.

Art. 17. Each share entitles to the casting of one vote.

Business year - Distribution of profits

Art. 18. The business year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year. The

board of directors draws up the annual accounts according to the legal prescriptions. It submits these documents with
a report of the company’s operations one month at least before the Statutory General Meeting to the statutory audi-
tor(s).

Art. 19. After deduction of general expenses and all charges, the balance represents the net profit of the company.

Five (5) per cent of this net profit shall be allocated to the legal reserve fund. Such deduction will cease to be compulsory
when the reserve fund reaches ten (10) per cent of the share capital of the company.

The balance is at the disposal of the General Meeting. Advances on dividends may be paid by the board of directors

in compliance with the legal requirements. The General Meeting can decide to assign profits and distributable reserves
to the reimbursement of the capital, without reducing the corporate capital.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. The company may be dissolved by a decision of the General Meeting voting with the same quorum as for

the amendment of the articles of incorporation. Should the company be dissolved, the liquidation will be carried out by
one or several liquidators, legal or physical bodies, appointed by the General Meeting which will specify their powers
and remunerations.

General provision

Art. 21. As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10th, 1915 on commercial companies to the laws modifying.

<i>Subscription

The one hundred (100) shares have been subscribed to as follows: 

The subscribed capital has been entirely paid up in cash. The result is that as of now the company has at its disposal

the sum of one hundred thousand euro (EUR 100,000.-) as was justified to the notary executing this deed who expressly
certifies it.

<i>Expenses

The amount of the expenses for which the company is liable as a result of its formation is approximately three thou-

sand euro (EUR 3,000.-).

<i>General meeting

The above-named parties, representing the whole of the subscribed capital and holding themselves to be duly con-

vened, then held an extraordinary general meeting and unanimously passed the following resolutions:

1.- The company’s address is fixed in L-2320 Luxembourg, 55, Boulevard de la Pétrusse.
2.- The following have been elected as directors, their mandates expiring at the issue of the annual general meeting

to be held in the year 2007:

a) The company MARELUX S.A. with registered office in L-2320 Luxembourg, 55, boulevard de la Pétrusse, repre-

sented through Mr Robert Mehrpahl nominated as managing director of the company, which may validly engage the
company under his sole signature against public administrations and for current managing acts, except disposal acts.

b) Mr Juan Garcia Marina, Administrator, with address Zenit, 21, 28023 Madrid, Spain, nominated as member of the

board of directors;

c) Miss Luisa Maria Bravo Mendez, Administrator, with address, Zenit, 21, 28023 Madrid, Spain, nominated as mem-

ber of the board of directors;

1. SOCIEDAD ESPANOLA INMUEBLOS Y LOCALES S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99 shares

2. Mr André Harpes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 share

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 shares

65059

3.- Mr Pierre Feltgen, lawyer, resident in Luxembourg, has been appointed as statutory auditor his term of office ex-

piring at the general meeting which will be called to deliberate on the operations of the first fiscal year in 2007:

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above-named

persons, this deed is worded in English followed by French translation; at the request of the same appearing persons, in
case of divergences between the English and French texts, the English version will be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Senningerberg, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, civil status

and residences, said persons appearing signed together with Us, the notary, this original deed.

Follows the German version of the previous text:

Im Jahre zweitausendzwei, den zwanzigsten Juni.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, im Amtssitze zu Niederanven.

Sind erschienen:

1.- die Gesellschaft spanischen Rechts SOCIEDAD ESPANOLA INMUEBLOS Y LOCALES S.L. mit Sitz in Spanien,

Madrid, Zenit, 21, vertreten durch Herrn Andre Harpes unter den Wortlaut und Bedingungen einer Vollmacht ausge-
stellt den 17. Mai 2002, von den Komparenten datiert, ne varietur gegengezeichnet und dem vorliegendem Notarakt
beigelegt.

2.- Herr André Harpes, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg Vorbenannte Personen ersuchen den unterzeichneten

Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktiengesellschaft wie folgt zu dokumentieren.

Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird

eine anonyme Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung LADINO S.A. gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates

können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Aus-
land errichtet werden.

Unter Vorbehalt der Rechtsbedingungen welche die Beendigung eines dem Festsetzten des Gesellschaftssitzes diene-

nenden Vertrages mit Drittparteiene, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kann der Sitz der Gesellschaft an
jede andere Adresse innerhalb des Grossherzogstums Luxemburg verlegt werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-

schäftsführung beauftragt sind.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Ankauf und Verkauf, die Bereederung und Befrachtung von Hochseeschiffen

sowie alle finanzielle oder kommerzielle Transaktionen welche direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Ver-
bindung stehen.

Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt einhundert tausend Euro (EUR 100.000,-) eingeteilt in einhundert (100)

Aktien mit einem Nominalwert von ein tausend Euro (EUR 1.000,-) pro Aktie.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.

Verwaltung - Überwachung

Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen, welche von der Generalversammlung für eine Dauer ernannt werden, die sechs Jahre nicht
überschreiten darf. Sie können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das frei gewordene

Amt vorläufig besetzen, jedoch muss diese Benennung durch die nächste Gesellschafterversammlung bestätigt werden.

Art. 7. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Der erste Vorsitzende wird von der

Generalversammlung gewählt. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat be-
stimmte Mitglied dessen Aufgaben.

Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei

ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann.

Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax ab-

geben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe müssen schriftlich bestätigt werden.

Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und unterschrieben ist, ist ge-

nauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.

Art. 8. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen. Bei Stimmengleich-

heit ist die Stimme des Vorsitzenden ausschlaggebend.

65060

Art. 9. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern

unterschrieben.

Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch einen Bevoll-

mächtigten.

Art. 10. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.

Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Gene-

ralversammlung vorbehalten ist.

Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine

Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung. Ausnahmsweise erfolgt die Benennung des ersten ge-
schäftsführenden Mitglieds des Verwaltungsrates durch die erste Generalversammlung der Aktionäre.

Art. 12. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Mitgliedern des Ver-

waltungsrates oder die einzelne Unterschrift des zur täglichen Geschäftsführung Delegierten des Verwaltungsrates
rechtsgültig vertreten.

Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die Unterschrift eines Mitgliedes des Verwal-

tungsrates rechtsgültig vertreten.

Art. 13. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte Kom-

missare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt.

Die Dauer der Amtszeit der Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann jedoch sechs Jahre

nicht überschreiten.

Generalversammlung

Art. 14. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes.

Art. 15. Die jährliche Generalversammlung tritt in Luxemburg an dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zu-

sammen und zwar am ersten Mittwoch des Monates März jedes Jahres um 14.00 Uhr, das erste Mal im Jahre 2003.

Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag

statt.

Art. 16. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine aussergewöhnliche Generalversammlung

einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens 20% (zwanzig Prozent) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.

Art. 17. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme, mit Ausnahme der gesetzlichen Einschränkungen.

Geschäftsjahr - Gewinnbeteiligung

Art. 18. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über

die Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.

Art. 19. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-

schaft dar. Von diesem Gewinn sind 5% (fünf Prozent) für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu verwenden; diese
Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% (zehn Prozent) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Mit Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften, kann der Verwaltungsrat

Zwischendividenden ausschütten.

Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benut-

zen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.

Auflösung - Liquidation

Art. 20. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie die Satzungsänderungen.

Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, vorzeitig oder am Ende ihrer Laufzeit, wird die Liquidation durch einen oder

mehrere Liquidationsverwalter durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die General-
versammlung unter Festlegung ihrer Aufgaben und Vergütungen ernannt werden.

Allgemeine Bestimmungen

Art. 21. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915 sowie auf die späteren Anderungen.

<i>Schätzung der Gründungskosten 

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, drei tausend euro (EUR 3.000,-).

65061

<i>Kapitalzeichnung

Die einhundert (100) Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100%) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von einhundert tausend euro (EUR 100.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.

<i>Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammen gefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Der Gesellschaftssitz wird auf L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse festgelegt
2.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern für die Dauer bis zur jährlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2007 wer-

den ernannt:

a) Die Gesellschaft MARELUX S.A., mit Sitz in L-2320 Luxemburg, 55, boulevard de la Pétrusse, welche durch Herrn

Robert Mehrfahl, als geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten wird und welcher allein zeichnungsbe-
rechtigt ist gegenüber öffentlichen Verwaltungen und für die tägliche Geschäftsführung, ausgenommen Dispositionsakte.

b) Herr Juan Garcia Marina, Administrator, mit Adresse in Zenit, 21, 28023 Madrid, Spanien als Mitglied des Verwal-

tungsrates ernannt,

c) Frau Luisa Maria Bravo Mendez, Administrator, mit Adresse in Zenit, 21, 28023 Madrid, Spanien, als Mitglied des

Verwaltungsrates ernannt.

3.- Zum Kommissar wird ernannt: für die Dauer bis zur jährlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2007, Herr

Pierre Feltgen, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Senningerberg, im Jahre, Monat und Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar die vor-

liegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. Harpes, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2002, vol. 14CS, fol. 3, case 6. – Reçu 1.000 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.

(55689/202/268) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

PI-S.A., Société Anonyme - Soparfi,

(anc. PI-S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 77.181. 

L’an deux mille deux, le dix-neuf juin.
Par-devant Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich.

S’est réunie:

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding PI-S.A. HOLDING, avec siège

social à L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy,

constituée suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, en date du 19 juillet

2000, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations, N

°

 13 du 9 janvier 2001,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 77.181,
L’assemblée est ouverte à 11.00 heures sous la présidence de Monsieur Régis Galiotto, employé privé, demeurant

professionnellement à Luxembourg-Eich,

qui désigne comme secrétaire Madame Céline Fournier, employée privée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg-Eich,

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Wolfgang Gerlach, employé privé, demeurant à Luxembourg,
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1.- Transformation de l’objet social de la société de holding en SOPARFI et adaptation subséquente de l’article 4 des

statuts qui aura la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te, échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de

1. SOCIEDAD ESPANOLA INMUEBLOS Y LOCALES S.L, vorgenannt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

99 Aktien

2. Herr André Harpes, vorgenannt:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1 Aktie

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 100 Aktien

Senningerberg, den 9. Juli 2000.

P. Bettingen.

65062

surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

2.- Suppression de toute référence à la loi du 31 juillet 1929 et adaptation subséquente de l’article 1

er

 des statuts

comme suit:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PI-S.A.»

3.- Divers.
Il.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-

tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-

nistration à proposer les points figurant à l’Ordre du jour.

L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de transformer l’objet social de la société de holding en SOPARFI, et modification affé-

rente de l’article 4 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans des sociétés luxem-

bourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par ven-
te,  échange ou de toute autre manière, de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion ou la mise en valeur du
portefeuille qu’elle possédera, l’acquisition, la cession et la mise en valeur de brevets et de licences y rattachées.

La société peut prêter ou emprunter avec ou sans garantie, elle peut participer à la création et au développement de

toutes sociétés et leur prêter tous concours. D’une façon générale elle peut prendre toutes mesures de contrôle, de
surveillance et de documentation et faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de supprimer toute référence à la loi du 31 juillet 1929 en conséquence l’article 1

er

 des

statuts est modifié pour avoir la teneur suivante:

«Art. 1

er

. Il existe une société anonyme luxembourgeoise sous la dénomination de PI-S.A.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui

incombent à la société à environ EUR 745,-.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg-Eich, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: R. Galiotto, C. Fournier, W. Gerlach, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 26 juin 2002, vol. 13CS, fol. 19, case 8. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55698/206/78) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

PI-S.A., Société Anonyme - Soparfi,

(anc. PI-S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding).

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 77.181. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 juillet 2002.

(55699/206/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

Luxembourg-Eich, le 18 juillet 2002.

P. Decker.

<i>Pour la société
P. Decker
<i>Notaire

65063

NATURAL GLOBAL RESOURCES S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

STATUTES

In the year two thousand and two, on the first of July.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared:

1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT, with registered office in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
represented by FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., with registered office
in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen,
duly represented by Mr Alhard von Ketelhodt, réviseur d’entreprises et expert-comptable, residing in L-1220 Lux-

embourg, 196, rue de Beggen,

by virtue of a proxy given 
2) ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT, with registered office in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
represented by FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., with registered office in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen,
duly represented by Mr Alhard von Ketelhodt, réviseur d’entreprises et expert-comptable, residing in L-1220 Lux-

embourg, 196, rue de Beggen,

by virtue of a proxy given 
which proxies, signed ne varietur by the appearing person and the attesting notary public, shall remain attached to

the present deed with which they shall be formalised.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorpo-

ration of a public limited company which they declare organized among themselves.

I. Name - Duration - Object - Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of NATURAL GLOBAL RESOURCES S.A.

Art. 2. The company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The object of the company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies

and foreign companies, and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription, or in any other man-
ner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind, and the administration, control and
development of its portfolio. 

 The company may carry out any commercial, industrial or financial operation which it may deem useful in accom-

plishment of its purposes in accordance with the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

II. Social Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty five thousand Euro (EUR 35,000.-) consisting of three hundred fifty

shares (350) of a par value of one hundred Euro (EUR 10.-) per share.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The company may, to the extent and under
terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. The com-
pany may issue certificates representing bearer shares. These certificates shall be signed by two directors.

The company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the company. The
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the company.

III. General meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations

65064

of the company. The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of
shareholders representing at least 20 % of the company’s share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Wednesday of
May at 10.00 a.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the previous business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

IV. Board of Directors

Art. 9. The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting
which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not ex-
ceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of share-holders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The en-
tirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 11 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the com-

pany as well as the representation of the company in relation with this management may be delegated to one or more
directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and
powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors
is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders. The company may also grant special powers
by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

65065

Art. 13. The company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to

whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

V. Supervision of the company

Art. 14. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

VI. Accounting year - Balance

Art. 15. The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on Decem-

ber 31st of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18 . These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law of August tenth, nineteen hundred
and fifteen on commercial companies, as amended.

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19 . All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on companies and amendments thereto.

<i>Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on December

31, 2002.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2003.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter: 

All the shares have been paid up to 100% percent by payment in cash, so that the sum of thirty five thousand Euro

(EUR 35.000,-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand six hundred Euro (EUR 1.600,-).

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
a) Mr Horst Wich, engineer, residing in 68-307 East Palm Canyon Drive, Cathedral City, California, United States of

America who is also appointed managing director of the company.

b) Mrs Dawne Carsen, energy consultant, residing in 69-115 Ramon Road, Cathedral City, California, United States

of America

c) Mr Thomas Wich, policeman, residing in 1170 North Golden Springs Drive, Diamond Bar, California, United States

of America

3. The following company is appointed statutory auditor:
AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, with registered office in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 shares
2) ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 shares
Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 shares

65066

4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2008.

5. The address of the company is set at L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
6. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commer-

cial companies, as amended, authorises the board of directors to delegate the daily management of the company and
the representation of the company in relation with this management to any of its members.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Follows the German translation:

Im Jahre zwei tausend und zwei, den ersten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven.

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft EUROPEAN TIME MANAGEMENT, mit Sitz zu Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
vertreten durch die FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., mit Sitz zu L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen,
vertreten durch Herrn Alhard von Ketelhodt, réviseur d’entreprises et expert comptable, mit Wohnsitz zu L-1220

Luxemburg, 196, rue de Beggen, 

durch eine Vollmacht, ausgestellt 
 2) Die Gesellschaft ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT, mit Sitz zu Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
vertreten durch die FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., mit Sitz zu L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen,
vertreten durch Herrn Alhard von Ketelhodt, réviseur d’entreprises et expert comptable, mit Wohnsitz zu L-1220

Luxemburg, 196, rue de Beggen, 

durch eine Vollmacht, ausgestellt 
Die Vollmachten nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar blei-

ben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden.

I. Name - Sitz - Dauer und Zweck

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen NATURAL GLO-

BAL RESOURCES S.A.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft besteht in dem Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen

Gesellschaften durch Kauf, Zeichnung oder auf jede andere Weise sowie durch die Übertragung und den Erwerb von
Wertpapieren jeder Art und jedwede sonstigen Massnahmen hinsichtlich der Anlage des Gesellschaftsvermögens in Be-
teiligungsrechten oder Wertpapieren sowie der Verwaltung, Kontrolle und Verwertung der erworbenen Beteiligungen.

Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die der Erreichung ihres Zweckes förderlich sind und im Rahmen der

Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliess-
lich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen («Gesetz vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn») zulässig
sind.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kön-

nen jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet wer-
den.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-

tigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland
behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Be-
schluss des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land ver-
legt werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

II. Kapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt fünfunddreissigtausend Euro (EUR 35.000,-) und ist in dreihundertfünfzig

(350) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, entsprechend den ge-

setzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen
des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namens- oder Inhaberaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offensteht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel neununddreissig des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-
hundertfünfzehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festge-
stellt.

65067

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, welche Inhaberaktien ver-
körpern. Diese Zertifikate werden von ebenfalls zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig

sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen,
um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Aus-
übung aller Rechte bezüglich solcher Aktien suspendieren, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesell-
schaft als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt benannt worden ist. 

III. Generalversammlung

Art. 7. Die Versammlung der Aktionäre («Generalversammlung») vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die

umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, vorzuneh-
men oder zu genehmigen. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag
von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in

der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils am dritten Mittwoch des Monats Mai um
10.00 Uhr eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktag statt.

 Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebigen, in der

Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

In der jeweiligen Einladung sowie im Verlauf der Versammlungsleitung werden die gesetzlich festgelegten Anwesen-

heitserfordernisse und Mehrheitsverhältnisse geregelt, sofern diese Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft.

Jede Aktie verleiht eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf den Generalversammlungen durch schriftliche Voll-

macht sowie durch per Telegraph, Telegramm, Telex oder Telefax erteilte Vollmacht vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung werden Beschlüsse ordnungsgemäss

einberufener Generalversammlungen durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen jeder Art aufstellen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

Generalversammlungen erfüllt werden müssen.

Sofern alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tages-

ordnung Kenntnis zu haben, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

IV. Verwaltungsrat

Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre
Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs
Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates
abberufen.

 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt

vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 10 . Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellver-

tretenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates
sein muss und welcher für die Protokollführung auf den Sitzungen des Verwaltungsrates und den Generalversammlungen
verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Ver-

waltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen sowie in den Sitzungen des Ver-

waltungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied
des Verwaltungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungszeit-

punkt eine Einladung, ausser in dringenden Fällen, in welchem Falle Art und Gründe der Eilbedürftigkeit im Einberufungs-
brief erwähnt sein müssen. Nach schriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gegebener Einwilligung
eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes kann auf die Einladung verzichtet werden.

Einer gesonderten Einladung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einem Zeitpunkt und an einem

Ort abgehalten werden, welche in einem vorhergehenden Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt worden waren. 

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein an-

deres Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Tele-
gramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung an Sitzungen teilnehmen oder

im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel, vorausgesetzt, dass alle Teilnehmer an der Sitzung sich untereinander aku-
stisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertre-

tenen Mitglieder.

65068

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschrei-

ben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich
bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.

Art. 11. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vor-

sitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet werden. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt
werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche dem Interesse der Gesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen
Handlungen ermächtigt, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung
vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf

die, in Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen übertragen
werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss geregelt. Die Übertra-
gung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Generalversammlung genehmigt werden. Der Verwaltungsrat kann
einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch beglaubigte oder privatschriftliche Bevollmächtigung übertragen.

Art. 13 . Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen verpflichtet.

V. Kontrolle

Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammmlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und
setzt ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 15. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16 . Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt,

bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Generalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages

des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-

hundertfünfzehn Vorschussdividenden ausschütten.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschliessende Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt.
Die Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Satzungsänderungen

Art. 18 . Diese Satzung kann unter Beachtung der, in Artikel siebenundsechzigeins des Gesetzes vom zehnten August

neunzehnhundertfünfzehn festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Generalversammlung ge-
ändert werden.

IX. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 19 Für sämtliche Fragen, welche durch diese Satzung nicht geregelt werden, gelten die einschlägigen Bestim-

mungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn.

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2003 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Verlesung der Satzung erklären die Erschienenen, die fünf tausend Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100 %) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von fünfunddreissig tausend Euro (EUR 35.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wur-
de.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen gemäss Artikel sechsundzwanzig des Gesetzes vom

zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen erfüllt sind.

1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Aktien
3) ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT, vorbenannt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 Aktien
Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 Aktien

65069

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-

dung erwachsen, auf ungefähr eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600,-).

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich

einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Es wird ein Rechnungsprüfer ernannt.
 2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
 a) Herr Horst Wich, Ingenieur, wohnhaft in 68-307 East Palm Canyon Drive, Cathedral City, California, United States

of America

welcher ebenfalls zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wird.
b) Frau Dawne Carsen, Unternehmensberaterin, wohnhaft in 69-115 Ramon Road, Cathedral City, California, United

States of America.

c) Herr Thomas Wich, Polizist, wohnhaft in 1170 North Golden Springs Drive, Diamond Bar, California, United

States of America.

3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt: AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, mit Sitz in L-1220 Luxemburg, 196, rue

de Beggen.

4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Generalversammlung, die

über das Geschäftsjahr 2008 befindet.

5. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.
6. Gemäss Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaf-

ten einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ermächtigt die Generalversammmlung den Verwaltungs-
rat, einem oder mehreren seiner Mitglieder die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche
Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. von Ketelhodt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 14, case 4. – Reçu 350 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55692/202/397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

NATURAL GLOBAL RESOURCES HOLDING S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.

STATUTES

In the year two thousand and two, on the first of July.
Before the undersigned Maître Paul Bettingen, notary, residing in Niederanven.

There appeared:

1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT, with registered office in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
represented by FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., with registered office in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen,
duly represented by Mr Alhard von Ketelhodt, réviseur d’entreprises et expert-comptable, residing in L-1220 Lux-

embourg, 196, rue de Beggen,

by virtue of a proxy given 
2) ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT, with registered office in Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
represented by FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., with registered office in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen,
duly represented by Mr Alhard von Ketelhodt, réviseur d’entreprises et expert-comptable, residing in L-1220 Lux-

embourg, 196, rue de Beggen, by virtue of a proxy given which proxies, signed ne varietur by the appearing person and
the attesting notary public, shall remain attached to the present deed with which they shall be formalised.

Such appearing parties, acting in their hereabove stated capacities, have drawn up the following Articles of Incorpo-

ration of a public limited company which they declare organized among themselves.

I. Name - Duration, Object, Registered Office

Art. 1. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the shares here-

after issued, a company in the form of a société anonyme, under the name of NATURAL GLOBAL RESOURCES HOLD-
ING S.A.

Art. 2. The company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The objet of the corporation is the taking of participating interests, in whatsoever form in other, either Lux-

embourg or foreign companies, and the management, control and development of such participating interests.

Senningerberg, den 18 Juli 2002.

P. Bettingen.

65070

 The corporation may in particular acquire all types of transferable securities, either by way of contribution, subscrip-

tion, option, purchase or otherwise, as well as realise them by sale, transfer, exchange or otherwise. The corporation
may also acquire and manage all patents and other rights deriving from these patents or complementary thereto.

 The corporation may borrow and grant any assistance, loan, advance or guarantee to companies in which it has a

direct and substantial interest.

 The Corporation shall not carry on any industrial activity nor maintain a commercial establishment open to the pub-

lic. In general, the corporation may take any measure and carry out any operation which it may deem useful to the ac-
complishment and development of its purposes, remaining always however, within the limits established by the Law of
July 31, 1929, concerning holding Companies, as well as by article 209 on commercial companies.

Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg-City. Branches or other offices may be

established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent, that would interfere with the normal activities of the company at its registered office
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

II. Social Capital - Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty five thousand Euro (EUR 35.000.-) consisting of three hundred fifty

shares (350) of a par value of one hundred Euro (EUR 100,-) per share.

The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles of Incorporation. The company may, to the extent and under
terms permitted by law, redeem its own shares.

Art. 6. The shares of the company may be in registered form or in bearer form or partly in one form or the other

form, at the option of the shareholders subject to the restrictions foreseen by law.

A register of registered shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any

shareholder. This register will contain all the information required by article thirty-nine of the law of August tenth, nine-
teen hundred and fifteen on commercial companies, as amended. Ownership of registered shares will be established by
inscription in the said register. Certificates of these inscriptions shall be issued and signed by two directors. The com-
pany may issue certificates representing bearer shares. These certificates shall be signed by two directors.

The company will recognise only one holder per share; in case a share is held by more than one person, the persons

claiming ownership of the share will have to name a unique proxy to present the share in relation to the company. The
company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as the sole owner in relation to the company.

III. General meetings of Shareholders

Art. 7. Any regularly constituted meeting of shareholders of the company shall represent the entire body of share-

holders of the company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations
of the company. The general meeting is convened by the board of directors. It may also be convoked by request of
shareholders representing at least 20 % of the company’s share capital.

Art. 8. The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the com-

pany, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the third Wednesday of
May at 10.00 a.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the previous business day.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another per-

son as his proxy in writing, cable, telegram, telex or telefax.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a sim-

ple majority of those present or represented.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take

part in any meeting of shareholders.

If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have

been informed of the agenda of the meeting the meeting may be held without prior notice or publication.

IV. Board of Directors

Art. 9 The company shall be managed by a board of directors composed of three members at least who need not

be shareholders of the company. The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting
which shall determine their number, remuneration and term of office. The term of the office of a director may not ex-
ceed six years and the directors shall hold office until their successors are elected.

The directors are elected by a simple majority vote of the shares present or represented.
Any director may be removed with or without cause by the general meeting of shareholders.
In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be

filled out on a temporary basis until the next meeting of shareholders, by observing the applicable legal prescriptions.

65071

Art. 10. The board of directors shall choose from among its members a chairman, and may choose from among its

members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two directors, at the place indicated in the notice of

meeting.

The chairman shall preside at all meeting of share-holders and of the board of directors, but in his absence, the share-

holders or the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four hours at least in

advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of
the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing,
by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication. A special convocation will not be
required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board
of directors.

Any directors may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex

or telefax another director as his proxy.

A director may represent more than one of his colleagues.
Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors.

Decisions shall be taken by a majority of votes of the directors present or represented at such meeting.
The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing,

by cable, telegram, telex or telefax, or any other similar means of communication, to be confirmed in writing. The en-
tirety will form the minutes giving evidence of the resolution. 

Art. 11. The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by

the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceed-
ings or otherwise shall be signed by the chairman, or by two directors.

Art. 12. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-

sition in the company’s interests. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting
of shareholders fall within the competence of the board of directors.

According to article 60 of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, the daily management of the com-

pany as well as the representation of the company in relation with this management may be delegated to one or more
directors, officers, managers or other agents, associate or not, acting alone or jointly. Their nomination, revocation and
powers shall be settled by a resolution of the board of directors. The delegation to a member of the board of directors
is submitted to prior authorisation of the general meeting of shareholders. The company may also grant special powers
by authentic proxy or power of attorney by private instrument.

Art. 13. The company will be bound by the joint signature of two directors or the sole signature of any persons to

whom such signatory power shall be delegated by the board of directors.

V. Supervision of the company

Art. 14. The operations of the company shall be supervised by one or several statutory auditors, which may be

shareholders or not. The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditors, and shall determine their
number, remuneration and term of office which may not exceed six years.

VI. Accounting year - Balance

Art. 15 . The accounting year of the company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-

cember 31st of the same year.

Art. 16. From the annual net profits of the company, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve required

by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10 %) of
the subscribed capital of the company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article 5 hereof.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, will determine how the re-

mainder of the annual net profits will be disposed of.

Interim dividends may be distributed by observing the terms and conditions foreseen by law.

VII. Liquidation

Art. 17. In the event of dissolution of the company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of shareholders effecting such dissolution and which
shall determine their powers and their compensation.

VIII. Amendment of the Articles of Incorporation

Art. 18. These Articles of Incorporation may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the conditions of quorum and majority foreseen in article 67-1 of the Law of August tenth, nineteen hundred
and fifteen on commercial companies, as amended.

65072

IX. Final clause - Applicable law

Art. 19. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law

of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto, as well as the law of
July thirty-first, nineteen hundred and twenty-nine on holding companies.

<i>Transitional dispositions

1) The first accounting year shall begin on the date of the formation of the company and shall terminate on December

31, 2002.

2) The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2003.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed as mentioned hereafter: 

All the shares have been paid up to 100% percent by payment in cash, so that the sum of thirty five thousand Euro

(EUR 35,000.-) is forthwith at the free disposal of the corporation, as has been proved to the notary.

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26 of

the law of August 10, 1915, on commercial companies and expressly states that they have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a

result of its formation are estimated at approximately one thousand six hundred Euro (EUR 1,600.-).

<i>General meeting of shareholders

The above named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as fully convened,

have immediately proceeded to an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted,
they have passed the following resolutions by unanimous vote.

1. The number of directors is fixed at three and the number of statutory auditors at one.
2. The following persons are appointed directors:
a) Mr Horst Wich, engineer, residing in 68-307 East Palm Canyon Drive, Cathedral City, California, United States of

America, who is also appointed managing director of the company,

b) Mrs Dawne Carsen, energy consultant, residing in 69-115 Ramon Road, Cathedral City, California, United States

of America,

c) Mr Thomas Wich, policeman, residing in 1170 North Golden Springs Drive, Diamond Bar, California, United States

of America,

3. The following company is appointed statutory auditor:
AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, with registered office in L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen
4. The term of office of the directors and of the statutory auditor shall end at the general meeting called to approve

the accounts of the accounting year 2008.

5. The address of the company is set at L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.
6. The general meeting, according to article 60 of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commer-

cial companies, as amended, authorises the board of directors to delegate the daily management of the company and
the representation of the company in relation with this management to any of its members.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with the notary,

the present original deed.

Follows the german translation:

Im Jahre zwei tausend und zwei, den ersten Juli.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven,

Sind erschienen:

1) Die Gesellschaft EUROPEAN TIME MANAGEMENT, mit Sitz zu Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
vertreten durch die FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., mit Sitz zu L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen,
vertreten durch Herrn Alhard von Ketelhodt, réviseur d’entreprises et expert comptable, mit Wohnsitz zu L-1220

Luxemburg, 196, rue de Beggen, 

durch eine Vollmacht, ausgestellt 
2) Die Gesellschaft ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT, mit Sitz zu Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 
vertreten durch die FIDUCIAIRE EUROLUX S.A., mit Sitz zu L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen,

1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 shares
2) ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT, prenamed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 shares
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 shares

65073

vertreten durch Herrn Alhard von Ketelhodt, réviseur d’entreprises et expert comptable, mit Wohnsitz zu L-1220

Luxemburg, 196, rue de Beggen, 

durch eine Vollmacht, ausgestellt 
Die Vollmachten nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar blei-

ben gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben formalisiert zu werden.

Die Erschienenen ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Aktiengesellschaft, die sie hiermit gründen,

wie folgt zu beurkunden.

I. Name - Sitz - Dauer und Zweck

Art. 1. Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Luxemburger Recht und führt den Namen NATURAL GLO-

BAL RESOURCES HOLDING S.A.

Art. 2. Die Dauer der Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit festgesetzt.

Art. 3. Der Zweck der Gesellschaft besteht darin Beteiligungen in jeder Form in anderen Gesellschaften aufzuneh-

men, in Luxemburg oder im Ausland, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Ausbreitung solcher Beteiligungen.

 Die Gesellschaft ist insbesonders befugt sämtliche Arten von übertragbaren Wertpapieren anzuschaffen, entweder

durch Einzahlung, Unterzeichnung, Option, Kauf oder anderswie, sowie diese Wertpapiere zu veräussern durch Ver-
kauf, Übertragung, Umtausch oder anderswie.

 Die Gesellschaft ist auch befugt jegliche Patente sowie sämtliche Rechte die mit diesen Patenten verbunden sind,

anzuschaffen und zu verwalten.

 Die Gesellschaft ist befugt durch Anleihen Geld aufzunehmen und den Gesellschaften in denen sie beteiligt ist Bei-

stand, Kredit, Vorschüsse oder Garantien zu leisten und gewähren.

 Die Gesellschaft wird sich keiner Handelstätigkeit hingeben und keine öffentliche Handelsstätte betreiben.
 Im allgemeinen ist die Gesellschaft befugt alles zu unternehmen was zur guten Ausführung des Gesellschaftszweckes

erforderlich erscheint, mit der Einschränkung wie sie gesetzlich (Gesetz vom 31.Juli 1929; Artikel 209 aus dem Gesetz
über die ordentlichen Gesellschaften) für Holdinggesell-schaften verankert ist.

Art. 4. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates kön-

nen jederzeit Filialen oder Geschäftsstellen sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland gegründet wer-
den.

Falls durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur die Gesellschaft in ihrer Tä-

tigkeit am Gesellschaftssitz oder die reibungslose Kommunikation zwischen dem Sitz der Gesellschaft und dem Ausland
behindert wird oder falls eine solche Behinderung vorauszusehen ist, kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Be-
schluß des Verwaltungsrates vorübergehend bis zur völligen Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt
werden. Eine solche Massnahme berührt die luxemburgische Staatszugehörigkeit der Gesellschaft nicht.

II. Kapital - Aktien

Art. 5. Das gezeichnete Kapital beträgt fünfunddreissigtausend Euro (EUR 35.000,-) und ist in dreihundertfünfzig

(350) Aktien mit einem Nominalwert von je einhundert Euro (EUR 100,-) eingeteilt.

Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Hauptversammlung, entsprechend den ge-

setzlichen Erfordernissen für Satzungsänderungen, erhöht oder herabgesetzt werden. Die Gesellschaft kann im Rahmen
des Gesetzes und nach den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwerben.

Art. 6. Die Aktien sind, nach Wahl der Aktionäre, Namens- oder Inhaberaktien.
Am Gesellschaftssitz wird ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offensteht.

Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel neununddreissig des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-
hundertfünfzehn vorgesehen sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festge-
stellt.

Es können Aktienzertifikate ausgestellt werden, welche die Eintragung im Register bestätigen und von zwei Verwal-

tungsratsmitgliedern unterzeichnet werden. Die Gesellschaft kann auch Zertifikate ausstellen, welche Inhaberaktien ver-
körpern. Diese Zertifikate werden von ebenfalls zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte das Eigentum an Aktien aufgeteilt oder streitig

sein, müssen diejenigen, die ein Recht an diesen Aktien geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen,
um die aus den Aktien resultierenden Rechte gegenüber der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann die Aus-
übung aller Rechte bezüglich solcher Aktien suspendieren, solange nicht eine einzige Person im Verhältnis zur Gesell-
schaft als zur Ausübung der Rechte an diesen Aktien berechtigt benannt worden ist. 

III. Generalversammlung

Art. 7. Die Versammlung der Aktionäre («Generalversammlung») vertritt alle Aktionäre der Gesellschaft. Sie hat die

umfassende Befugnis, Handlungen im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft anzuordnen, vorzuneh-
men oder zu genehmigen. Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen. Sie kann auch auf Antrag
von Aktionären, welche wenigstens ein Fünftel des Kapitals vertreten, einberufen werden.

Art. 8. Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen, in

der Einladung bestimmten Ort der Gemeinde des Gesellschaftssitzes jeweils am dritten Mittwoch des Monats Mai um
10.00 Uhr eines jeden Jahres oder, wenn dieser Tag auf einen Feiertag fällt, am vorhergehenden Werktag statt.

 Ausserordentliche Generalversammlungen können jederzeit an einem beliebigen Ort und zu einem beliebigen, in der

Einladung bestimmten Zeitpunkt innerhalb oder ausserhalb des Grossherzogtums Luxemburg einberufen werden.

65074

In der jeweiligen Einladung sowie im Verlauf der Versammlungsleitung werden die gesetzlich festgelegten Anwesen-

heitserfordernisse und Mehrheitsverhältnisse geregelt, sofern diese Satzung nicht anderweitige Bestimmungen trifft.

Jede Aktie verleiht eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf den Generalversammlungen durch schriftliche Voll-

macht sowie durch per Telegraph, Telegramm, Telex oder Telefax erteilte Vollmacht vertreten lassen.

Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen des Gesetzes oder dieser Satzung werden Beschlüsse ordnungsgemäss

einberufener Generalversammlungen durch einfache Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre getroffen.

Der Verwaltungsrat kann weitere Bedingungen jeder Art aufstellen, welche von den Aktionären zur Teilnahme an

Generalversammlungen erfüllt werden müssen.

Sofern alle Aktionäre auf einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind und bestätigen, von der Tages-

ordnung Kenntnis zu haben, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.

IV. Verwaltungsrat

Art. 9. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die nicht Aktionäre der Ge-

sellschaft zu sein brauchen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung ernannt. Ihre
Anzahl, Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der Generalversammlung festgesetzt. Die Amtszeit darf sechs
Jahre nicht überschreiten und endet grundsätzlich mit der Bestellung des jeweiligen Nachfolgers.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden und vertretenen Aktionären

gewählt. Die Generalversammlung kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen Mitglieder des Verwaltungsrates
abberufen.

 Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder das freie Amt

vorläufig besetzen. Die nächste Generalversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 10. Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und kann einen stellvertre-

tenden Vorsitzenden bestellen. Er kann auch einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Verwaltungsrates sein
muss und welcher für die Protokollführung auf den Sitzungen des Verwaltungsrates und den Generalversammlungen
verantwortlich ist.

Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder durch zwei seiner Mitglieder einberufen. Sitzungen des Ver-

waltungsrates finden an dem, in der Einladung bestimmten Ort statt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende führt den Vorsitz in allen Generalversammlungen sowie in den Sitzungen des Ver-

waltungsrates. In seiner Abwesenheit kann die Generalversammlung mit Mehrheit der Anwesenden ein anderes Mitglied
des Verwaltungsrates ernennen, um zeitweilig den Vorsitz in diesen Versammlungen oder Sitzungen zu führen.

Jedes Mitglied des Verwaltungsrates erhält mindestens vierundzwanzig Stunden vor dem vorgesehenen Sitzungszeit-

punkt eine Einladung, ausser in dringenden Fällen, in welchem Falle Art und Gründe der Eilbedürftigkeit im Einberufungs-
brief erwähnt sein müssen. Nach schriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Telegramm gegebener Einwilligung
eines jeden Verwaltungsratsmitgliedes kann auf die Einladung verzichtet werden.

Einer gesonderten Einladung bedarf es nicht für Sitzungen des Verwaltungsrates, die zu einem Zeitpunkt und an einem

Ort abgehalten werden, welche in einem vorhergehenden Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzt worden waren. 

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann sich in der Sitzung des Verwaltungsrates aufgrund einer Vollmacht durch ein an-

deres Mitglied vertreten lassen. Die Vollmacht kann privatschriftlich, durch Fernschreiben, Fernkopierer oder Tele-
gramm erteilt werden.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann im Wege einer telephonischen Konferenzschaltung an Sitzungen teilnehmen oder

im Rahmen ähnlicher Kommunikationsmittel, vorausgesetzt, dass alle Teilnehmer an der Sitzung sich untereinander aku-
stisch verstehen. Die Teilnahme an einer Sitzung auf solchem Wege gilt als persönliche Teilnahme an dieser Sitzung.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Die Beschlussfassung des Verwaltungsrates erfolgt mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwesenden und vertre-

tenen Mitglieder.

Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch im Umlaufverfahren (durch Brief, Telegramm, Fernschrei-

ben, Fernkopierer oder andere ähnliche Kommunikationsmittel) gefasst werden, vorausgesetzt, sie werden schriftlich
bestätigt. Die Gesamtheit der Unterlagen bildet das Protokoll und dient als Nachweis für den Beschluss.

Art. 11. Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates werden Protokolle geführt, welche vom Vor-

sitzenden oder in dessen Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern
unterzeichnet werden. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder vor anderen Stellen vorgelegt
werden sollen, werden vom Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

Art. 12. Der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle Verwaltungs- und Ver-

fügungshandlungen vorzunehmen, welche dem Interesse der Gesellschaft dienen. Der Verwaltungsrat ist zu sämtlichen
Handlungen ermächtigt, welche nicht durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich der Generalversammlung
vorbehalten sind.

Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können auf

die, in Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn aufgeführten Personen übertragen
werden; deren Ernennung, Abberufung und Befugnisse werden durch Verwaltungsratsbeschluss geregelt. Die Übertra-
gung an ein Verwaltungsratsmitglied muss von der Generalversammlung genehmigt werden. Der Verwaltungsrat kann
einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch beglaubigte oder privatschriftliche Bevollmächtigung übertragen.

Art. 13 . Dritten gegenüber wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmit-

gliedern oder durch die Einzelunterschrift entsprechend bevollmächtigter Personen verpflichtet.

65075

V. Kontrolle

Art. 14. Die Gesellschaft unterliegt der Kontrolle durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer, die nicht Aktionäre

der Gesellschaft zu sein brauchen. Die Generalversammmlung ernennt die Rechnungsprüfer, bestimmt ihre Zahl und
setzt ihre Vergütung sowie die Dauer ihrer Amtszeit fest. Die Dauer der Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.

VI. Geschäftsjahr - Bilanz

Art. 15 Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar jedes Jahres und endet am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 16. Es werden jährlich mindestens fünf Prozent des Reingewinnes vorweg den gesetzlichen Rücklagen zugeführt,

bis diese zehn Prozent des in Artikel fünf dieser Statuten vorgesehenen Gesellschaftskapitals betragen.

Die Generalversammlung bestimmt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Verwendung des restlichen Betrages

des Reingewinns.

Der Verwaltungsrat kann unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Gesetzes vom zehnten August neunzehn-

hundertfünfzehn Vorschussdividenden ausschütten.

VII. Auflösung der Gesellschaft

Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst, so wird die anschliessende Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt.
Die Generalversammlung ernennt sie und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

VIII. Satzungsänderungen

Art. 18. Diese Satzung kann unter Beachtung der, in Artikel siebenundsechzigeins des Gesetzes vom zehnten August

neunzehnhundertfünfzehn festgelegten Anwesenheits- und Mehrheitsvoraussetzungen von der Generalversammlung ge-
ändert werden.

IX. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 19 . Für alle Punkte die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des

Gesetzes vom 10. August 1915, so wie auf die späteren Änderungen, und auf die Bestimmungen des Gesetzes vom 31.
Juli 1929 über die Holdinggesellschaften. 

<i>Übergangsbestimmungen

1) Das erste Geschäftsjahr beginnt mit Gründung und endet am 31. Dezember 2002.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung wird im Kalenderjahr 2003 stattfinden.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Nach erfolgter Verlesung der Satzung erklären die Erschienenen, die fünf tausend Aktien wie folgt zu zeichnen: 

Sämtliche Aktien wurden zu hundert Prozent (100 %) in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe

von fünfunDdreissig tausend Euro (EUR 35.000,-) zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wur-
de.

<i>Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen gemäss Artikel sechsundzwanzig des Gesetzes vom

zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften einschliesslich nachfolgender Änderungen und
Ergänzungen erfüllt sind.

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Grün-

dung erwachsen, auf ungefähr eintausend sechshundert Euro (EUR 1.600,-)

<i>Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung, zu der sie sich als ordentlich

einberufen erklären, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei festgelegt. Es wird ein Rechnungsprüfer ernannt.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
a) Herr Horst Wich, Ingenieur, wohnhaft in 68-307 East Palm Canyon Drive, Cathedral City, California, United States

of America, 

welcher ebenfalls zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt wird.
b) Frau Dawne Carsen, Unternehmensberaterin, wohnhaft in 69-115 Ramon Road, Cathedral City, California, United

States of America,

c) Herr Thomas Wich, Polizist, wohnhaft in 1170 North Golden Springs Drive, Diamond Bar, California, United

States of America.

3. Zum Rechnungsprüfer wird ernannt:
AUDIT &amp; BUSINESS CONSULTING, mit Sitz in L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen
4. Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers enden mit der Generalversammlung, die

über das Geschäftsjahr 2008 befindet.

1) EUROPEAN TIME MANAGEMENT vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 Aktien
3) ST. THOMAS ASSET MANAGEMENT, vorbenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175 Aktien
Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 Aktien

65076

5. Die Anschrift der Gesellschaft lautet: L-1220 Luxemburg, 196, rue de Beggen.
6. Gemäss Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaf-

ten einschliesslich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen ermächtigt die Generalversammmlung den Verwaltungs-
rat, einem oder mehreren seiner Mitgliedern die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche
Vertretung Dritten gegenüber zu übertragen.

Worüber Urkunde aufgenommen wurde zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: A. von Ketelhodt, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 4 juillet 2002, vol. 14CS, fol. 14, case 5. – Reçu 350 Euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Kopie Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55693/202/406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

BLAZE HOLDINGS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

STATUTES

In the year two thousand two, on the fourth of July,
Before Maître Paul Bettingen, notary residing in Niederanven

There appeared:

ZILVER-BERK B.V., with registered office Amsteldijk 194, 1079 LK Amsterdam, The Netherlands (company Number:

33250278), here represented by Miss Manuela d’Amore, private employee, with professional address in L-1724 Luxem-
bourg, 9b, boulevard du Prince Henri, by virtue of a power of attorney, given under private seal;

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited company, which is hereby incorporated. 

Art. 1. There is formed by the present appearing party mentioned above and all persons and entities who may be-

come partners in the future, a private limited company (société à responsabilité limitée) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law dated 10th August, 1915 on commercial companies, as well
as by the present articles (hereafter the «Company»). 

Art. 2. The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition

of participations in any enterprise in any form whatsoever, and the administration, management, control and develop-
ment of those participations.

In particular, the Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities and

patents of whatever origin, to participate in the creation, development and control of any enterprise, to acquire, by way
of investment, subscription, underwriting or option, securities and patents, to realize them by way of sale, transfer, ex-
change or otherwise, to develop such securities and patents, to grant to companies which are controlled by the same
ultimate shareholder as the Company itself, any assistance, loans, advances and guarantees.

The Company may borrow funds from its shareholders, affiliated companies or third parties. It may issue debenture

loans, including convertible loans, by way of issue of registered bonds, with any denomination whatsoever and payable
in any currency whatsoever. Bonds may only be issued by way of a private placement.

The Company may engage in any transactions involving immovable and movable property. The Company may acquire,

transfer and manage any real estate of whatever kind in whatever country or location. The Company may further engage
and execute any operations which pertain directly or indirectly to the management and the ownership of real estate. 

The Company may carry out any industrial or commercial activity which directly or indirectly favours the realisation

of its object. 

Art. 3. The Company is formed for an unlimited period of time. 

Art. 4. The Company will have the name BLAZE HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its partners.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad. 

Art. 6. The Company’s subscribed share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (EUR. 12,500.-), rep-

resented by one hundred (100) shares having a nominal value of one hundred twenty-five Euros (EUR. 125.-) per share
each. 

Senningerberg, den 18. Juli 2002

P. Bettingen.

65077

Art. 7. The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the share-

holders meeting, in accordance with article 14 of these articles of association. 

Art. 8. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to

the number of shares in existence.

Art. 9. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.

Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company. 

Art. 10. In case of a single partner, the Company’s shares held by the single partner are freely transferable. 
In the case of plurality of partners, the shares held by each partner may be transferred by application of the require-

ments of article 189 of the law of 10th August, 1915 on commercial companies. 

Art. 11. The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single partner or of one of the partners

will not bring the Company to an end. 

Art. 12. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed, revoked
and replaced by the general shareholder meeting, by a decision adopted by partners owning more than half of the share
capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circum-

stances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided the
terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders

fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any member of the board of managers. The board of managers may elect among its members a general
manager who may bind the Company by his sole signature, provided he acts within the limits of the powers of the board
of managers.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may

subdelegate his powers for specific tasks to one or several ad hoc agents.

The general shareholders meeting or the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will

determine this agent’s responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any
other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. 

Art. 13. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal

liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. The single partner assumes all powers conferred to the general shareholder meeting.
In case of a plurality of partners, each partner may take part in collective decisions irrespectively of the number of

shares, which he owns. Each partner has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only
validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority of the

partners owning at least three quarters of the Company’s share capital, subject to the provisions of the law of 10th
August, 1915, as amended. 

Art. 15. The Company’s year starts on the 1st January and ends on the 31st December. 

Art. 16. Each year, with reference to 31st December, the Company’s accounts are established and the manager, or

in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the
company’s assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office. 

Art. 17. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, am-

ortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to 5 % of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to 10 % of the Company’s nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in

the Company. 

Art. 18. At the time of winding up the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

partners or not, appointed by the partners who shall determine their powers and remuneration. 

Art. 19. Reference is made to the provisions of the law of 10th August, 1915, as amended, for all matters for which

no specific provision is made in these articles of association.

<i> Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows: 

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of Euros 12,500.- is at the free disposal of

the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

ZILVER-BERK B.V.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 shares
Total   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 shares

65078

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31st December, 2002.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder, representing the entire subscribed capital of the Company,

has herewith adopted the following resolutions:

1) The number of managers is set at two. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period

of time:

Mr Alain Heinz, Director of Companies, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince

Henri,

Mr Joseph Mayor, Director of Companies, with professional address in L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du Prince

Henri,

who will have the necessary power to validly bind the company by thier respective sole signature.
2) The registered office is established in L-1724 Luxembourg 9b, boulevard du Prince Henri.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Senningerberg, on the years and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille deux, le quatre juillet. 
Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven.

A Comparu:

ZILVER-BERK B.V., ayant son siège social à Amsteldijk 194, 1079 LK Amsterdam, The Netherlands (Numéro de la

société: 33250278),

ici représentée par Mademoiselle Manuela d’Amore, employée privée, résidant professionnellement à L-1724 Luxem-

bourg 9b, boulevard du Prince Henri, en vertu d’une procuration sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné, res-

tera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, ès-qualités en vertu desquelles il agit, a requis le notaire instrumentaire d’arrêter ainsi qu’il suit les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’elle déclare constituer: 

Art. 1

er

. Il est formé par le présent, entre le comparant et toutes les personnes qui pourraient devenir associés par

la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la «Société»). 

Art. 2. L’objet de la Société est d’exercer toute opération se rapportant directement ou indirectement à la prise de

participations dans toute entreprise sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion, l’administration, le contrôle et
le développement de ces participations.

En particulier, la Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre un portefeuille de

valeurs mobilières et de brevets de n’importe quelle origine, pour participer dans la constitution, le développement et
le contrôle de n’importe quelle entreprise, pour acquérir, par voie d’investissement, de souscription ou d’option des
valeurs mobilières et des brevets, pour en disposer par voie de vente, transferts, échanges ou autrement, pour déve-
lopper ses valeurs mobilières et brevets, pour accorder à des sociétés qui sont contrôlées par le même actionnaire ul-
time que la Société tout type d’assistances, prêts, avances et garanties.

La Société peut emprunter des fonds à ses actionnaires, sociétés filiales ou tiers. Elle peut émettre des emprunts obli-

gataires, y compris des emprunts convertibles, par voie d’émission d’obligations nominatives, sous quelque dénomina-
tion que ce soit et payable dans n’importe quelle devise que ce soit. Les obligations peuvent seulement être émises au
moyen de placement privé.

La Société peut s’engager dans n’importe quelle transaction impliquant des biens meubles et immeubles. La Société

peut acquérir, transférer et gérer tout bien immobilier de n’importe quelle forme. La Société peut acquérir, transférer
et gérer des immeubles sous n’importe quelle forme, peu importe leur lieu de situation. La Société peut enfin s’engager
dans n’importe quelle opération qui a trait, directement ou indirectement, à la gestion ou à la possession de biens im-
mobiliers.

La Société peut exercer toute activité industrielle ou commerciale qui peut directement ou indirectement favoriser

la réalisation de son objet. 

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée. 

Art. 4. La Société prend la dénomination de BLAZE HOLDINGS, S.à r.l.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés. 

65079

La Société peut ouvrir des succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu’à l’étranger.

Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (EUR. 12.500,-) représenté

par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (EUR 125,-) chacune. 

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l’associé unique sinon de l’assem-

blée des associés, conformément à l’article 14 des présents statuts. 

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l’actif

social ainsi que des bénéfices. 

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour cha-

cune d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une
seule et même personne.

Art. 10. Toutes cessions de parts sociales détenues par l’associé unique sont libres.
En cas de pluralité d’associés, les parts sociales peuvent être cédées, à condition d’observer les exigences de l’article

189 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. 

Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique, sinon d’un des associés, ne mettent

pas fin à la Société. 

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un Con-

seil de gérance. Le ou les gérant(s) n’ont pas besoin d’être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et rem-
placés par l’assemblée des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital
social. 

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes cir-

constances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du res-
pect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du Conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par

la seule signature d’un membre quelconque du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut élire parmi ses membres
un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre des
compétences du Conseil de gérance.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance pourra déléguer

ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

L’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance déterminera la

responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n’importe
quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du Conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants

présents ou représentés. 

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société. 

Art. 14. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
En cas de pluralité d’associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adop-
tées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. 

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l’accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915, telle que modifiée. 

Art. 15. L’année sociale de la Société commence le 1

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil de gé-

rance dresse un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. 

Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan. 

Art. 17. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé 5 % pour la constitution d’un fonds
de réserve jusqu’à ce que celui-ci atteigne 10 % du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de
l’assemblée générale. 

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales

de la loi du 10 août 1915.

65080

<i>Souscription et libération

Les parts sociales ont été souscrites par: 

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de Euros 12.500,- se

trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentaire.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à approximativement mille cinq cents Euros (1.500,-
EUR).

<i>Assemblée générale constitutive

Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé, préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, a

pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de deux. Sont nommés membres du conseil de gérance pour

une durée indéterminée:

M. Alain Heinz, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du

Prince Henri,

M. Joseph Mayor, Administrateur de Sociétés, avec adresse professionnelle L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard du

Prince Henri,

 qui auront le pouvoir d’engager valablement la société par leur seule signature.
2. Le siège social de la société est établi à L-1724 Luxembourg 9b, boulevard du Prince Henri.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et, en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Signé: M. d’Amore, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 5 juillet 2002, vol. 135S, fol. 86, case 3. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à la société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(55695/202/255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juillet 2002.

MAP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 55.699. 

Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 6, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(55588/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

MAP INVEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 45, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 55.699. 

Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 juillet 2002, vol. 571, fol. 6, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(55590/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ZILVER-BERK B.V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100 parts sociales

Senningerberg, le 18 juillet 2002

P. Bettingen.

<i>Le Bureau
Signature

Le Bureau
Signature

65081

MOBILTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1617 Luxembourg, 70A, rue de Gasperich.

STATUTS

L’an deux mille deux, le quatre juillet.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

A comparu:

Monsieur Ralph Bourens, employé privé, demeurant à L-1617 Luxembourg, 70A, rue de Gasperich.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d’une société à responsabilité limitée

qu’il déclare constituer par les présentes.

Art. 1

er

. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et

par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l’achat et la vente de tout matériel informatique, de télécommunications et d’audio-

visuel ainsi que les accessoires correspondants.

Elle peut faire toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant

directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société prend la dénomination de MOBILTEC, S.à r.l., société à responsabilité limitée.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.

Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts so-

ciales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l’associé unique, Monsieur Ralph Bourens, employé privé, demeurant

à L-1617 Luxembourg, 70A, rue de Gasperich,

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille

cinq cents euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que l’associé reconnaît.

Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en

conformité avec les dispositions légales afférentes.

Art. 8. La société n’est pas dissoute par le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un associé.

Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d’un associé ne pourront, pour quelque motif que ce

soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révo-

cables par l’assemblée des associés.

L’acte de nomination fixera l’étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l’assemblée n’en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l’accomplissement de son objet social.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartien-

nent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu’il possède. Chaque associé peut se faire
valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Aussi longtemps que la société ne compte qu’un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée gé-

nérale. Il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l’associé unique, agissant en lieu et place de l’assemblée générale, sont inscrites sur un procès-verbal

ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établis par écrit. Ceci ne vise pas les opérations courantes conclues dans les conditions normales.

Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’assemblée des associés.

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

65082

Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se référent et se soumettent aux dis-

positions légales.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille deux.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de huit cent soixante-dix euros (EUR
870,-).

<i>Décision de l’associé unique

Le comparant, représentant la totalité du capital social, a ensuite pris les décisions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Ralph Bourens, prénommé.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant.
3.- L’adresse de la société est fixée à L-1617 Luxembourg, 70A, rue de Gasperich,

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: R. Bourens, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 9 juillet 2002, vol. 13CS, fol. 40, case 10. – Reçu 125 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(55617/227/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ZIPA FOOD TRADING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 32, rue du Curé.

R. C. Luxembourg B 68.383. 

<i>Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du 2 juillet 2002

Le Conseil a décidé à l’unanimité le transfert du siège social de la société du 3, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg

au maintenant 32, rue du Curé, L-1368 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 juillet 2002. 

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55564/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

ELI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1311 Luxembourg, 11, boulevard Marcel Cahen.

R. C. Luxembourg B 61.091. 

<i>Décision prise par la gérante en date du 12 juillet 2002

1) Transfert du siège social de la société:
La gérante a décidé de transférer le siège social de la société avec effet au 15 juillet 2002 d’anciennement 32, rue du

Curé, L-1368 Luxembourg au maintenant 11, boulevard Marcel Cahen, L-1311 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 juillet 2002.

Enregistré à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 4. – Reçu 12 euros.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(55571/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Luxembourg, le 17 juillet 2002.

E. Schlesser.

ZIPA FOOD TRADING S.A.
Signature

ELI, S.à r.l.
J. Mitrofanova

65083

ANNIBAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 35.593. 

Les statuts coordonnés du 11 juin 2002, enregistrés à Luxembourg, le 18 juillet 2002, vol. 571, fol. 18, case 1, ont été

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 juillet 2002.

(55577/795/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 juillet 2002.

SEB INVEST SELECT AMERICA, Fonds Commun de Placement.

AUFLÖSUNG

Infolge des stark rückläufigen Fondsvolumens hat die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Anteilinhaber und im

Einklang mit Artikel 12, Punkt 2, des Verwaltungsreglements beschlossen, den SEB INVEST SELECT AMERICA mit Wir-
kung zum 31. Oktober 2002 aufzulösen.

Gemäß Artikel 21 (3) des abgeänderten Gesetzes vom 30. März 1988 über Anlageorganismen wurde die Ausgabe von

Anteilen unverzüglich eingestellt. Unter Berücksichtigung einer egalitären Behandlung aller Anteilinhaber erfolgt die
Rücknahme von Anteilen, wie bisher ohne Rücknahmegebühr, weiterhin bis zum 31. Oktober 2002. Die um Zusammen-
hang mit der Liquidation zu erwartenden Kosten werden bereits jetzt bei der Anteilwertberechnung berücksichtigt.

Nach dem 31. Oktober 2002 wird die SEB PRIVATE BANK S.A. als Depotbank den Liquidationserlös abzüglich der

Liquidationskosten und Honorare («Netto-Liquidationserlös») auf Anweisung des Liquidators SEB INVEST LUXEM-
BOURG S.A. unter den Anteilinhabern des Fonds nach deren Anspruch verteilen. Der Netto-Liquidationserlös, der
nicht zum Abschluß des Liquidationsverfahrens von Anteilinhabern eingezogen worden ist, wird von der Depotbank für
Rechnung der Anteilinhaber bei der Caisse de Consignations in Luxemburg hinterlegt, wo dieser Betrag verfällt, wenn
er nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert wird.

Luxemburg, im August 2002.

(04253/255/19) 

<i>SEB INVEST LUXEMBOURG S.A..

I.Q. HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 79.210. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 octobre 2002 à 14.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (04296/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ALUMEX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 72.376. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 octobre 2002 à 11.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

I (04299/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ANNIBAL HOLDING S.A.
Signatures
<i>Administrateurs

65084

SEFIPAR S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 28.854. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>9 octobre 2002 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2002.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I (04259/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

WALFRA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 58.998. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>4 octobre 2002 à 9.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Nominations statutaires.
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales.

6. Divers.

I (04297/696/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

T.F.M. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 640.000.

Siège social: L-1136 Luxembourg, 1, place d’Armes.

R. C. Luxembourg B 63.979. 

Messieurs les Actionnaires sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>27 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social de la société avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Examen des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 2001
2. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
3. Examen de l’opportunité de continuer l’activité de la société malgré la perte de plus de la moitié de son capital

social, conformément à l’article 100 de la loi du 10 août 1915

4. Nominations et révocations statutaires
5. Renouvellement des mandats d’administrateur
6. Décision sur l’opportunité d’engager la responsabilité de l’administrateur délégué, notamment sur le fondement

de l’article 59 alinéa premier de la loi du 10 août 1915

7. Décision sur l’opportunité d’engager la responsabilité de l’actionnaire majoritaire au motif de la rupture des projets

communs de développement du successeur de Lantis, au risque de ruiner la société

8. Décision sur l’opportunité d’engager la responsabilité d’un administrateur au motif d’infractions commises à la loi

du 10 août 1915 et aux statuts de notre société, pour avoir déprécié sans l’avis des administrateurs et des associés
les travaux de recherche et développement des exercices 2000 et 2001 sans fondement

Les propriétaires d’actions au porteur sont invités à justifier leur qualité par le dépôt de leurs titres au siège social

ou à la banque. En cas de dépôt à une banque, ils sont invités à présenter un certificat de blocage pour la date de l’as-
semblée.
II (04204/279/27) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

65085

BUILDING HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 62.727. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu le <i>24 octobre 2002 à 17.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.

L’Assemblée Générale du 2 septembre 2002 n’a pas pu délibérer valablement sur le point 5 de l’ordre du jour, le

quorum prévu par la loi n’ayant pas été atteint.
I (04298/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUDOVICA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 37.306. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le jeudi<i> 10 octobre 2002 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (04305/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PORTUNUS INVESTMENT HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 11, avenue Emile Reuter.

R. C. Luxembourg B 62.264. 

Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>8 octobre 2002 à 14.00 heures au siège social de la société, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

a. rapport du Conseil d’Administration sur l’exercice 2002;
b. rapport du Commissaire de Surveillance
c. lecture et approbation du Bilan et du Compte de Profits et Pertes arrêtés au 30 juin 2002;
d. affectation du résultat;
e. décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire;
f. divers.

I (04308/045/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

COREVEST - COMPAGNIE DE RECHERCHES ET D’INVESTISSEMENTS, Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 17.190. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 septembre 2002 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2000 et au 31 décembre 2001

65086

3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04153/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

NAJA INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 20.475. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>26 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2002
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Délibération conformément à l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales
6. Divers

II (04166/506/16) 

<i>Le Conseil d’administration.

UNIO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.

R. C. Luxembourg B 81.268. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

qui se tiendra au siège social de la société à Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo, le jeudi <i>26 septembre 2002 à 10.30 heures,
pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux Comptes sur l’exercice clôturé  au  31  décembre

2001;

2. Examen et approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001;
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Affectation des résultats;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

II (04193/546/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EUROPEAN MARKETING HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 67.899. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 septembre 2002 à 10.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commis-

saire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers

II (04152/029/18) 

<i>Le Conseil d’administration.

65087

SOCIETE INTERNATIONALE DE PUBLICITE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 14.052. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi <i>30 septembre 2002 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Rapport du Commissaire à la liquidation, la FIDUCIAIRE GLACIS
2. Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3. Clôture de la liquidation.
4. Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04225/755/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 64.347. 

Etant donné que la première Assemblée Générale Extraordinaire du 26 août 2002 n’a pu être tenue à défaut de quo-

rum suffisant, Mesdames et Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à une 

SECONDE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

de notre société, qui aura lieu le <i>4 octobre 2002 à 14.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

– Modification de la dernière phrase de l’article 22 des statuts qui se lira désormais comme suit: «Le prix ainsi dé-

terminé sera payable au plus tard le premier jour ouvrable du mois du calcul de la VNI applicable.»

Les décisions concernant tous les points de l’ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Elles seront prises à la simple

majorité des actions présentes ou représentées à l’Assemblée.

Afin de participer à l’Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur pour le 25 septembre

2002 au plus tard au siège de KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.
Des procurations sont disponibles au siège de la Sicav.
II (04141/755/18) 

<i>Le Conseil d’Administration.

AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1471 Luxembourg, 308, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 40.361. 

LIQUIDATION PROCEDURE OF AUSTRIAN FINANCIAL AND 

FUTURES TRUST FIRST FUTURES FUND SERIES I

The liquidation procedure is anticipated to be closed by the end of September 2002.
Shareholders are kindly requested to claim their liquidation proceeds in proportion of their shares until the end of

September to 

UNICO FINANCIAL SERVICES S.A.
308, route d’Esch
L-1471 Luxembourg
C/o Judith Funk / Paul Martin
Tel: +(352) 26 40 85 57 / 85 53
Fax: +(352) 26 40 88 10
The shareholders claims shall be documented by documents evidencing their title and shall be verified by the admin-

istrator.

Please note that
Liquidation proceed which will remain unpaid after the closing of the liquidation procedure will be kept under the

custody of the custodian of the Company for a period of six months. At the expiration of this period, unclaimed assets
will be deposited under the custody of the Caisse des Consignations to the benefit of the unidentified shareholders.

July 23, 2002.

III (03858/755/24) 

<i>The Board of Directors.

65088

LAND’S END S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 63.908. 

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 

qui se tiendra le lundi <i>30 septembre 2002 au 23, avenue de la Porte-Neuve à Luxembourg, avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapport du Commissaire aux Comptes,
– Approbation des comptes annuels au 30 juin 2002 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Nominations statutaires.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer

leurs titres cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04116/755/17) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ODYSSET S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 59.476. 

Les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, le <i>27 septembre 2002 à 11.00 heures, pour délibérer
sur l’ordre du jour conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, des rapports de gestion du Conseil d’Administration et des rapports du Com-

missaire aux comptes

2. Approbation des comptes annuels au 30 juin 2000 et au 30 juin 2001
3. Affectation du résultat
4. Décharge à donner aux administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Ratification de la cooptation d’un nouvel administrateur
6. Nominations statutaires
7. Divers

II (04151/029/19) 

<i>Le Conseil d’administration.

SNA &amp; ASSOCIES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 71.496. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra en date du <i>27 septembre 2002 à 11.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2001
3. Décharge au conseil d’administration et au commissaire aux comptes 
4. Nominations statutaires
5. Divers

II (04167/506/15) 

<i>Le conseil d’administration.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Premium Invest Fund

Premium Invest Fund

Credit Suisse Euro Bond Express

Gourmet Trade S.A.

Stora Luxembourg, S.à r.l.

Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l.

Kronprinzbau Stuttgart, S.à r.l.

Grand Garage Jean Muller, S.à r.l.

Garage Muller-Locations

Polichem S.A.

Credit Suisse Commodity Fund (Lux)

Siewit S.A.

Stora Enso, S.à r.l.

Pasie S.A.

Bogazzi International S.A.

Bogazzi International S.A.

Bogazzi International S.A.

Europe Property S.A.

Publicis Graphics Group Holding S.A.

Energy Systems International S.A.

C.B.R. Finance S.A.

Next, S.à r.l.

Alexa International S.A.

Trascania Holding S.A.

Threeland Hôtels S.A.

Hervain Investissements S.A.

Bogazzi S.A.

Bogazzi S.A.

Patmark S.A.

Odyssey Asset Management Systems S.A.

Odyssey Asset Management Systems S.A.

Performance International S.A.

ExxonMobil Luxembourg et Cie S.C.A.

ExxonMobil Luxembourg

Fricky S.A.

Fricky S.A.

Fricky S.A.

Fricky S.A.

FinanzInvest, GmbH

Cerep, S.à r.l.

CGS International Holdings (Luxembourg), S.à r.l.

NCI Luxembourg S.A.

Cerep Finance, S.à r.l.

Allied Arthur Pierre S.A.

Argenta Life Luxembourg

Ratio Holdings S.A.

Vavisto Holding S.A.

Takolux S.A.

TSM, Tuyauterie Soudure Maintenance S.A.

Ladino S.A.

PI-S.A.

PI-S.A.

Natural Global Resources S.A.

Natural Global Resources Holding S.A.

Blaze Holdings, S.à r.l.

Map Invest S.A.

Map Invest S.A.

Mobiltec, S.à r.l.

Zipa Food Trading S.A.

Eli, S.à r.l.

Annibal Holding S.A.

SEB Invest Select America

I.Q. Holding S.A.

Alumex Holding S.A.

Sefipar S.A.

Walfra Investments S.A.

T.F.M. International S.A.

Building Holding S.A.

Ludovica S.A.

Portunus Investment Holding S.A.

Corevest - Compagnie de Recherches et d’Investissements

Naja Investment S.A.

Unio Holding

European Marketing Holding S.A.

Société Internationale de Publicité S.A.

KB Lux Special Opportunities Fund, Sicav

Austrian Financial and Futures Trust

Land’s End S.A.H.

Odysset S.A.

SNA &amp; Associés S.A.