This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
49393
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1030
5 juillet 2002
S O M M A I R E
A.M.P.G. S.A., A.M.P. Grenailles S.A., Luxem-
CommTrust Investment Management S.A., Lu-
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49400
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49426
A.R.D. Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
49429
Dreyfus Group S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49416
A.R.D. Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
49429
E.V.L. Distribution, S.à r.l., Alzingen . . . . . . . . . . .
49401
A.R.D. Development S.A., Luxembourg . . . . . . . . .
49429
Edisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49436
A.T.T.C. Services, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . .
49416
Edisa S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49436
Acord International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
49426
EF Cultural Tours, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
49424
Andell Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
EF Cultural Tours, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
49424
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49439
EL 3000 S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49428
Andell Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
Energo Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49394
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49439
Erasmus Finance & Investments S.A., Luxem-
Andell Investments (Luxembourg), S.à r.l., Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49433
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49439
Erasmus Finance & Investments S.A., Luxem-
APN Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
49438
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49433
APN Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
49438
Erasmus Finance & Investments S.A., Luxem-
Arlvest S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49421
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49433
(La) Balme S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49431
Euro Flor Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49434
Barbieri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49427
Euro Flor Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49434
Barbieri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49427
Euro Flor Invest S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49434
Barbieri S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49427
European Systems Development S.A., Luxem-
Bedminster (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . .
49395
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49434
Benelux Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49423
European Systems Development S.A., Luxem-
Benelux Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49423
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49434
Benelux Partners S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49423
European Systems Development S.A., Luxem-
Berman Corporation Holding S.A., Luxembourg . .
49435
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49434
Biloxi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49432
Expense Reduction Analysts (Europe) S.A., Lu-
Blaque S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49438
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49415
Blaque S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49438
Expense Reduction Analysts (European Holdings)
Bona S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49402
S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49423
Borderline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49433
F & S Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
49432
Borderline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49433
Feluca S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49430
Borderline S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49433
Fiduciary Asset Backed Securities S.A., Luxem-
Brainz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49440
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49436
Brainz S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49440
Fingreen S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49429
Briboislux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
49403
FMC Finance S.à r.l. Luxembourg -IV, Luxem-
Bristol (Luxembourg), S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
49410
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49404
Cafinalux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49394
FMC Finance S.à r.l. Luxembourg -IV, Luxem-
Cantobre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49437
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49406
Cantobre S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49437
Graphique Systèmes S.A., Luxembourg . . . . . . . .
49419
CDRJ Participations (Lux), S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
49436
GVV S.A., Wormeldange. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49417
49394
CAFINALUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 45.948.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 33, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 avril 2002.
(31316/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
ENERGO FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 42, rue de Clausen.
R. C. Luxembourg B 63.364.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 33, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31317/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
LRI-FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, Parc d’Activités Syrdall.
R. C. Luxembourg B 28.101.
—
Le bilan au 30 septembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 34, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(31455/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
GVV S.A., Wormeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49417
S.I. Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
49419
Iefam Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
49427
S.I. Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
49419
Itech Professionals S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
49437
S.I. Investissements S.A., Luxembourg . . . . . . . . . .
49419
Julius Baer Multibond, Sicav, Luxemburg . . . . . . . .
49421
Salp Europe S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
49428
Julius Baer Multicash, Sicav, Luxemburg . . . . . . . .
49420
Santo Spirito, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49435
Julius Baer Multistock, Sicav, Luxemburg . . . . . . .
49422
Santo Spirito, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49435
Kimberley S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49432
Santo Spirito, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49435
Le Foyer, Ottaviani & Associés Patrimonium
Suisimmo S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49416
Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49430
Technology Capital Group S.A.H., Luxembourg . .
49403
Leroy - Merlin & Cie Valaction, S.C.A., Luxem-
Technology Capital Group S.A.H., Luxembourg . .
49404
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49418
The U.S. High Yield Fund Sicav, Luxembourg . . . .
49418
LFG-London Financial Group S.A., Luxembourg .
49407
The U.S. High Yield Fund Sicav, Luxembourg . . . .
49418
LRI-Fund Management Company S.A., Munsbach
49394
Transcontinental Investment Corporation S.A.,
Luxsat International S.A., Steinsel . . . . . . . . . . . . .
49424
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49426
M.M.Warburg-Luxinvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49425
Trosten S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49431
Nestor Investment Management S.A., Luxem-
Trosten S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49431
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49425
Trosten S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49431
Oberland S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49430
Trosten S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49432
Omnitech S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49420
Vantalux, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .
49407
Parbat Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
49416
Vontobel Luxembourg S.A., Munsbach. . . . . . . . . .
49428
Quadrante S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
49429
Windows International S.A., Luxembourg . . . . . . .
49418
Remapa Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
49435
Wine Acquisitions S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
49425
Robertson Finance & Co Holding S.A., Luxem-
Yamamoto Holdings S.A., Luxemburg . . . . . . . . . .
49409
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49440
CAFINALUX S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
ENERGO FINANCE S.A.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
LRI-FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
Signature
49395
BEDMINSTER (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the seventeenth of April.
Before us Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand
Duchy of Luxembourg,
There appeared:
BEDMINSTER (No. 1 COMPANY) LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having
its registered office at the Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England,
duly represented by Maître Lydie Beuriot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal
given on the 26th day of March, 2002.
Such proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of
incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:
Title I - Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,
a corporation with limited liability (société à responsabilité limitée), under the name of BEDMINSTER (LUXEMBOURG),
S.à r.l.
Art. 2. The corporation is established for an undetermined period.
Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
Art. 4. The purpose of the corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of partic-
ipations in whichever form in domestic and foreign companies and branches. The company may also contract loans and
grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation.
Furthermore, the corporation may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, ex-
change, sale or otherwise.
The corporation may hold interests in partnerships.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses as well as rights deriving there from or supplementing
them.
In addition, the corporation may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or
abroad.
In general, the corporation may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.
Title II - Capital - Units
Art. 5. The subscribed capital is set at fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) represented by five
hundred (500) corporate units with a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each.
The units have been fully subscribed by BEDMINSTER (No. 1 COMPANY) LIMITED, having its registered office at
the Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England.
All the units have been fully paid in by the subscriber so that the amount of fifteen thousand United States Dollars
(USD 15,000.-) is at the free disposal of the corporation, as was certified to the notary executing this deed.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the corporation shall represent the entire body of members
of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of
the corporation.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the corporation by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the corpo-
ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the corporation.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship
with the number of units in existence.
Art. 8. If the corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
49396
The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the corporation represented by him are recorded on
minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into
under normal conditions.
Art. 9. If the corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the mem-
bers.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members rep-
resenting at least three quarters (3/4) of the corporation’s capital.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
Art. 10. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members
will not bring the corporation to an end.
Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or docu-
ments of the corporation.
Title III - Administration
Art. 12. The corporation shall be managed by a board of managers composed of two managers at least who need
not to be members of the corporation.
The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-
pensation and duration of their mandates. Their mandate may not exceed a period of six years and they shall hold office
until their successors are appointed.
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of man-
agers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting.
Reasonable written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers, except in circum-
stances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers’ meetings.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position on behalf of the Company in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and
the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be man-
agers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and
fix their emoluments.
Art. 16. The corporation will be bound by the joint signature of two managers or the single or joint signature of
any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of
the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The accounting year of the corporation shall begin on September first of each year and shall terminate on
August thirty-first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on August thirty-first, of the year two thousand and two.
49397
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each fiscal year and will be at
the disposal of the members at the registered office of the corporation.
Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation.
The general meeting of members, upon recommendation of the board of managers will determine how the annual
net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
1. Interim accounts are drafted on a quarter or semi-annual basis,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the board of managers if there is enough cash. Otherwise, the
decision has to be taken by an extraordinary general meeting of the members.
Title IV - Winding up - Liquidation
Art. 20. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i> Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, on commercial companies and expressly states that they have
been fulfilled.
<i> Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
For the purpose of registration, the share capital is valued at sixteen thousand six hundred twenty-two Euro thirty-
four cents (EUR 16,622.34).
<i>Resolutions of the sole memberi>
The prenamed sole member, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolu-
tions:
1) The registered office of the corporation is at L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
2) The number of managers is fixed at two.
3) The following persons are appointed managers:
- Mr Michael McDonald, director, residing at L-4973 Dippach, 162, route de Luxembourg,
- Mr Pierre Metzler, lawyer, residing at L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
4) The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members to be held for the purpose
of approving the annual accounts as of 31 August 2002.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundzwei, den siebzehnten April.
Vor Uns Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Grossherzogtum
Luxemburg:
Ist erschienen:
BEDMINSTER (No. 1 COMPANY) LIMITED, eine Gesellschaft gegründet unter den Gesetzen von England und
Wales, mit Sitz in the Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England,
hier vertreten durch Maître Lydie Beuriot, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Voll-
macht gegeben am 26. März 2002.
Die oben genannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den instru-
mentierenden Notar, an vorliegender Urkunde anliegend, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, hat den unterzeichneten Notar untersucht, die Satzungen einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, welche den entsprechenden Gesetzen und den vorliegenden Satzungen unterworfen
wird, wie folgt zu dokumentieren:
Titel I - Bezeichnung - Dauer - Sitz - Zweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem Zeichner und all denen Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden
könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), unter der Bezeichnung BEDMIN-
STER (LUXEMBOURG), S.à r.l. gegründet.
49398
Art. 2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt.
Er kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort im Grossherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Filialen oder andere Niederlassungen können, entweder in Luxemburg oder im Ausland,
durch Beschluss des Verwaltungsrats eröffnet werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an in- und ausländischen Gesellschaften und Filialen. Die Gesellschaft kann ebenfalls An-
leihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung,
Darlehen, Vorschüssen oder Sicherheiten gewähren.
Desweiteren, kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch, Verkauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Personengesellschaften haben.
Sie kann ausserdem Patente und Lizenzen sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, ver-
werten und veräussern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Luxemburg oder im Ausland gelegene Immobilien erwerben, verwalten, ver-
werten und veräussern.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännischen, gewerblichen und finanziellen Geschäfte ob im Bereich von
Wertpapieren oder Immobilien tätigen, welche den obengenannten Zweck fördern oder ergänzen.
Titel Il - Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf fünfzehntausend US Dollar (USD 15.000,-) festgelegt, eingeteilt
in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je dreissig US Dollar (USD 30,-).
Die Anteile wurden vollständig von BEDMINSTER (No 1. COMPANY) LIMITED, mit Sitz in the Pavilions, Bridgwater
Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England gezeichnet.
Sämtliche Gesellschaftsanteile wurden integral durch den Zeichner eingezahlt, so dass der Betrag von fünfzehntau-
send US Dollar (USD 15.000,-) der Gesellschaft fortan zur freien Verfügung steht, worüber dem beurkundenden Notar
der entsprechende Nachweis erbracht wurde.
Art. 6. Jede ordnungsmässig einberufene Hauptversammlung der Gesellschafter wird die Gesamtheit der Mitglieder
der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Akten bezüglich des Geschäfts der Ge-
sellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vereinbart, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäss einberufenen Haupt-
versammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschaftern angenom-
men.
Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Satzungsbestimmungen können jederzeit durch den alleinigen Gesellschaf-
ter oder durch die Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten,
abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einen einstimmigen Beschluss
ändern.
Falls alle Gesellschafter an der Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und falls sie er-
klären, dass sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung
oder Bekanntmachung abgehalten werden.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen und ausserordentlichen General-
versammlungen.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von mehr als
einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Anteils aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt ein anteilmässiges, im direkten Verhältnis zur Gesamtzahl der bestehenden Anteile,
Recht am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle der Haupt-
versammlung zuerkannten Befugnisse.
Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden in ein Pro-
tokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
Ebenfalls werden die Verträge welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesell-
schaft eingegangen werden, in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt. Nichtsdestoweniger ist diese
letzte Vorschrift für laufende Geschäfte die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden nicht anwendbar.
Art. 9. Falls die Gesellschaft wenigstens zwei Gesellschafter zählt, sind die Gesellschaftsanteile zwischen den Gesell-
schaftern frei übertragbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung der
Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Bei Todesfall von einem Gesellschafter, ist der Übertrag von Anteilen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der
Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel (3/4) der den Überlebenden gehörende Rechte vertreten, unterlegen.
In diesem Fall, jedoch, bedarf es keiner Zustimmung, falls die Gesellschaftsanteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder
an den überlebenden Ehepartner übertragen werden.
Art. 10. Das Ableben, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen
Gesellschafters oder eines der Gesellschafter werden in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft hervorrufen.
49399
Art. 11. Aus keinem Grund und in keinem Fall sind die Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters
befugt, die Güter und Dokumente der Gesellschaft versiegeln zu lassen.
Titel III - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens zwei Geschäftsführern verwaltet, die
nicht Gesellschafter sein müssen.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter, die über ihre Befugnisse, Bezüge und
Amtszeit entscheidet, ernannt und abberufen. Ihr Mandat darf den Zeitraum von sechs Jahren nicht überschreiten, und
sie werden, solange ihre Nachfolger nicht bestimmt wurden, im Amt bleiben.
Art. 13. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wäh-
len, der nicht Geschäftsführer sein muss, und der dafür verantwortlich sein wird, die Protokolle der Verwaltungsrats-
sitzungen und der Hauptversammlungen der Gesellschafter zu führen.
Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden, oder zwei Geschäftsführern, an dem in der Ein-
berufung festgesetzten Ort zusammenkommen.
Vernünftiger schriftlicher Bescheid von jeder Sitzung des Verwaltungsrats wird jedem Geschäftsführer für die Sitzung
gegeben werden, ausser im Falle von Dringlichkeit, in welchem Fall die Natur von solchen Umständen in der Einberufung
erläutert werden müssen. Eine spezielle Einberufung wird nicht notwendig sein für eine Verwaltungsratssitzung, welche
zu einer Stunde und an einem Ort, die in einem vorausgehenden Arbeitsplan des Verwaltungsrats festgehalten worden
waren, stattfinden soll.
Jeder Geschäftsführer kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche, oder per Kabel, Telegramm, Te-
lex oder Telefax gegebene Vollmacht an einen anderen Geschäftsführer handlungsfähig werden.
Stimmen können ebenfalls schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax abgegeben werden.
Der Verwaltungsrat kann nur ordnungsgemäss beraten und handeln, wenn wenigstens die Mehrzahl der Geschäfts-
führer an der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit
Stimmenmehrheit der an einer solchen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Schriftliche Entscheidungen welche von allen Geschäftsführern gutgeheissen und unterschrieben wurden, werden die
gleiche Wirkung als die Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen wurden, haben.
Art. 14. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, im Falle seiner Abwesenheit,
vom pro tempore Vorsitzenden, welcher den Vorsitz einer solchen Verwaltungsratssitzung übernahm, unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle welche vor Gericht oder anderswo vorgezeigt werden könnten, wer-
den von dem Vorsitzenden, dem Sekretär oder von zwei Geschäftsführern unterschrieben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen
im Namen der Gesellschaft und in dessen Interessen, vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten
sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tagtägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Ge-
sellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Gesellschafter, an einen oder mehrere Geschäftsführer des
Verwaltungsrats oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht Geschäftsführer sein müssen), welche unter den Bedin-
gungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten, übertragen. Er kann ausserdem jegliche
Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht Geschäftsführer sein muss, übertragen, Beamte und
Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, oder durch die Ein-
zelunterschrift oder die gemeinsame Unterschrift der Person oder Personen welcher(n) solche Vertretungsmacht von
dem Verwaltungsrat Übertragen werden wird, verpflichtet.
Art. 17. Die Geschäftsführer gehen in der Ausübung ihres Mandats keinerlei persönlichen Verpflichtungen hinsicht-
lich der von der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten ein. Als Bevollmächtigte der Gesellschaft haften sie ledig-
lich für die korrekte Ausführung ihrer Aufgaben.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am ersten September eines jeden Jahres beginnen und am einund-
dreissigsten August enden, mit der Ausnahme vom ersten Geschäftsjahr, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft
beginnen und am einunddreissigsten August zweitausendsundzwei enden wird.
Art. 19. Der Jahresabschluss wird von den Geschäfts- führern am Ende eines jeden Geschäftsjahres aufgestellt und
den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden.
Von dem Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwen-
det werden. Dieser Abzug wird nicht mehr zwingend sein sobald die Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftska-
pitals erreicht hat.
Auf Empfehlung des Verwaltungsrats, wird die Hauptversammlung der Gesellschafter darüber entscheiden, wie über
den Nettogewinn verfügt werden wird.
Vorschüsse auf Dividenden können unter folgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Trimestrielle oder semestrielle Aufstellungen der Aktiven und Passiven werden erstellt,
2. Diese Aufstellungen zeigen einen Gewinn inbezüglich den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr,
3. Der Beschluss, Vorschüsse auf Dividenden auszuschütten, wird vom Verwaltungsrat getroffen, wenn ausreichende
Bargeldmittel zur Verfügung stehen. Andernfalls, muss der Beschluss von einer ausserordentlichen Hauptversammlung
der Gesellschafter getroffen werden.
49400
Titel IV - Abwicklung - Auflösung
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidator(en) (wel-
che natürliche Personen oder Körperschaften sein können), die durch die Hauptversammlung ernannt werden, welche
über diese Abwicklung der Gesellschaft entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird, erfolgen.
Art. 21. Alle Punkte, die nicht in den vorliegenden Satzungen vorgesehenen sind, werden gemäss den Bestimmungen
des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen
festgelegt.
<i> Bescheinigungi>
Der amtierende Notar erklärt hiermit die in Artikel 183 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünf-
zehn über die Handelsgesell- schaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass
sie erfüllt worden sind.
<i> Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus
Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) abgeschätzt.
Zwecks Einregistrierung ist das gezeichnete Kapital auf sechzehntausendsechshundertzweiundzwanzig Euro vierund-
dreissig Cents (EUR 16.622,34) abgeschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Alsdann hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüs-
se gefasst:
1. Der Gesellschaftssitz ist in L-2210 Luxemburg, 54, Boulevard Napoléon I
er
, festgelegt.
2. Die Zahl der Geschäftsführer ist auf zwei festgesetzt.
3. Die folgenden Personen werden als Geschäftsführer ernannt:
- Herr Michael McDonald, Direktor, wohnaft in L-4973 Dippach, 162, route de Dippach,
- Herr Pierre Metzler, Jurist, wohnhaft in L-2763 Luxemburg, 6, rue Ste Zithe,
4. Die Frist der Amtszeit der Geschäftsführer wird mit der Hauptversammlung der Gesellschafter, welche den Jah-
resabschluss der Gesellschaft zum 31. August 2002 genehmigt, ablaufen.
Der amtierende Notar welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der Kom-
parentin, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst und der Urkunde eine deutsche Fassung beigefügt ist. Auf
Antrag derselben Komparentin und im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
wird die englische Fassung vorgehen.
Worüber urkunde, Geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung der Urkunde an die erschienene Person, hat diese mit dem Notar die vorliegende Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: L. Beuriot, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 135S, fol. 1, case 10. – Reçu 170,45 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier dem Memorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(31033/222/350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
A.M.P.G. S.A., A.M.P. GRENAILLES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1050 Luxembourg, 50, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 35.568.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire alors de résidence à Mersch, maintenant à Hesperange, en date du 5
décembre 1990, acte publié au Mémorial C n
°
184 du 17 avril 1991, modifiée par-devant le même notaire en date
du 18 janvier 1991, acte publié au Mémorial C n
°
269 du 13 juillet 1991, en date du 3 août 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
673 du 7 septembre 1999, et en date du 6 octobre 1999, acte publié au Mémorial C n
°
985 du 22
décembre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31062/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Luxemburg-Bonneweg, den 22. April 2002.
T. Metzler.
<i>Pour A.M.P. GRENAILLES S.A., en abrégé
i>A.M.P.G. S.A.
KPMG Financial Engineering
Signature
49401
E.V.L. DISTRIBUTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5836 Alzingen, 6, rue Nicolas Wester.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le seize avril.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1. Monsieur Eric Lemonnier, agent commercial, demeurant 28 rue des Elliets, F-59610 Fourmies (France);
2. Madame Véronique Fund, secrétaire, demeurant 28 rue des Elliets, F-59610 Fourmies (France), ici représenté par
Monsieur Eric Lemonnier prénommé, en vertu d’une procuration donnée le 12 avril 2002.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, an-
nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Lesquels comparants, ès-qualités qu’ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une société à
responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. Dénomination - Siège - Durée - Objet
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives ainsi que par
les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de E.V.L. DISTRIBUTION, S.à r.l.
Art. 3. Le siège social est établi à Alzingen.
Il peut être transféré en tout autre localité du Grand-Duché en vertu d’une décision de l’assemblée générale des
associés.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 5. La société a pour objet le commerce d’import-export et négoce de tous biens et marchandises, le commerce
de produits et services en tout genre destinés en particulier à l’agriculture en général.
Elle peut en outre faire toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières, pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’objet social ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) représenté par cent
(100) parts sociales d’une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR) chacune.
Chaque part donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Ces parts ont été souscrites comme suit:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en numéraire à un compte bancaire, de
sorte que la somme de douze mille cinq cents Euros (12.500,- EUR) se trouve dès maintenant à la disposition de la so-
ciété, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant.
Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social
ainsi que des bénéfices.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune
d’elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule
et même personne.
Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre
vifs à des non-associés que moyennant l’agrément unanime de tous les associés. Les parts sociales ne peuvent être trans-
mises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément unanime.
Dans ce dernier cas cependant, le consentement n’est pas requis lorsque toutes les parts sont transmises soit à des
ascendants ou descendants, soit au conjoint survivant.
Art. 11. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 12. Les créanciers, ayants-droits ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés
sur les biens et documents de la société.
Titre III. Administration
Art. 13. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non qui, vis-à-vis des tiers, ont les pouvoirs les
plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations
relatifs à son objet.
Art. 14. Le décès d’un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n’entraîne pas la dissolution de la
société.
1. Monsieur Eric Lemonnier prénommé: quarante neuf parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49
2. Madame Véronique Fund prénommée: cinquante et une parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
49402
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 16. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appar-
tiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.
Art. 17. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles ont été adoptées par des as-
sociés représentant plus de la moitié du capital social.
Titre IV. Exercice social - Répartition des bénéfices
Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Exceptionnellement, le premier exercice commence aujourd’hui et finit le 31 décembre 2002.
Art. 19. Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-
prenant l’indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre communication au siège so-
cial de l’inventaire et du bilan.
Art. 20. Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortisse-
ments et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d’un
fonds de réserve jusqu’à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition de l’assemblée
générale.
Titre V. Dissolution - Liquidation
Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Titre VI. Disposition générale
Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas réglé par les présents statuts, les associés s’en réfèrent aux dispositions légales
en vigueur.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ mille Euros (1.000,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt les associés, représentant l’intégralité du capital et se considérant comme dûment convoqués, se sont
réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la société est établi à L-5836 Alzingen, 6 rue Nicolas Wester.
2. L’assemblée générale désigne comme gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Eric Lemonnier prénommé.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour engager la société en toutes circonstances par sa seule signature in-
dividuelle.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: E. Lemonnier - G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 135S, fol. 1, case 5. – Reçu 125 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Kirsch.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31038/220/101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BONA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 59.696.
Constituée par-devant M
e
Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 11 juin 1997, acte
publié au Mémorial C n
°
524 du 25 septembre 1997. Le capital a été converti en Euros en date du 20 décembre
2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31065/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Hesperange, le 24 avril 2002.
G. Lecuit.
<i>Pour BONA S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
49403
BRIBOISLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 7, Grand-rue.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 16 avril 2002.
(31011/231/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
TECHNOLOGY CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.059.
—
L’an deux mille deux, le vingt et un mars.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Monsieur Pierre Lentz, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Strassen,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme TECHNOLOGY CA-
PITAL GROUP S.A. avec siège social à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir qui lui a été délivré par ledit conseil d’administration dans sa réunion du 19 mars 2002, dont
un extrait du procès-verbal restera annexé aux présentes après avoir été signé ne varietur par le comparant et le notaire
instrumentant.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1. La société anonyme TECHNOLOGY CAPITAL GROUP S.A. a été constituée suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, en date du 2 mars 2000, publié au Mémorial, Recueil C numéro 510 du 18 juillet 2000.
2. L’article cinq des statuts prévoit un capital autorisé dans les termes suivants:
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de USD 10.000.000,- (dix millions d’US dollars)
qui sera représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de USD 100,- (cent US dollars) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 2 mars 2005, à aug-
menter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.»
3) En vertu de la prédite autorisation, le conseil d’administration a décidé en sa réunion du 19 mars 2002 de réaliser
une tranche du capital autorisé à concurrence de quatre millions six cent mille US dollars (4.600.000,- USD) pour porter
le capital social de son montant actuel de neuf cent mille US dollars (900.000,- USD) à cinq millions cinq cent mille US
dollars (5.500.000,- USD) par l’émission de quarante-six mille (46.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent
US dollars (100,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et avantages que les actions existantes, et a accepté la sous-
cription des quarante-six mille (46.000) actions nouvellement émises par l’actionnaire majoritaire, les autres actionnaires
ayant renoncé à leur droit de souscription et a accepté la libération des actions nouvelles moyennant incorporation de
bénéfices jusqu’à due concurrence, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément, par
un bilan daté au 31 décembre 2001 et certifié exact par les administrateurs de la société,
lequel bilan restera annexé aux présentes pour être formalisé avec elles.
A la suite de l’augmentation de capital ainsi réalisée, le premier alinéa de l’article 5 des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 5.- 1
er
alinéa. Le capital souscrit est fixé à USD 5.500.000,- (cinq millions cinq cent mille US dollars) repré-
senté par 55.000 (cinquante-cinq mille) actions d’une valeur nominale de USD 100,- (cent US dollars) chacune.»
<i>Evaluationi>
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital est évaluée à la somme de 5.223.711,06 EUR.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
à raison des présentes est évalué à environ 3.200,- EUR.
<i>Pour la société
i>J. Seckler
<i>Le Notairei>
49404
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Lentz, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2002, vol. 12CS, fol. 59, case 2. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31039/220/61) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
TECHNOLOGY CAPITAL GROUP S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 75.059.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31040/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
FMC FINANCE S.à r.l. LUXEMBOURG -IV, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 82.631.
—
In the year two thousand and two, on the sixteenth day of April.
Before Us, Maître Léon Thomas, called Tom Metzler, notary, residing in Luxembourg-Bonnevoie.
There appeared:
The company FRESENIUS MEDICAL CARE A.G., duly registered in Hof an der Saale, Germany, under HRB 2460,
business address at D-61352 Bad Homburg, Else-Kröner-Str. 1,
duly represented by Maître Patricia Thill, lawyer, residing in L-2763 Luxembourg, 6, rue Zithe by virtue of a proxy
given under private seal on April 2, 2002.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The presaid FRESENIUS MEDICAL CARE A.G., is the sole member of FMC FINANCE, S.à.r.l. LUXEMBOURG - IV,
which has its registered office at L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur, incorporated by a deed of Maître
Jean Seckler, notary public, residing in Junglinster, on June 11, 2001, published in the Mémorial, official gazette of Lux-
embourg, Recueil des Sociétés et Associations C, no 1217 dated December 22, 2001.
The agenda is the following:
<i> Agenda:i>
1) Change of the currency of the company’s corporate capital from USD into EUR at the exchange rate of February
25, 2002 of 1.- USD=1.14207 EUR;
2) Conversion of the corporate capital into EUR;
3) Increase of the converted corporate capital by an amount of EUR 396.50 (three hundred ninety-six Euro fifty Eu-
rocents) to bring the corporate capital from its present amount of EUR 57,103.50 (fifty-seven thousand one hundred
three Euro fifty Eurocents) to the amount of EUR 57,500.- (fifty-seven thousand five hundred Euros) without creation
of new corporate units;
4) Determination of the par value of the corporate units to an amount of EUR 115.- (one hundred fifteen Euro);
5) Subsequent amendment of article 6, first and second paragraph, of the Articles of Association so as to reflect the
foregoing to read as follows:
«The corporate capital is set at EUR 57,500.- (fifty-seven thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hun-
dred) corporate units of EUR 115.- (one hundred fifteen Euro) each, which have been subscribed by FRESENIUS MED-
ICAL CARE A.G. a public limited company registered in Hof an der Saale, Germany, having its business address in D-
61352 Bad Homburg v.d.H., Germany, Else-Körner-Str. 1.
The subscriber states and acknowledges that each corporate unit has been fully paid up so that the amount of EUR
57,500.- (fifty-seven thousand five hundred Euro) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having
been given to the undersigned notary.»;
6) Miscellaneous.
The appearing party, represented as here above stated, in its capacity as sole member of FMC FINANCE, S.à.r.l.
LUXEMBOURG IV has requested the undersigned notary to state its following resolutions:
<i> First resolutioni>
The sole member resolves to designate the company’s corporate capital in EUR and to change the currency from
USD into EUR at the exchange rate of February 25, 2002 of 1.- USD=1.14207 EUR.
Hesperange, le 15 avril 2002.
G. Lecuit.
Hespérange, le 15 avril 2002.
G. Lecuit.
49405
<i> Second resolutioni>
The company’s corporate capital amounting to USD 50,000.- (fifty thousand United States Dollars) shall be converted
into EUR 57,103.50 (fifty-seven thousand one hundred three Euro fifty Eurocents) at the exchange rate of February 25,
2002 of 1.- USD=1.14207 EUR.
<i> Third resolutioni>
The converted corporate capital shall be increased by an amount of EUR 396.50 (three hundred ninety-six Euro fifty
Eurocents) to bring it from its present amount of EUR 57,103.50 (fifty-seven thousand one hundred three Euro fifty
Eurocents) to the amount of EUR 57,500.- (fifty-seven thousand five hundred Euro) without creation of new corporate
units.
<i> Fourth resolutioni>
The par value of each corporate unit shall be determined to EUR 115.- (one hundred fifteen Euro).
<i> Fifth resolutioni>
Article 6, first and second paragraph of the articles of association shall be amended so as to reflect the said change
of currency and increase in capital.
Consequently, article 6, first and second paragraph shall now read as follows:
«The corporate capital is set at EUR 57,500.- (fifty-seven thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hun-
dred) corporate units of EUR 115.- (one hundred fifteen Euro) each, which have been subscribed by FRESENIUS MED-
ICAL CARE A.G. a public limited company registered in Hof an der Saale, Germany, having its business address in D-
61352 Bad Homburg v.d.H., Germany, Else-Körner-Str. 1.
The subscriber states and acknowledges that each corporate units has been fully paid up so that the amount of EUR
57,500.- (fifty-seven thousand five hundred Euro) is now at the free disposal of the company, evidence hereof having
been given to the undersigned notary.»
It has been certified to the notary that the amount of EUR 396.50 (three hundred ninety-six Euro fifty Eurocents) is
immediately at the disposal of the company.
<i> Costs, evaluationi>
The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently
stated, are evaluated at approximately EUR 1,000.- (one thousand Euro).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on request of the appearing per-
son, the present deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the
English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des Vorangehenden:
Im Jahre zweitausendundzwei, am sechzehnten April.
Vor Uns Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg.
Ist erschienen:
Die Gesellschaft FRESENIUS MEDICAL CARE A.G., mit Gesellschaftssitz in Hof an der Saale, Germany, eingetragen
unter HRB 2460, Geschäftsadresse in D-61352 Bad Homburg, Else-Körner-Str. 1,
ordnungsgemäss vertreten durch Maître Patricia Thill, Rechtsanwältin, wohnhaft in L-2763 Luxemburg, 6, rue Zithe
Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht, ausgestellt am 2. April 2002.
Die besagte Vollmacht bleibt nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den unterzeichne-
ten Notar an dieser Urkunde anliegend, um mit ihr gleichzeitig registriert zu werden.
Die vorgenannte FRESENIUS MEDICAL CARE A.G., ist die alleinige Gesellschafterin von FMC FINANCE, S.à r.l. LU-
XEMBOURG - IV, mit Gesellschaftssitz in L-1258 Luxemburg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur, gegründet durch Urkunde
von Maître Jean Seckler, Notar, mit Amtswohnsitz in Junglinster, am 11. Juni 2001, veröffentlicht im Mémorial, Amtsblatt
von Luxemburg, Recueil des Sociétés et Associations C, Nr. 1217 vom 22. Dezember 2001.
Die Tagesordnung ist die folgende:
<i> Tagesordnungi>
1) Änderung der Währung des Stammkapitals der Gesellschaft von USD in EUR zum Umtauschkurs vom 25.02.2002
von 1,- USD=1,14207 EUR;
2) Umrechnung des Stammkapitals der Gesellschaft in Euro;
3) Erhöhung des umgerechneten Stammkapitals der Gesellschaft um EUR 396,50 (drei hundert sechs und neunzig
Euro fünfzig Eurocents) von dem derzeitigen Betrag des Stammkapitals von EUR 57.103,50 (sieben und fünfzig tausend
ein hundert drei Euro fünfzig Eurocents) auf den Betrag von EUR 57.500 (sieben und fünfzig tausend fünf hundert Euro)
ohne Bildung neuer Geschäftsanteile;
4) Bestimmung des Nennwertes pro Geschäftsanteil auf EUR 115,- (ein hundert fünfzehn Euro);
5) Demgemässe Änderung von Artikel 6, erster und zweiter Absatz, des Gesellschaftsvertrages zur Wiedergabe des
Vorhergehenden:
«Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 57.500 (sieben und fünfzig tausend fünf hundert Euro) festgesetzt eingeteilt in
500 (fünf hundert) Geschäftsanteile zu jeweils EUR 115,- (ein hundert fünfzehn Euro) welche alle von FRESENIUS ME-
DICAL CARE A.G. einer Aktiengesellschaft eingetragen in Hof an der Saale, Deutschland, mit Geschäftsadresse in D-
61352 Bad Homburg v.d.H., Germany, Else-Körner-Str. 1 gezeichnet worden sind.
49406
Der Zeichnende stellt fest und bestätigt, dass jeder Anteil voll einbezahlt worden ist, so dass der Betrag von EUR
57.500 (sieben und fünfzig tausend fünf hundert Euro) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies
dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.»;
6) Verschiedenes.
Die erschienene Partei, vertreten wie vorgenannt, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafterin von FMC FI-
NANCE, S.à r.l. LUXEMBOURG - IV, ersuchte den unterzeichneten Notar ihre folgenden Beschlüsse aufzunehmen:
<i> Erster Beschlußi>
Die alleinige Gesellschafterin beschliesst, das Stammkapital der Gesellschaft in EUR auszuweisen und die Währung
von USD in EUR zum Umtauschkurs vom 25. Februar 2002 von 1,- USD=1,14207 EUR umzuwandeln.
<i> Zweiter Beschlußi>
Das Stammkapital der Gesellschaft von USD 50.000,- (fünfzig tausend US Dollar) wird zum Umtauschkurs vom 25.
Februar 2002 von 1 USD=1.14207 EUR in EUR 57.103,50 (sieben und fünfzig tausend ein hundert drei Euro fünfzig Eu-
rocents) umgerechnet.
<i> Dritter Beschlußi>
Das umgerechnete Stammkapital wird um einen Betrag von EUR 396,50 (drei hundert sechs und neunzig Euro fünfzig
Eurocents) von seinem derzeitigen Betrag von EUR 57.103,50 (sieben und fünfzig tausend ein hundert drei Euro fünfzig
Eurocents) auf einen Betrag von EUR 57.500 (sieben und fünfzig tausend fünf hundert Euro) erhöht, und zwar ohne Bil-
dung neuer Geschäftsanteile.
<i> Vierter Beschlußi>
Es wird ein Nennwert von EUR 115,- (ein hundert fünfzehn Euro) pro Geschäftsanteil festgelegt.
<i> Fünfter Beschlußi>
Artikel 6, erster und zweiter Absatz, des Gesellschaftsvertrages werden zur Wiedergabe der besagten Umwandlung
des Stammkapitals und Kapitalerhöhung geändert.
Danach lautet Artikel 6, erster und zweiter Absatz, nun wie folgt:
«Das Gesellschaftskapital ist auf EUR 57.500,- (sieben und fünfzig tausend fünf hundert Euro) festgesetzt eingeteilt in
500 (fünf hundert) Geschäftsanteile zu jeweils EUR 115,- (ein hundert fünfzehn Euro) welche alle von FRESENIUS ME-
DICAL CARE A.G. einer Aktiengesellschaft eingetragen in Hof an der Saale, Deutschland, mit Geschäftsadresse in D-
61352 Bad Homburg v.d.H., Germany, Else-Körner-Str. 1 gezeichnet worden sind.
Der Zeichnende stellt fest und bestätigt, dass jeder Anteil voll einbezahlt worden ist, so dass der Betrag von EUR
57.500,- (sieben und fünfzig tausend fünf hundert Euro) ab sofort zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, so wie dies
dem beurkundenden Notar nachgewiesen wurde.»
Gegenüber dem Notar wurde der Nachweis erbracht, dass der Betrag von EUR 396,50 (drei hundert sechs und
neunzig Euro fünfzig Eurocents) zur sofortigen Verfügung der Gesellschaft steht.
<i> Kosten, Bewertungeni>
Die Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben, auf welche Art auch immer entstanden zu Lasten der Gesellschaft
infolge der gegenwärtigen Kapitalerhöhung, werden geschätzt auf EUR 1.000,- (ein tausend Euro).
Der unterzeichnete Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Wunsch der Er-
schienenen, die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung und im
Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und deutschen Text die englische Fassung massgeblich ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, mit dem Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung der Urkunde an die Erschienene, hat diese zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde un-
terzeichnet.
Gezeichnet: Thill, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 134S, fol. 98, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
(31059/222/154) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
FMC FINANCE S.à r.l. LUXEMBOURG -IV, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur.
R. C. Luxembourg B 82.631.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31060/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Luxemburg-Bonneweg, den 23. April 2002.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 23 avril 2002.
Signature.
49407
VANTALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2514 Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre Sauvage.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31041/207/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
LFG-LONDON FINANCIAL GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
—
STATUTS
L’an deux mille deux, le vingt-six mars.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant à L-5335 Moutfort, 14, Soibelwee.
2.- Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
Lesquels comparants ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont constituer entre eux:
Art. 1
er
. Il est formé par la présente une société anonyme sous la dénomination de LFG - LONDON FINANCIAL
GROUP S.A.
Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision du Conseil d’Admi-
nistration.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autre-
ment.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,
prêts, avances ou garanties.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d’autres personnes morales et physi-
ques.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et fi-
nancières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
Art. 4. Le capital social est fixé à trente et un mille Euros (31.000,- EUR), divisé en cent (100) actions de trois cent
dix Euros (310,- EUR) chacune.
Art. 5. Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
Les actions de la société peuvent être créées au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représen-
tatifs de plusieurs actions.
La société pourra procéder au rachat de ses actions au moyen de ses réserves disponibles et en respectant les dis-
positions de l’article 49-2 de la loi de 1915.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans; ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur, les administrateurs restants ont le droit d’y pourvoir provisoirement;
dans ce cas l’assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l’élection définitive.
Art. 7. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Le conseil d’administration peut désigner son président; en cas d’absence du président, la présidence de la réunion
peut être conférée à un administrateur présent.
Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le man-
dat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopieur ou télex, étant admis. En cas d’urgen-
ce, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télécopieur ou télex.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante. Le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion
journalière ainsi que la représentation à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnai-
res ou non.
G. d’Huart.
49408
Il peut leur confier tout ou partie de l’administration courante de la société, de la direction technique ou commerciale
de celle-ci.
La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée gé-
nérale.
La société se trouve engagée par la signature conjointe de deux administrateurs, ou par la seule signature de l’admi-
nistrateur-délégué.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le deuxième lundi du mois d’avril à 11.30 heures au
siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalable-
ment connaissance de l’ordre du jour.
Le conseil d’administration peut décider que, pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter
en personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution du bénéfice net.
Art. 13. Sous réserve des dispositions de l’article 72-2 de la loi de 1915 le conseil d’administration est autorisé à
procéder à un versement d’acomptes sur dividendes.
Art. 14. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur appli-
cation partout où il n’y est pas dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2002.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2003.
<i>Souscription et libérationi>
Les comparants précités ont souscrit aux actions créées de la manière suivante:
Toutes les actions ont été entièrement libérées en numéraire de sorte que la somme de trente et un mille Euros
(31.000,- EUR) est à la disposition de la société ainsi qu’il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expres-
sément.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élèvent approximativement à la somme de mille trois cent
trente euros.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en assemblée
générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était ré-
gulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois, et celui des commissaires aux comptes à un.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateurs:
a) Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant à L-5335 Moutfort, 14, Soibelwee.
b) Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel.
c) Monsieur Robert Becker, administrateur, demeurant à L-1145 Luxembourg, 18, rue des Aubépines.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
- La société à responsabilité limitée FIDUCIAIRE BECKER + CAHEN & ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à L-1537
Luxembourg, 3, rue des Foyers.
4.- Les mandats des administrateurs et commissaire prendront fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2007.
5.- Le siège social est établi à L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.
1.- Monsieur Gernot Kos, expert comptable, demeurant à L-5335 Moutfort, 14, Soibelwee, cinquante actions,
50
2.- Monsieur Thierry Hellers, expert comptable, demeurant à L-2134 Luxembourg, 52, rue Charles Martel, cin-
quante actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent actions, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
49409
6.- Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs de ses membres aux fonctions d’administrateur-
délégué.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg. Date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Kos - Hellers - J. Seckler
Enregistré à Grevenmacher, le 10 avril 2002, vol. 517, fol. 62, case 12. – Reçu 310 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31043/231/123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
YAMAMOTO HOLDINGS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent.
H. R. Luxemburg B 25.174.
—
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendzwei, den fünfzehnten April.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker im Amtssitz in Luxemburg-Eich.
Ist erschienen:
Die Aktiengesellschaft Holding M.M.WARBURG & CO HOLDING S.A. mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2, place Dar-
gent,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer
17.881,
hier vertreten durch Herrn Peter Johannsen, Bankkaufmann, wohnhaft in Bofferdange und Herrn Günther Hinz, Ju-
rist, wohnhaft in Lorentzweiler,
handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder.
Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, erklärt:
Daß sie die alleinige Eigentümerin sämtlicher Aktien welche das gesamte Kapital der Aktiengesellschaft Holding
YAMAMOTO HOLDINGS S.A. mit Sitz in L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent, darstellen, ist,
welche gegründet wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch den Notar André Schwachtgen im Amtssitz
in Luxemburg am 19. November 1986, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Num-
mer 46 vom 24. Februar 1987,
abgeändert auf Grund von Urkunden aufgenommen durch denselben Notar André Schwachtgen am 30. Januar 1989,
veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 186 vom 6. Juli 1989, und am 13.
Dezember 1989, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 268 vom 7. August
1990, und am 18. Februar 1991, veröffentlicht im Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer
347 vom 24. September 1991,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B unter Nummer
25.174.
Daß die Gesellschaft ein Kapital hat von 220.000,- USD, eingeteilt in 2.200 Aktien zu je 100,- USD.
Die Komparentin, vertreten wie eingangs erwähnt, welche die gesamten Aktien besitzt, beschliesst die Gesellschaft
YAMAMOTO HOLDINGS S.A. ohne Liquidation mit Wirkung zum heutigen Tage aufzulösen.
Die Tätigkeit der Gesellschaft ist somit eingestellt und die alleinige Aktionärin übernimmt persönlich alle Aktiva und
Passiva der aufgelösten Gesellschaft, welche keine Immobilien besitzt. Somit gilt die Liquidation der Gesellschaft als ab-
geschlossen.
Den Verwaltungsratsmitgliedern und dem Kommissar wird andurch Entlastung erteilt.
Die Komparentin verpflichtet sich die Aktien der aufgelösten Gesellschaft zu vernichten.
Die Geschäftsbücher und -unterlagen der aufgelösten Gesellschaft werden während fünf Jahren am Sitz der Gesell-
schaft M.M. WARBURG & CO HOLDING S.A. in L-1413 Luxemburg, 2, place Dargent, aufbewahrt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg-Eich in der Amtsstuhe des amtierenden Notars, Datum wie eingangs
erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben die Komparenten, handelnd wie eingangs er-
wähnt, mit dem amtierenden Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: P. Johannsen, G. Hinz, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 134S, fol. 97, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Kirsch.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
(31078/206/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Junglinster, le 23 avril 2002.
J. Seckler.
Luxemburg-Eich, den 23. April 2002.
P. Decker.
49410
BRISTOL (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
—
STATUTES
In the year two thousand and two, on the seventeenth of April.
Before us Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand
Duchy of Luxembourg,
There appeared:
BEDMINSTER (N
°
2. COMPANY) LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, having
its registered office at the Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England,
duly represented by Maître Lydie Beuriot, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal
given on the 26th day of March 2002.
Such proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party, represented as hereabove stated, has requested the notary to state the following articles of
incorporation of a limited liability company governed by the relevant laws and the present articles:
Title I - Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,
a corporation with limited liability (société à responsabilité limitée), under the name of BRISTOL (LUXEMBOURG) S.à
r.l.
Art. 2. The corporation is established for an undetermined period.
Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg-City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
Art. 4. The purpose of the corporation is the acquisition, the management, the enhancement and disposal of par-
ticipations in whichever form in domestic and foreign companies and branches. The company may also contract loans
and grant all kinds of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect partici-
pation.
Furthermore, the corporation may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, ex-
change, sale or otherwise.
The corporation may hold interests in partnerships.
It may also acquire, enhance and dispose of patents and licenses as well as rights deriving there from or supplementing
them.
In addition, the corporation may acquire, manage, enhance and dispose of real estate located in Luxembourg or
abroad.
In general, the corporation may carry out all commercial, industrial and financial operations, whether in the area of
securities or of real estate, likely to enhance or to supplement the above-mentioned purpose.
Title II - Capital - Units
Art. 5. The subscribed capital is set at fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) represented by five
hundred (500) corporate units with a par value of thirty United States Dollars (USD 30.-) each.
The units have been fully subscribed by BEDMINSTER (N
°
2 COMPANY) LIMITED, having its registered office at
the Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England.
All the units have been fully paid in by the subscriber so that the amount of fifteen thousand United States Dollars
(USD 15,000.-) is at the free disposal of the corporation, as was certified to the notary executing this deed.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the corporation shall represent the entire body of mem-
bers of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations
of the corporation. Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be
passed by a simple majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the corporation by a unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The corporation will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the corpo-
ration has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as
the sole owner in relation to the corporation.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the corporation in direct proportion to its relationship
with the number of units in existence.
Art. 8. If the corporation has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
49411
The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn-up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the corporation represented by him are recorded on
minutes or drawn-up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into
under normal conditions.
Art. 9. If the corporation has at least two members, the corporate units are freely transferable between the mem-
bers.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members rep-
resenting at least three quarters (3/4) of the corporation’s capital.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units
representing no less than three quarters (3/4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
Art. 10. Death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members
will not bring the corporation to an end.
Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or docu-
ments of the corporation.
Title III - Administration
Art. 12. The corporation shall be managed by a board of managers composed of two managers at least who need
not to be members of the corporation.
The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-
pensation and duration of their mandates. Their mandate may not exceed a period of six years and they shall hold office
until their successors are appointed.
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,
who needs not to be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of man-
agers and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting.
Reasonable written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers, except in circum-
stances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of the meeting.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously
adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the
managers’ meetings.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dis-
position on behalf of the Company in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the corporation and
the representation of the corporation for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of
members, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not to be man-
agers) deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers
and special mandates to any persons who need not to be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and
fix their emoluments.
Art. 16. The corporation will be bound by the joint signature of two managers or the single or joint signature of
any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of
the corporation. As agents of the corporation, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The accounting year of the corporation shall begin on September first of each year and shall terminate on
August thirty-first, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the
corporation and shall terminate on August thirty-first, of the year two thousand and two.
49412
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each fiscal year and will be at
the disposal of the members at the registered office of the corporation.
Out of the annual net profits of the corporation, five percent (5%) shall be placed into the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the corporation.
The general meeting of members, upon recommendation of the board of managers will determine how the annual
net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
1. Interim accounts are drafted on a quarter or semi-annual basis,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the board of managers if there is enough cash. Otherwise, the
decision has to be taken by an extraordinary general meeting of the members.
Title IV - Winding up - Liquidation
Art. 20. In the event of dissolution of the corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto.
<i> Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 183
of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen, on commercial companies and expressly states that they have
been fulfilled.
<i> Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be borne by the company as a
result of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).
For the purpose of registration, the share capital is valued at sixteen thousand six hundred twenty-two Euro thirty-
four cents (EUR 16,622.34).
<i>Resolutions of the sole member:i>
The prenamed sole member, representing the entire subscribed capital, has immediately taken the following resolu-
tions:
1) The registered office of the corporation is at L-2210 Luxembourg, 54 boulevard Napoléon I
er
.
2) The number of managers is fixed at two.
3) The following persons are appointed managers:
- Mr Michael McDonald, director, residing at L-4973 Dippach, 162, route de Luxembourg,
- Mr Pierre Metzler, lawyer, residing at L-2763 Luxembourg, 6, rue Ste Zithe.
4) The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members to be held for the purpose
of approving the annual accounts as of 31 August 2002.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundzwei, den siebzehnten April.
Vor Uns Maître Léon Thomas genannt Tom Metzler, Notar mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg, Großherzogtum
Luxemburg:
Ist erschienen:
BEDMINSTER (N
°
2 COMPANY) LIMITED, eine Gesellschaft gegründet unter den Gesetzen von England und
Wales, in the Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England,
hier vertreten durch Maître Lydie Beuriot, Jurist, wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privatschriftlichen Voll-
macht gegeben am 26. März 2002.
Die oben genannte Vollmacht bleibt, nach ne varietur Unterzeichnung durch die erschienene Person und den instru-
mentierenden Notar, an vorliegender Urkunde anliegend, um mit derselben einregistriert zu werden.
Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, hat den unterzeichneten Notar ersucht, die Satzungen einer Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, welche den entsprechenden Gesetzen und den vorliegenden Satzungen unterworfen
wird, wie folgt zu dokumentieren:
Titel I - Bezeichnung - Dauer - Sitz - Zweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem Zeichner und all denen Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden
könnten, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), unter der Bezeichnung BRISTOL
(LUXEMBOURG), S.à r.l. gegründet.
49413
Art. 2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt.
Er kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Filialen oder andere Niederlassungen können, entweder in Luxemburg oder im Ausland,
durch Beschluss des Verwaltungsrats eröffnet werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an in- und ausländischen Gesellschaften und Filialen. Die Gesellschaft kann ebenfalls An-
leihen aufnehmen und den Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung,
Darlehen, Vorschüssen oder Sicherheiten gewähren.
Desweiteren, kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch, Verkauf oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräußern.
Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Personengesellschaften haben.
Sie kann außerdem Patente und Lizenzen sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte erwerben, ver-
werten und veräußern.
Darüber hinaus kann die Gesellschaft in Luxemburg oder im Ausland gelegene Immobilien erwerben, verwalten, ver-
werten und veräußern.
Generell kann die Gesellschaft alle kaufmännischen, gewerblichen und finanziellen Geschäfte ob im Bereich von
Wertpapieren oder Immobilien tätigen, welche den obengenannten Zweck fördern oder ergänzen.
Titel Il - Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf fünfzehntausend US Dollar (USD 15.000,-) festgelegt, eingeteilt
in fünfhundert (500) Anteile mit einem Nennwert von je dreißig US Dollar (USD 30,-).
Die Anteile wurden vollständig von BEDMINSTER (N
°
2 COMPANY) LIMITED, mit Sitz in the Pavilions, Bridgwater
Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, England, gezeichnet.
Sämtliche Gesellschaftsanteile wurden integral durch den Zeichner eingezahlt, so daß der Betrag von fünfzehntausend
US Dollar (USD 15.000,-) der Gesellschaft fortan zur freien Verfügung steht, worüber dem beurkundenden Notar der
entsprechende Nachweis erbracht wurde.
Art. 6. Jede ordnungsmäßig einberufene Hauptversammlung der Gesellschafter wird die Gesamtheit der Mitglieder
der Gesellschaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Akten bezüglich des Geschäfts der Ge-
sellschaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vereinbart, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Haupt-
versammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschaftern angenom-
men.
Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Satzungsbestimmungen können jederzeit durch den alleinigen Gesellschaf-
ter oder durch die Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten,
abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einen einstimmigen Beschluss
ändern.
Falls alle Gesellschafter an der Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und falls sie er-
klären, daß sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder
Bekanntmachung abgehalten werden.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen und außerordentlichen General-
versammlungen.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von mehr als
einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht die Ausübung aller Rechte des betreffenden Anteils aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt ein anteilmäßiges, im direkten Verhältnis zur Gesamtzahl der bestehenden Anteile,
Recht am Gesellschaftsvermögen und -gewinn.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle der Haupt-
versammlung zuerkannten Befugnisse.
Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden in ein Pro-
tokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
Ebenfalls werden die Verträge welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesell-
schaft eingegangen werden, in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt. Nichtsdestoweniger ist diese
letzte Vorschrift für laufende Geschäfte die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden nicht anwendbar.
Art. 9. Falls die Gesellschaft wenigstens zwei Gesellschafter zählt, sind die Gesellschaftsanteile zwischen den Gesell-
schaftern frei übertragbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung der
Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Bei Todesfall von einem Gesellschafter, ist der Übertrag von Anteilen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der
Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel (3/4) der den Überlebenden gehörende Rechte vertreten, unterlegen.
In diesem Fall, jedoch, bedarf es keiner Zustimmung, falls die Gesellschaftsanteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder
an den überlebenden Ehepartner übertragen werden.
Art. 10. Das Ableben, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen
Gesellschafters oder eines der Gesellschafter werden in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft hervorrufen.
49414
Art. 11. Aus keinem Grund und in keinem Fall sind die Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters
befugt, die Güter und Dokumente der Gesellschaft versiegeln zu lassen.
Titel III - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens zwei Geschäftsführern verwaltet, die
nicht Gesellschafter sein müssen.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter, die über ihre Befugnisse, Bezüge und
Amtszeit entscheidet, ernannt und abberufen. Ihr Mandat darf den Zeitraum von sechs Jahren nicht überschreiten, und
sie werden, solange ihre Nachfolger nicht bestimmt wurden, im Amt bleiben.
Art. 13. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär
wählen, der nicht Geschäftsführer sein muß, und der dafür verantwortlich sein wird, die Protokolle der Verwaltungs-
ratssitzungen und der Hauptversammlungen der Gesellschafter zu führen.
Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden, oder zwei Geschäftsführern, an dem in der Ein-
berufung festgesetzten Ort zusammenkommen.
Vernünftiger schriftlicher Bescheid von jeder Sitzung des Verwaltungsrats wird jedem Geschäftsführer für die Sitzung
gegeben werden, außer im Falle von Dringlichkeit, in welchem Fall die Natur von solchen Umständen in der Einberufung
erläutert werden müssen. Eine spezielle Einberufung wird nicht notwendig sein für eine Verwaltungsratssitzung, welche
zu einer Stunde und an einem Ort, die in einem vorausgehenden Arbeitsplan des Verwaltungsrats festgehalten worden
waren, stattfinden soll.
Jeder Geschäftsführer kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche, oder per Kabel, Telegramm, Te-
lex oder Telefax gegebene Vollmacht an einen anderen Geschäftsführer handlungsfähig werden.
Stimmen können ebenfalls schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax abgegeben werden.
Der Verwaltungsrat kann nur ordnungsgemäß beraten und handeln, wenn wenigstens die Mehrzahl der Geschäfts-
führer an der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit
Stimmenmehrheit der an einer solchen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Schriftliche Entscheidungen welche von allen Geschäftsführern gutgeheißen und unterschrieben wurden, werden die
gleiche Wirkung als die Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen wurden, haben.
Art. 14. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, im Falle seiner Abwesenheit,
vom pro tempore Vorsitzenden, welcher den Vorsitz einer solchen Verwaltungsratssitzung übernahm, unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle welche vor Gericht oder anderswo vorgezeigt werden könnten, wer-
den von dem Vorsitzenden, dem Sekretär oder von zwei Geschäftsführern unterschrieben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat hat die weitgehendsten Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen
im Namen der Gesellschaft und in dessen Interessen, vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten
sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tagtägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Ge-
sellschaft sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem vor-
ausgehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Gesellschafter, an einen oder mehrere Geschäftsführer des
Verwaltungsrats oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht Geschäftsführer sein müssen), welche unter den Bedin-
gungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten, übertragen. Er kann ausserdem jegliche
Befugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht Geschäftsführer sein muss, übertragen, Beamte und
Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, oder durch die Ein-
zelunterschrift oder die gemeinsame Unterschrift der Person oder Personen welcher(n) solche Vertretungsmacht von
dem Verwaltungsrat Übertragen werden wird, verpflichtet.
Art. 17. Die Geschäftsführer gehen in der Ausübung ihres Mandats keinerlei persönlichen Verpflichtungen hinsicht-
lich der von der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten ein. Als Bevollmächtigte der Gesellschaft haften sie ledig-
lich für die korrekte Ausführung ihrer Aufgaben.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am ersten September eines jeden Jahres beginnen und am einund-
dreißigsten August enden, mit der Ausnahme vom ersten Geschäftsjahr, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft
beginnen und am einunddreißigsten August zweitausendundzwei enden wird.
Art. 19. Der Jahresabschluss wird von den Geschäfts- führern am Ende eines jeden Geschäftsjahres aufgestellt und
den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden.
Von dem Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5%)für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwen-
det werden. Dieser Abzug wird nicht mehr zwingend sein sobald die Rücklage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftska-
pitals erreicht hat.
Auf Empfehlung des Verwaltungsrats, wird die Hauptversammlung der Gesellschafter darüber entscheiden, wie über
den Nettogewinn verfügt werden wird.
Vorschüsse auf Dividenden können unter folgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Trimestrielle oder semestrielle Aufstellungen der Aktiven und Passiven werden erstellt,
2. Diese Aufstellungen zeigen einen Gewinn inbezüglich den Gewinnvortrag aus dem Vorjahr,
3. Der Beschluss, Vorschüsse auf Dividenden auszuschütten, wird vom Verwaltungsrat getroffen, wenn ausreichende
Bargeldmittel zur Verfügung stehen. Andernfalls, muß der Beschluß von einer außerordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschafter getroffen werden.
49415
Titel IV - Abwicklung - Auflösung
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidator(en)
(welche natürliche Personen oder Körperschaften sein können), die durch die Hauptversammlung ernannt werden, wel-
che über diese Abwicklung der Gesellschaft entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird, erfol-
gen.
Art. 21. Alle Punkte, die nicht in den vorliegenden Satzungen vorgesehenen sind, werden gemäß den Bestimmungen
des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen
festgelegt.
<i> Bescheinigungi>
Der amtierende Notar erklärt hiermit die in Art. 183 des Gesetzes vom zehnten August neunzehnhundertfünfzehn
über die Handelsgesellschaften vorgesehenen Bedingungen überprüft zu haben, und bescheinigt ausdrücklich, dass sie
erfüllt worden sind.
<i> Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus
Anlass ihrer Gründung entstehen werden, sind auf ungefähr eintausenddreihundert Euro (EUR 1.300,-) abgeschätzt.
Zwecks Einregistrierung ist das gezeichnete Kapital auf sechzehntausendsechshundertzweiundzwanzig Euro vierund-
dreissig Cents (EUR 16.622,34) abgeschätzt.
<i>Beschlüsse des alleinigen Gesellschaftersi>
Alsdann hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, folgende Beschlüs-
se gefaßt:
1. Der Gesellschaftssitz ist in L-2210 Luxemburg, 54, Boulevard Napoléon I
er
, festgelegt.
2. Die Zahl der Geschäftsführer ist auf zwei festgesetzt.
3. Die folgenden Personen werden als Geschäftsführer ernannt:
- Herr Michael McDonald, Direktor, wohnhaft in L-4973 Dippach, 162, route de Dippach,
- Herr Pierre Metzler, Jurist, wohnhaft in L-2763 Luxemburg, 6, rue Ste Zithe.
4. Die Frist der Amtszeit der Geschäftsführer wird mit der Hauptversammlung der Gesellschafter, welche den Jah-
resabschluss der Gesellschaft zum 31. August 2002 genehmigt, ablaufen.
Der amtierende Notar welcher die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Antrag der Kom-
parentin, gegenwärtige Urkunde in englischer Sprache verfasst und der Urkunde eine deutsche Fassung beigefügt ist. Auf
Antrag derselben Komparentin und im Falle von Widersprüchen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
wird die englische Fassung vorgehen.
Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung der Urkunde an die erschienene Person, hat diese mit dem Notar die vorliegende Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: Beuriot, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 18 avril 2002, vol. 135S, fol. 1, case 11. – Reçu 170,45 euros.
<i>Le Receveur ff i>(signé): Kirsch.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreies Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations, erteilt.
(31061/222/351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (EUROPE) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 70.797.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 avril 2002i>
- Mr Fabio Mazzoni and Mr Joseph Mayor present their resignation to the General Meeting with effect as from 23
April 2002.
- The General Meeting approves unanimously and expressly the resignation of Mr Fabio Mazzoni and Mr Joseph May-
or as directors of the Company with effect as from 23 April 2002 and, by special vote, gives them full and entire discharge
for their mandate up to this date.
- The General Meeting thanks the two directors for their duties up to this date.
- Mr Philip Rizzo decides to remain on duty.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31127/587/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Luxemburg-Bonnevoie, den 22. April 2002.
T. Metzler.
Pour extrait certifié conforme
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Domiciliatairei>
49416
PARBAT FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 41.084.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 31 juillet 1992, acte publié au
Mémorial C n
°
560 du 1
er
décembre 1992.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31063/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
SUISIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 72.162.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 7 octobre 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
986 du 22 décembre 1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31064/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
DREYFUS GROUP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 61.604.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 22 octobre 1997, acte publié
au Mémorial C n
°
95 du 13 février 1998.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31066/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 59.364.
—
En date du 15 avril 2002, l’associé unique à savoir la société anonyme A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND TAX
CONSULTANTS) S.A., établie et ayant son siège social à L-2213 Luxembourg, rue de Nassau 16, a décidé de convertir
le capital social de 500.000,- LUF en euros 12.394,68 (douze mille trois cent quatre vingt quatorze euros et soixante
huit cent) et de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
Il en résulte que l’article 5 des statuts en son alinéa premier aura dorénavant la teneur suivante:
«Le capital est fixé à la somme de 12.394,68 euros (douze mille trois cent quatre vingt quatorze euros et soixante
huit cent) représenté par 500 (cinq cent) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»
Luxembourg, le 15 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 17 avril 2002, vol. 567, fol. 4, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(31231/813/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour PARBAT FINANCE S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour SUISIMMO S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour DREYFUS GROUP S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour la société
i>A.T.T.C. (ADVISORS IN TRUST AND TAX CONSULTANTS) S.A.
Signature
<i>Le géranti>
49417
GVV S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5480 Wormeldange, 11, rue Principale.
H. R. Luxemburg B 28.724.
—
<i>Sitzungsprotokoll über die ausserordentliche Generalversammlung vom 14. März 2002i>
Am Mittwoch, den 14. März 2002 um 19.00 Uhr, sind die Aktionäre der in Ausführung von Artikel 9 der Satzung am
Sitz der Gesellschaft zur ausserordentlichen Generalversammlung zusammengetreten.
Der Vorsitz wird von Frau Marianne Snela geführt.
Diese bestellt zum Stimmzähler Herrn Heinz Mette.
Zur Schriftführerin wird Frau Dr. Paporn Kaveewatcharanont bestimmt.
Sodann werden folgende Erklärungen abgegeben, die von der Hauptversammlung zur Kenntnis genommen werden:
- dass aus der vom Büro unterschriebenen Anwesenheitsliste hervor geht, dass sämtliche Aktionäre anwesend oder
vertreten sind, welche Aktien besitzen; dass die Hauptversammlung ordnungsgemäss zusammengesetzt ist und gültige
Beschlüsse hinsichtlich der Tagesordnung fassen kann.
<i>Tagesordnung:i>
1. Demission von Herrn Heinz Mette, Pensionär, wohnhaft in Wasserbillig
2. Neuwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars
Ad1) Die Demission von Herrn Heinz Mette wird zur Kenntnis genommen. Für seine geleistete Arbeit wird ihm ge-
dankt und entlast erteilt.
Ad2) Die Versammlung beschliesst folgenden Verwaltungsrat zur wählen:
Dame Marianne Snela, Kauffrau, wohnhaft in Wasserbillig
Dame Dr. Paporn Kaveewatcharanont, Zahnärztin, wohnhaft in Remich
Herrn Frank Mette, Unternehmer, wohnhaft in Remich
Als Abschlussprüfer wurde die
FIDUCIAIRE SOCODIT S.A.
77, route de Trèves
L-6793 Grevenmacher
gewählt.
Die Amtszeit der gewählten Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden im Jahr 2007.
Da keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, wird gegenwärtiges Protokoll verlesen und vom Vorsitzenden, dem
Stimmzähler und der Schriftführerin unterfertigt.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2002, vol. 169, fol. 23, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(31073/206/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
GVV S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5480 Wormeldange, 11, rue Principale.
H. R. Luxemburg B 28.724.
—
<i>Sitzung des Verwaltungsrates vom 14. März 2002i>
Am 14. März 2002, 19.30 Uhr.
Sind:
1. Dame Marianne Snela, Kauffrau, wohnhaft in Wasserbillig.
2. Dame Dr. Paporn Kaveewatcharanont, Zahnärztin, wohnhaft in Remich
3. Herr Frank Mette, Unternehmer, wohnhaft in Remich
handelnd in ihrer Eigenschaft als Verwaltungsratsmitglieder der GVV S.A. im Anschluss an die Generalversammlung
zusammengetreten und haben einstimmig nachfolgenden Beschluss gefasst.
<i>Erster und einziger Beschlussi>
Der Verwaltungsrat beschliesst, im Einverständnis mit der Generalversammlung, Dame Marianne Snela, vorbenannt,
zum administrateur-délégué (geschäftsführendem Verwaltungsratsmitglied) zu ernennen, mit Generalvollmacht für die
tägliche Geschäftsführung mit unbeschränkter Vollmacht Darlehen aufzunehmen, Hypotheken zu bestellen, eintragen
und streichen zu lassen.
Ihr Mandat endet sofort nach der jährlichen Hauptversammlung von 2007.
Also beschlossen in Wormeldange, am 14. März 2002.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 mars 2002, vol. 169, fol. 23, case 9. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(31074/206/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
M. Snela / F. Mette / P. Kaveewatcharanont
M. Snela / F. Mette / P. Kaveewatcharanont
49418
WINDOWS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 47.135.
Constituée par-devant M
e
Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 10 mars 1994, acte publié au
Mémorial C n
°
272 du 15 juillet 1994. Le capital a été converti en EUR par acte sous seing privé le 28 novembre
2000; l’avis afférent a été publié au Mémorial C n
°
713 du 3 septembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31067/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
LEROY - MERLIN & CIE VALACTION, Société en commandite par actions.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 64.283.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 mai 1998, acte publié au
Mémorial C n
°
530 du 21 juillet 1998, modifiée par-devant le même notaire en date du 7 avril 1999, acte publié au
Mémorial C n
°
522 du 8 juillet 1999 et en date du 18 août 1999, acte publié au Mémorial C n
°
874 du 20 novembre
1999.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31068/528/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
THE U.S. HIGH YIELD FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.001.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 35, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2002.
(31079/051/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
THE U.S. HIGH YIELD FUND SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 26.001.
—
Faisant suite à l’assemblée générale du 21 mars 2002, la composition du conseil d’administration de la société est la
suivante:
M. Paul Lowenstein
M. James J. Sullivan
M. Masahiko Sasaki
Pour réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 35, case 7. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31083/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
<i>Pour WINDOWS INTERNATIONAL S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour LEROY - MERLIN & CIE VALACTION S.E.C.P.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.
Signature
49419
S.I. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 65.630.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 juillet 1998, acte publié au
Mémorial C n
°
747 du 16 octobre 1998. Le capital a été converti en Euros le 31 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31069/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
S.I. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 65.630.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 juillet 1998, acte publié au
Mémorial C n
°
747 du 16 octobre 1998. Le capital a été converti en Euros le 31 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31070/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
S.I. INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 65.630.
Constituée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 8 juillet 1998, acte publié au
Mémorial C n
°
747 du 16 octobre 1998. Le capital a été converti en Euros le 31 décembre 2001.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 20, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31071/528/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
GRAPHIQUE SYSTEMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 39.553.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567,
fol. 32, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31247/693/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
<i>Pour S.I. INVESTISSEMENTS S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour S.I. INVESTISSEMENTS S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
<i>Pour S.I. INVESTISSEMENTS S.A.
i>KPMG Financial Engineering
Signature
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
435.260,64 EUR
Augmentation de capital du 1
er
février 2001 . . . . .
- 37.500,00 EUR
Bénéfice de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.287,63 EUR
./. Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.615,00 EUR
./. Réserve pour impôt sur la fortune . . . . . . . . . . .
- 12.825,00 EUR
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
415.608,27 EUR
Signature.
49420
JULIUS BAER MULTICASH, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 36.405.
—
Im Jahre zweitausendzwei, am dritten April um 9.00 Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxemburg-Eich, Großherzogtum Luxemburg,
Fand die außerordentliche Generalversammlung der Anteilseigner des JULIUS BAER MULTICASH, einer Investment-
gesellschaft mit veränderlichem Kapital, welche ihren Geschäftssitz in 69, route d’Esch, L-1470 Luxemburg hat, («die
Gesellschaft»), gegründet in Luxemburg am 15. März 1991 durch Urkunde des Notars Joseph Kerschen, mit damaligem
Amtssitze in Luxemburg-Eich, Großherzogtum Luxemburg, welche im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations («Mémorial») C Nr. 204 vom 6. Mai 1991 veröffentlicht wurde, statt.
Die Satzung wurde zuletzt durch notarielle Urkunde vom 11. Mai 1999 aufgenommen durch Notar Edmond Schro-
eder mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C Nr 523, vom 8. Juli 1999, abgeändert.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B
unter Nummer 36.405.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Hermann Beythan, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
welcher als Sekretär bestimmt Frau Bärbel Frey, Privatangestellte, wohnhaft in L-1470 Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt als Stimmenzähler Herr Martin Bock, Privatangestellter, wohnhaft in Luxemburg.
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:
Die anwesenden oder vertretenen Anteilseigner und die Anzahl der Anteile, welche jeder von ihnen hält, sind aufge-
zeichnet in einer Anwesenheitsliste, die von den Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseigner und von den Mitglie-
dern des Büros unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten, paraphiert ne varietur, sind dieser
Originalurkunde beigebogen und werden mit ihr einregistriert.
Einberufungsschreiben wurden veröffentlicht:
- im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 15. März 2002 und 25. März 2002,
- in der Zeitung «Luxemburger Wort» vom 15. März 2002 und 25. März 2002,
- den Eignern von Namensanteilen wurden sie am 25. März 2002 per Post zugesandt.
Von 1.179.135,070 Anteilen, welche ausgegeben wurden und in Umlauf sind, sind 71.606,000 Anteile bei der gegen-
wärtigen außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder vertreten.
Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:
Allgemeine Überarbeitung und Neufassung der Satzung, insbesondere:
- die Änderung des Geschäftsjahres auf neu jeweils 1. Juli bis 30. Juni (Artikel 28, erster Absatz) sowie Änderung des
Zeitpunktes der jährlichen Generalversammlung auf den Monat November (Artikel 10, erster Absatz);
- Einführung zusätzlicher Bestimmungen bezüglich der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder (Artikel 14);
- die Straffung der Formulierung der Anlagerestriktionen des Artikels 17.
- Präzisierung der Definition eines Bewertungstages (Artikel 24, erster Absatz);
- die Bestätigung der Trennung der Haftung für Verbindlichkeiten zwischen den Anteilsklassen (Artikel 26, (B), e);
- Verschiedenes.
Da weniger als die Hälfte aller ausgegebenen Anteile auf der gegenwärtigen Generalversammlung vertreten sind, ist
die gegenwärtige Versammlung nicht ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann daher nicht wirksam über die Punkte
der Tagesordnung entscheiden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anleger nochmals einzuberufen per Schreiben und
Veröffentlichung wie vorgesehen im Gesetz und in der Satzung. Die zweite Versammlung kann wirksam über alle Punkte
derselben Tagesordnung beschliessen, unabhängig von der Zahl der Anteile, welche anwesend oder vertreten sind.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde diese Versammlung und dieses Protokoll am 3. April 2002 um 9:30
Uhr unterzeichnet.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, 69, route d’Esch, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt sind, haben alle mit Uns Notar die gegenwärtige Urkunde, unterschrieben.
Gezeichnet: H. Beythan, B. Frey, M. Bock, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 134S, fol. 87, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
(31077/206/56) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
OMNITECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 80.903.
—
Les statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
J. Elvinger.
(31354/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Luxemburg-Eich, den 23. April 2002.
P. Decker.
49421
ARLVEST S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2763 Luxembourg, 38-40, rue Sainte Zithe.
R. C. Luxembourg B 74.573.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i> qui a eu lieu le 19 avril 2002 au siège sociali>
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire que:
- l’assemblée a décidé de révoquer l’actuel commissaire aux comptes, THEMIS AUDIT LIMITED, avec effet au 19 avril
2002 et de lui donner décharge pour l’exécution de son mandat jusqu’à ce jour;
- l’assemblée a décidé de nommer aux fonctions de nouveau commissaire aux comptes de la société:
Madame Catherine Koch, administrateur de sociétés, demeurant à L-2763 Luxembourg, 38-40, Sainte Zithe.
Son mandat prendra fin à lors de la prochaine assemblée statutaire appelée à délibérer sur les comptes annuels de la
société au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 27 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 34, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31125/250/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
JULIUS BAER MULTIBOND, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 32.187.
—
Im Jahre zweitausendzwei, am dritten April um neun Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxemburg-Eich, Großherzogtum Luxemburg,
Fand die außerordentliche Generalversammlung der Anteilseigner des JULIUS BAER MULTIBOND, einer Invest-
mentgesellschaft mit veränderlichem Kapital, welche ihren Geschäftssitz in 69, route d’Esch, L-1470 Luxemburg hat,
(«die Gesellschaft»), gegründet in Luxemburg am 1. Dezember 1989 durch Urkunde des Notars Joseph Kerschen, mit
damaligem Amtssitze in Luxemburg-Eich, Großherzogtum Luxemburg, welche im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations («Mémorial») C Nr. 21 vom 19. Januar 1990 veröffentlicht wurde, statt.
Die Satzung wurde zuletzt durch notarielle Urkunde vom 11. Mai 1999 aufgenommen durch Notar Edmond Schro-
eder zeit dem damaligen Amtssitz in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 514, vom 6. Juli 1999, abgeändert.
Die Gesellschaft ist eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion B
unter Nummer 32.187.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Hermann Beythan, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
welcher als Sekretär bestimmt Frau Bärbel Frey, Privatangestellte, wohnhaft in L-1470 Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt als Stimmenzähler Herrn Martin Bock, Privatangestellter, wohnhaft in L-1470 Luxem-
burg.
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:
Die anwesenden oder vertretenen Anteilseigner und die Anzahl der Anteile, welche jeder von ihnen hält, sind aufge-
zeichnet in einer Anwesenheitsliste, die von den Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseigner und von den Mitglie-
dern des Büros unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten, paraphiert ne varietur, sind dieser
Originalurkunde beigebogen und werden mit ihr einregistriert.
Einberufungsschreiben wurden veröffentlicht:
- im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 15. März 2002 und 25. März 2002,
- in der Zeitung «Luxemburger Wort» vom 15. März 2002 und 25. März 2002,
- den Eignern von Namensanteilen wurden sie am 25. März 2002 per Post zugesandt.
Von 20.689.833,942 Anteilen, welche ausgegeben wurden und in Umlauf sind, sind 461.720,000 Anteile bei der ge-
genwärtigen außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder vertreten.
Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:
- Allgemeine Überarbeitung und Neufassung der Satzung, insbesondere:
die Änderung des Geschäftsjahres auf neu jeweils 1. Juli bis 30. Juni (Artikel 28, erster Absatz) sowie Änderung des
Zeitpunktes der jährlichen Generalversammlung auf den Monat November (Artikel 10, erster Absatz);
- Einführung zusätzlicher Bestimmungen bezüglich der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder (Artikel 14);
- die Straffung der Formulierung der Anlagerestriktionen des Artikels 17.
- Präzisierung der Definition eines Bewertungstages (Artikel 24, erster Absatz);
- die Bestätigung der Trennung der Haftung für Verbindlichkeiten zwischen den Anteilsklassen (Artikel 26, (B), e);
- Verschiedenes.
Da weniger als die Hälfte aller ausgegebenen Anteile auf der gegenwärtigen Generalversammlung vertreten sind, ist
die gegenwärtige Versammlung nicht ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann daher nicht wirksam über die Punkte
der Tagesordnung entscheiden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anleger nochmals einzuberufen per Schreiben und
Veröffentlichung wie vorgesehen im Gesetz und in der Satzung. Die zweite Versammlung kann wirksam über alle Punkte
derselben Tagesordnung beschliessen, unabhängig von der Zahl der Anteile, welche anwesend oder vertreten sind.
<i>Pour ARLVEST S.A. HOLDING
i>Signature
<i>Un mandatairei>
49422
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde diese Versammlung und dieses Protokoll am 3. April 2002 um 9.15
Uhr unterzeichnet.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, 69, route d’Esch, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt sind, haben alle mit Uns Notar die gegenwärtige Urkunde, unterschrieben.
Gezeichnet: H. Beythan, B. Frey, M. Bock, P. Decker.
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol.134S, fol. 87, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
(31075/206/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
JULIUS BAER MULTISTOCK, Investmentgesellschaft mit veränderlichem Kapital.
Gesellschaftssitz: L-1470 Luxemburg, 69, route d’Esch.
H. R. Luxemburg B 32.188.
—
Im Jahre zweitausendzwei, am dritten April, um neun Uhr.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Decker, mit Amtssitze in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Fand die außerordentliche Generalversammlung der Anteilseigner des JULIUS BAER MULTISTOCK, einer Invest-
mentgesellschaft mit veränderlichem Kapital, welche ihren Geschäftssitz in 69, route d’Esch, L-1470 Luxemburg hat,
(«die Gesellschaft»), gegründet in Luxemburg am 1. Dezember 1989 durch Urkunde des Notars Joseph Kerschen, mit
damaligem Amtssitze in Luxemburg-Eich, Großherzogtum Luxemburg, welche im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations («Mémorial») C Nr. 21 vom 19. Januar 1990 veröffentlicht wurde, statt.
Die Satzung wurde zuletzt durch notarielle Urkunde vom 11. Mai 1999 aufgenommen durch Notar Edmond Schro-
eder mit dem damaligen Amtssitz in Mersch, veröffentlicht im Mémorial C Nr 518, vom 7. Juli 1999, abgeändert.
Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht in Luxemburg, Sektion
B, unter Nummer 32.188
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Hermann Beythan, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg,
welcher als Sekretär bestimmt Frau Bärbel Frey, Privatangestellte, wohnhaft in L-1470 Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt als Stimmenzähler Herr Martin Bock, Privatangestellter, wohnhaft in L-1470 Luxem-
burg.
Der Vorsitzende erklärt und bittet den Notar zu beurkunden:
Die anwesenden oder vertretenen Anteilseigner und die Anzahl der Anteile, welche jeder von ihnen hält, sind aufge-
zeichnet in einer Anwesenheitsliste, die von den Bevollmächtigten der vertretenen Anteilseigner und von den Mitglie-
dern des Büros unterzeichnet ist. Diese Anwesenheitsliste und die Vollmachten, paraphiert ne varietur, sind dieser
Originalurkunde beigebogen und werden mit ihr einregistriert.
Einberufungsschreiben wurden veröffentlicht:
- im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C vom 15. März 2002 und 25. März 2002,
- in der Zeitung Luxemburger Wort vom 15. März 2002 und 25. März 2002,
- den Eignern von Namensanteilen wurden sie am 25. März 2002 per Post zugesandt.
Von 45.692.722,262 Anteilen, welche ausgegeben wurden und in Umlauf sind, sind 681.395 Anteile bei der gegenwär-
tigen außerordentlichen Generalversammlung anwesend oder vertreten.
Die Tagesordnung der Versammlung ist wie folgt:
Allgemeine Überarbeitung und Neufassung der Satzung, insbesondere:
- die Änderung des Geschäftsjahres auf neu jeweils 1. Juli bis 30. Juni (Artikel 28, erster Absatz) sowie Änderung des
Zeitpunktes der jährlichen Generalversammlung auf den Monat November (Artikel 10, erster Absatz);
- Einführung zusätzlicher Bestimmungen bezüglich der Wahl der Verwaltungsratsmitglieder (Artikel 14);
- die Straffung der Formulierung der Anlagerestriktionen des Artikels 17.
- Präzisierung der Definition eines Bewertungstages (Artikel 24, erster Absatz);
- die Bestätigung der Trennung der Haftung für Verbindlichkeiten zwischen den Anteilsklassen (Artikel 26, (B), e);
- Verschiedenes.
Da weniger als die Hälfte aller ausgegebenen Anteile auf der gegenwärtigen Generalversammlung vertreten sind, ist
die gegenwärtige Versammlung nicht ordnungsgemäss zusammengesetzt und kann daher nicht wirksam über die Punkte
der Tagesordnung entscheiden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anleger nochmals einzuberufen per Schreiben und
Veröffentlichung wie vorgesehen im Gesetz und in der Satzung. Die zweite Versammlung kann wirksam über alle Punkte
derselben Tagesordnung beschliessen, unabhängig von der Zahl der Anteile, welche anwesend oder vertreten sind.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, wurde diese Versammlung und dieses Protokoll am 3. April 2002 um 9.45
Uhr unterzeichnet.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, 69, route d’Esch, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, welche alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand
und Wohnort bekannt sind, haben alle mit Uns Notar die gegenwärtige Urkunde, unterschrieben.
Gezeichnet: H. Beythan, B. Frey, M. Bock, P. Decker.
Luxemburg-Eich, den 23. April 2002.
P. Decker.
49423
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2002, vol. 134S, fol. 87, case 6. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, erteilt.
(31076/206/57) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS (EUROPEAN HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 69.496.
—
<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 22 avril 2002i>
<i>Third resolutioni>
The General Meeting approves unanimously and expressly the resignation of Mr Fabio Mazzoni and Mr Joseph Mayor
as directors of the Company with effect as from 22 April 2002 and, by special vote, gives them full and entire discharge
for their mandate up to this date.
The General Meeting thanks the two directors for their duties up to this date.
Mr Philip Rizzo confirms that he is willing to remain a director of the Board.
<i>Fourth resolutioni>
All the three shareholders agree to appoint Mr Bert Hummel as director. Mr Hummel is appointed for a duration of
six years.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31126/587/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
BENELUX PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.695.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31272/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BENELUX PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.695.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31273/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BENELUX PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 60.695.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31274/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Luxemburg-Eich, den 23. April 2002.
P. Decker.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Domiciliatairei>
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
49424
LUXSAT INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-7327 Steinsel, 35, rue John F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 69.926.
—
<i>Minutes of the Ordinary General Meeting of the Shareholders held the 11th April 2002i>
<i>Fourth resolutioni>
The General Meeting accepts the resignation of Mr Robert Monteux as Director and managing-director of the Com-
pany, and of Mr Fabio Mazzoni and Mr Joseph Mayor as Directors of the Company with effect as from 11th April 2002
and gives them discharge for the performance of their mandate until the date of their resignation.
<i>Fifth resolutioni>
The General Meeting appoints as new directors:
1. Mr Hassan Tatanaki, company director, residing in 1 El Moshier Ahmed Ismail Street, Heliopolis 11 361, Cairo,
Egypt,
2. Mr James Von Claer, company director, residing in 39, avenue Pierre Premier de Serbie, F-75008 Paris,
3. Mr Adrian Escher, company director, residing in KPMG, Mühlmattstrasse 56, Postfach 2701, 5001 Aarau, Switzer-
land,
4. Mr Mohammed Osama Kebir, company director, residing in 1 El Moshier Ahmed Ismail Street, Heliopolis 11 361,
Cairo, Egypt,
5. Mr Remi Scheengans, company director, residing in 108, avenue Victor Hugo, F-92170 Vanves,
6. Mr Thierry Maman, company director, residing in 82, rue Lauriston, F-75116 Paris.
Their mandate will expire on the date of the Statutory General Meeting to be held in 2007.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 34, case 5. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31129/587/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
EF CULTURAL TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.074.
—
<i>Extrait des décisions des Associés en date du 21 mars 2002i>
Les associés de la société à responsabilité limitée EF CULTURAL TOURS, S.à r.l., ont pris en date du 21 mars 2002
les résolutions suivantes:
- Monsieur Frederik Lambert Olsson, ayant pour adresse professionnelle Sturegallerian 11A, S-11487 Stockholm, a
été nommé aux fonctions de gérant en remplacement de Casper Leopold Erik Seifert, demeurant à Luzern (CH), dé-
missionnaire, avec effet au 21 mars 2002.
- Le siège social de la société est transféré du 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg au 27, avenue Monterey, L-
2163 Luxembourg avec effet au 21 mars 2002.
A l’issue de cette réunion, les gérants sont:
- Pieter van Nugteren;
- Frederik Lambert Olsson.
Les gérants sont nommés pour une durée indéterminée.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31310/029/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
EF CULTURAL TOURS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.074.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 30 septembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567,
fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31311/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour extrait certifié conforme
<i>Pour la société
i>Signature
P. van Nugteren
<i>Géranti>
Pour extrait sincère et conforme
P. van Nugteren
<i>Géranti>
49425
M. M. WARBURG-LUXINVEST.
H. R. Luxemburg B 29.905.
—
<i>Unterschriftenverzeichnis 1. April 2002i>
Ernst-Ludwig Drayß, Président, (gemeinsam mit A, B oder C), Catégorie A
Bernhard Kuhn, Administrateur, (gemeinsam mit A, B, oder C), Catégorie A
Sylvan Trachsler, Administrateur, (gemeinsam mit A, B oder C), Catégorie A
Rudy Pomper, Administrateur, (gemeinsam mit A, B oder C), Catégorie A
Sabine Büchel, Directeur, (gemeinsam mit A, B oder C), Catégorie B
Hermann Knödgen, Fondé de Pouvoir, (gemeinsam mit A, B oder C), Catégorie B
Anja Franzen, (gemeinsam mit A, B oder C), Catégorie B
Carmen Lauterbach, (gemeinsam mit A, B oder C), Catégorie B
Yves Schalk, (gemeinsam mit A, B oder C), Catégorie B
Daniela Alken, (gemeinsam mit A oder B), Catégorie C
Verena Rings, (gemeinsam mit A oder B), Catégorie C
Andrea Schmitt, (gemeinsam mit A oder B), Catégorie C
Helga Müller, (gemeinsam mit A oder B), Catégorie C
Stephan Schilken, (gemeinsam mit A oder B), Catégorie C
Die rechtsverbindliche Zeichnung erfolgt durch
- diejenigen Mitglieder des Verwaltungsrats, die in der Gruppe A aufgeführt sind
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräusserung und Belastung von Grundstücken zu allen rechtsgeschäft-
lichen Handlungen, die ein Handelsgewerbe mit sich bringt, berechtigt sind (Gruppe B)
- Unterschriftsträger, die mit Ausnahme der Veräusserung oder Belastung von Grundstücken, der Eingehung von
Wechselverbindlichkeiten, der Aufnahme von Darlehen und der Prozessführung zu allen Rechtshandlungen berechtigt
sind, die der Betrieb eines Handelsgeschäftes mit sich bringt (Gruppe C).
Alle vorherigen Eintragung sind zu löschen respektive mit Wirkung von heute an ungültig.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31130/000/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.832.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(31131/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
WINE ACQUISITIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 18, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 81.866.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 12 avril 2002i>
<i>Résolutioni>
Les mandats des administrateurs et du commissaire aux comptes venant à échéance, l’assemblée décide d’élire pour
la période expirant à l’assemblée statuant sur l’exercice 2002.
<i>Conseil d’administrationi>
M. Marco Sterzi, Président.
Mme Laura Guardamagna, Administrateur.
Mme Sonja Bemtgen, Administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
FIDUCIAIRE GRAND-DUCALE S.A., 3, rue Rheinsheim, L-2419 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31253/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
NESTOR INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Signatures
Pour extrait conforme
Signature
49426
CommTrust INVESTMENT MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 68.172.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(31132/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
TRANSCONTINENTAL INVESTMENT CORPORATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R. C. Luxembourg B 17.152.
—
<i>Extrait du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnairesi>
<i>tenue en date du 7 décembre 2001i>
Conseil d’Administration
Ayant constaté les démissions de leurs fonctions d’administrateur présentées le 31 janvier 2002 par Messieurs Carlo
Schlesser, Jean-Robert Bartolini, de Mademoiselle Carole Caspari et de FINIM LIMITED en tant qu’administrateurs ainsi
que celle de FIN-CONTROLE en tant que commissaire aux comptes, les actionnaires décident ensuite de pourvoir à
leur remplacement par la nomination avec effet immédiat:
des administrateurs suivants pour une durée de six ans:
A.T.T.C. MANAGEMENT, S.à r.l, 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
A.T.T.C. DIRECTORS, S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
A.T.T.C. SERVICES, S.à r.l., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
Du commissaire aux comptes suivant pour une durée de six ans:
A.T.T.C. CONTROL S.A., 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg.
<i>Conversion de la monnaie d’expression du capitali>
L’Assemblée Générale décide, conformément à la loi du 10 décembre 1998, de convertir la monnaie d’expression du
capital social actuel de 5.000.000,- LUF (cinq millions de francs luxembourgeois) en euros 123.946,76 et d’incorporer
53,24 euros (soit 2.148,- LUF) provenant des bénéfices reportés, au capital social de la manière à porter ce dernier à
124.000,- euros (cent vingt quatre mille euros).
L’Assemblée décide ensuite de supprimer la valeur nominale des actions et de modifier l’art 3. al. 1 des statuts comme
suit:
Art. 3. al. 1. Le capital social est fixé à cent vingt quatre mille euros (124.000,- euros), divisé en cinq mille (5.000)
actions sans désignation de valeur nominale.
L’Assemblée Générale décide également de convertir le capital autorisé de LUF en euro de sorte que le troisième
alinéa de l’article 3 des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 3. al. 3. Le Conseil d’Administration est autorisé à augmenter le capital social à concurrence de soixante qua-
torze mille trois cent quatorze euros et quatre vingt un cent (74.314,81 euros) pour le porter de son montant actuel
de cent vingt quatre mille euros (124.000,- euros) à cent quatre vingt dix huit mille trois cent quatorze euros et quatre
vingt un cent (198.314,81 euros) le cas échéant par l’émission d’actions nouvelles jouissant des mêmes droits et avan-
tages que les actions existantes.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 2002, vol. 567, fol. 16 case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Signature.
(31232/813/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
ACORD INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1220 Luxembourg, 68, rue de Beggen.
R. C. Luxembourg B 51.407.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 avril 2002, vol. 567, fol. 26, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31271/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
CommTrust INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
Signatures
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signatures
<i>Administrateursi>
Luxembourg, le 26 avril 2002.
49427
BARBIERI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.008.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 42, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2000.
(31248/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BARBIERI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.008.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 42, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2000.
(31249/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BARBIERI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 42.008.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 42, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2000.
(31250/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
IEFAM HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1635 Luxembourg, 87, allée Léopold Goebel.
R. C. Luxembourg B 70.560.
—
EXTRAIT
L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg le 19 avril 2002 a pris à l’unanimité les résolutions suivan-
tes:
1. Le siège social est transféré au 87, allée Léopold Goebel, L-1635 Luxembourg;
2. L’assemblée prend acte de la démission des trois administrateurs en la personne de Monsieur Olivier Dewalque,
Madame Marie-Anne Schartz et Madame Andrea Dany et nomme trois nouveaux administrateurs comme suit:
- Monsieur Raymond Henschen, Maître en Sciences Economiques, demeurant à L-2241 Luxembourg, rue Tony New-
man n
°
20;
- Madame Monique Haas, Maître en Sciences Economiques, demeurant à L-2241 Luxembourg, rue Tony Newman n
°
20;
- Madame Bénédicte Robaye, administrateur de sociétés, demeurant à B-6760 Léglise, rue des Combattants n
°
26.
3. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Laurent Pêcheur
et nomme en son remplacement la société FIDUPLAN S.A., avec siège social au 87, allée Léopold Goebel, L-1635
Luxembourg.
4. Par votes spéciaux, décharge pleine et entière est accordée aux quatre administrateurs et au commissaire aux
comptes sortants pour leurs mandats et gestion jusqu’à ce jour.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31259/693/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
<i>Le Conseil d’Administration
i>Signature
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 19 avril 2002.
Signature.
49428
SALP EUROPE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.
R. C. Luxembourg B 71.694.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 21 mars 2002i>
Lors de ladite assemblée les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolutioni>
Décharge est accordée au commissaire aux comptes démissionnaire: Madame Evelyne Jastrow.
<i>Seconde résolutioni>
Est nommé commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société MG
CONSULTING S.A. avec siège social à 17 avenue de La Libération, L-3850 Schifflange. Son mandat prenant fin lors de
l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2002.
<i>Troisième résolutioni>
Décharge est accordée à l’administrateur démissionnaire, Monsieur Leo Staut, à partir du 7 juin 2001 et ratifie la dé-
cision du conseil d’administration du 7 juin 2001 nommant Monsieur Noël Delaby en qualité d’administrateur afin
d’achever le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21 mars 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 33, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31235/000/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 avril 2002.
EL 3000 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 78.806.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567,
fol. 32, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31237/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
VONTOBEL LUXEMBOURG S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-5365 Munsbach, 1A, Parc d’Activité Syrdall.
H. R. Luxemburg B 78.142.
—
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2001, der am 19. April 2002, vol. 567, fol. 17, case 12, in Luxemburg einge-
tragen wurde, wurde im Handelsregister in Luxemburg am 22. April 2002 hinterlegt. Im Hinblick dieses Jahresabschlus-
ses hat der Abschlussprüfer, ERNST & YOUNG, sein Testat erteilt.
Der Verwaltungsrat hat durch Beschluss vom 19. März 2002 die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ERNST 6 YOUNG
S.A., 7, Parc d’Activité Syrdall, L-5365 Munsbach, als Abschlussprüfer für das am 31. Dezember 2002 endende Geschäfts-
jahr ernannt.
Zum Zwecke der Veröffentlichung des Vorstehenden im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 24. April 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 43, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31251/260/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour extrait conforme
SALP EUROPE S.A.
Signature / Signature / Signature
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 5.659,97 EUR
Perte de l’exercice 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 35.140,66 EUR
Report à nouveau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 40.800,63 EUR
Signature.
VONTOBEL LUXEMBOURG S.A.
Signature
49429
FINGREEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 71.188.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567,
fol. 32, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31246/693/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
QUADRANTE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 82.001.
—
L’assemblée générale des actionnaires du 27 mars 2002 a décidé de révoquer M. Filippo Giardiello comme adminis-
trateur de la société et de le remplacer par M
e
Pierre Thielen, avocat, résidant à Luxembourg.
M. Renato Preti a été nommé Président du Conseil d’Administration.
Le 8 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 30, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31252/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
A.R.D. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.774.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31275/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
A.R.D. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.774.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31276/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
A.R.D. DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 52.774.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31277/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.202,56 EUR
Bénéfice de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.879,74 EUR
./. Affectation à la réserve légale . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.660,00 EUR
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91.422,30 EUR
Signature.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
49430
FELUCA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 9-11, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 68.497.
—
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 22 avril 2002, que l’assemblée
a pris, entre autres, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée prend acte et accepte les démissions présentées par Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant
à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d’Administrateur de la société et par Monsieur Pierre
Bouchoms, employé privé, demeurant à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) de sa fonction d’Administrateur
de la société.
<i>Troisième résolutioni>
En remplacement des Administrateurs démissionnaires, l’Assemblée décide de nommer, avec effet immédiat, les Ad-
ministrateurs suivants:
- Mlle Luisa Annamaria Di Giacomo demeurant à Turin (Italie) via Cibrario 26 bis Code Postal 10144 Code Fiscal
DGCLNN76L69D205H, Avocat Stagiaire;
- Mlle Federica Di Giacomo demeurant à Turin (Italie) via Cibrario 26 bis Code Postal 10144 Code Fiscal
DGCFRC72H59D205M, employée privée.
Le mandat des administrateurs prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice clô-
turé au 31 décembre 2001.
Luxembourg, le 25 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 40, case 10. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31254/043/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
OBERLAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.813.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2002i>
<i>lors de la décision circulaire du Conseil d’Administration de la sociétéi>
En date du 1
er
mars 2002, il a été décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg au 11B, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 43, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31255/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
LE FOYER, OTTAVIANI & ASSOCIES PATRIMONIUM SICAV,
Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R. C. Luxembourg B 80.237.
—
Le bilan au 31 décembre 2001, enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 37, case *11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 avril 2002.
(31258/010/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
<i>Le Conseil d’Administration
i>C. Di Giacomo / F. Di Giacomo
<i>Administrateur / Administrateuri>
Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour OBERLAND S.A.
i>P. Sganzerla
<i>Expert comptable
Administrateur de la Sociétéi>
BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG
Société Anonyme
V. Jean / C. Hagen De Mulder
<i>Mandataire Principal / Fondé de Pouvoiri>
49431
LA BALME S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 69.696.
—
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 1i>
<i>eri>
<i> mars 2002i>
<i>lors de la décision circulaire du Conseil d’Administration de la sociétéi>
En date du 1
er
mars 2002, il a été décidé de transférer le siège social de la société du 398, route d’Esch, L-1471 Luxem-
bourg au 11B, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg.
Enregistré à Luxembourg, le 25 avril 2002, vol. 567, fol. 43, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31256/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
TROSTEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.417.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2001 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567,
fol. 32, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31261/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
TROSTEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.417.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567,
fol. 32, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Signature.
(31262/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
TROSTEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.417.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567,
fol. 32, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour publication
Pour extrait conforme et sincère
<i>Pour LA BALME S.A.
i>P. Sganzerla
<i>Expert comptable
Administrateur de la sociétéi>
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 133.845,06 EUR
Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 66.492,34 EUR
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 200.337,40 EUR
Signature.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 152.780.945,- ITL
Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 106.379.235,- ITL
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 259.160.180,- ITL
Signature.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 72.116.232,- ITL
Perte de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 80.664.713,- ITL
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 152.780.945,- ITL
49432
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur ff.i>(signé): Signature.
(31263/693/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
TROSTEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 63.417.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567,
fol. 32, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567, fol. 32, case 3. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(31264/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
KIMBERLEY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 43.064.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 2000 (version abrégée), enregistrés à Luxembourg, le 24 avril 2002, vol. 567,
fol. 32, case 3, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
AFFECTATION DU RESULTAT
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31260/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BILOXI S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxmebourg B 39.674.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 21, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
La société INVEST CONTROL, S.à r.l. a été nommée en tant que nouveau commissaire aux comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
(31267/567/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
F & S LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 53.128.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31290/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 72.116.232,- ITL
Signature.
Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 1.140.202,- LUF
Bénéfice de l’exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
168.052,- LUF
Report à nouveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 972.150,- LUF
Signature.
BILOXI S.A.
Signature
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
49433
BORDERLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.389.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31278/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BORDERLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.389.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31279/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BORDERLINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 63.389.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31280/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
ERASMUS FINANCE & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.388.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31281/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
ERASMUS FINANCE & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.388.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31282/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
ERASMUS FINANCE & INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 57.388.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31283/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
49434
EUROPEAN SYSTEMS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.818.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31284/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
EUROPEAN SYSTEMS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.818.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31285/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
EUROPEAN SYSTEMS DEVELOPMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.818.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31286/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
EURO FLOR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.495.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31287/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
EURO FLOR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.495.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31288/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
EURO FLOR INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 50.495.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2002, vol. 566, fol. 84, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31289/816/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
49435
SANTO SPIRITO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 52.450.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567,
fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31292/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
SANTO SPIRITO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 52.450.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567,
fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31293/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
SANTO SPIRITO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 52.450.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2001, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567,
fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31294/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BERMAN CORPORATION HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 81.193.
—
Suivant une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 2 avril 2002 de la société BERMAN COR-
PORATION HOLDING S.A., il a été décidé:
1. du remplacement de la société SOFICODEC, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes et de remplacer par:
INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 21, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31268/567/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
REMAPA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 32.149.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31376/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Gérantei>
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Gérantei>
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Gérantei>
BERMAN CORPORATION HOLDING S.A.
Signature
Luxembourg-Bonnevoie, le 24 avril 2002.
Signature.
49436
EDISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.161.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567,
fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31295/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
EDISA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 53.161.
—
L’assemblée générale de la société anonyme EDISA S.A., réunie à Luxembourg, le 15 mars 2002 a pris les résolutions
suivantes:
<i>Third resolutioni>
In compliance with article 100 of the commercial law of August 10, 1915, the Meeting votes for the continuation of
the Company’s activities.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides to convert the subscribed capital from ten million pesetas (ESP 10,000,000.-) sixty thousand one
hundred and one Euros twenty-one cents (EUR 60,101.21) represented by 10,000 shares without nominal value.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting decides to amend article 3 of the Articles of Incorporation, which will henceforth have the following
wording:
Art. 3. Le capital social est fixé à soixante mille cent et un euros vingt et un cents (EUR 60.101,21) divisé en dix mille
(10.000) actions sans valeur nominale.»
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31296/029/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
CDRJ PARTICIPATIONS (LUX), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 63.928.
—
Avec effet au 15 avril 2002, la société BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A., 12-16 avenue Monterey, L-
2163 Luxembourg, a dénoncé le domicile établi en ses locaux de la société à responsabilité limitée CDRJ PARTICIPA-
TIONS (LUX), S.à r.l.
A dater de ce 15 avril 2002, CDRJ PARTICIPATIONS, S.à r.l., n’a plus de siège social.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31297/029/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
FIDUCIARY ASSET BACKED SECURITIES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 47.046.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31364/211/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
BGL-MeesPierson TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
49437
CANTOBRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.272.
—
Le bilan au 30 avril 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31298/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
CANTOBRE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 50.272.
—
<i>Extrait du procès-verbali>
L’assemblée générale de la société anonyme CANTOBRE S.A. réunie au siège social le 14 mars 2001 a pris les réso-
lutions suivantes:
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting decides to convert the subscribed capital from eleven million Belgian Francs (BEF 11,000,000.-) into two
hundred seventy-two thousand six hundred eighty-two euros eighty-eight euros cents (EUR 272,682.88)
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting decides to increase the present converted capital by two thousand three hundred seventeen euros
twelve euros cents (EUR 2,317.12) to bring it from two hundred seventy-two thousand six hundred eighty-two euros
eighty-eight euros cents (EUR 272,682.88) to two hundred seventy-five thousand euros (EUR 275,000.-), represented
by eleven thousand (11,000) shares with a par value of EUR 27.50 each.
<i>Subscription - Paymenti>
The Meeting decides to accept the subscription and payment of the increasing amount of the corporate capital by
incorporation of reserves in the amount of two thousand three hundred seventeen euros twelve euro cents (EUR
2,317.12) and to allocate the profit of this increase to the present shareholders in proportion to their existing shares.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting decides to convert the authorized capital from twenty million Belgian Francs (BEF 20,000,000.-) into four
hundred ninety-five thousand seven hundred ninety-seven euros five cents (EUR 495,787.05).
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting decides to round up the converted authorized capital within the same limits by two hundred and twelve
euros ninety-five cents (EUR 212.95) to bring it to four hundred ninety-six thousand euros (EUR 496,000.-).
<i>Eight resolutioni>
The Meeting decides to amend article 5, first and second paragraph, of the Articles of Incorporation, which will hence-
forth have the following wording:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à deux cent soixante-quinze mille euros (EUR 275.000,-), représenté par onze
mille (11.000) actions d’une valeur nominale de EUR 27,50 chacune.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31299/029/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
ITECH PROFESSIONALS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.
R. C. Luxembourg B 60.349.
—
Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 30, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31445/536/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour extrait sincère et conforme
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Pour extrait conforme et sincère
J. Lorang
<i>Administrateuri>
Luxembourg, le 26 avril 2002.
Signature.
49438
BLAQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.571.
—
Suite à l’assemblée générale de la société anonyme BLAQUE S.A. réunie au siège social le 4 avril 2002, le Conseil
d’Administration se compose comme suit:
- Maarten van de Vaart, private employee, demeurant à Steinsel, administrateur;
- Hans de Graaf, private employee, demeurant à Mamer, administrateur;
- Peter Bun, private employee, demeurant à Berbourg, administrateur.
Le commissaire aux comptes est COMCOLUX S.A., une société ayant son siège social à Luxembourg.
Tous les mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale de l’année 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31302/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BLAQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.571.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567,
fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31303/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
APN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.906.
—
Suite à l’assemblée générale de la société anonyme APN HOLDING S.A. réunie au siège social le 9 avril 2002, le Con-
seil d’Administration se compose comme suit:
- Maarten van de Vaart, private employee, residing at Steinsel, administrateur;
- Hans de Graaf, private employee, residing at Mamer, administrateur;
- Peter Bun, private employee, residing at Berbourg, administrateur.
Le commissaire aux comptes est COMCOLUX S.A., une société ayant son siège social à Luxembourg.
Tous les mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale de l’année 2005.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31304/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
APN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 69.906.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567,
fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31305/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
49439
ANDELL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.068.
—
<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 31 décembre 2001i>
Entre:
Mrs Ellen Bronfman Hauptman, 18A, Danvers Street, London, United Kingdom
Et le trust:
THE CHARLES BRONFMAN TRUST, 157, Church Street, New Haven, United States of America
Mrs Ellen Bronfman Hauptman cède et vend à THE CHARLES BRONFMAN TRUST, qui accepte et acquiert 2.000
actions d’une valeur nominale de 1.000,- euros chacune, représentant 20% du capital social de la société ANDELL IN-
VESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., selon les conditions de vente et autres stipulées dans le contrat.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31313/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
ANDELL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.068.
—
<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 19 décembre 2001i>
Entre le trust:
THE C. BRONFMAN FAMILY TRUST, Chancery House, High Street Bridgetown, Barbados
Et:
Mrs Ellen Bronfman Hauptman, 18A, Danvers Street, London, United Kingdom
THE C. BRONFMAN FAMILY TRUST cède et vend à Mrs Ellen Bronfman Hauptman, qui accepte et acquiert 2.000
actions d’une valeur nominale de 1.000,- euros chacune, représentant 20% du capital social de la société ANDELL IN-
VESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., selon les conditions de vente et autres stipulées dans le contrat.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31314/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
ANDELL INVESTMENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 27, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 82.068.
—
<i>Extrait du contrat d’achat et de vente de parts sociales daté du 17 décembre 2001i>
Entre le trust:
THE CB FAMILY TRUST, 12 Par-la-ville Road, Hamilton, Bermuda
Et la société:
ANDELL HOLDINGS LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, United States of America
THE CB FAMILY TRUST cède et vend à la société ANDELL HOLDINGS LLC, qui accepte et acquiert 4.000 actions
d’une valeur nominale de 1.000,- euros chacune, représentant 40% du capital social de la société ANDELL INVEST-
MENTS (LUXEMBOURG), S.à r.l., selon les conditions de vente et autres stipulées dans le contrat.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31315/029/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
Pour extrait sincère et conforme
UNIVERSAL MANAGEMENT SERVICES, S.à r.l.
<i>Gérant
i>Signatures
49440
BRAINZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.575.
—
Suite à l’assemblée générale de la société anonyme BRAINZ S.A. réunie au siège social le 4 avril 2002, le Conseil d’Ad-
ministration se compose comme suit:
- Maarten van de Vaart, private employee, demeurant à Steinsel, administrateur;
- Hans de Graaf, private employee, demeurant à Mamer, administrateur;
- Peter Bun, private employee, demeurant à Begbourg, administrateur.
Le commissaire aux comptes est COMCOLUX S.A., une société ayant son siège social à Luxembourg.
Tous les mandats viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale de l’année 2008.
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567, fol. 29, case 8. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31306/029/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
BRAINZ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 12-16, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 57.575.
—
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 23 avril 2002, vol. 567,
fol. 29, case 8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(31307/029/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
ROBERTSON FINANCE & CO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R. C. Luxembourg B 81.390.
—
Suivant une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 2 avril 2002 de la société ROBERTSON
FINANCE & CO HOLDING S.A., il a été décidé:
1. du remplacement de la société SOFICODEC, S.à r.l. en tant que commissaire aux comptes et de remplacer par:
INVEST CONTROL, S.à r.l., avec siège social au 6, avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg.
Luxembourg, le 2 avril 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 22 avril 2002, vol. 567, fol. 21, case 4. – Reçu 12 euros.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(31269/567/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 2002.
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>H. de Graaf
<i>Administrateuri>
Pour extrait sincère et conforme
H. de Graaf
<i>Administrateuri>
ROBERTSON FINANCE & CO HOLDING S.A.
Signature
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange
Sommaire
Cafinalux S.A.
Energo Finance S.A.
LRI-Fund Management Company S.A.
Bedminster (Luxembourg), S.à r.l.
A.M.P.G. S.A., A.M.P. Grenailles S.A.
E.V.L. Distribution, S.à r.l.
Bona S.A.
Briboislux, S.à r.l.
Technology Capital Group S.A.
Technology Capital Group S.A.
FMC Finance S.à r.l. Luxembourg -IV
FMC Finance S.à r.l. Luxembourg -IV
Vantalux, S.à r.l.
LFG-London Financial Group S.A.
Yamamoto Holdings S.A.
Bristol (Luxembourg), S.à r.l.
Expense Reduction Analysts (Europe) S.A.
Parbat Finance S.A.
Suisimmo S.A.
Dreyfus Group S.A.
A.T.T.C. Services, S.à r.l.
GVV S.A.
GVV S.A.
Windows International S.A.
Leroy - Merlin & Cie Valaction
The U.S. High Yield Fund Sicav
The U.S. High Yield Fund Sicav
S.I. Investissements S.A.
S.I. Investissements S.A.
S.I. Investissements S.A.
Graphique Systèmes S.A.
Julius Baer Multicash
Omnitech S.A.
Arlvest S.A. Holding
Julius Baer Multibond
Julius Baer Multistock
Expense Reduction Analysts (European Holdings) S.A.
Benelux Partners S.A.
Benelux Partners S.A.
Benelux Partners S.A.
Luxsat International S.A.
EF Cultural Tours, S.à r.l.
EF Cultural Tours, S.à r.l.
M.M.Warburg-Luxinvest
Nestor Investment Management S.A.
Wine Acquisitions S.A.
CommTrust Investment Management S.A.
Transcontinental Investment Corporation S.A.
Acord International S.A.
Barbieri S.A.
Barbieri S.A.
Barbieri S.A.
Iefam Holding S.A.
Salp Europe S.A.
El 3000 S.A.
Vontobel Luxembourg S.A.
Fingreen S.A.
Quadrante S.A.
A.R.D. Development S.A.
A.R.D. Development S.A.
A.R.D. Development S.A.
Feluca S.A.
Oberland S.A.
Le Foyer, Ottaviani & Associés Patrimonium Sicav
La Balme S.A.
Trosten S.A.
Trosten S.A.
Trosten S.A.
Trosten S.A.
Kimberley S.A.
Biloxi S.A.
F & S Luxembourg S.A.
Borderline S.A.
Borderline S.A.
Borderline S.A.
Erasmus Finance & Investments S.A.
Erasmus Finance & Investments S.A.
Erasmus Finance & Investments S.A.
European Systems Development S.A.
European Systems Development S.A.
European Systems Development S.A.
Euro Flor Invest S.A.
Euro Flor Invest S.A.
Euro Flor Invest S.A.
Santo Spirito, S.à r.l.
Santo Spirito, S.à r.l.
Santo Spirito, S.à r.l.
Berman Corporation Holding S.A.
Remapa Holding S.A.
Edisa S.A.
Edisa S.A.
CDRJ Participations (Lux), S.à r.l.
Fiduciary Asset Backed Securities S.A.
Cantobre S.A.
Cantobre S.A.
Itech Professionals S.A.
Blaque S.A.
Blaque S.A.
APN Holding S.A.
APN Holding S.A.
Andell Investments (Luxembourg), S.à r.l.
Andell Investments (Luxembourg), S.à r.l.
Andell Investments (Luxembourg), S.à r.l.
Brainz S.A.
Brainz S.A.
Robertson Finance & Co Holding S.A.