logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

10465

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 219

8 février 2002

S O M M A I R E

Abatel S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10475

NGI S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10473

ACM/EFM  Emerging  Markets  Umbrella  Funds, 

Novalux S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10473

Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10481

Nukol S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10475

Access Self-Storage Holdings S.A., Luxembourg . .

10508

ODD Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

10474

AFIB S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10509

ODD Investments S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . 

10474

BCP Investimentos International S.A.H., Sennin- 

ÖkoVision Lux S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

10475

gerberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10466

Opacco Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

10475

Callahan  InvestCo  Germany  2,  S.à r.l.,  Luxem- 

Parnuk S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10474

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10482

Parnuk S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10474

Callahan  InvestCo  Germany  2,  S.à r.l.,  Luxem- 

Phipe Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . 

10475

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10490

Piquemal, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

10476

Callahan  InvestCo  Germany  2,  S.à r.l.,  Luxem- 

Platy Finance S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . 

10476

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10508

PNA S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . . 

10476

European  Engineering & Environment  Corpora- 

Prémaman-Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . 

10476

tion S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

10466

Quartz Finance S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10469

Intercoiffure La Coiffe, S.à r.l., Roeser. . . . . . . . . . .

10466

Refinancing & Investments S.A.H., Luxembourg  . 

10477

International Cruising S.A., Luxembourg . . . . . . . .

10466

(Les) Résidences du Golf S.A., Luxembourg . . . . . 

10469

International  Wood  Trading,  S.à r.l.,  Luxem- 

Richemont S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10477

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10467

RLT S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10477

Konsolida S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10467

RLT S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10477

Konsolida S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10467

Rolinsky Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

10478

LCF Rothschild Fund, Sicav, Luxembourg. . . . . . . .

10468

RSL S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10479

Lloyds  Americas  Asset  Management Sicav, Lu- 

S.I.I.,  Société  d’Investissement  Internationaux 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10467

S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10479

Luxco Investments Holdings S.A., Luxembourg . . .

10468

Salorix Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10478

M.R.I. Investments S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . .

10472

Salros S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . 

10479

Marine Resources Inc. S.A.H., Luxembourg . . . . . .

10470

Scala International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

10479

Marine Resources Inc. S.A.H., Luxembourg . . . . . .

10470

Scala International S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . 

10479

Mario Holding S.A., Senningerberg . . . . . . . . . . . . .

10469

Schumann-Lavédrine Finance S.A., Luxembourg . 

10473

Marita S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10471

Sheen Asia Enterprise S.A., Luxembourg  . . . . . . . 

10480

Maxad Oil & Gas, S.à r.l., Luxembourg-Kirchberg .

10471

Silver Tongue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

10511

Meline Développements S.A., Luxembourg  . . . . . .

10471

Silver Tongue S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . 

10512

Micaze S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10470

Sinpar Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

10480

Molene Financière Holding S.A., Luxembourg . . . .

10471

Sodiphar, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

10480

Monet Group S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

10472

Sofiac S.A., Luxembourg-Kirchberg . . . . . . . . . . . . 

10481

Monlux, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10468

Spa Trans, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

10481

Motorway-Luxembourg  S.A., Luxembourg-Gas- 

Stemel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10482

perich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10477

Stemel Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . 

10482

Motorway-Luxembourg  S.A., Luxembourg-Gas- 

Stratego Trust S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . 

10481

perich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10478

Suria Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

10509

Moutarderie  de  Luxembourg,  S.à r.l.,  Luxem- 

Suria Holdings, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

10509

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10473

Systel S.A. Soparfi, Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10510

Movida Contemporain, S.à r.l., Bereldange. . . . . . .

10472

Systel S.A. Soparfi, Peppange . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10511

Movida Contemporain, S.à r.l., Bereldange. . . . . . .

10472

Tanaform S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

10509

Netway S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10473

V2 Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . 

10480

10466

BCP INVESTIMENTOS INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aérogolf Center.

R. C. Luxembourg B 48.121. 

Suite à la réunion du Conseil d’Administration en date du 2 juillet 2001, Mme Dulce Maria Pereira Cardoso Mota

Jorge Jacinto, Company Director, Lisbonne (Portugal), a été cooptée en qualité d’administrateur, avec effet au 31 mai
2001, en remplacement de M. Diogo Cordeiro Crespo Cabral Campello, administrateur démissionnaire, dont elle ter-
minera le mandat.

Cette cooptation fera l’objet d’une ratification lors d’une prochaine assemblée générale des actionnaires.
Monsieur Fernando Jorge Filomeno de Figueiredo Ribeiro est en outre nommé Président du Conseil d’Administration

avec effet au 31 mai 2001.

Le 2 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 28, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61166/032/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

EUROPEAN ENGINEERING &amp; ENVIRONMENT CORPORATION S.A. HOLDING,  

Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 27.855. 

Statuts coordonnés au 1

er

 juin 2001, enregistrés à Luxembourg le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 24, case 1, déposés

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61213/531/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

INTERCOIFFURE LA COIFFE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3395 Roeser, 18, route de Bivange.

R. C. Luxembourg B 24.686. 

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg le 30 juillet 2001

Les associés de la INTERCOIFFURE LA COIFFE, S.à r.l. ont décidé de convertir le capital social en EUR rétroactive-

ment au 1

er

 janvier 2001 de la façon suivante:

Le capital social de 12.394,68   est représenté par 100 parts sociales sans valeur nominale, chacune entièrement li-

bérées en numéraire.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61259/503/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

INTERNATIONAL CRUISING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.407. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61260/024/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

<i>Pour BCP INVESTIMENTOS INTERNATIONAL S.A.
L’Agent domiciliataire
Signatures

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Signature.

Conversion de 500.000,- LUF / (40,3399). . . . . . . .

12.394,68 

Luxembourg, le 30 juillet 2001.

Signature.

INTERNATIONAL CRUISING S.A., Société Anonyme
Signature / Signature
<i>Un administrateur / <i>Un administrateur

10467

INTERNATIONAL WOOD TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 71.268. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61262/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

KONSOLIDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.409. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

(61268/587/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

KONSOLIDA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 65.409. 

<i>Extrait des décisions prises par l’assemblée générale des actionnaires en date du 20 décembre 2000

Est nommée comme nouveau commissaire aux comptes de la société, en remplacement de WOOD APPLETON

OLIVER &amp; CO. S.A., la société WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., ayant son siège social
9B, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg.

Le mandat du commissaire aux comptes viendra à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2006.

<i>Composition du conseil d’administration de la société

- Monsieur Fabio Mazzoni,
- Monsieur Benoît Georis,
- Madame Géraldine Laera Schmit.

<i>Commissaire aux comptes de la société

- WOOD APPLETON OLIVER EXPERTS-COMPTABLES, S.à r.l., société ayant son siège social 9B, boulevard du Prin-

ce Henri, L-1724 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 décembre 2000.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61267/587/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

LLOYDS AMERICAS ASSET MANAGEMENT SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.813. 

Le bilan au 31 mai 2001, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 19, case 6, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61274/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signature

<i>Un mandataire
Signature

Luxembourg, le 26 septembre 2001.

M.-C. Piasta / M.E. De Leye.

10468

LCF ROTHSCHILD FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R. C. Luxembourg B 76.441. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 27 juillet 2001

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas distribuer de dividende pour l’exercice clôturé au 31 mars 2001.
- L’Assemblée Générale Ordinaire décide le renouvellement du mandat des Administrateurs sortants pour une nou-

velle période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

- L’Assemblée Générale Ordinaire décide de réélire PricewaterhouseCoopers en qualité de Réviseur d’Entreprises,

pour une nouvelle période d’un an prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2002.

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d’Administration est composé de:

<i>Président du Conseil d’Administration

LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE, représentée par Pierre Palasi, Membre du

Directoire.

<i>Administrateurs

- L.C.F. ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT S.A., représentée par Samuel Pinto, Directeur Général Adjoint;
- Christophe Boulanger, Sous-Directeur, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE;
- François Des Robert, Directeur, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE;
- Lionel Errera, Sous-Directeur, LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE;
- Frédéric Otto, Directeur Général, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg;
- Benoît de Hults, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg;
- Geoffroy Linard de Guertechin, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg;
- Guy Verhoustraeten, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg;
- Edward de Burlet, Directeur, BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD, Luxembourg.

<i>Réviseur d’Entreprises

PricewaterhouseCoopers, Espace Ariane, 400, route d’Esch, L-1471 Strassen.

Luxembourg, le 28 septembre 2001.

(61272/010/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

LUXCO INVESTMENTS HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 60.981. 

L’assemblée générale des actionnaires, tenue en date du 18 septembre 2001, a décidé de transférer le siège social du

18, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61275/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MONLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1514 Luxembourg, 2, rue Xavier de Feller.

R. C. Luxembourg B 83.357. 

<i>Décision de l’Associé unique du 29 août 2001

Monsieur Marc Wagner, associé unique et gérant unique de la société MONLUX, S.à r.l. a décidé de transférer, avec

effet immédiat, le siège de ladite société à L-1514 Luxembourg, 2, rue Xavier de Feller, 3

ème

 étage.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61291/503/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

BANQUE PRIVEE EDMOND DE ROTHSCHILD LUXEMBOURG, Société Anonyme
V. Jean / C. Bouillon
<i>Mandataire principal / Fondé de pouvoir

Pour extrait conforme
Signature

10469

LES RESIDENCES DU GOLF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 46.783. 

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 août 2001

Les actionnaires de la société anonyme LES RESIDENCES DU GOLF S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordi-

naire, au siège social, le 29 août 2001, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

* Monsieur Dick Kwist, administrateur de sociétés, demeurant à L-1149 Luxembourg, 222, rue des Sept Arpents,

démissionne de son poste d’Administrateur de la société.

* Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
* Est nommé Administrateur en remplacement de l’Administrateur démissionnaire, jusqu’à l’Assemblée Générale An-

nuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2002, Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, de-
meurant à Luxembourg.

* Le nouvel Administrateur déclare accepter son mandat.
Le conseil d’administration aura donc désormais la composition suivante:
Monsieur François Muller, ingénieur, demeurant à Genève, Suisse;
Monsieur Henri Biermann, consultant, demeurant à Roodt-sur-Syr;
Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg. 
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les

comptes de l’exercice clos en 2002.

Par ailleurs,
* La FIDUCIAIRE ROBERT ELVINGER, ayant son siège social à L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte-Croix, démission-

ne de son poste de Commissaire aux Comptes de la société.

* Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
* Est nommé Commissaire aux Comptes en remplacement du Commissaire aux Comptes démissionnaire, jusqu’à

l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2002, la société LUX AUDIT
S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

* Le nouveau Commissaire aux Comptes déclare accepter son mandat.

Luxembourg, le 29 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61273/503/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MARIO HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff, Aerogolf Center.

R. C. Luxembourg B 72.982. 

Les comptes annuels au 30 juin 2001, enregistrés à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 28, case 5, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61278/032/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

QUARTZ FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 22.321. 

<i>Résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 6 septembre 2001

1. La démission du Commissaire aux Comptes Alain Marthoz est acceptée et décharge lui est donnée.
2. Monsieur Didier Pilier, demeurant 13B, rue de Céroux, B-1380 Lasne, est nommé Commissaire aux Comptes jus-

qu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61317/792/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour extrait conforme
Signature

Le 28 septembre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
D. Fontaine
<i>Administrateur

10470

MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 27.230. 

<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration du 21 août 2001

«... en vertu de l’autorisation lui accordée par l’assemblée générale, le conseil prend, à l’unanimité des voix, les réso-

lutions suivantes:

1. Le conseil d’administration décide de supprimer la valeur nominale des actions.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, le conseil d’admi-

nistration décide de convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2002, le capital social et le capital autorisé, actuellement exprimés

en francs belges (BEF), en euros (EUR). Ainsi, le capital social s’établit à EUR 161.130,79 (cent soixante et un mille cent
trente euros et soixante-dix-neuf cents) et le capital autorisé à EUR 2.478.935,25 (deux millions quatre cent soixante-
dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents).

3. Le conseil d’administration décide de modifier les alinéas 1

er

 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur

suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 161.130,79 (cent soixante et un mille cent trente euros et

soixante-dix-neuf cents, représenté par 6.500 (six mille cinq cents) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 2.478.935,25 (deux millions

quatre cent soixante-dix-huit mille neuf cent trente-cinq euros et vingt-cinq cents) qui sera représenté par 100.000 (cent
mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

4. Mandat est donné à chaque administrateur agissant individuellement, ou à BDO COMPAGNIE FIDUCIAIRE, afin

de procéder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir
des statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente.»

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61276/200/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MARINE RESOURCES INC., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 15, rue de la Chapelle.

R. C. Luxembourg B 27.230. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61277/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MICAZE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 29.396. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue le 15 juin 2001 à Luxembourg

L’assemblée décide de supprimer la désignation de la valeur nominale des actions, d’augmenter le capital social de la

société à concurrence de ITL 182.775,- pour le porter à ITL 450.182.775,- par incorporation du résultat reporté à due
concurrence et de convertir le capital social pour le fixer à EUR 232.500,- (deux cent trente-deux mille cinq cents euros)
avec effet au 1

er

 janvier 2001.

L’Assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la résolution qui précède.

En conséquence, l’article 5 alinéa 1

er

 des statuts aura la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa.  Le capital social est fixé  à deux cent trente-deux mille cinq cents euros (EUR 232.500,-)

représenté par quatre-vingt-dix mille (90.000) actions sans désignation de valeur nominale.»

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 24, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61288/531/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er 

octobre 2001.

Pour extrait conforme
Signatures

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

F. Baden.

Pour copie conforme
Signatures
<i>Administrateurs

10471

MARITA S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.427. 

Statuts coordonnés au 16 juillet 2001, vol. 558, fol. 24, case 1, déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61279/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MAXAD OIL &amp; GAS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 77.725. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 20, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 septembre 2001.

(61283/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MELINE DEVELOPPEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 55.353. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 28, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61285/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MOLENE FINANCIERE HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 16, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 65.795. 

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 9 août 2001

Les actionnaires de la société MOLENE FINANCIERE HOLDING S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire

au siège social le 9 août 2001, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- la démission avec effet immédiat de Monsieur Robert Elvinger, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, de son

poste d’administrateur est acceptée;

- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat;
- la démission avec effet immédiat de Monsieur Max Galowich, juriste, demeurant à Luxembourg, de son poste d’ad-

ministrateur est acceptée;

- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat;
- la démission avec effet immédiat de Monsieur Jean-Paul Frank, expert-comptable, demeurant à Luxembourg, de son

poste d’administrateur est acceptée;

- pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
- Sont nommés Administrateurs en remplacement des Administrateurs démissionnaires:
* Monsieur Jean Hoffmann, administrateur de sociétés, domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue

de l’Eau;

* Monsieur Marc Koeune, économiste, domicilié professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau;
* Madame Nicole Thommes, employée privée, domiciliée professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau;
* Madame Andrea Dany, employée privée, domiciliée professionnellement à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
- Les nouveaux Administrateurs qui déclarent accepter leur mandat respectif sont nommés jusqu’à l’Assemblée gé-

nérale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2003.

- La démission avec effet immédiat de la société LUX-AUDIT S.A., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57,

avenue de la Faïencerie, de son poste de commissaire aux comptes est acceptée.

- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat.
- Est nommée commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, la société

CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Signature.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

R. P. Pels.

10472

- Le nouveau commissaire aux comptes qui déclare accepter son mandat est nommé jusqu’à l’Assemblée générale

annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2003.

Luxembourg, le 9 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61289/503/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MONET GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 77.061. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 28, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61290/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

M.R.I. INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 50.286. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61296/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MOVIDA CONTEMPORAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 24, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.740. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 84, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(61298/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MOVIDA CONTEMPORAIN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 24, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 51.740. 

<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire du 27 août 2001

L’associé unique de la société MOVIDA CONTEMPORAIN, S.à r.l. a décidé de convertir le capital social en EUR pour

le 1

er

 janvier 2001.

Le capital social de 500.000,- LUF est ainsi converti de la façon suivante: 

Le capital social de 12.500,- EUR est représenté par 500 parts sociales de 25,- EUR chacune.

Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 84, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61299/503/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour extrait conforme
Signatures

D. C. Oppelaar.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

<i>Pour MOVIDA CONTEMPORAIN, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Conversion (40,3399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.394,68 EUR

Augmentation de capital par incorporation de réserves . . .

105,32 EUR

12.500,00 EUR

Luxembourg, le 27 août 2001.

Signature.

10473

MOUTARDERIE DE LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2529 Luxembourg, 30, rue des Scillas.

R. C. Luxembourg B 73.567. 

Les comptes annuels au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 557, fol. 84, case

8, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

(61297/503/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

NETWAY, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 61.036. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61301/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

NGI, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 64.060. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61302/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

NOVALUX S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 23.627. 

Statuts coordonnés au 17 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, vol. 558, fol. 24, case 1, déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61303/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SCHUMANN-LAVEDRINE FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 59.398. 

RECTIFICATIF

Suite  à  l’Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2001, les actionnaires de la société

SCHUMANN LAVEDRINE FINANCE S.A. souhaitent apporter la rectification suivante:

- Monsieur Olivier Lavédrine est nommé Administrateur et non Administrateur-délégué.
- Le conseil d’administration est donc composé comme suit:
- Madame Manette Ernst-Schumann, administrateur-délégué;
- Monsieur Olivier Lavédrine, administrateur;
- Monsieur François Metzler, administrateur;
- Monsieur Lex Thiellen, administrateur.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61330/503/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

<i>Pour MOUTARDERIE DE LUXEMBOURG, S.à r.l.
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Signature.

Pour extrait conforme
Signature

10474

ODD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 41.014. 

EXTRAIT

Il résulte de l’assemblée générale ordinaire de la société anonyme ODD INVESTMENTS S.A., tenue en date du 25

juin 2001 à Luxembourg, que la démission de la société BARTON PROPERTIES LTD en tant que commissaire aux comp-
tes a été acceptée et que la société CORPORATE ADVISORY BUSINESS S.A. avec siège social à Luxembourg, a été
nommée commissaire aux comptes pour un mandat de cinq ans prenant fin au terme de l’assemblée générale annuelle
de 2006.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 juillet 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61305/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

ODD INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2613 Luxembourg, 5, place du Théâtre.

R. C. Luxembourg B 41.014. 

Les bilans de la société au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000,

enregistrés à Luxembourg, le 20 septembre 2001, vol. 557, fol. 99, case 4, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61306/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

PARNUK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 35.817. 

Le bilan au 30 juin 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61309/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

PARNUK S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 35.817. 

<i>Résolutions prises par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 12 septembre 2001

1. La démission de l’administrateur Alain Marthoz est acceptée et décharge lui est donnée.
2. L’administrateur suivant est nommé jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle:
Monsieur Claude Schroeder, demeurant 498, route de Thionville, L-5886 Alzingen.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs. 

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61310/792/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

<i>Pour ODD INVESTMENTS S.A.
Signature
<i>Un administrateur

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un mandataire

D. Fontaine
<i>Administrateur

Pour extrait conforme
D. Fontaine
<i>Administrateur

10475

NUKOL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 55.705. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61304/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

ÖKOVISION LUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.642. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61307/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

OPACCO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.162. 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 septembre 2001 a décidé de transférer le siège

social de la société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61308/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

PHIPE HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 42.238. 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 septembre 2001 a décidé de transférer le siège

social de la société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61312/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

ABATEL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 59.248. 

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires en date du 3 août 2001 que:
L’Assembée Générale Extraordinaire prend acte de la démission de M. Rémy Meneguz, M. Giovanni Vittore et M.

Frédéric Noël, Administrateurs, et leur accorde décharge pleine et entière.

L’Assemblée appelle aux fonctions d’administrateurs:
- M. José Marc Vincentelli, employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Président du Conseil d’Administration;
- M. Raffaele Gentile, employé privé, demeurant à L-Wormeldange-Haut, Administrateur;
- M. Federico Roberto Marro, employé privé, demeurant à L-Luxembourg, Administrateur.
Les nouveaux Administrateurs termineront le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  

Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61388/058/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

F. Baden.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

F. Baden.

Signature.

Signature.

ABATEL S.A.
Signature

10476

PIQUEMAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 80.262. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 28, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61313/724/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

PLATY FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.315. 

Statuts coordonnés au 18 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, vol. 558, fol. 24, case 1, déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61314/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

PNA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 72.754. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 19, case 11, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 août 2001.

(61315/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

PREMAMAN-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 8, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 36.137. 

<i>Extrait de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2001

Les actionnaires de la société PREMAMAN-LUXEMBOURG S.A., réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au

siège social, le 30 août 2001, ont décidé, à l’unanimité, de prendre les résolutions suivantes:

- Monsieur Gaston Escojido, demeurant à Knokke/Heist (Belgique) démissionne de son poste d’Administrateur-Dé-

légué de la société

- Pleine et entière décharge lui est donnée pour l’exercice de son mandat
- Monsieur Gaston Escojido reste néanmoins administrateur de la société
- Est nommé Administrateur-Délégué en remplacement de l’Administrateur-Délégué  démissionnaire, jusqu’à  l’As-

semblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos en 2004, Monsieur Denis Escojido, di-
recteur de société, demeurant à B-1180 Uccle

- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’Administrateur-Délégué ou par celle

de deux administrateurs dont l’Administrateur-Délégué qui détient un droit de co-signature obligatoire.

Le conseil d’administration garde donc la même composition, à savoir:
Monsieur Gaston Escojido, demeurant à Knokke/Heist (Belgique)
Monsieur Denis Escojido, demeurant à Uccle (Belgique) (Administrateur-Délégué)
Monsieur Raymond Errera, demeurant à Bruxelles (Belgique)
Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle appelée à statuer sur les

comptes de l’exercice clos en 2004.

Luxembourg, le 30 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 11 septembre 2001, vol. 557, fol. 66, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61316/503/29) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

 

D. C. Oppelaar.

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Signature.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Pour extrait conforme
Signatures

10477

REFINANCING &amp; INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 4.728. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61319/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

RICHEMONT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.576. 

Le texte des statuts coordonnés a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre

2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61320/226/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

RLT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 45.713. 

Le bilan au 30 juin 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61321/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

RLT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 45.713. 

Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61322/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MOTORWAY-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg-Gasperich, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.047. 

Constituée le 24 février 1989 suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire à Luxembourg-Bonnevoie, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, n

°

 186 du 6 juillet 1989 et modifiée suivant acte reçu par

le prédit notaire Tom Metzler, en date du 1

er

 octobre 1999, non encore publié au Mémorial C.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 3 septembre 2001

<i>Attribution de titres et pouvoirs

<i>1. Directeur Général

Le conseil d’administration décide de retirer le titre de Directeur Général, attribué à Monsieur C. Baer et de retirer,

à partir du 1

er

 septembre 2001, les pouvoirs lui attribués par décision du conseil d’administration du 21 mars 2000.

Le conseil d’administration attribue le titre de Directeur Général à Monsieur François-Xavier Dumont de Chassart,

demeurant à L-1952 Luxembourg, 14, rue Nina et Julien Lefèvre.

Dans les limites des articles 11 et 12 des statuts qui requièrent la signature conjointe de deux mandataires pour les

engagements dans le cadre de la gestion journalière, Monsieur Xavier Dumont de Chassart, directeur général, est char-

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

F. Baden.

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signature

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signature

10478

gé, conformément à l’article 11 des statuts, à partir du 1

er

 septembre 2001, de la gestion journalière et de la représen-

tation de la société en ce qui concerne cette gestion, conformément aux statuts avec

- un administrateur,
- le directeur
- un autre mandataire désigné par le conseil d’administration.

<i>2. Mandataires

Le conseil désigne, en application des articles 11 et 12 des statuts, les personnes suivantes en tant que mandataires:
- Monsieur Ralf Hirtz, demeurant à Soterstrasse 28, 54295 Trier, Allemagne;
- Monsieur Raphaël de Liedekerke.
Monsieur Raphaël de Liedekerke bénéficiera plus particulièrement à cet effet de pouvoirs de signature vis-à-vis des

organismes financiers suivant procuration spécifique.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61294/222/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

MOTORWAY-LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1014 Luxembourg-Gasperich, 310, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 30.047. 

Constituée le 24 février 1989 suivant acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire à Luxembourg-Bonnevoie, publié au

Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 186 du 6 juillet 1989 et modifiée suivant acte
reçu par le prédit notaire Tom Metzler, en date du 1

er

 octobre 1999, non encore publié au Mémorial C.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2001

L’assemblée prend acte de la démission de Monsieur Etienne Deleval en tant qu’administrateur à partir du 7 mars

2001.

L’assemblée décide de nommer en qualité d’administrateur Monsieur Guy Lafage, demeurant 1170 Bruxelles, 7, Squa-

re de l’Arbalète.

Son mandat prendra cours ce jour pour une durée de trois ans et s’achèvera à l’issue de l’assemblée générale de l’an

2004.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61295/222/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

ROLINSKY HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 42.914. 

Statuts coordonnés au 17 juillet 2001, enregistrés à Luxembourg, vol. 558, fol. 24, case 1, déposés au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61323/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SALORIX HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 38.749. 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue en date du 7 septembre 2001 a décidé de transférer le siège

social de la société du 400, route d’Esch, L-1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61326/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour extrait conforme
J.-L. Layon / G. Lafage
<i>Administrateurs

Pour extrait conforme
J.-L. Layon / G. Lafage
<i>Administrateur / Administrateur

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

Signature.

Signature.

10479

RSL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2338 Luxembourg, 13, rue Plaetis.

R. C. Luxembourg B 68.350. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61325/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SALROS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 78.197. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 20, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 septembre 2001.

(61327/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SCALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 16.121. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61328/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SCALA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 16.121. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61329/792/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

S.I.I., SOCIETE D’INVESTISSEMENT INTERNATIONAUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 241, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 75.632. 

Il résulte d’une décision prise en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 19 septembre 2001 que Monsieur

Jean-Luc Gerard, commerçant, demeurant à F-Betting-les-St. Avold a été nommé administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 13, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61336/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

D. Fontaine
<i>Administrateur

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

D. Fontaine
<i>Administrateur

D. Fontaine
<i>Administrateur

Signature.

10480

SHEEN ASIA ENTERPRISE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 57.968. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61331/792/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SINPAR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 31, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 71.396. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 31, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

(61334/024/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SODIPHAR, Société à responsabilité limitée Holding.

Capital social: LUF 1.000.000,-.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 398, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 55.822. 

En date du 23 août 2001, l’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société du 400, route d’Esch, L-

1471 Luxembourg au 398, route d’Esch, L-1471 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 2001, vol. 558, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61337/502/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

V2 HOLDING, Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 10A, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 71.169. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 71, case 2, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 27 juillet 2001

AFFECTATION DU RESULTAT

Le bénéfice de EUR 49.755,37 est affecté comme suit: 

La répartition des résultats est conforme à la proposition d’affectation.
L’assemblée ratifie la décision prise par le conseil d’administration du 10 avril 2000 à savoir l’acceptation de la démis-

sion de Madame Patricia Thill, administrateur de la société, et la nomination en qualité de nouvel administrateur de Ma-
dame Paule Kettenmeyer, Maître en droit, demeurant à Luxembourg. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée
générale à tenir en 2005.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61362/297/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

STRATEGO INT’L, S.à r.l.
<i>Domiciliataire
Signature

SINPAR HOLDING S.A.
Société Anonyme Holding
Signatures
<i>Administrateurs

Signature.

affectation à la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.487,77 EUR

report sur l’exercice suivant . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.267,60 EUR

Bénéfice de l’exercice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49.755,37 EUR

Signature.

10481

SOFIAC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.

R. C. Luxembourg B 59.717. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 20, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 septembre 2001.

(61338/521/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SPA TRANS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2630 Luxembourg, 7, rue de Trèves.

<i>Décision collective du 11 mai 2001

Le soussigné, Monsieur David Fisher, seul associé de la S.à r.l. SPA TRANS, a pris ce jour les décisions suivantes à

l’unanimité.

1. Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2000 et le rapport de gestion pour l’année 2000 sont approuvés.
2. Décharge est donnée au gérant Monsieur David Fisher, pour l’exercice de son mandat pour l’année 2000.
3. La perte de l’exercice 2000 au montant de 34.545 LUF est reportée à nouveau.

<i>Rapport de gestion sur l’année 2000

L’année 2000 se clôture avec une perte de 34.545,- LUF. Au cours de l’exercice 2000 les affaires ont connu un déve-

loppement normal.

Enregistré à Luxembourg, le 19 septembre 2001, vol. 557, fol. 96, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61339/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

STRATEGO TRUST S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R. C. Luxembourg B 81.625. 

<i>Résolution prise par le conseil d’administration du 10 avril 2001

Messieurs Michel Reynders et Herbert Grossmann sont nommés administrateurs-délégués, avec pouvoir d’engager

la société sous leur seule signature dans le cadre de la gestion journalière.

Enregistré à Luxembourg, le 26 septembre 2001, vol. 558, fol. 21, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61342/792/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

ACM/EFM EMERGING MARKETS UMBRELLA FUNDS, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 47.220. 

Faisant suite à l’assemblée générale extraordinairement tenue au 22 août 2001, sont nommés administrateurs:
- Johann Kernbauer, Directeur Général. Capital Invest, Obere Donaustraße 19. A-1020 Vienne.
- Margarete Strasser, Vice-Président. CAPITAL INVEST. Obere Donaustraße 19. A-1020 Vienne.
- Robert Schredl, Service Legal. CAPITAL INVEST, Obere Donaustraße 19. A- 1020 Vienne.
- Yves Prussen, Docteur en droit. ELVINGER, HOSS &amp; PRUSSEN. 2, place Winston Churchill, B.P. 425, L-2014

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 septembre 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 27 septembre 2001, vol. 558, fol. 25, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61392/051/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

STENHAM GESTINOR AUDIT, S.à r.l.
Signature

Luxembourg, le 11 mai 2001.

D. Fisher.

Pour extrait conforme
H. Grossmann / D. Fontaine
<i>Administrateur / Administrateur

STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A.

10482

STEMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration du 21 août 2001

«... En vertu de cette autorisation, les membres du conseil d’administration décident de prendre les résolutions sui-

vantes par voie circulaire:

1. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 octobre 2001, le capital social, actuellement exprimé en francs luxembourgeois (LUF), en

euros (EUR), de sorte qu’il s’établisse à EUR 2.027.769,03 (deux millions vingt-sept mille sept cent soixante-neuf euros
et trois cents).

2. Il est décidé d’augmenter le capital social souscrit par incorporation de bénéfices reportés de EUR 12.230,97 (dou-

ze mille deux cent trente euros et quatre-vingt-sept cents) de sorte qu’il s’établisse à EUR 2.040.000,00 (deux millions
quarante mille euros) sans émission d’actions nouvelles.

3. Il est décidé d’augmenter le capital autorisé de sorte qu’il s’établisse à EUR 12.400.000,00 (douze millions quatre

cent mille euros)

4. Il est décidé de modifier les alinéas 1 et 4 de l’article 5 des statuts pour leur donner la teneur suivante:

«Art. 5. 1

er

 alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 2.040.000,00 (deux millions quarante mille euros), représenté

par 4.000 (quatre mille) actions sans désignation de valeur nominale.»

«4

ème

 alinéa. Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de 12.400.000,00 (douze millions

quatre cent mille euros) qui sera représenté par des actions sans désignation de valeur nominale.»

5. Il est décidé de donner mandat à chaque gérant, agissant individuellement, afin de procéder aux écritures compta-

bles qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des statuts coordonnés suite aux
résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 21 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 août 2001, vol. 557, fol. 30, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61340/200/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

STEMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61341/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

CALLAHAN InvestCo GERMANY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

In the year two thousand one, on the fifth day of September.
Before Us, Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Hesperange.

There appeared for an Extraordinary General Meeting (the «Meeting») of the shareholders of CALLAHAN InvestCo

GERMANY 2, S.à r.l., (the «Company»), a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 58,
rue Charles Martel in L-2134 Luxembourg, in the process of registration with the Trade and Companies Registry at the
District Court of Luxembourg, constituted by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated July
11, 2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

CALLAHAN ASSOCIATES INTERNATIONAL L.L.C., a limited liability company organised under the laws of the

State of Delaware, United States of America, having its registered office at 33 Riverside Avenue, Third Floor, Westport,
Connecticut 06880-422358, United States of America;

hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy issued on

September 5, 2001;

Mr Wesley Dickson, company director, residing at Westport, Connecticut 06880-422358, United States of America;
hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy issued on

September 5, 2001;

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registra-
tion authorities.

The representative of the shareholders declares and requests the notary to state that:
I. Five hundred shares (500) shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share, representing the

entirety of the voting share capital of the Company of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) are duly rep-

Pour extrait conforme
Signature

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

F. Baden.

10483

resented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda,
hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 3,756,250.- (three million seven hundred fifty-

six thousand two hundred and fifty Euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount
of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 3,768,750.- (three million seven hundred sixty-eight thou-
sand seven hundred and fifty Euro) by way of the creation and issue of 150,250 (one hundred fifty thousand two hundred
fifty) new ordinary shares, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

3. Subscription to the increase specified under item 2. above and payment of the subscribed shares;
4. Decrease of the share capital of the Company from its new amount of EUR 3,768,750.- (three million seven hun-

dred sixty-eight thousand seven hundred and fifty Euro) to EUR 3,756,250.- (three million seven hundred fifty-six thou-
sand two hundred and fifty Euro) by way of the cancellation of 495 (four hundred ninety-five) ordinary shares held by
CALLAHAN ASSOCIATES INTERNATIONAL L.L.C. and 5 (five) shares of Mr Wesley Dickson with the repayment to
CALLAHAN ASSOCIATES INTERNATIONAL L.L.C. of an amount of EUR 12,375.- (twelve thousand three hundred
seventy-five Euro) and to Mr Wesley Dickson of an amount of EUR 125.- (one hundred and twenty-five Euro) corre-
sponding to the nominal amount of the shares cancelled which have been totally subscribed and paid up;

5. Amendment of article 4, first indent of the Company’s articles of association, in order to (i) reflect the increase

specified under item 2. above and (ii) reflect the decrease specified under item 4. above; and

6. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority

to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares and of the cancelled stock in the share register of the Company.

III. The shareholders state unanimously:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the shareholders being represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the
agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase and hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR

3,756,250.- (three million seven hundred fifty-six thousand two hundred and fifty Euro) in order to bring the share cap-
ital of the Company from its present amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred Euro) to EUR 3,768,750.-
(three million seven hundred sixty-eight thousand seven hundred and fifty Euro) by way of the creation and issue of
150,250 (one hundred fifty thousand two hundred fifty) new ordinary shares, having a par value of EUR 25.- (twenty-
five Euro) each.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions and payments to the share capital increase:

Intervention - Subscription - Payment

Thereupon:
GERMANY TELECOMMUNICATIONS 1, S.à r.l., having its registered office at 43 Grosvenor Street, Fourth Floor,

London, W1X 9FH, England («GT»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a
proxy issued on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 27,551 (twenty-seven thousand five hundred fifty-one)
newly issued ordinary shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay
them up entirely by a contribution in kind consisting of 23,274 (twenty-three thousand two hundred seventy-four) Class
A ordinary shares - series X held by GT in CALLAHAN InvestCo GERMANY 1, S.à r.l., a Luxembourg société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at 58, rue Charles Martel, L- 2134 Luxembourg, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Registry under the number B 74 512 («InvestCo 1»), having a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each;

SANTANDER CENTRAL HISPANO BANK &amp; TRUST (BAHAMAS) LTD., having its registered office at PO Box

N1682, Bahamas Financial Centre, 3er floor, Charlotte and Shirley Street, Nassau, Bahamas («SANTANDER BAHA-
MAS»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a proxy issued on September 5,
2001, declares to (i) subscribe 23,143 (twenty-three thousand one hundred forty-three) newly issued ordinary shares
of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up entirely by a contribution
in kind consisting of 19,550 (nineteen thousand five hundred fifty) Class A ordinary shares - series X held by
SANTANDER BAHAMAS in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

CALLAHAN ASSOCIATES HOLDINGS (GERMANY 1) L.L.C., having its registered office at c/o Suite 650, 3200

Cherry Creek South Drive, Denver, Colorado 80209. U.S.A. («CAI-INVESTOR»), hereby represented by Me Gérald
Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a proxy issued on September 5, 2001 declares to (i) subscribe 2,394 (two
thousand three hundred ninety-four) newly issued ordinary shares of the Company, having a par value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up entirely by a contribution in kind consisting of 2,022 (two thousand twen-
ty-two) Class A ordinary shares - series X held by CAI-INVESTOR in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.-
(twenty-five Euro) each;

ML PRIVATE EQUITY ASSOCIATES II L.L.C., having its registered office at World Financial Center, 250 Vesey Street,

North Tower 12th Floor, New York, NY 10281, U.S.A. («ML»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-
law, acting by virtue of a proxy issued on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 5,511 (five thousand five hundred

10484

and eleven) newly issued ordinary shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and
(ii) to pay them up entirely by a contribution in kind consisting of 4,656 (four thousand six hundred fifty-six) Class A
ordinary shares - series X held by ML in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

CAPITAL COMMUNICATIONS CDPQ, INC., having its registered office at 1981, McGill College Avenue, Montreal

(Quebec) Canada H3A3C7 («CDPQ»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a
proxy issued on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 51,796 (fifty-one thousand seven hundred ninety-six) newly
issued ordinary shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up
entirely by a contribution in kind consisting of 43,754 (forty-three thousand seven hundred fifty-four) Class A ordinary
shares - series X held by CDPQ in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

TRIMARAN FUND II, L.L.C., having its registered office at 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY 10019,

U.S.A. («TFII»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a proxy issued on Sep-
tember 5, 2001, declares to (i) subscribe 2,459 (two thousand four hundred fifty-nine) newly issued ordinary shares of
the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up entirely by a contribution
in kind consisting of 2,077 (two thousand seventy-seven) Class A ordinary shares - series X held by TFII INT. in InvestCo
1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each; 

TRIMARAN PARALLEL FUND II, L.P., having its registered office at 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York,

NY 10019, U.S.A. («TPFII»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a proxy issued
on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 638 (six hundred thirty-eight) newly issued ordinary shares of the Com-
pany, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up entirely by a contribution in kind
consisting of 539 (five hundred thirty-nine) Class A ordinary shares - series X held by TPFII in InvestCo 1, having a nom-
inal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each; 

TRIMARAN CAPITAL, L.L.C., having its registered office at 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY

10019, U.S.A. («TC LLC»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a proxy issued
on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 173 (one hundred seventy-three) newly issued ordinary shares of the
Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up entirely by a contribution in
kind consisting of 147 (one hundred forty-seven) Class A ordinary shares - series X held by TC LLC in InvestCo 1, having
a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

CIBC WORLD MARKETS IRELAND LIMITED, having its registered office at 425 Lexington Avenue, Third Floor,

New York, NY 10019, U.S.A. («CIBC WM»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue
of a proxy issued on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 1,607 (one thousand six hundred and seven) newly
issued ordinary shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up
entirely by a contribution in kind consisting of 1,358 (one thousand three hundred fifty-eight) Class A ordinary shares -
series X held by CIB WM in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

CIBC EMPLOYEE PRIVATE EQUITY FUND (TRIMARAN) PARTNERS, having its registered office at 425 Lexington

Avenue, Third Floor, New York, NY 10019, U.S.A. («CIBC EPEF»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-
at-law, acting by virtue of a proxy issued on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 1,737 (one thousand seven
hundred thirty-seven) newly issued ordinary shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro)
each and (ii) to pay them up entirely by a contribution in kind consisting of 1,468 (one thousand four hundred sixty-
eight) Class A ordinary shares - series X held by CIBC EPEF in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-
five Euro) each,

KDG INVESTORS, L.P., having its registered office at Walkerhouse Mary Street, P.O. Box 265, George Town, Grand

Cayman («KIL»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a proxy issued on Sep-
tember 5, 2001, declares to (i) subscribe 11,021 (eleven thousand twenty-one) newly issued ordinary shares of the Com-
pany, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up entirely by a contribution in kind
consisting of 9,310 (nine thousand three hundred and ten) Class A ordinary shares - series X held by KIL in InvestCo
1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

DSL HOLDINGS LIMITED, having its registered office at West Wind Building, P.O. Box 1111, Grand Cayman, Cay-

man Islands, B.W.I. («DSL»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a proxy is-
sued on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 6,613 (six thousand six hundred and thirteen) newly issued
ordinary shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up entirely
by a contribution in kind consisting of 5,586 (five thousand five hundred eighty-six) Class A ordinary shares - series X
held by DSL in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

AG (GERMANY) L.L.C., having its registered office at c/o Angelo Gordon &amp; Company, 26th Floor, 245 Park Avenue,

New York, N.Y. 10167, U.S.A. («AG»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a
proxy issued on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 7,722 (seven thousand seven hundred twenty-two) newly
issued ordinary shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up
entirely by a contribution in kind consisting of 6,523 (six thousand five hundred twenty-three) Class A ordinary shares
- series X held by AG in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

BOCP/BFIP/BFCP HOLDCO CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) L.P., having its registered office at c/o Walkers,

Walkers House, Mary Street, George Town, P.O. Box 265GT, Grand Cayman («BLACKSTONE OFFSHORE/FAMILY
HOLDCO»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law, acting by virtue of a proxy issued on Septem-
ber 5, 2001, declares to (i) subscribe 5,680 (five thousand six hundred eighty), newly issued ordinary shares of the Com-
pany, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii) to pay them up entirely by a contribution in kind
consisting of 4,798 (four thousand seven hundred ninety-eight) Class A ordinary shares - series X held by BLACK-
STONE OFFSHORE/FAMILY HOLDCO in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each; 

10485

INVESTCORP CGC LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office at West Wind Building, P.O. Box 1111,

Grand Cayman, Cayman Islands, B.W. I. («INVESTCORP»), hereby represented by Me Gérald Origer, attorney-at-law,
acting by virtue of a proxy issued on September 5, 2001, declares to (i) subscribe 2,205 (two thousand two hundred
and five), newly issued ordinary shares of the Company, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each and (ii)
to pay them up entirely by a contribution in kind consisting of 1,863 (one thousand eight hundred sixty-three) Class A
ordinary shares - series X held by INVESTCORP in InvestCo 1, having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five Euro)
each;

All the above mentionned subscribers to the shares of the Company are hereafter collectively referred to as the

«Non-VCOC Shareholders» and all the shares of InvestCo 1 contributed by the Non-VCOC shareholders to the Com-
pany are hereafter collectively referred to as the «Shares».

The valuation of the contribution in kind of the Shares contributed to the Company is evidenced by, inter alia, a bal-

ance sheet of InvestCo 1 as of December 31, 2000 and signed for approval by a manager of InvestCo 1, which evidences
that the aggregate value of the Shares is worth at least EUR 3,756,250.- (three million seven hundred fifty-six thousand
two hundred and fifty Euro).

It results furthermore from a certificate dated September 5, 2001, issued by a Manager of InvestCo 1 that, in accord-

ance with the records of InvestCo 1 and as of the date of issuance of the certificate:

1. the Shares are in registered form;
2. the Shares are fully paid-up;
3. the Non-VCOC Shareholders are solely entitled to the Shares and have the power to dispose of the Shares;
4. the Shares are freely transferable by the Shareholders and none of the Shares are encumbered with any pledge or

usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct on the Shares and none of the Shares are subject to any
attachment. 2,022 (two thousand twenty-two) Class A ordinary shares - series X of CALLAHAN ASSOCIATES HOLD-
INGS (GERMANY 1) L.L.C. (the «Pledgor») in the Company, pledged in favour of MERRILL LYNCH CAPITAL COR-
PORATION (the «Pledgee») pursuant to a Pledge Agreement dated 13th July, 2000 (the «Original Pledge Agreement»),
have been released pursuant to a Partial Release and Amendment Agreement dated September 5, 2001 by and between
the Pledgor and the Pledgee;

5. there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person or entity may be entitled to

demand that one or more of the Shares be transferred to it;

6. all transfer formalities required in Luxembourg subsequent to the contribution in kind of the Shares to the share

capital increase of the Company in order to perfect the transfer of the Shares to the Company have been or will be
effected upon receipt of a certified copy of the present deed, documenting the said contribution in kind; and

7. on September 5, 2001, the Shares are worth at least EUR 3,756,250.- (three million seven hundred fifty-six thou-

sand two hundred and fifty Euro), this estimation being based on generally accepted accountancy principles, such valu-
ation being supported by the enclosed balance sheet and since the balance sheet date no material changes have occurred,
which would have depreciated the contribution made to InvestCo 2.

The InvestCo 1 managers’ certificate, and the interim balance sheet of InvestCo 1 as December 31, 2000, after having

been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company from its new amount of EUR 3,768,750.- (three

million seven hundred sixty-eight thousand seven hundred and fifty Euro) to EUR 3,756,250.- (three million seven hun-
dred fifty-six thousand two hundred and fifty Euro) by way of the cancellation of 495 (four hundred ninety-five) ordinary
shares of CALLAHAN ASSOCIATES INTERNATIONAL L.L.C. and 5 (five) shares of Mr Wesley Dickson with the re-
payment to CALLAHAN ASSOCIATES INTERNATIONAL L.L.C. of an amount of EUR 12,375.- (twelve thousand three
hundred seventy-five Euro) and to Mr Wesley Dickson of an amount of EUR 125.- (one hundred and twenty-five Euro)
corresponding to the nominal amount of the shares cancelled which have been totally subscribed and paid up.

The repayment shall be effectued under observance of the provisions of the article 69 (2) of the law on commercial

companies.

The Meeting resolves to record that the shareholdings in the Company are, as a consequence of the above resolu-

tions, as follows:

 GT: 27,551 (twenty-seven thousand five hundred and fifty-one) ordinary shares of the Company;
 SANTANDER BAHAMAS: 23,143 (twenty-three thousand one hundred and forty-three) ordinary shares of the

Company;

 CAI-INVESTOR: 2,394 (two thousand three hundred and ninety-four) ordinary shares of the Company;
 ML: 5,511 (five thousand five hundred and eleven) ordinary shares of the Company; 
 CDPQ: 51,796 (fifty-one thousand seven hundred and ninety-six) ordinary shares of the Company;
 TFII: 2,459 (two thousand four hundred and fifty-nine) ordinary shares of the Company;
 TPFII: 638 (six hundred and thirty-three) ordinary shares of the Company;
 TC LLC: 173 (one hundred and seventy-three) ordinary shares of the Company;
 CIBC WM: 1,607 (one thousand six hundred and seven) ordinary shares of the Company;
 CIBC EPEF: 1,737 (one thousand seven hundred and thirty-seven) ordinary shares of the Company;
 KIL: 11,021 (eleven thousand and twenty-one) ordinary shares of the Company;
 DSL: 6,613 (six thousand six hundred and thirteen) ordinary shares of the Company;
 AG: 7,722 (seven thousand seven hundred and twenty-two) ordinary shares of the Company;
 BLACKSTONE OFFSHORE/FAMILY HOLDCO: 5,680 (five thousand six hundred and eighty) ordinary shares of the

Company;

10486

 INVESTCORP: 2,205 (two thousand two hundred and five) ordinary shares of the Company;
and the following resolutions are taken by such shareholders unanimously: 

<i>Fifth resolution

As a consequence of the third and the fourth resolutions, the Meeting resolves to amend article 4, first indent of the

Company’s articles of association, so that it shall henceforth read as follows:

«Art. 4. First indent - Capital
The Company’s subscribed and fully paid share capital is fixed at three million seven hundred fifty-six thousand two

hundred and fifty Euro (EUR 3,756,250.-), represented by one hundred fifty thousand two hundred fifty (150,250) ordi-
nary shares having a nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) per share.»

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares and of the cancelled stock in the share register
of the Company.

Nothing else being on the agenda, the Meeting is closed.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the amount of 3,756,250 Euro is evaluated at 151,526,749.- LUF .
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of this deed, is approximately 1,700,000.- LUF.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version including the amendment of article
4 of the articles of association. At the request of the appearing person and in case of discrepancies between the English
and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing person, the said appearing person signed with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal, incluant la traduction allemande de l’article 6 des statuts:

L’an deux mille un, le cinq septembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu pour une Assemblée Générale Extraordinaire (l’«Assemblée») des associés de CALLAHAN InvestCo

GERMANY 2, S.à r.l. (la «Société») ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, en cours d’en-
registrement au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée sous la forme d’une société à res-
ponsabilité limitée suivant acte reçu par Me Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 juillet 2001,
lequel n’a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

CALLAHAN ASSOCIATES INTERNATIONAL L.L.C., une société anonyme organisée selon les lois de l’Etat du De-

laware, aux Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social à 33 Riverside Avenue, Third Floor, Westport, Connecticut
06880-422358, Etats-Unis d’Amérique, 

ici représentée par Me Gérald Origer, avocat résidant au Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé,

donnée le 5 septembre 2001.

M. Wesley Dickson, administrateur de sociétés, résidant à Westport, Connecticut 06880-422358, Etats-Unis d’Amé-

rique,

ici représenté par Me Gérald Origer, avocat résidant au Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé,

donnée le 5 septembre 2001.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

instrumentaire, resteront annexées au présent acte afin d’être enregistrées avec l’acte auprès des administrations.

Le représentant des associés expose et prie le notaire d’acter que:
I. Cinq cents (500) parts sociales ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25,-) chacune, représentant la

totalité du capital social votant de la Société d’un montant de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500,-) sont repré-
sentées à l’Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points
figurant à l’ordre du jour tel que ci-après reproduit.

II. Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 3.756.250 (trois millions sept cent cinquante-

six mille deux cent cinquante Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille cinq cents Euro)
à un montant de EUR 3.768.750 (trois millions sept cent soixante-huit mille sept cent cinquante Euro) par la création et
l’émission de 150.250 (cent cinquante mille deux cent cinquante) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

3. Souscription à l’augmentation telle que spécifiée au point 2. ci-avant et paiement des parts souscrites
4. Réduction du capital social de la Société pour le porter de EUR 3.768.750,- (trois millions sept cent soixante-huit

mille sept cent cinquante Euro) à un montant de EUR 3.756.250 (trois millions sept cent cinquante-six mille deux cent
cinquante Euro) par l’annulation de 495 (quatre cent quatre-vingt-quinze) parts sociales ordinaires détenues par CAL-
LAHAN ASSOCIATES INTERNATIONAL L.L.C. et 5 (cinq) parts sociales ordinaires détenues par M Wesley Dickson,

10487

par remboursement à CALLAHAN ASSOCIATES INTERNATIONAL L.L.C. d’un montant de EUR 12.375 (douze mille
trois cent soixante-quinze Euro) et à M Wesley Dickson d’un montant de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euro) correspon-
dant au nombre respectif de parts sociales annulées qui avaient été intégralement souscrites et libérées;

5. Modification de l’article 4, premier alinéa, des statuts de la Société pour refléter (i) l’augmentation de capital telle

que spécifiée au point 2. ci-avant et (ii) la réduction de capital spécifiée au point 4. ci-avant; et

6. Modification du registre des associés et pouvoir accordé à tout avocat ou employé de BEGHIN &amp; FEIDER en as-

sociation avec ALLEN &amp; OVERY afin de réaliser les inscriptions concernant les parts sociales nouvellement émises et
celles relatives à l’annulation des parts sociales dans le registre des associés.

III. L’Assemblée décide unanimement:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représentée, l’Assemblée décide de faire abstraction des convocations d’usage, les

associés représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du
jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 3.756.250 (trois millions sept

cent cinquante-six mille deux cent cinquante Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 12.500 (douze mille
cinq cent Euro) à un montant de EUR 3.768.750 (trois millions sept cent soixante-huit mille sept cent cinquante Euro)
par la création et l’émission de 150.250 (cent cinquante mille deux cent cinquante) parts sociales ordinaires, ayant une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune,

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer les souscriptions et paiements suivants, relatifs à l’augmentation de

capital susmentionnée:

Intervention - Souscription - Paiement

GERMANY TELECOMMUNICATION 1, S.à r.l., ayant son siège social au 43, Grosvenor Street, quatrième étage,

Londres, W1X 9FH, Royaume-Uni («GT»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration
sous seing privé, donnée le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 27.551 (vingt-sept mille cinq cent cinquante et une)
parts sociales ordinaires de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer en-
tièrement par un apport en nature consistant en 23.274 (vingt-trois mille deux cent soixante-quatorze) parts sociales
de catégorie A, série X, détenues par GT dans le capital social de CALLAHAN INVESTCO GERMANY 1, S.à r.l., société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, enre-
gistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74 512 (InvestCo 1), d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

SANTANDER CENTRAL HISPANO BANK &amp; TRUST (BAHAMAS) LTD., ayant son siège social à PO Box N1682,

Bahamas Financial Center, 3rd floor, Charlotte and Shirley Street, Nassau, Bahamas («SANTANDER BAHAMAS»), ici
représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 5 septembre 2001,
déclare (i) souscrire 23.143 (vingt-trois mille cent quarante-trois) parts sociales ordinaires de la Société d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature consistant en
19.550 (dix-neuf mille cinq cent cinquante) parts sociales ordinaires de catégorie A - série X, détenues par SANTAN-
DER BAHAMAS dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

CALLAHAN ASSOCIATES HOLDING (GERMANY 1) L.L.C., ayant son siège social à Suite 650, 3200 Cherry Creek

South Drive, Denver, Colorado 80209, USA («CAI-INVESTOR»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en ver-
tu d’une procuration sous seing privé, donnée le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 2.394 (deux mille trois cent
quatre-vingt-quatorze) parts sociales ordinaires de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) cha-
cune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature consistant en 2.022 (deux mille vingt-deux) parts sociales
ordinaires de catégorie A - série X, détenues par CAI-INVESTOR dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur no-
minale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

ML PRIVATE EQUITY ASSOCIATES II L.L.C., ayant son siège social au World Trade Financial Center, 250 Vesey

Street, North Tower 12th Floor, New York 10281, USA. («ML»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu
d’une procuration sous seing privé, donnée le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 5.511 (cinq mille cinq cent onze)
parts sociales ordinaires de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer en-
tièrement par un apport en nature consistant en 4.656 (quatre mille six cent cinquante-six) parts sociales ordinaires de
catégorie A - série X, détenues par ML IBK dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-
cinq Euro) chacune; 

CAPITAL COMMUNICATIONS CDPQ, INC., ayant son siège social au 1981, McGill College Avenue, Montreal

(Quebec) Canada H3A3C7 («CDPQ»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous
seing privé, donnée le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 51.796 (cinquante et un mille sept cent quatre-vingt-seize)
parts sociales ordinaires de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer en-
tièrement par un apport en nature consistant en 43.754 (quarante-trois mille sept cent cinquante-quatre) parts sociales
ordinaires de catégorie A - série X, détenues par CDPQ dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de
EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

TRIMARAN FUND II L.L.C., ayant son siège social au 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY 10019,

USA. («TFII»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 5
septembre 2001, déclare (i) souscrire 2.459 (deux mille quatre cent cinquante-neuf) parts sociales ordinaires de la So-
ciété d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature

10488

consistant en 2.077 (deux mille soixante-dix-sept) parts sociales ordinaires de catégorie A - série X, détenues par TFII
dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

TRIMARAN PARALLEL FUND II, L.P., ayant son siège social au 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY

10019, USA. («TPFII»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous seing privé, don-
née le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 638 (six cent trente-huit) parts sociales ordinaires de la Société d’une
valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature consistant
en 539 (cinq cent trente-neuf) parts sociales ordinaires de catégorie A - série X, détenues par TPFII dans le capital social
de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

TRIMARAN CAPITAL, L.L.C., ayant son siège social au 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY 10019,

USA. («TC LLC»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée
le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 173 (cent soixante-treize) parts sociales ordinaires de la Société d’une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature consistant en 147
(cent quarante-sept) parts sociales ordinaires de catégorie A - série X, détenues par TC LLC dans le capital social de
InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

CIBC WORLD MARKETS IRELAND LIMITED, ayant son siège social au 425 Lexington Avenue, Third Floor, New

York, NY 10019, USA. («CIBC WM»), ici représentée Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous seing
privé, donnée le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 1.607 (mille six cent sept) parts sociales ordinaires de la Société
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature con-
sistant en 1.358 (mille trois cent cinquante-huit) parts sociales ordinaires de catégorie A, série X, détenues par CIBC
WM dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

CIBC EMPLOYEE PRIVATE EQUITY FUND (TRIMARAN) PARTNERS, ayant son siège social au 425 Lexington Ave-

nue, Third Floor, New York, NY 10019, USA. («CIBC EPEF»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu
d’une procuration sous seing privé, donnée le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 1.737 (mille sept cent trente-sept)
parts sociales ordinaires de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer en-
tièrement par un apport en nature consistant en 1.468 (mille quatre cent soixante-huit) parts sociales ordinaires de ca-
tégorie A, série X, détenues par CIBC EPEF dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,-
(vingt-cinq Euro) chacune;

KDG INVESTORS L.P., ayant son siège social à Walkerhouse Mary Street, P.O. Box 265, George Town, Grand Cay-

man, Cayman Islands («KIL»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous seing privé,
donnée le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 11.021 (onze mille vingt et une) parts sociales ordinaires de la Société
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature con-
sistant en 9.310 (neuf mille trois cent dix) parts sociales ordinaires de catégorie A, série X, détenues par KIL dans le
capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

DSL HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social au West Wind Building, P.O. Box 1111, Grand Cayman, Cayman

Islands, B.W.I: («DSL»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous seing privé, don-
née le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 6.613 (six mille six cent treize) parts sociales ordinaires de la Société
d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature con-
sistant en 5.586 (cinq mille cinq cent quatre-vingt-six) parts sociales ordinaires de catégorie A, série X, détenues par
DSL dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

AG (GERMANY) L.L.C., ayant son siège social à Angelo Gordon &amp; Company, 26th floor, 245 Park Avenue, New

York, N.Y. 10167, USA. («AG»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous seing
privé, donnée le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 7.722 (sept mille sept cent vingt-deux) parts sociales ordinaires
de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport
en nature consistant en 6.523 (six mille cinq cent vingt-trois) parts sociales ordinaires de catégorie A, série X, détenues
par AG dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune,

BOCP/BFIP/BFCP HOLDCO CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) L.P., ayant son siège social à Walkers, Walkers Hou-

se, Mary Street, George Town, P.O. Box 265GT, Grand Cayman («BLACKSTONE OFFSHORE/FAMILY HOLDCO»),
ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée le 5 septembre 2001,
déclare (i) souscrire 5.680 (cinq mille six cent quatre-vingt) parts sociales ordinaires de la Société d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un apport en nature consistant en 4.798 (quatre
mille sept cent quatre-vingt-dix-huit) parts sociales ordinaires de catégorie A, série X, détenues par BLACKSTONE
OFFSHORE/FAMILY HOLDCO dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro)
chacune;

INVESTCORP CGC LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à West Building, P.O. Box 1111, Grand Cayman

Cayman Islands, B.W.I. («INVESTCORP»), ici représentée par Me Gérald Origer, avocat, en vertu d’une procuration
sous seing privé, donnée le 5 septembre 2001, déclare (i) souscrire 2.205 (deux mille deux cent cinq) parts sociales or-
dinaires de la Société d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune, et (ii) les payer entièrement par un
apport en nature consistant en 1.863 (mille huit cent soixante-trois) parts sociales ordinaires de catégorie A, série X,
détenues par BLACKSTONE OFFSHORE/FAMILY HOLDCO dans le capital social de InvestCo 1, d’une valeur nominale
de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

Les souscripteurs des parts sociales de la Société susmentionnés sont collectivement désignés comme les «Partenai-

res Non-VCOC» et toutes les parts sociales de InvestCo 1 souscrites par les Partenaires Non-VCOC sont désignées
par les «Parts Sociales».

L’évaluation de l’apport en nature, à la Société, des Parts Sociales se base, inter alia, sur un bilan de InvestCo 1 au 31

décembre 2000, signé et approuvé par le gérant de InvestCo 1, et démontrant que les Parts Sociales apportées à la So-

10489

ciété ont une valeur nominale minimale de EUR 3.756.250,- (trois millions sept cent cinquante-six mille deux cent cin-
quante Euro).

De plus, il résulte d’un certificat en date du 5 septembre 2001, signé par le gérant de InvestCo 1, que:
1. les Parts Sociales sont sous formes nominatives;
2. les Parts Sociales sont entièrement libérées;
3. les Partenaires Non-VCOC sont seuls propriétaires des Parts Sociales et sont seuls attitrés à disposer des Parts

Sociales; 

4. les Parts Sociales sont librement cessibles et ne sont grevées d’aucune sûreté ou privilège; 2.022 (deux mille vingt-

deux) parts sociales ordinaires de classe A, série X, détenues par CALLAHAN ASSOCIATES HOLDINGS (GERMANY)
L.L.C. (le «débiteur gagiste») dans le capital social de InvestCo 1 et nanties au profit de MERRILL LYNCH CAPITAL
CORPORATION (le «créancier gagiste») par un acte de nantissement en date du 13 juillet 2000, ont été libérées par
un acte de libération partielle en date du 5 septembre entre le débiteur gagiste et le créancier gagiste;

5. aucun droit de préemption ni aucun droit permettant à un tiers de réclamer qu’une ou plusieurs Parts Sociales lui

soient cédées n’est attaché aux Parts Sociales,

6. toutes les formalités requises au Luxembourg pour l’apport en nature ont été ou vont être remplies sur réception

d’une copie du présent acte par le notaire soussigné;

7. au 5 septembre 2001, les Parts Sociales apportées à la Société ont une valeur nominale minimum de EUR 3.756.250

(trois millions sept cent cinquante-six mille cent deux cent cinquante Euro), cette estimation étant fondée sur les prin-
cipes généraux de comptabilité, appuyée par le bilan ci-inclus et aucun événement ultérieur n’étant venu déprécier la
valeur de l’apport fait à la Société.

Le certificat délivré par le gérant de InvestCo 1 ainsi que le bilan intermédiaire de InvestCo au 31 décembre 2000,

après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties et le notaire soussigné, seront
annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société pour le porter de EUR 3.768.750 (trois millions sept cent

soixante-huit mille sept cent cinquante Euro) à un montant de EUR 3.756.250 (trois millions sept cent cinquante-six mille
deux cent cinquante Euro) par l’annulation de 495 (quatre cent quatre-vingt-quinze) parts sociales détenues par CAL-
LAHAN InvestCo INTERNATIONAL L.L.C. et de 5 (cinq) parts sociales détenues par M. Wesley Dickinson par rem-
boursement à CALLAHAN InvestCo INTERNATIONAL L.L.C., d’un montant de EUR 12.375 (douze mille trois cent
soixante-quinze Euro) et à M. Wesley Dickinson d’un montant de EUR 125,- (cent vingt-cinq Euro) correspondant à la
valeur nominale des parts sociales annulées qui ont été qui souscrites et libérées dans leur totalité.

Ledit remboursement ne pourra se faire que sous observation de l’article 69 (2) de la loi sur les sociétés commer-

ciales.

L’Assemblée constate que l’actionnariat de la Société est, à ce jour et en conséquence des précédentes résolutions,

composé comme suit:

 GT: 27.551 (vingt-sept mille cinq cent cinquante et une) parts sociales ordinaires de la Société;
 SANTANDER BAHAMAS: 23.143 (vingt-trois mille cent quarante-trois) parts sociales ordinaires de la Société,
 CAI-INVESTOR: 2.394 (deux mille trois cent quatre-vingt-quatorze) parts sociales ordinaires de la Société; 
 ML: 5.511 (cinq mille cinq cent onze) parts sociales ordinaires de la Société;
 CDPQ: 51.796 (cinquante et un mille sept cent quatre-vingt-seize) parts sociales ordinaires de la Société;
 TFII: 2.459 (deux mille quatre cent cinquante-neuf) parts sociales ordinaires de la Société;
 TPFII: 638 (six cent trente-huit) parts sociales ordinaires de la Société;
 TC LLC: 173 (cent soixante-treize) parts sociales ordinaires de la Société;
 CIBC WM: 1.607 (mille six cent sept) parts sociales ordinaires de la Société; 
 CIBC EPEF: 1.737 (mille sept cent trente-sept) parts sociales ordinaires de la Société;
 KIL: 11.021 (onze mille vingt et une) parts sociales ordinaires de la Société;
 DSL: 6.613 (six mille six cent treize) parts sociales ordinaires de la Société;
 AG: 7.722 (sept mille sept cent vingt-deux) parts sociales ordinaires de la Société;
  BLACKSTONE OFFSHORE/FAMILY HOLDCO: 5.680 (cinq mille six cent quatre-vingt) parts sociales ordinaires de

la Société;

 INVESTCORP: 2.205 (deux mille deux cent cinq) parts sociales ordinaires de la Société;
et les résolutions suivantes sont adoptées par les partenaires susmentionnés, à l’unanimité:

<i>Cinquième résolution

En conséquence de la troisième et de la quatrième résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 4, alinéa pre-

mier des statuts de la Société, de façon à ce que celui-ci se lise dorénavant comme suit:

«Art. 4. alinéa 1

er

 - Capital Social

Le capital social entièrement souscrit et libéré de la Société est fixé à un montant de EUR 3.756.250 (trois millions

sept cent cinquante-six mille deux cent cinquante Euro), représenté par 150.250 (cent cinquante mille deux cent cin-
quante) parts sociales, entièrement souscrites et libérées, d’une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.»

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société dans le but d’y faire apparaître les modifications

susmentionnées et donne pouvoir et autorise tout avocat ou employé de l’étude BEGHIN &amp; FEIDER in association with
ALLEN &amp; OVERY à effectuer, au nom et pour le compte de la Société, l’inscription des Parts Sociales nouvellement
créées ainsi que des parts sociales annulées dans le registre des actionnaires de la Société.

10490

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de 3.756.250,- Euro est évalué à 151.526.749,- LUF.
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué à environ 1.700.000,- LUF. 

Dont acte
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française et de l’article 4 des statuts. A la requête de ces mêmes parties compa-
rantes, et en cas de distorsions entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Hesperange.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom, pré-

nom usuel, état et demeure, les ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Origer, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 131S, fol. 63, case 8. – Reçu un million cinq cent quinze mille

deux cent soixante-sept francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

(61436/220/497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

CALLAHAN INVESTCO GERMANY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

In the year two thousand one, on the fifth day of September.
Before Us, Maître Gérald Lecuit, notary, residing in Hesperange.

There appeared for an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CALLAHAN INVESTCO GERMANY

2, S.à r.l. (the «Company»), a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 58, rue Charles
Martel in L-2134 Luxembourg, in the process of registration with the Trade and Companies Registry at the District
Court of Luxembourg, constituted by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in Hesperange, dated July 11,
2001, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, as amended pursuant to a deed of the
same notary Lecuit on September 5, 2001 not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:

(a) GERMANY TELECOMMUNICATIONS 1, S.à r.l., having its registered office at 43 Grosvenor Street, Fourth

Floor, London, WlX 9FH, England («GT»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(b) SANTANDER CENTRAL HISPANO BANK &amp; TRUST (BAHAMAS) LTD., having its registered office at P.O. Box

N1682, Bahamas Financial Centre, 3rd floor, Charlotte and Shirley Street, Nassau (Bahamas) («SANTANDER BAHA-
MAS»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(c) CALLAHAN ASSOCIATES HOLDINGS (GERMANY 1) L.L.C., having its registered office at c/o Suite 650, 3200

Cherry Creek South Drive, Denver, Colorado 80209. U.S.A. («CAI-INVESTOR»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(d) ML PRIVATE EQUITY ASSOCIATES II L.L.C., having its registered office at World Financial Center, 250 Vesey

Street, North Tower 12th Floor, New York, NY 10281, U.S.A. («ML»),

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(e) CAPITAL COMMUNICATIONS CDPQ, INC., having its registered office at 1981, McGill College Avenue, Mon-

treal (Quebec) Canada H3A3C7 («CDPQ»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(f) TRIMARAN FUND II, L.L.C., having its registered office at 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY

10019, U.S.A. («TFII»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(g) TRIMARAN PARALLEL FUND II, L.P., having its registered office at 425 Lexington Avenue, Third Floor, New

York, NY 10019, U.S.A. («TPFII»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(h) TRIMARAN CAPITAL, L.L.C., having its registered office at 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY

10019, U.S.A. («TC LLC»);

hereby represented by Mr Gérald Onger, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued on

September 5, 2001;

Hesperange, le 27 septembre 2001.

G. Lecuit.

10491

(i) CIBC WORLD MARKETS IRELAND LIMITED, having its registered office at 425 Lexington Avenue, Third Floor,

New York, NY 10019, U.S.A. («CIBC WM»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(j) CIBC EMPLOYEE PRIVATE EQUITY FUND (TRIMARAN) PARTNERS, having its registered office at 425 Lexing-

ton Avenue, Third Floor, New York, NY 10019, U.S.A. («CIBC EPEF»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(k) KDG INVESTORS, L.P., having its registered office at Walkerhouse Mary Street, P.O. Box 265, George Town,

Grand Cayman («KIL»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(l) AG (GERMANY) L.L.C., having its registered office at c/o ANGELO GORDON &amp; COMPANY, 26th Floor, 245

Park Avenue, New York, N.Y. 10167, U.S.A. («AG»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(m) BOCP/BFIP/BFCP HOLDCO CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) L.P., having its registered office at c/o Walkers,

Walkers House, Mary Street, George Town, P.O. Box 265GT, Grand Cayman («BLACKSTONE OFFSHORE/FAMILY
HOLDCO»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(n) INVESTCORP CGC LIMITED PARTNERSHIP, having its registered office at West Wind Building, P.O. Box 1111,

Grand Cayman, Cayman Islands B.W.I. («INVESTCORP»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001;

(o) DSL HOLDINGS LIMITED, having its registered office at West Wind Building, P.O. Box 1111, Grand Cayman,

Cayman Islands, B.W.I. («DSL»);

hereby represented by Mr Gérald Origer, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a power of attorney issued

on September 5, 2001.

Such proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and

the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed together with the deed with the registra-
tion authorities.

The representative of the shareholders declares and requests the notary to state that:
I. 150,250 (one hundred fifty thousand two hundred fifty) ordinary shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-

five Euro) per share, representing the entirety of the voting share capital of the Company of EUR 3,756,250.- (three
million seven hundred fifty-six thousand two hundred fifty Euro) are duly represented at this Meeting which is conse-
quently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Designation, with effect to the end of the Meeting (i.e. after the fourth resolution) of the current 150,250 (one

hundred fifty thousand two hundred fifty) ordinary shares of the Company as the «Class A Ordinary Shares»;

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 2,232,800.- (two million two hundred thirty-

two thousand eight hundred Euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of EUR
3,756,250 (three million seven hundred fifty-six thousand two hundred fifty Euro) to EUR 5,989,050.- (five million nine
hundred eighty-nine thousand fifty Euro) by way of the creation and issue of 82,118 (eighty-two thousand one hundred
eighteen) Class A-2 Ordinary Shares and 7,194 (seven thousand one hundred ninety-four) Class A-3 Ordinary shares,
having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each;

4. Subscription to the increase specified under item 3. above and payment of the subscribed shares;
5. Amendment of the Company’s articles of association and restatement in their entirety;
6. Amendment in the share register of the Company in order to reflect the above change; with power and authority

to any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed on behalf of the
Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

III. That after deliberation, the following resolutions were unanimously taken:

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notices,

the Shareholders being represented consider themselves as duly convened and declare having perfect knowledge of the
agenda which has been made available to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to design, with effect to the end of the Meeting the current 150,250 (one hundred fifty thousand

two hundred fifty) ordinary shares of the Company as the «Class A Ordinary Shares».

<i>Third resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 2,232,800.- (two million

two hundred thirty-two thousand eight hundred Euro) in order to bring the share capital of the Company from its
present amount of EUR 3,756,250 (three million seven hundred fifty-six thousand two hundred fifty Euro) to EUR
5,989,050.- (five million nine hundred eighty-nine thousand fifty Euro) by way of the creation and issue of 82,118 (eighty-

10492

two thousand one hundred eighteen) Class A-2 Ordinary Shares and 7,194 (seven thousand one hundred ninety-four)
Class A-3 Ordinary shares, having a par value of EUR 25.- (twenty-five Euro) each.

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions and payments or the nominal amount as per

subscription to the share capital increase:

Intervention - Subscription - Payment

1) 17,035 newly issued Class A-2 Ordinary Shares and 2,039 newly issued Class A-3 Ordinary Shares have been sub-

scribed by GT, and have been entirely paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of EUR 476,850.-.

2) 14,038 newly issued Class A-2 Ordinary Shares have been subscribed by SANTANDER BAHAMAS, and have been

entirely paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of EUR. 350,950.-.

3) 1,433 newly issued Class A-2 Ordinary Shares have been subscribed by CAI-INVESTOR, and have been entirely

paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of EUR 35,825.-.

4) 3,407 newly issued Class A-2 Ordinary Shares and 256 newly issued Class A-3 Ordinary Shares have been sub-

scribed by ML, and have been entirely paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of EUR 91,575.-.

5) 32,026 newly issued Class A-2 Ordinary Shares and 3,832 newly issued Class A-3 Ordinary Shares have been sub-

scribed by CDPQ, and have been entirely paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of EUR 896,450.-.

6) 6,814 newly issued Class A-2 Ordinary Shares and 676 newly issued Class A-3 Ordinary Shares have been sub-

scribed by KIL, and have been entirely paid up by a contribution in cash of an aggregate amount of EUR 187,250.-.

7) 4,099 newly issued Class A-2 Ordinary Shares have been subscribed by AG, and have been entirely paid up by a

contribution in cash of an aggregate amount of EUR 102,475.-.

8) 3,266 newly issued Class A-2 Ordinary Shares and 391 newly issued Class A-3 Ordinary Shares have been sub-

scribed by BLACKSTONE OFFSHORE/FAMILY HOLDCO, and have been entirely paid up by a contribution in cash of
an aggregate amount of EUR 91,425.-.

Evidence of the above cash payments, as listed from item 1 through item 8, has been given to the undersigned notary

by a certificate dated September 5, 2001 issued by COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Frankfurt Branch to the
undersigned notary who formally acknowledges the availability of the aggregate amount of EUR 2,232,800.- (two million
two hundred thirty-two thousand eight hundred Euro).

<i>Fifth resolution

As a consequence of the third and the fourth resolutions, the Meeting resolves to amend the Company’s articles of

association and to restate them in their entirety so that they shall henceforth read as follows:

«Articles of association

Chapter I. Name - Duration - Obiect - Registered office - Definitions

Art. 1.- Name
The Company is a private limited liability company (société  à responsabilité limitée) under Luxembourg law. The

name of the Company is CALLAHAN INVESTCO GERMANY 2, S.à r.l.,

Art. 2. - Duration
The Company shall exist for an unlimited duration.

Art. 3. - Object
The object of the Company is directly or indirectly to acquire, hold, monitor and manage participating interests in

any enterprise in the communications sector in Germany, including (but not limited to) a substantial participation in
NRW HOLDCO and BW HOLDCO (each as defined in Article 5) and their respective subsidiaries, to direct the inter-
ests of its Shareholders towards the aforementioned enterprises and to coordinate the decisions of its Shareholders in
this respect.

In general, the Company may carry out all transactions and activities pertaining directly or indirectly to the invest-

ments in the communications sector, and the administration, management, operation, control and development of those
investments.

The Company may use its funds: (a) to invest in real estate, (b) to establish, manage, develop and dispose of its assets

as they may be composed from time to time, namely, but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin,
(c) to participate in the creation, development and control of any enterprise, (d) to acquire, by way of investment, sub-
scription, underwriting or option, any securities and any intellectual property rights, (e) to realize them by way of sale,
transfer, exchange or otherwise, (f) to receive or grant licenses on intellectual property rights and (g) to grant to, or
for the benefit of, companies in which the Company has a direct or indirect participation, any assistance including finan-
cial assistance, loans, advances or guarantees.

The Company may make any investment which it considers necessary or useful to fulfill or develop its business pur-

pose, including, without limitation, the entry into and carrying out of any commercial transactions which directly or in-
directly favor the realization of its purpose.

Art. 4. - Registered office
The Company has its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the City of Luxembourg and to any other place within the Grand

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Shareholders.

The Company may, by resolution of the Shareholders have offices and branches (whether or not permanent estab-

lishments) both in Luxembourg and abroad.

10493

Art. 5. - Definitions
For the purpose of these Articles of Association:
1. «Admitted Shareholder» has the meaning set forth in Article 9.2.
2. «Affiliate» means, with respect to any Person, any other Person that, directly or indirectly, controls, is controlled

by, or is under common control with, such first Person. For the purpose of this definition, «control» will mean, as to
any Person, the power to direct or cause the direction of the management and policies of such Person, whether through
the ownership of voting securities, by contract (including without limitation a limited partnership agreement or general
partnership agreement) or otherwise. In addition, limited partners of a partnership and Persons directly or indirectly
owning interests in such limited partnership interests will be deemed to be Affiliates of such partnership.

3. BW HOLDCO means CALLAHAN BADEN-WÜRTTEMBERG GMBH, a limited liability company formed under

the laws of Germany.

4. «Business Day» means any day other than a Saturday or a Sunday or other day on which banking institutions in

London, England, Luxembourg City, Luxembourg or New York, New York are required or authorized to remain closed.

5. «Class A Ordinary Shares» and «Class A-2 Ordinary Shares» and «Class A-3 Ordinary Shares» have the respective

meanings set forth in Article 6.

6. «Company» means CALLAHAN INVESTCO GERMANY 2, S.à r.l.
7. «Company Securities» means, collectively, the INVESTCO 2 Securities (BW-A), the INVESTCO 2 Securities (BW-

B) and the INVESTCO 2 Securities (NRW).

8. «Distribution» and «Distributions» mean any distribution by the Company, whether in the form of dividends, re-

turn of capital payments, liquidation (full or partial) payments or otherwise.

9. «EUR» means the Euro, i.e., the single currency of the participating member states of the European Union as con-

stituted by the Treaty on the European Union and as referred to in legislation of the Economic and Monetary Union.

10. INVESTCO 2 Securities (BW-A) means, collectively, the INVESTCO 2 Shares (BW-A), the Loan Notes (Series

2) issued by the Company on September 5, 2001, and the Preferred Equity Certificates (Series 2) issued by the Company
pursuant to the Terms and Conditions thereof on September 5, 2001.

11. INVESTCO 2 Securities (BW-B) means, collectively, the INVESTCO 2 Shares (BW-B), the Loan Notes (Series 3)

issued by the Company on September 5, 2001, and the Preferred Equity Certificates (Series 3) issued by the Company
pursuant to the Terms and Conditions thereof on September 5, 2001.

12. INVESTCO 2 Securities (NRW) means, collectively, the INVESTCO 2 Shares (NRW), the Loan Notes (Series 1)

issued by the Company on September 5, 2001, and the Preferred Equity Certificates (Series 1) issued by the Company
pursuant to the Terms and Conditions thereof on September 5, 2001.

13. INVESTCO 2 Shares (BW-A) means the Class A-2 Ordinary Shares.
14. INVESTCO 2 Shares (BW-B) means the Class A-3 Ordinary Shares. 
15. INVESTCO 2 Shares (NRW) means the Class A Ordinary Shares.
16. «Law» means the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August, 1915, as amended.
17. «Manager» has the meaning set forth in Article 11.1.
18. «NRW HOLDCO» means CALLAHAN NORDRHEIN-WESTFALEN GMBH, a limited liability company formed

under the laws of Germany.

19.«Ordinary Shares» means, collectively, the INVESTCO 2 Shares (BW-A), the INVESTCO 2 Shares (BW-B) and

the INVESTCO 2 Shares (NRW).

20. «Original Shareholder» has the meaning set forth in Article 9.1.
21. «Person» means an individual, corporation, partnership, company, joint venture, association, trust, unincorporat-

ed organization, government (or any agency, instrumentality or political subdivision thereof) or other entity.

22. «Register of Shares» has the meaning set forth in Article 7.2.
23. «Shares» means shares in the capital of the Company.
24. «Shareholder» means any Person registered as such in the Register of Shares kept pursuant to Article 7.2.
25. «Tranche BW-A Distribution» means, with respect to any Distribution, the portion thereof equal to the product

of the TRANCHE BW-A Percentage and the aggregate amount of the Distribution.

26. «Tranche BW-B Distribution» means, with respect to any Distribution, the portion thereof equal to the product

of the «Tranche BW-B Percentage and the aggregate amount of the Distribution.

27. «Tranche BW-A Percentage» means 34.879848%. 
28. «Tranche BW-B Percentage» means 3.327387%.
29. «Tranche NRW Distribution» means, with respect to any Distribution, the portion thereof equal to the product

of the Tranche NRW Percentage and the aggregate amount of the Distribution.

30. «Tranche NRW Percentage» 61.792765%.

Chapter II. Capital and Shares

Art. 6. Capital
The nominal value of the Company’s subscribed share capital is fixed at EUR 5,989,050 (five million nine hundred

eighty-nine thousand fifty Euro), represented by three tranches of Ordinary Shares: (i) the INVESTCO 2 Shares (NRW),
(ii) the INVESTCO 2 Shares (BW-A) and (iii) the INVESTCO 2 Shares (BW-B).

Section 1- INVESTCO 2 Shares (NRW)

INVESTCO 2 Shares (NRW) consist of the following:
one hundred fifty thousand two hundred fifty (150,250) ordinary shares (designated hereby as the «Class A Ordinary

Shares») having a nominal value of EUR 25.- per share.

10494

The voting powers, preferences and relative, participating, optional or other special rights, and the qualifications, lim-

itations or restrictions of the classes of INVESTCO 2 Shares (NRW) are as follows:

All Class A Ordinary Shares shall be identical in all respects and shall share ratably in the payment of Tranche NRW

Distributions. All Class A Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with the
effect that the issued number of Class A Ordinary Shares is reduced.

l. Distributions. Holders of the Class A Ordinary Shares will be entitled to receive all Tranche NRW Distributions

made, when, as, and if declared by the Shareholders Meeting out of funds legally available therefor, in accordance with
applicable law. Any such amounts distributable to the holders of the Class A Ordinary Shares will be distributed on a
parity, share for share.

2. Voting Rights. Each Class A Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

Shareholders have the right to vote.

3. Liquidation Rights. In the event of any voluntary or involuntary Liquidation, dissolution or winding up of the Com-

pany (a «Liquidation»), after payment of all applicable debts and liabilities of the Company, a holder of Class A Ordinary
Shares will be entitled to receive that portion of such remaining assets to which such holder would have been entitled
if such Liquidation had been a Tranche NRW Distribution by the Company. Any such amounts distributable to the hold-
ers of the Class A Ordinary Shares will be distributed on a parity, share for share. Neither the merger nor consolidation
of the Company into or with any other entity or entities, nor the merger or consolidation of any other entity or entities
into or with the Company, nor a sale, transfer, lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or
any part of the assets of the Company shall be deemed to be a liquidation, dissolution or winding up of the Company
within the meaning of this paragraph 3, unless such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in
connection with or intended to be a plan of complete liquidation, dissolution or winding up of the Company.

Redemption; Convertibility; Assessability. Class A Ordinary Shares will not be subject to mandatory redemption, will

not be convertible into any other Shares and will be non-assessable.

Section 2 - INVESTCO 2 Shares BW-A

INVESTCO 2 Shares (BW-A) consist of the following:
eighty-two thousand one hundred eighteen (82,118) ordinary shares (designated hereby as the «Class A-2 Ordinary

Shares») having a nominal value of EUR 25.- per share.

The voting powers, preferences and relative, participating, optional or other special rights, and the qualifications, lim-

itations or restrictions of the INVESTCO 2 Shares (BW-A) are as follows:

All Class A-2 Ordinary Shares shall be identical in all respects and shall share ratably in the payment of Tranche BW-

A Distributions. All Class A-2 Ordinary Shares purchased or otherwise acquired by the Company shall be retired with
the effect that the issued number of Class A-2 Ordinary Shares is reduced.

1. Distributions. Holders of the Class A-2 Ordinary Shares will be entitled to receive all Tranche BW-A Distributions

made, when, as, and if declared by the Shareholders Meeting out of funds legally available therefor, in accordance with
applicable law. Any such amounts distributable to the holders of the Class A-2 Ordinary Shares will be distributed on a
parity, share for share.

2. Voting Rights. Each Class A-2 Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

Shareholders have the right to vote.

3. Liquidation Rights. In the event of any voluntary or involuntary Liquidation, after payment of all applicable debts

and liabilities of the Company, a holder of Class A-2 Ordinary Shares will be entitled to receive that portion of such
remaining assets to which such holder would have been entitled if such Liquidation had been a Tranche BW-A Distri-
bution by the Company. Any such amounts distributable to the holders of the Class A-2 Ordinary Shares will be dis-
tributed on a parity, share for share. Neither the merger nor consolidation of the Company into or with any other entity
or entities, nor the merger or consolidation of any other entity or entities into or with the Company, nor a sale, transfer,
lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or any part of the assets of the Company shall be
deemed to be a liquidation, dissolution or winding up of the Company within the meaning of this paragraph 3, unless
such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of com-
plete liquidation, dissolution or winding up of the Company.

4. Redemption; Convertibility; Assessability. Class A-2 Ordinary Shares will not be subject to mandatory redemption,

will not be convertible into any other Shares and will be non-assessable.

Section 3 - INVESTCO 2 Shares BW-B

INVESTCO 2 Shares (BW-B) consist of the following:
seven thousand one hundred ninety four (7,194) ordinary share (designated hereby as the «Class A-3 Ordinary

Shares») having a nominal value of EUR 25.- per share.

The voting powers, preferences and relative, participating, optional or other special rights and the qualifications, lim-

itations or restrictions of the INVESTCO 2 Shares (BW-B) are as follows:

All Class A-3 Ordinary Shares shall be identical in all respects and shall share ratably in the payment of Tranche BW-

B Distributions. All Class A-3 Ordinary Shares purchased of otherwise acquired by the Company shall be retired with
the effect that the issued number of Class A-3 Ordinary Shares is reduced.

1. Distributions. Holders of the Class A-3 Ordinary Shares will be entitled to receive all Tranche BW-B Distributions

made, when, as, and if declared by the Shareholders Meeting out of funds legally available therefor, in accordance with
applicable law. Any such amounts distributable to the holders of the Class A-3 Ordinary Shares will be distributed on a
parity, share for share.

2. Voting Rights. Each Class A-3 Ordinary Share will entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which

Shareholders have the right to vote.

10495

3. Liquidation Rights. In the event of any voluntary or involuntary Liquidation, after payment of all applicable debts

and liabilities of the Company, a holder of Class A-3 Ordinary Shares will be entitled to receive that portion of such
remaining assets to which such holder would have been entitled if such Liquidation had been a Tranche BW-B Distri-
bution by the Company. Any such amounts distributable to the holders of the Class A-3 Ordinary Shares will be dis-
tributed on a parity, share for share. Neither the merger nor consolidation of the Company into or with any other entity
or entities, nor the merger or consolidation of any other entity or entities into or with the Company, nor a sale, transfer,
lease or exchange (for cash, securities or other consideration) of all or any part of the assets of the Company shall be
deemed to be a liquidation, dissolution or winding up of the Company within the meaning of this paragraph 3, unless
such merger, consolidation, sale, transfer, lease or exchange shall be in connection with or intended to be a plan of com-
plete liquidation, dissolution winding up of the Company.

4. Redemption; Convertibility, Assessability. Class A-3 Ordinary Shares will not be subject to mandatory redemption,

will not be convertible into any other Shares and will be non-assessable.

Section 4 - Further Provisions

Ordinary Shares of the Company, of any tranche or tranches authorized herein, may be issued by the Company from

time to time pursuant to a resolution of the Shareholders of the Company for such consideration permitted by Law as
may be fixed from time to time by the Shareholders of the Company (provided that such consideration shall be at least
25 .- EUR).

All Shares shall vote together, and except as may be required by law, the holders of any separate tranche of Shares

shall not be entitled to vote separately on any matter.

No Shares of any tranche shall be entitled to any pre-emptive rights with respect to any Shares of the Company,

except as all the Shareholders may have otherwise agreed in a written agreement signed by all Shareholders.

Each Distribution shall be made at the same time to each outstanding tranche of shares, with the amount of each such

Distribution to be allocated among all outstanding tranches based on their then respective Tranche Percentages. No
Distribution shall be made on any tranche of Shares unless a Distribution is concurrently made on all other tranches of
Shares. No Distribution shall be made on any tranche of Shares unless the rights of all Shares of such tranche specified
in Article 6 are observed. 

Art. 7. - Shares and Register of Shares
1. Shares:
The Shares are in registered form. The Company may issue share certificates which merely evidence the registration

of the Shares, but the failure to issue share certificates shall not affect the rights of a holder of Shares.

The Shares are indivisible with regard to the Company. Joint ownership of shares shall be permitted. Joint owners of

Shares must be represented vis-à-vis the Company by a single Person. As long as this clause has not been fulfilled, the
rights relative to such Shares shall be suspended.

2. Register of Shares:
A register of shares (the «Register of Shares») will be kept at the registered office of the Company, which shall be

accessible to all Shareholders. It may be kept in any appropriate form, including computerized form.

The Register of Shares will contain:
 the name and domicile or registered office of each Shareholder;
 the date of admission of each Shareholder;
 the number of Shares held by each Shareholder, and the amount paid up by each Shareholder on its Shares;
 a record of all Share transfers, including the date on which they took place;
 a record of all Distributions with respect to Shares, including the date on which they took place.
Each entry in the Register of Shares shall be made by the Manager or the Manager’s designee upon the (i) receipt

from the Shareholder or Shareholders concerned of such information that the Manager deems sufficient to evidence
the entry at issue and (ii) in the case of a transfer, compliance with the provisions of Article 8 hereof. The Register of
Shares, together with the evidence referred to above, shall constitute conclusive evidence with respect to the ownership
of Shares of the Company and of the number of Shares thereof a Shareholder from time to time owns.

Art. 8. Transfer of Shares
No Shareholder shall, directly or indirectly, sell, assign, encumber, pledge, grant an option to acquire or otherwise

transfer, whether by operation of law or otherwise, any Shares or any right, title or interest therein, except as permitted
by this Article 8 or as the Shareholders may otherwise agree in a written agreement signed by all Shareholders.

Any transfer in violation of the preceding sentence shall be null and void, and the Company shall not register any such

transfer.

Any transfer of Shares shall be valid against the Company and third parties only upon recording of such transfer by

the Company in the Register of Shares in accordance with Article 7.2 hereof.

The transfer of a Share shall be effected, subject to the requirements of this Article 8 of these Articles of Association,

Article 189 of the Law and the above paragraph only by means of the procedures laid down in article 1690 of the Lux-
embourg Civil Code.

Chapter III. Shareholders

Art. 9. Original and Admitted Shareholders
1. Original Shareholders
Each Shareholder of the Company on the date of adoption of these Articles of Association (including, for the avoid-

ance of doubt, those Shareholders admitted at the Shareholders Meeting at which these Articles of Association were
restated) shall be referred to as an «Original Shareholder.»

10496

2. Admitted Shareholders
Each Shareholder subsequently admitted to the Company shall be referred to as an «Admitted Shareholder.»
The conditions for admission as a Shareholder of the Company, as well as the grounds on which existing Shareholders

may object in writing, or, as the case may be, pursuant to a vote of the Shareholders at a Shareholders Meeting, to the
proposed admission of a new Shareholder, may be set forth in an agreement in writing entered into among the Share-
holders at any time or from time to time.

Art. 10. Shareholders’ Liability
Shareholders shall be liable only up to the amount of their subscription and such liability shall not be joint or several.

Chapter IV. Administration and Supervision

Art. 11. Manager
1. The Company is administered by a Manager or Managers. The Shareholders may at any time or from time to time

enter into one or more agreements in writing concerning the Manager, including without limitation the nomination, ap-
pointment and replacement of the Manager.

2. Decisions on the following matters shall be taken by the Manager, and the Manager shall see to the performance

thereof: (a) registered office facility; (b) issuance of accounting statements and tax accounting; (c) general corporate ad-
ministration; (d) maintaining the Register of Shares; (e) maintaining contribution and distribution information for all
Shareholders (including capital account data); (f) submission of annual and other periodic reports and filings with appli-
cable Luxembourg authorities for the maintenance of the Company’s existence and good standing (if applicable) and
remittance of fees required in connection therewith; (g) custodial services; (h) transfer agency services; and (i) those
matters expressly reserved to the Manager by the Law.

Art. 12. Delegation of Powers and Representation of the Company
1. The Manager, acting under the instructions of the Shareholders, may represent the Company vis-à-vis third parties.
2. Unless the Shareholders shall so instruct, the Manager shall not create, or approve the creation of, any committees

nor delegate all or any aspect of the Manager’s authority to any committee.

3. If a Shareholders resolution has been taken to that effect, the Manager may represent the Company vis-à-vis third

parties, or appoint one or more agents acting on an ad hoc basis to so represent the Company, in relation to any specific
matter (it being understood that a Shareholders’ resolution may appoint directly an agent other than the Manager).

Art. 13. Proceedings
If instructed by the Shareholders, the Manager shall pursue or defend (as the case may be) legal proceedings on behalf

and in the name of the Company, whether the Company shall be plaintiff or defendant in such legal proceedings.

Chapter V. Shareholders Meetings

Art. 14. Composition and Powers
1. Any Extraordinary or General Meeting (a «Shareholders Meeting») may be attended by all Shareholders.
2. The Shareholders have the most extensive powers to take resolutions with respect to the Company. Decisions

on all matters shall be taken by the Shareholders. Within the competence of the Shareholders are all acts that are not
explicitly reserved to the Manager by the Law, by these Articles of Association and/or any written agreement entered
into among the Shareholders at any time or from time to time.

Art. 15. Meetings - Notices of Meetings - Information
1. At least a majority of all Shareholders Meetings each year (and in any event one such meeting annually) shall be

held in Luxembourg. Any Shareholders Meeting with Shareholders taking part in the meeting by telephone or video con-
ference will be deemed to be a meeting held in Luxembourg if at least one Shareholder is physically present in Luxem-
bourg and the conference is initiated from Luxembourg. Participation by telephone or by video conference shall require
the signing of the resolutions passed at the Shareholders Meeting by those Shareholders which were not physically rep-
resented at the Shareholders Meeting or which did not physically participate at the Shareholders Meeting and in such
case the formalities indicated in Article 15.2 must be complied with.

2. Shareholders Meetings shall occur as often as is required for the conduct of the Company’s affairs and the exercise

of the Company’s rights in NRW HOLDCO and/or BW HOLDCO and in any event (i) at least once each year and (ii)
immediately prior to every meeting of any board or shareholders of NRW HOLDCO and/or BW HOLDCO. A Share-
holders Meeting may be called by Shareholder(s) owning in the aggregate at least 10% of the outstanding Shares or such
higher percentage as may be required by the nonwaivable provisions of the Law. Written notice of any Shareholders
Meeting shall be sent by the Shareholder(s) calling the Shareholders Meeting to the Company, which in turn shall send
written notice of any such meeting within one day of its receipt thereof to all Shareholders. The Shareholders Meeting
shall be held no sooner than 10 days after the sending of the notice by the Company. The notice period shall begin to
run on the day following the dispatch of the notice by the Company. The day of the Shareholders Meeting shall not
count in determining the notice period. Notice of a Shareholders Meeting shall indicate the place and time of said meet-
ing as well as a description of any business to be transacted at such meeting, and be accompanied by any relevant doc-
umentation.

3. Any Shareholder may propose matters for the agenda of a Shareholders Meeting, and the other Shareholders shall

be given written notice of such agenda items as soon before the Shareholders Meeting as practical (but, in any case, at
least five days prior to the Shareholders Meeting).

4. If the notice requirements set forth in this Article 15 are not satisfied, valid resolutions may nevertheless be adopt-

ed if each Shareholder either (i) signs a waiver of notice or (ii) is present or represented by proxy at the Shareholders
Meeting (other than to oppose the holding of the Shareholders Meeting).

10497

5. The Company shall provide and cause to be provided to the Shareholders, upon reasonable written request, any

and all existing information or data, and a copy of any existing document pertaining to the Company or any entity in
which it holds an investment, or their respective assets or financial situation.

Art. 16. Decision making process within the Shareholders Meeting
1. Attendance quorum
A quorum for the transaction of business at any Shareholders Meeting shall require the attendance of such Share-

holders as the Shareholders shall agree in writing.

If a quorum is not present at the opening of any Shareholders Meeting, then the Shareholders represented may not

transact any business other than adjourning such meeting to a date at least 15 days following dispatch to each Share-
holder of a written notice of the reconvened meeting setting forth the fact of the adjournment, the date, time and place
of the reconvened meeting. If a quorum is still not present at such reconvened meeting, then the Shareholders present
shall be deemed to constitute a quorum and, subject to any requirement for a greater vote under the Law, may transact
by the affirmative vote of more than 50% of the total Shares outstanding represented thereat, all business with respect
to the items set forth in the notice (or accompanying documentation) provided to all Shareholders in connection with
the originally scheduled meeting, subject to any additional requirement in any agreement of the Shareholders.

Shareholders may attend the Shareholders Meeting in person or by duly authorized representatives.
2. Voting majority
Unless explicitly provided otherwise under the Law, any agreement among the Shareholders regarding voting or

these Articles of Association, decisions on all matters:

(a) shall be taken by the Shareholders; and
(b) shall be taken upon a vote as required by written agreement of Shareholders.
Any decision on the following matters shall be taken only upon the affirmative vote of the Shareholders which own

in the aggregate 90% of the outstanding Shares of the Company:

(a) any action an effect of which is to expand the business of the Company into activities other than owning and man-

aging the Company’s investment in NRW HOLDCO and BW HOLDCO and their respective Affiliates from time to
time (provided that investments in, or acquisition of, additional cable properties (including Level 4 operations) or com-
munications properties (including city carriers) in Germany, shall only require such vote specified in any agreement of
all the Shareholders);

(b) the filing or approval for filing, of any bankruptcy, receivership or liquidation proceeding, or any other judicial pro-

ceeding relating to the assertion of rights by the creditors of the Company as a whole;

(c) any action an effect of which is to change the corporate form of the Company, other than any action specified in

any agreement of all the Shareholders as requiring a different vote.

Any action an effect of which is to change the jurisdiction of formation of the Company shall be taken upon the unan-

imous vote of the Shareholders.

Any decision to modify these Articles of Association or to liquidate the Company shall only be taken upon the affirm-

ative vote of the Shareholders which own in the aggregate 75% of the outstanding Shares of the Company.

Art. 17. Resolutions Taken Other Than At The Occasion Of Physical Meeting
Resolutions of Shareholders may instead of being passed at a Shareholders Meeting of Shareholders, alternatively be

passed in writing, provided that such resolutions are so passed with the unanimous vote of all the Shareholders who
are entitled to vote and that such resolutions bear the signature of each Shareholder of the Company.

Art. 18. Minutes
Minutes shall be kept of every Shareholders Meeting stating the location and the date of the meeting, the persons

attending as well as the agenda, and summarizing the deliberations and setting forth the resolutions adopted by the
Shareholders.

Minutes of the Shareholders Meeting shall be signed by at least two Shareholders.
In addition to the English language version of the minutes of each Shareholders Meeting, the Company shall also cause,

to the extent required, to be prepared and maintained a French language translation of the minutes of each Shareholders
Meeting. In the event of any inconsistencies between the French and English language versions of the minutes, the English
language version will control.

Copies or extracts to be produced in legal proceedings or otherwise shall be signed by the Manager.
An attendance list indicating the names of Shareholders and the number of Shares held by them shall be signed by

each one of them or by their proxy before entering the Shareholders Meeting.

Chapter VI. Decision Making Process in NRW HOLDCO and BW HOLDCO

Art. 19. Scope
Any written agreement entered into among the Shareholders at any time or from time to time may contain specific

procedures and rules concerning the exercise, by the Company and its competent bodies, of all governance rights which
the Company has in NRW HOLDCO and/or BW HOLDCO.

Chapter VII. Inventories and Annual Accounts - Auditor

Art. 20. Financial Year - Establishment of the Annual Accounts
1. The financial year of the Company shall commence on 1 August and end on 31 July of the following year.
2. The Manager shall annually close the books of the Company as of the last day of every financial year and as soon

as reasonably possible thereafter, but in no event later than 60 days, the Company shall draw up annual accounts con-
sisting of a balance sheet, a profit and loss account, and explanatory notes, and shall within that period submit these

10498

documents to the Shareholders. It shall make the underlying documents available for inspection to the Shareholders at
the Company’s registered office.

The Manager shall within that period also submit an annual report.
3. The Manager shall ensure that the annual accounts, the annual reports and the particulars to be added in accord-

ance with Section XIII of the Law, are available at its registered office as from the date that the Shareholders Meeting
dealing with such documents is called. The Shareholders shall be permitted to inspect at any time these documents and
to obtain copies thereof without charge.

4. Notwithstanding the above, each Shareholder shall have the right, upon reasonable notice to the Manager, to ex-

amine all books, documents and correspondence of the Company.

5. The Shareholders Meeting shall approve and adopt the annual accounts. This approval and adoption shall constitute

a discharge and release from liability for the Manager and for the auditor with respect to all acts that arise from these
documents or the result of which is embodied therein, unless a proviso or qualification has explicitly been made, and
without prejudice to what has been or will be provided thereon by the Law.

Art. 21. Auditor
The books and accounts of the Company shall be audited by an audit firm appointed by the Shareholders Meeting.

Chapter VIII. Dissolution - Winding Up

Art. 22. Winding up
In case of the winding up of the Company for any reason or at any time, the winding up shall be carried out by one

or several liquidators designated by the Shareholders Meeting and, if no such designation is made, the Manager will be
considered as the liquidator.

The Manager shall be vested for this purpose with the most extensive powers conferred by the Law.
The Shareholders Meeting shall determine the emoluments of the liquidator(s).

Art. 23. Distribution
After reimbursement of the capital, distribution after liquidation shall take place pursuant to Article 6.

Chapter IX. Various Provisions

Art. 24. Notices
For the purposes of these Articles of Association, notices have to be sent in person, by telegram, electronic mail,

overnight courier, by registered mail or by telefax with confirmation receipt.

Art. 25. U.S. Tax Treatment
The Company intends timely to elect to be classified as a fiscally transparent (i.e., passthrough) entity for U.S. tax

purposes effective for its first taxable year. In this connection, the Manager, and each other person so authorized by
action of the Shareholders, shall have the authority to execute and file such an election on behalf of the Company. The
Shareholders shall reasonably cooperate to effect such election.

<i>Sixth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and em-

powers and authorizes any lawyer or employee of BEGHIN &amp; FEIDER in association with ALLEN &amp; OVERY to proceed
on behalf of the Company to the registration of the newly issued shares in the share register of the Company.

<i>Costs

For the purpose of the registration, the amount of 2,232,800.- EUR is evaluated at 90,070,929.- LUF.
The aggregate amount of the costs, expenditures and remunerations in any form whatsoever, which the corporation

incurs or for which it is liable by reason of the increase, is approximately 1,100,000.- LUF.

<i>Statement

Nothing else being on the agenda, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French version including the articles of association in German. At
the request of the same appearing parties, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French/
German texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Hesperange, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the appearing person, said appearing person signed with Us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du procès-verbal, incluant la traduction allemande de l’article 6 des statuts:

L’an deux mille un, le cinq septembre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.

Ont comparu pour une assemblée générale extraordinaire des associés de la société CALLAHAN INVESTCO GER-

MANY 2, S. à r. l., (ci-après la «Société») ayant son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, en cours
d’enregistrement au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Me Gé-
rard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange, en date du 11 juillet 2001, lequel n’a pas encore été publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du même notaire Lecuit en date
du 5 septembre 2001 en cours de publication:

a) GERMANY TELECOMMUNICATIONS 1 S.à r.l., ayant son siège social à 43 Grosvenor Street, Fourth Floor, Lon-

don, W1X 9FH, England («GT»);

10499

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

b) SANTANDER CENTRAL HISPANO BANK &amp; TRUST (BAHAMAS) LTD, ayant son siège social à P.O. Box N1682,

Bahamas Financial Centre, 3rd floor, Charlotte and Shirley Street, Nassau (Bahamas) («SANTANDER BAHAMAS»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

c) CALLAHAN ASSOCIATES HOLDINGS (GERMANY 1) L.L.C., ayant son siège social à c/o Suite 650, 3200 Cherry

Creek South Drive, Denver, Colorado 80209. U.S.A. («CAI-INVESTOR»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

d) ML PRIVATE EQUITY ASSOCIATES II LLC, ayant son siège social à World Financial Center, 250 Vesey Street,

North Tower 12th Floor, New York, NY 10281, U.S.A. («ML IBK»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

e) CAPITAL COMMUNICATIONS CDPQ, INC., ayant son siège social à 1981, McGill College Avenue, Montreal

(Quebec) Canada H3A3C7 («CDPQ»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

f) TRIMARAN FUND II, L.L.C., ayant son siège social à 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY 10019,

U.S.A. («TFII»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

g) TRIMARAN PARALLEL FUND II, L.P., ayant son siège social à 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY

10019, U.S.A. («TPFII»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

h) TRIMARAN CAPITAL, L.L.C., ayant son siège social à 425 Lexington Avenue, Third Floor, New York, NY 10019,

U.S.A. («TC LLC»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

i) CIBC WORLD MARKETS IRELAND LIMITED, ayant son siège social à 425 Lexington Avenue, Third Floor, New

York, NY 10019, U.S.A. («CIBC WM»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

j) CIBC EMPLOYEE PRIVATE EQUITY FUND (TRIMARAN) PARTNERS, ayant son siège social à 425 Lexington Ave-

nue, Third Floor, New York, NY 10019, U.S.A. («CIBC EPEF»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en venu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

k) KDG INVESTORS, L.P., ayant son siège social à Walkerhouse Mary Street, P.O. Box 265, George Town, Grand

Cayman («KIL»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

l) AG (GERMANY) L.L.C., ayant son siège social à c/o ANGELO GORDON &amp; COMPANY, 26th Floor, 245 Park

Avenue, New York, N.Y. 10167, U.S.A. («AG»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

m) BOCP/BFIP/BFCPHOLDCO CAPITAL PARTNERS (CAYMAN) L.P., ayant son siège social à c/o Walkers, Walk-

ers House, Mary Street, George Town, P.O. Box 265GT, Grand Cayman («BLACKSTONE OFFSHORE/FAMILY HOL-
DCO»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

n) INVESTCORP CGC LIMITED PARTNERSHIP, ayant son siège social à West Wind Building, P.O. Box 1111, Grand

Cayman, Cayman Islands S.W.I. («INVESTCORP»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

o) DSL HOLDINGS LIMITED, ayant son siège social à West Wind Building, P.O. Box 1111, Grand Cayman, Cayman

Islands, B.W.I. («DSL»);

Ici représentée par Monsieur Gérald Origer, avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing

privé, donnée le 5 septembre 2001.

Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire

soussigné resteront annexées au présent acte afin d’être enregistrées avec l’acte.

Le représentant des associés expose et prie le notaire d’acter que:
I. 150.250 (cent cinquante mille deux cent cinquante) Parts Sociales Ordinaires ayant une valeur nominale de EUR

25,- (vingt-cinq Euro) chacune, représentant la totalité du capital social votant de la Société  d’un montant de EUR
3.756.250 (trois millions sept cent cinquante-six mille deux cent cinquante) sont représentées à l’Assemblée qui est par

10500

conséquent régulièrement constituée et peut valablemement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour tel
que ci-après reproduit.

Il. La présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Désignation avec effet à la fin de l’Assemblée (c’est-à-dire après la quatrième résolution) des actuelles 150.250 (cent

cinquante mille deux cent cinquante) Parts Sociales Ordinaires comme «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A»,

3. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de EUR 2.232.800 (deux millions deux cent trente deux

mille huit cents Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 3.756.250 (trois millions sept cent cinquante-six
mille deux cent cinquante Euro) à un montant de EUR 5.989.050 (cinq millions neuf cent quatre-vingt neuf mille cinquan-
te Euro) par la création et l’émission de 82.118 (quatre-vingt deux mille cent dix-huit) Parts Sociales Ordinaires de Ca-
tégorie A-2 et 7.194 (sept mille cent quatre-vingt-quatorze) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-3, ayant une valeur
nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune;

4. Souscription à l’augmentation telle que spécifiée ci-avant et paiement des Parts Sociales Ordinaires souscrites;
5. Modification et refonte des statuts de la Société;
6. Modification du registre des associés de la Société afin d’y inscrire les changements visés ci-dessus et pouvoir ac-

cordé à tout avocat ou employé de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp; OVERY afin de procéder pour le
compte de la Société aux inscriptions concernant les Parts Sociales Ordinaires nouvellement émises dans le registre des
associés.

III. Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises, à l’unanimité:

<i>Première résolution

L’intégralité du capital social étant représentée à la présente Assemblée, l’Assemblée décide de renoncer aux forma-

lités de convocation, les associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir
eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide, avec effet à la fin de l’ Assemblée de désigner les 150.250 (cent cinquante mille deux cent cin-

quante) Parts Sociales Ordinaires comme «Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A».

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de EUR 2.232.800 (deux millions deux

cent trente-deux mille huit cents Euro) pour le porter de son montant actuel de EUR 3.756.250 (trois millions sept cent
cinquante-six mille deux cent cinquante Euro) à un montant de EUR 5.989.050 (cinq millions neuf cent quatre-vingt neuf
mille cinquante Euro) par la création et l’émission de 82.118 (quatre-vingt deux mille cent dix-huit) Parts Sociales Or-
dinaires de Catégorie A-2 et 7.194 (sept mille cent quatre-vingt-quatorze) Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-3,
ayant une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq Euro) chacune.

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide d’accepter et d’enregister les souscriptions et paiements de l’augmentation de capital suivants:

Intervention - Souscription - Paiement

1) 17.035 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-2 et 2.039 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-3 ont été

souscrites par GT, et ont été entièrement payées par un apport en espèces d’un montant total de EUR 476.850;

2) 14.038 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-2 ont été souscrites par SANTANDER BAHAMAS, et ont été

entièrement payées par un apport en espèces d’un montant total de EUR 350.950;

3) 1.433 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-2 ont été souscrites par CAI-INVESTOR, et ont été entièrement

payées par un apport en espèces d’un montant total de EUR 35.825;

4) 3.407 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-2 et 256 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-3 ont été sous-

crites par ML, et ont été entièrement payées par un apport en espèces d’un montant total de EUR 91.575;

5) 32.026 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-2 et 3.832 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-3 ont été

souscrites par CDPQ, et ont été entièrement payées par un apport en espèces d’un montant total de EUR 896.450;

6) 6.814 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-2 et 676 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-3 ont été sous-

crites par KIL, et ont été entièrement payées par un apport en espèces d’un montant total de EUR 187.250;

7) 4.099 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-2 ont été souscrites par AG, et ont été entièrement payées par

un apport en espèces d’un montant total de EUR 102.475;

8) 3.266 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-2 et 391 Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A-3 ont été sous-

crites par BLACKSTONE OFFSHORE/FAMILY HOLDCO, et ont été entièrement payées par un apport en espèces d’un
montant total de EUR 91.425;

La preuve des paiements en espèces mentionnés ci-dessus, et numérotés de 1) à 8), a été documentée au notaire

instrumentaire par un certificat en date du 5 septembre 2001 émis par la COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT
Frankfurt Branch au notaire soussigné qui reconnaît formellement la disponibilité du montant total de EUR 2.232.800
(deux millions deux cents trente-deux mille huit cents Euro).

<i>Cinquième résolution

En conséquence des troisième et quatrième résolutions, l’Assemblée décide de modifier et de refondre les statuts de

la Société, qui auront désormais la teneur suivante:

10501

 Kapitel l. Firma - Dauer - Zweck - eingetragener Geschäftssitz - Definitionen

Art. 1. Firma
Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach luxemburgischen Recht. Der Name der Gesell-

schaft ist CALLAHAN INVESTCO GERMANY 2, S.à r.l.

Art. 2. Dauer
Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.

Art. 3. Zweck
Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb, die Anlage, die Beaufsichtigung und das Management

von Anteilen an Unternehmen, die in Deutschland im Kommunikationssektor tätig sind, einschließlich (aber nicht be-
schränkt auf) eine wesentliche Beteiligung an NRW HOLDCO und BW HOLDCO (jeweils wie im Artikel 5 definiert)
und deren jeweiligen Filialen, sowie die Orientierung der Interessen ihrer Gesellschafter in Richtung der vorgenannten
Unternehmen und die Koordinierung der diesbezüglichen Entscheidungen ihrer Gesellschafter.

Im allgemeinen ist die Gesellschaft befugt, sämtliche Geschäfte und Tätigkeiten durchzuführen, die direkt oder indi-

rekt zu Investitionen in den Kommunikationssektor gehören; sowie dazu gehört weiterhin die Verwaltung, das Manage-
ment, die Vornahme, die Kontrolle und die Entwicklung solcher Anlagen.

Die Gesellschaft kann ihre Gelder für die folgenden Zwecke verwenden: (a) Investitionen in Immobilien, (b) Einrich-

tung, Management, Entwicklung und Veräußerung ihrer Vermögenswerte, wie diese sich von Zeit zu Zeit zusammenset-
zen, nämlich - allerdings nicht beschränkt auf - ihr Portofolio von Wertpapieren beliebigen Ursprungs, (c) die Beteiligung
bei der Gründung, Entwicklung und Kontrolle beliebiger Unternehmen, (d) der Erwerb durch Anlage, Zeichnung, Erst-
zeichnung oder anhand von Operationen von Wertpapieren und jeglicher geistiger Eigentumsrechte, (e) deren Veräu-
ßerung durch Verkauf, der Übertragung, des Tauschgeschäfts oder anderweitig, (f) das Erhalten oder die Gewährung
von Lizenzen für geistige Eigentumsrechte sowie (g) die Gewährung von Beistand, einschließlich finanzieller Unterstüt-
zung, Darlehen, Vorauszahlungen oder Bürgschaften oder Garantien, für oder zugunsten von Unternehmen, an denen
die Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt ist.

Die Gesellschaft kann jegliche Anlagen tätigen die sie zur Erfüllung oder Weiterentwicklung des Geschäftszwecks vor-

nehmen, die sie für notwendig oder nützlich hält, um ihren Geschäftszweck zu erfüllen oder weiterzuentwickeln, ein-
schließlich, aber nicht beschränkt auf das Eingehen oder die Vornahme von geschäftlichen Transaktionen, die die
Realisierung ihres Geschäftszwecks direkt oder indirekt fördern.

Art. 4. Geschäftssitz
Der Geschäftssitz der Gesellschaft lautet: 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxemburg.
Die Gesellschaft kann ihren Geschäftssitz innerhalb der Stadt Luxemburg oder innerhalb des Großherzogtums Lu-

xemburg an einen anderen Ort verlegen, soweit die Gesellschafter einen dementsprechenden Beschluss fassen.

Die Gesellschaft kann per Beschluss ihrer Gesellschafter Niederlassungen und Zweigstellen in Luxemburg und im

Ausland unterhalten (unabhängig davon, ob es sich um ständige Niederlassungen handelt oder nicht).

Art. 5. Definitionen
Für die Zwecke dieser Satzung gelten die folgenden Definitionen:
1. «zugelassener Gesellschafter» hat die im Artikel 9.2 festgelegte Bedeutung;
2. «verbundenes Unternehmen» bedeutet in Bezug auf eine Person jede andere Person, die direkt oder indirekt die

erstgenannte Person kontrolliert, von dieser kontrolliert wird oder mit ihr unter einer gemeinsamen Kontrolle steht.
Für die Zwecke dieser Definition bezeichnet der Begriff «kontrollieren» in Bezug auf beliebige Personen die Macht, das
Management und die Politik einer Person zu leiten oder leiten zu lassen, sei es auf der Basis der Inhaberschaft stimmbe-
rechtigter Wertpapiere, auf der Basis eines Vertrags (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kommanditgesellschafts-
verträge oder allgemeine Personengesellschaftsverträge) oder anderweitig. Weiterhin gelten die Kommanditisten einer
Kommanditgesellschaft sowie Personen, die direkt oder indirekt Anteile an solchen Kommanditisten-beteiligungen ha-
ben, als verbundene Unternehmen solcher Kommanditgesellschaften;

3. BW HOLDCO bedeutet CALLAHAN BADEN-WÜRTTEMBERG GMBH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung, die laut deutschem Recht gegründet wurde.

4. «Geschäftstag» ist jeder Tag außer Samstagen und Sonntagen oder den Tagen, an dem die Bankinstitute in London,

England, Luxemburg-Stadt, Luxemburg oder New York, New York geschlossen bleiben müssen oder können,

5.  «ordentliche Geschäftsanteile der Klasse A»,  «ordentliche Geschäftsanteile der Klasse A-2»,  «ordentliche Ge-

schäftsanteile der Klasse A-3», «Geschäftsanteile der Klasse B-2», haben die im Artikel 6 festgelegte Bedeutung;

6. «Gesellschaft» ist die CALLAHAN INVESTCO GERMANY 1, S.à r.l.;
7. «Gesellschaftswertpapiere» beziehen sich gemeinsam auf die INVESTCO 2 WERTPAPIERE (BWA), die INVEST-

CO 2 WERTPAPIERE (BW-B) und die INVESTCO 2 WERTPAPIERE (NRW).

8. «Ausschüttung» und «Ausschüttungen» bezieht sich auf Ausschüttungen der Gesellschaft in Form von Dividenden,

Erträgen aus Kapitalauszahlungen, Liquidationzahlungen (vollständig oder teilweise) oder Sonstigem.

9. «EURO» ist der Euro, d.h. die Einheitswährung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die kraft dem Vertrag

der Europäischen Union eingerichtet wurde und auf die in den Regelungen der Wirtschafts- und Währungsunion Bezug
genommen wird;

10. INVESTCO WERTPAPIERE (BW-A) bezieht sich gemeinsam auf die INVESTCO 2 WERTPAPIERE (BW), die

Schuldscheine (Serie 2), die von der Gesellschaft am 5. September 2001 ausgegeben wurden, und die Vorzugsgesell-
schaftskapitalzertifikate (Serie 2), die von der Gesellschaft laut deren Bedingungen am 5. September 2001 ausgegeben
wurden;

11. INVESTCO 1 Sicherheiten (BW-B) bezieht sich gemeinsam auf die INVESTCO 1 WERTPAPIERE (NRW), die

Schuldscheine (Serie 3), die von der Gesellschaft am 5. September 2001 ausgegeben wurden, und auf die Vorzugsgesell-

10502

schaftskapitalzertifikate (Serie 1), die von der Gesellschaft laut deren Bedingungen am 5. September 2001 ausgegeben
wurden;

12. INVESTCO 2 WERTPAPIERE (BW) bezieht sich gemeinsam auf alle Wertpapiere INVESTCO, auf alle INVESTCO

2 WERTPAPIERE (NRW), die Schuldscheine (Serie 1) welche von der Gesellschaft am 5. September 2001 ausgegeben
wurden, sowie die Vorzugsgesellschaftskapitalzertifikate (Serie 1) die von der Gesellschaft laut deren Bedingungen am
5. September 2001 ausgegeben wurden;

13. INVESTCO 2 Wertpapiere (BW-A) bezieht sich auf die ordentlichen Anteile der Klasse A-2;
14. INVESTCO 2 Anteile (BW-B) bezieht sich auf die ordentlichen Anteile der Klasse A-3;
15. INVESTCO 2 Anteile (NRW) bezieht sich auf die ordentlichen Anteile der Klasse A;
16. «Recht» ist das luxemburgische Recht für Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 so wie abgeändert;
17. «Geschäftsführer» hat die im Artikel 11.1 festgelegte Bedeutung;
18. NRW HOLDCO bedeutet CALLAHAN NORDRHEIN-WESTFALEN GMBH, eine Gesellschaft mit beschränkter

Haftung, die laut deutschem Recht gegründet wurde;

19. «ordentliche Geschäftsanteile» sind gemeinsam die INVESTCO 2 Geschäftsanteile (BW-A), die INVESTCO 2 Ge-

schäftsanteile (BW-B) und die INVESTCO 2 Geschäftsanteile (NRW);

20. «ursprünglicher Gesellschafter» hat die im Artikel 9.1 festgelegte Bedeutung;
21. «Person» bezeichnet Privatpersonen, Kapital- und Personengesellschaften, Unternehmen, Joint Ventures, Verei-

nigungen, Trusts, nicht eingetragene Organisationen, Regierungskörperschaften (oder Körperschaften von Agenturen,
vollständig beherrschte Gesellschaften oder politische Unterabteilungen solcher Regierungen) oder sonstige Körper-
schaften;

22. «Anteilregister» hat die im Artikel 7.2 festgelegte Bedeutung;
23. «Anteile» sind die Anteile am Kapital der Gesellschaft;
24. «Gesellschafter» sind die Personen, die als solche im Geschäftsanteilregister eingetragen sind, das gemäß Artikel

7.2 unterhalten wird;

25. «Tranche BW-A Ausschüttung» bezieht sich in Bezug auf alle Ausschüttungen auf einen diesbezüglichen Teil, der

gleich dem Produkt des Tranche BW-A Prozentsatzes und dem Gesamtausschüttungsbetrag ist;

26. «Tranche BW-B Ausschüttung» bezieht sich in Bezug auf alle Ausschüttungen auf einen diesbezüglichen Teil, der

gleich dem Produkt des Tranche BW-B Prozentsatzes und dem Gesamtausschüttungsbetrag ist;

27. «Tranche BW-A Prozentsatz» heißt 34.879848 %;
28. «Tranche BW-B Prozentsatz heißt 3.327387 % Tranche NRW Ausschüttung» bezieht sich in Bezug auf alle Aus-

schüttungen auf den diesbezüglichen Anteil, der gleich dem Produkt der Tranche NRW Prozentsatzes und dem Gesamt-
betrag der Ausschüttung ist;

29. «Tranche NRW Prozentsatz» heißt 61.792765 % bezieht sich auf den Quotienten (in Prozent ausgedrückt) (a)

des originalen Gesamtkaufspreises der INVESTCO 1 Sicherheiten (NRW) zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe, und auf (b) den
originalen Gesamtkaufspreis der Gesellschaftssicherheiten zum Zeitpunkt ihrer Ausgabe.

Kapitel II. Kapital und Anteile

Art. 6. Kapital
Der Nennwert des gezeichneten Gesellschaftskapitals wird mit 5.989.050 (fünf Millionen, neunhundertneunundacht-

zig tausend und fünfzig) Euro festgelegt, und setzt sich aus drei Tranchen von ordentlichen Geschäftsanteilen zusammen:
(i) die INVESTCO 2 Geschäftsanteile (NRW), (ii), die INVESTCO 2 Geschäftsanteile (BWA), und (iii), die INVESTCO
2 Geschäftsanteile (BW-B)

Abschnitt 1. - INVESTCO 2 Geschäftsanteile (NRW)
INVESTCO 2 Geschäftsanteile (NRW) setzen sich wie folgt zusammen:
einhundertundfünfzigtausendzweihundertfünfzig (150.250) Geschäftsanteile (die hiermit als
«ordentliche Geschäftsanteile der Klasse A», bezeichnet werden) und deren Nennwert je Euro 25,- beträgt;
Die Stimmrechte, die Vorzugsrechte sowie die Verhältnis, Beteiligungs-, Options-, oder sonstigen Sonderrechte und

die mit den Geschäftsanteilklassen der INVESTCO 1 Geschäftsanteilen und den betreffenden Serien verbundenen Be-
dingungen, Auflagen und Einschränkungen der Serien der Klassen der INVESTCO 2 Geschäftsanteile (NRW) sind wie
folgt:

Sämtliche ordentliche Geschäftsanteile der Klasse A sind in jeder Hinsicht identisch, zu den Zahlungen der Tranche

NRW Ausschüttungen. Sämtliche Geschäftsanteile der Klasse A, die von der Gesellschaft gekauft oder anderweitig er-
worben wurden, werden mit der Wirkung zurückgezogen, dass die ausgegebene Anzahl der Geschäftsanteile der Klasse
A reduziert wird.

1. Ausschüttungen. Die Inhaber von Geschäftsanteilen von ordentlichen Geschäftsanteilen der Klasse A haben das

Recht alle Tranche NRW Ausschüttungen zu erhalten wenn diese gemacht werden und wenn solche von einer Gesell-
schafterversammlung beschlossen werden, aus den Geldern die ihr dafür zur Verfügung stehen so wie im Gesetz vor-
gesehen. Diese Gelder werden pro rata zu den Zahl von Anteilen ausgeschüttet.

2. Stimmrechte. Jeder Geschäftsanteil der Klasse A verleiht dem Inhaber das Recht, bei sämtlichen Angelegenheiten,

die der Abstimmung der Gesellschafter bedürfen, mit einer Stimme abzustimmen.

3. Rechte bei Auflösung. Im Falle einer freiwilligen oder zwangsläufigen Auflösung, Liquidation oder Abwicklung

(«Auslösung») hat der Inhaber von Geschäftsanteilen der Klasse A aus einer bestimmten Serie nach Begleichung sämt-
licher entsprechenden Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein Recht auf Erhalt des Teil der verbleibenden
Vermögenswerte, auf die er gemäß Teil II dieses Absatzes A Anspruch hätte, wäre die Auflösung eine Tranche NRW
Ausschüttung seitens der Gesellschaft. Sämtliche Beträge, die an die Inhaber einer Serie von Geschäftsanteilen der Klas-
se A auszuschütten sind, werden paritätisch Anteil für Anteil ausgeschüttet, soweit im Teil II dieses Absatzes A, Ab-
schnitt 1 des Artikels 6 nicht anderweitig vorgesehen. Weder eine Fusion noch eine Zusammenlegung der Gesellschaft

10503

mit bzw. in eine oder mehrere andere Körperschaften und weder die Fusion noch eine Zusammenlegung einer oder
mehrerer anderer Körperschaften mit bzw. in die Gesellschaft und weder ein Verkauf, eine Übertragung noch ein Ver-
leasen oder Austausch (gegen Bargeld, Wertpapiere oder sonstige Gegenleistungen) aller oder einiger Vermögenswerte
der Gesellschaft wird als Auflösung, Liquidation oder Abwicklung der Gesellschaft im Sinne dieser Ziffer 3 betrachtet,
es sei denn, eine Fusion, eine Zusammenlegung, ein Verkauf, eine Übertragung, ein Verleasen bzw. ein Austausch erfol-
gen in Verbindung mit oder sind Teil eines Plan einer vollständigen Auflösung, Liquidation oder Abwicklung der Gesell-
schaft.

4. Rückkauf; Umwandelbarkeit; Abtretbarkeit. Für ordentliche Geschäftsanteile der Klasse A gilt kein obligatorischer

Rückkauf; diese Geschäftsanteile können nicht in andere Geschäftsanteile (des) umgewandelt und nicht abgetreten wer-
den.

Abschnitt 2 - INVESTCO 2 Geschäftsanteile (BW-A)
INVESTCO 2 Geschäftsanteile (BW-A) setzen sich wie folgt zusammen:
zweiundachtzigtausend einhundert und achtzehn (82.118) Geschäftsanteile (die hiermit als «ordentliche Geschäftsan-

teile der Klasse A-2», bezeichnet werden) und deren Nennwert je Euro 25,0 beträgt;

Die Stimmrechte, die Vorzugsrechte sowie die Verhältnis-, Beteiligungs-, Options-, oder sonstigen Sonderrechte und

die mit den Geschäftsanteilklassen der INVESTCO 2 Geschäftsanteilen und den betreffenden Serien verbundenen Be-
dingungen, Auflagen und Einschränkungen der Serien der Klassen der INVESTCO 2 Geschäftsanteile (BW-A) sind wie
folgt:

Sämtliche ordentliche Geschäftsanteile der Klasse A-2 sind in jeder Hinsicht identisch, zu den Zahlungen der Tranche

BW-A Ausschüttungen. Sämtliche Geschäftsanteile der Klasse A-2, die von der Gesellschaft gekauft oder anderweitig
erworben wurden, werden mit der Wirkung zurückgezogen, dass die ausgegebene Anzahl der Geschäftsanteile der Klas-
se A reduziert wird.

1. Ausschüttungen. Die Inhaber von Geschäftsanteilen von ordentlichen Geschäftsanteilen der Klasse A-2 haben das

Recht alle Tranche BW-A Ausschüttungen zu erhalten wenn diese gemacht werden und wenn solche von einer Gesell-
schafterversammlung beschlossen werden, aus den Geldern die ihr dafür zur Verfügung stehen so wie im Gesetz vor-
gesehen. Diese Gelder werden pro rata zu den Zahl von Anteilen ausgeschüttet.

2. Stimmrechte. Jeder Geschäftsanteil der Klasse A verleiht dem Inhaber das Recht, bei sämtlichen Angelegenheiten,

die der Abstimmung der Gesellschafter bedürfen, mit einer Stimme abzustimmen.

3. Rechte bei Auflösung. Im Falle einer freiwilligen oder zwangsläufigen Auflösung, Liquidation oder Abwicklung

(«Auslösung») hat der Inhaber von Geschäftsanteilen der Klasse A aus einer bestimmten Serie nach Begleichung sämt-
licher entsprechenden Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein Recht auf Erhalt des Teil der verbleibenden
Vermögenswerte, auf die er gemäß Teil Il dieses Absatzes A Anspruch hätte, wäre die Auflösung eine Tranche BW A
Ausschüttung seitens der Gesellschaft. Sämtliche Beträge, die an die Inhaber einer Serie von Geschäftsanteilen der Klas-
se A-2 auszuschütten sind, werden paritätisch Anteil für Anteil ausgeschüttet, soweit im Teil II dieses Absatzes A, Ab-
schnitt 1 des Artikels 6 nicht anderweitig vorgesehen. Weder eine Fusion noch eine Zusammenlegung der Gesellschaft
mit bzw. in eine oder mehrere andere Körperschaften und weder die Fusion noch eine Zusammenlegung einer oder
mehrerer anderer Körperschaften mit bzw. in die Gesellschaft und weder ein Verkauf, eine Übertragung noch ein Ver-
leasen oder Austausch (gegen Bargeld, Wertpapiere oder sonstige Gegenleistungen) aller oder einiger Vermögenswerte
der Gesellschaft wird als Auflösung, Liquidation oder Abwicklung der Gesellschaft im Sinne dieser Ziffer 3 betrachtet,
es sei denn, eine Fusion, eine Zusammenlegung, ein Verkauf, eine Übertragung, ein Verleasen bzw. ein Austausch erfol-
gen in Verbindung mit oder sind Teil eines Planes einer vollständigen Auflösung, Liquidation oder Abwicklung der Ge-
sellschaft.

4. Rückkauf; Umwandelbarkeit; Abtretbarkeit. Für ordentliche Geschäftsanteile der Klasse A-2 gilt kein obligatori-

scher Rückkauf; diese Geschäftsanteile können nicht in andere Geschäftsanteile (des) umgewandelt und nicht abgetreten
werden.

Abschnitt 3 - INVESTCO 2 Geschäftsanteile (BW-B)
INVESTCO 2 Geschäftsanteile (BW-B) setzen sich wie folgt zusammen:
siebentausend einhundertvierundneunzig (7.194) Geschäftsanteile (die hiermit als «ordentliche Geschäftsanteile der

Klasse A-3», bezeichnet werden) und deren Nennwert je Euro 25,- beträgt;

Die Stimmrechte, die Vorzugsrechte sowie die Verhältnis-, Beteiligungs-, Options-, oder sonstigen Sonderrechte und

die mit den Geschäftsanteilklassen der INVESTCO 2 Geschäftsanteilen und den betreffenden Serien verbundenen Be-
dingungen, Auflagen und Einschränkungen der Serien der Klassen der INVESTCO 2 Geschäftsanteile (BW-B) sind wie
folgt:

Sämtliche ordentliche Geschäftsanteile der Klasse A sind in jeder Hinsicht identisch, zu den Zahlungen der Tranche

BW-B Ausschüttungen, Absatz A, Abschnitt 1 von Artikel 6 nicht anderweitig vorgesehen. Die Anteile einer jeden Serie
der Geschäftsanteile der Klasse A sind in jeder Hinsicht miteinander identisch, soweit in diesem Absatz A, Abschnitt 1
des Artikels 6 nicht anderweitig vorgesehen. Die Anteile jeder Serie von Geschäftsanteilen der Klasse A nehmen anteil-
mäßig (soweit im Teil II dieses Absatzes A, Abschnitt 1 des Artikels 6 nicht anderweitig vorgesehen) an der Ausschüttung
von Tranche BW-B teil.

Sämtliche Geschäftsanteile der Klasse A-3, die von der Gesellschaft gekauft oder anderweitig erworben wurden, wer-

den mit der Wirkung zurückgezogen, daß die ausgegebene Anzahl der Geschäftsanteile der Klasse A reduziert wird.

1. Ausschüttungen. Die Inhaber von Geschäftsanteilen von ordentlichen Geschäftsanteilen der Klasse A haben das

Recht alle Tranche BW-B Ausschüttungen zu erhalten wenn diese gemacht werden und wenn solche von einer Gesell-
schafterversammlung beschlossen werden, aus den Geldern die ihr dafür zur Verfügung stehen so wie im Gesetz vor-
gesehen. Diese Gelder werden pro rata zu den Zahl von Anteilen ausgeschüttet.

10504

2. Stimmrechte. Jeder Geschäftsanteil der Klasse A-3 verleiht dem Inhaber das Recht, bei sämtlichen Angelegenheiten,

die der Abstimmung der Gesellschafter bedürfen, mit einer Stimme abzustimmen.

3. Rechte bei Auflösung. Im Falle einer freiwilligen oder zwangsläufigen Auflösung, Liquidation oder Abwicklung

(«Auslösung») hat der Inhaber von Geschäftsanteilen der Klasse A aus einer bestimmten Serie nach Begleichung sämt-
licher entsprechenden Schulden und Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein Recht auf Erhalt des Teil der verbleibenden
Vermögenswerte, auf die er gemäß Teil II dieses Absatzes A Anspruch hätte, wäre die Auflösung eine Tranche BW-B
Ausschüttung seitens der Gesellschaft. Sämtliche Beträge, die an die Inhaber einer Serie von Geschäftsanteilen der Klas-
se A-3 auszuschütten sind, werden paritätisch Anteil für Anteil ausgeschüttet, soweit im Teil lI dieses Absatzes A, Ab-
schnitt 1 des Artikels 6 nicht anderweitig vorgesehen. Weder eine Fusion noch eine Zusammenlegung der Gesellschaft
mit bzw. in eine oder mehrere andere Körperschaften und weder die Fusion noch eine Zusammenlegung einer oder
mehrerer anderer Körperschaften mit bzw. in die Gesellschaft und weder ein Verkauf, eine Übertragung noch ein Ver-
leasen oder Austausch (gegen Bargeld, Wertpapiere oder sonstige Gegenleistungen) aller oder einiger Vermögenswerte
der Gesellschaft wird als Auflösung, Liquidation oder Abwicklung der Gesellschaft im Sinne dieser Ziffer 3 betrachtet,
es sei denn, eine Fusion, eine Zusammenlegung, ein Verkauf, eine Übertragung, ein Verleasen bzw. ein Austausch erfol-
gen in Verbindung mit oder sind Teil eines Plan einer vollständigen Auflösung, Liquidation oder Abwicklung der Gesell-
schaft.

4. Rückkauf; Umwandelbarkeit; Abtretbarkeit. Für ordentliche Geschäftsanteile der Klasse A-3 gilt kein obligatori-

scher Rückkauf; diese Geschäftsanteile können nicht in andere Geschäftsanteile (des) umgewandelt und nicht abgetreten
werden.

Abschnitt 4 - Zusätzliche Bestimmungen
Die Geschäftsanteile der Gesellschaft einer oder mehrerer hier genehmigten Tranchen (und einer oder mehrerer

Klassen einer Tranche sowie auch beliebiger Serien dieser Klasse(n)) können von der Gesellschaft von Zeit zu Zeit ge-
mäß eines Beschlusses der Gesellschafter der Gesellschaft gegen Entgelt ausgegeben werden, das gesetzlich erlaubt ist
und von Zeit zu Zeit von den Gesellschaftern festgelegt werden kann (jedoch unter der Voraussetzung, dass dieses Ent-
gelt mindestens Euro 25,- beträgt).

Sämtliche Geschäftsanteile stimmen gemeinsam ab, und, ausgenommen des gesetzlich Vorgeschriebenen, sind die In-

haber einer separaten Tranche, Klasse oder Anteilsserie nicht dazu berechtigt, getrennt über Geschäfte abzustimmen.

Keine Geschäftsanteile keiner Tranche, Klasse oder Serie haben Anrecht auf Vorkaufsrechte in Bezug auf die Anteile

der Gesellschaft, es sei denn, sämtliche Gesellschafter beschlossen Anderweitiges in einer schriftlichen Vereinbarung,
die von allen Gesellschaftern unterschrieben wurde.

Alle Ausschüttungen finden quotenmäßig als Tranche BW Ausschüttung und als Tranche NRW Ausschüttung statt.

Solange keine Ausschüttung Zug um Zug mit allen anderen Tranchen von Geschäftsanteilen durchgeführt wird, wird
keine Ausschüttung für keine Tranchen von Geschäftsanteilen vorgenommen. Solange die Rechte aller Klassen von Ge-
schäftsanteilen dieser in Artikel 6 aufgeführten Tranche nicht beachtet werden, wird keine Ausschüttung für Tranchen
von Anteilen vorgenommen.

Art. 7. Geschäftsanteile und Geschäftsanteilregister
1. Geschäftsanteile
Die Geschäftsanteile sind Namensanteile und werden in ein Register aufgenommen. Die Gesellschaft kann Anteils-

zertifikate ausgeben, die lediglich die Eintragung der Geschäftsanteile nachweisen, wobei die Unterlassung einer solchen
Ausgabe aber die Rechte des Inhabers von Geschäftsanteilen nicht beeinträchtigt.

Die Geschäftsanteile sind in Bezug auf die Gesellschaft unteilbar. Eine gemeinsame Inhaberschaft von Geschäftsantei-

len ist zulässig. Die Gemeinschaftsinhaber von Geschäftsanteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft von einer ein-
zigen Person vertreten lassen. Solange diese Bestimmung nicht erfüllt ist, sind die Rechte bezüglich solcher
Geschäftsanteile einstweilig aufgehoben.

2. Geschäftsanteilregister
Am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft wird ein Geschäftsanteilregister («Geschäftsanteilregister») unter-

halten, das allen Gesellschaftern zur Einsicht zur Verfügung steht. Es kann in jeder angemessenen Form unterhalten wer-
den, einschließlich einer computerisierten Form.

Das Geschäftsanteilregister enthält die folgenden Angaben:
Name und Wohnsitz des eingetragenen Geschäfts jedes Gesellschafters;
Datum der Zulassung jedes Gesellschafters;
die Anzahl der von jedem Gesellschaft pro Klasse und Serie gehaltenen Geschäftsanteile sowie den von jedem Ge-

sellschafter auf seine Geschäftsanteile eingezahlten Betrag;

eine Aufzeichnung sämtlicher Geschäftsanteilübertragungen, einschließlich dem Datum der Übertragung;
eine Aufzeichnung sämtlicher Ausschüttungen in Bezug auf Geschäftsanteile, einschließlich dem Datum ihrer Vornah-

me.

Jeder Eintrag im Geschäftsanteilregister wird vom Geschäftsführer oder einer von ihm dafür benannten Person vor-

genommen, wenn (1) der Geschäftsführer von dem oder den betreffenden Gesellschaftern die Informationen erhalten
hat, die er im Sinne eines Nachweises des betreffenden Eintrags für hinreichend hält, und (ii) die Bestimmungen des Ar-
tikels 8 dieses Vertrags im Falle einer Übertragung erfüllt worden sind. Das Geschäftsanteilregister stellt zusammen mit
den vorgenannten Nachweisen einen schlüssigen Nachweis über die Inhaberschaft von Geschäftsanteilen an der Gesell-
schaft sowie über die Anzahl der Geschäftsanteile dar, die ein Gesellschafter von Zeit zu Zeit hält.

Art. 8. Übertragung von Geschäftsanteilen
Kein Gesellschafter ist befugt, Geschäftsanteile oder Rechte, Ansprüche oder Interessen daran direkt oder indirekt

zu veräußern, abzutreten, zu verpfänden, eine Kauf- oder anderweitige Übertragungsoption darauf zu gewähren, sei es

10505

kraft Gesetz oder auf anderen Wege, es sei denn, solche Vorgänge werden durch diesen Artikel 8 oder durch schriftli-
che und von allen Gesellschaftern unterzeichnete Vereinbarungen genehmigt.

Übertragungen unter Verletzung des vorstehenden Satzes sind null und nichtig, und die Gesellschaft wird solche

Übertragungen nicht in das Geschäftsanteilsregister aufnehmen.

Eine Übertragung von Geschäftsanteilen wird gegenüber der Gesellschaft und dritten Parteien erst gültig, wenn diese

Übertragung von der Gesellschaft gemäß Artikel 7.2 dieses Vertrags in das Geschäftsanteilregister aufgenommen wor-
den ist.

Die Übertragung von Geschäftsanteilen muß vorbehaltlich dieses Artikels 8 dieser Satzung, des Artikels 189 des Ge-

setzes und vorbehaltlich des vorstehenden Absatzes anhand der im Artikel 1690 des Luxemburger Code Civil nieder-
gelegten Verfahren erfolgen.

Kapitel III. Gesellschafter

Art. 9. Ursprüngliche und zugelassene Gesellschafter
1. Ursprüngliche Gesellschafter
Jeder Gesellschafter der Gesellschaft, der am Tag der Annahme dieser Satzung existiert (einschließlich, um jeden

Zweifel auszuschalten, den Gesellschaftern, die bei der Gesellschafterversammlung zugelassen wurden, bei der diese Sat-
zung neu formuliert wurde), wird als «ursprünglicher Gesellschafter» bezeichnet.

2. Zugelassene Gesellschafter
Jeder Gesellschafter, der später von der Gesellschaft als solcher zugelassen wird, wird als «zugelassener Gesellschaf-

ter» bezeichnet.

Die Bedingungen für eine Zulassung als Gesellschafter sowie die Gründe, aus denen die bestehenden Gesellschafter

schriftlich oder gegebenenfalls im. Rahmen einer Abstimmung der Gesellschafter bei einer Gesellschafterversammlung
Einwände gegen eine Zulassung erheben können, können in einem schriftlichen Vertrag niedergelegt werden, der von
Zeit zu Zeit oder zu beliebigen Zeitpunkten zwischen den Gesellschaftern geschlossen wird.

Art. 10. Haftung der Gesellschafter
Die Gesellschafter haften bis zum Betrag ihrer Zeichnung, und diese Haftung ist nicht gesamtschuldnerisch.

Kapitel IV. Verwaltung und Aufsicht

Art. 11. Geschäftsführer
1. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Die Gesellschafter können von Zeit

zu Zeit einen oder mehrere schriftliche Verträge bezüglich der Geschäftsführung abschließen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf deren Nominierung, Bestellung und Absetzung bzw. Austausch.

2. Dem Geschäftsführer obliegt die Entscheidung über die nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten, und der Ge-

schäftsführer wird die Sorge für deren Umsetzung tragen: (a) eingetragene Büroeinrichtung; (b) Ausgabe von Geschäfts-
büchern und Steuerunterlagen; (c) allgemeine Unternehmensverwaltung; (d) Unterhaltung des Geschäftsanteilregisters;
(e) Unterhaltung von Einlagen- und Ausschüttungsinformationen für alle Gesellschafter (einschließlich Kapitalkontenda-
ten); (f) Vorlage der jährlichen oder anderweitig regelmäßigen Berichte und Akten bei den zuständigen luxemburgischen
Behörden zur Aufrechterhaltung der Existenz und des guten Rufs der Gesellschaft (soweit anwendbar) sowie die Über-
weisung von dabei fällig werdenden Gebühren; (g) Aufbewahrungsdienste; (h) Transferagentendienste; und (i) die Ange-
legenheiten, die einem Geschäftsführer kraft Gesetz vorbehalten sind.

Art. 12. Delegierung von Befugnissen und Vertretung der Gesellschaft
1. Der Geschäftsführer kann die Gesellschaft gemäß den Weisungen der Gesellschafter gegenüber dritten Parteien

vertreten.

2. Soweit die Gesellschafter keine anderweitigen Weisungen ausgeben, ist der Geschäftsführer nicht befugt, Komitees

einzurichten, deren Einrichtung zu genehmigen oder alle oder einige Aspekte seiner Befugnisse an ein Komitee zu dele-
gieren.

3. Wenn ein diesbezüglicher Gesellschafterbeschluss verabschiedet wird, kann der Geschäftsführer die Gesellschaft

gegenüber dritten Parteien vertreten oder einen oder mehrere Handlungsbevollmächtigte bestellen, die die Gesellschaft
auf einer ad-hoc-Basis in Bezug auf spezifische Angelegenheiten vertreten können (dabei gilt, dass ein solcher Handlungs-
bevollmächtigter auch direkt durch Gesellschafterbeschluss bestellt werden kann).

Art. 13. Gerichtsverfahren
Soweit er von den Gesellschaftern entsprechende Weisungen erhalten hat, wird der Geschäftsführer Gerichtsver-

fahren bzw. die Verteidigung in Gerichtsverfahren im und auf den Namen der Gesellschaft führen, unabhängig davon, ob
die Gesellschaft Klägerin oder Beklagte ist.

Kapital V. Gesellschafterversammlungen

Art. 14. Zusammensetzung und Befugnisse
1. Alle Gesellschafter wohnen den außergewöhnlichen oder gewöhnlichen Hauptversammlungen («Gesellschafter-

versammlungen») bei.

2. Den Gesellschaftern obliegt weiteste Vollnacht, Beschlüsse in Bezug auf die Gesellschaft zu fassen. Die Entschei-

dung über sämtliche Angelegenheiten wird von den Gesellschaftern getroffen. Der Kompetenzbereich der Gesellschaf-
ter beinhaltet jegliche Handlungen, die nicht kraft Gesetz, kraft dieser Satzung und/oder kraft einem zwischen den
Gesellschaftern von Zeit zu Zeit geschlossenem Vertrag ausdrücklich dem Geschäftsführer vorbehalten sind.

Art. 15. Versammlungen - Einladungen - Informationen
1. Mindestens die Mehrheit aller Gesellschafterversammlungen ist pro Jahr in Luxemburg abzuhalten (in jedem Fall

aber eine dieser Versammlungen pro Jahr). Versammlungen, an denen Gesellschafter per Telefon- oder Videokonferenz

10506

beiwohnen, gelten als in Luxemburg abgehaltene Versammlungen, wenn mindestens ein Gesellschafter körperlich in Lu-
xemburg anwesend ist und die Konferenz von Luxemburg aus initiiert wird. Bei einer Teilnahme von Gesellschaftern
per Telefon- oder Videokonferenz müssen die bei der Versammlung gefaßten Beschlüsse von den Gesellschaftern, die
bei der Versammlung nicht körperlich anwesend oder vertreten waren, unterzeichnet werden, und für diesen Fall finden
die im Artikel 15.2 genannten Formalitäten Anwendung.

2. Gesellschafterversammlungen finden so oft statt, wie es für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft und die

Ausübung ihrer Rechte an NRW HOLDCO und/oder BW HOLDCO erforderlich ist, in jedem Fall aber (i) mindestens
einmal pro Jahr und (ii) umgehend vor jeder Sitzung des Vorstands oder der Gesellschafter der NRW HOLDCO und/
oder BW HOLDCO. Gesellschafterversammlungen können einberufen werden von einem oder mehreren Gesellschaf-
tern, der/die insgesamt mindestens 10% der ausstehenden Geschäftsanteile oder den höheren Prozentsatz innehat/in-
nehaben, der durch unverzichtbare gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben ist. Der/die Gesellschafter, der/die die
Versammlung einberuft/einberufen, sendet/senden eine schriftliche Einladung an die Gesellschaft, die ihrerseits innerhalb
von einem Tag nach Erhalt der Einladung die schriftlichen Mitteilungen an alle Gesellschafter versendet. Eine Gesellschaf-
terversammlung wird frühestens 10 Tage nach Versand der vorgenannten schriftlichen Mitteilungen seitens der Gesell-
schaft abgehalten. Diese Frist beginnt an dem Tag, der dem Versand der Mitteilungen seitens der Gesellschaft folgt. Der
Tag, an dem die Versammlung stattfindet, wird nicht mitgezählt. Eine Einladung zu Gesellschafterversammlungen enthält
Angaben über Ort und Zeit der Versammlung, eine Darlegung der zu behandelnden Geschäftsangelegenheiten und alle
sachdienlichen Dokumentationen.

3. Jeder Gesellschafter ist befugt, Tagesordnungspunkte für eine Gesellschafterversammlung vorzuschlagen; die ande-

ren Gesellschafter erhalten so früh, wie es vor der Versammlung möglich ist (in jedem Fall aber spätestens fünf Tage vor
der Versammlung) schriftlichen Bescheid über diese Tagesordnungspunkte.

4. Werden die Mitteilungsanforderungen in diesem Artikel 15 nicht erfüllt, können bei der betreffenden Versammlung

dennoch gültige Beschlüsse verabschiedet werden, wenn jeder Gesellschafter entweder (i) einen Mitteilungsverzicht un-
terzeichnet oder (ii) bei der Gesellschafterversammlung anwesend ist oder durch einen Stimmrechtsbevollmächtigten
vertreten ist (der allerdings nicht den Auftrag haben darf, Einspruch gegen das Abhalten der Versammlung einzulegen).

5. Die Gesellschaft trägt Sorge dafür, dass die Gesellschafter auf angemessenen schriftlichen Wunsch hin sämtliche

verfügbaren Informationen und Daten sowie eine Kopie aller verfügbaren Dokumente erhalten, die sich auf die Gesell-
schaft oder eine Körperschaft, in die die Gesellschaft investiert hat, beziehen.

Art. 16. Entscheidungsverfahren bei Gesellschafterversammlungen
1. Beschlussfähigkeit
Eine Gesellschafterversammlung ist zur Durchführung von Maßnahmen beschlussfähig, wenn die Anzahl an Gesell-

schaftern anwesend ist, die die Gesellschafter schriftlich beschließen.

Liegt bei Eröffnung einer Gesellschafterversammlung keine Beschlussfähigkeit vor, sind die vertretenen Gesellschafter

nicht zur Durchführung von Maßnahmen befugt, sondern müssen die Versammlung auf ein Datum frühestens 15 Tage
nach Versand einer schriftlichen Einladung für die vertagte Versammlung vertagen; in dieser Mitteilung sind die Tatsache
der Vertagung sowie Datum, Uhrzeit und Ort der vertagten Sitzung zu nennen. Wenn auch bei dieser vertagten Sitzung
keine offizielle Beschlussfähigkeit vorliegt, gilt diese Sitzung dennoch als beschlussfähig, und die anwesenden oder ver-
tretenen Gesellschafter sind vorbehaltlich einer gesetzlichen Anforderung an eine höhere Anzahl befugt, sämtliche An-
gelegenheiten mit der Ja-Stimme der Inhaber von über 50% der gesamten vertretenen ausgegebenen Geschäftsanteile
zu entscheiden, die in der vorgenannten Mitteilung (oder der beigefügten Dokumentation) aufgeführt waren, die allen
Gesellschaftern in Zusammenhang mit der ursprünglich anberaumten Sitzung zugestellt wurde; dies gilt vorbehaltlich zu-
sätzlicher Anforderungen aus Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern.

Die Gesellschafter können den Gesellschafterversammlungen persönlich beiwohnen oder sich durch einen ordnungs-

gemäß bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen.

2. Stimmenmehrheit
Soweit kraft Gesetz, kraft etwaiger Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern über Abstimmungen oder kraft die-

ser Satzung nicht ausdrücklich anderweitig erforderlich, werden die Entscheidungen über sämtliche Angelegenheiten:

(a) von allen Gesellschaftern getroffen; und
(b) mit der Stimmenmehrheit getroffen, die von den Gesellschaftern in einer schriftlichen Vereinbarung festgelegt

wird.

Entscheidungen über die folgenden Angelegenheiten dürfen nur mit der Ja-Stimme einer Mehrheit der Inhaber von

insgesamt 90% der ausgegebenen Geschäftsanteile an der Gesellschaft getroffen werden:

(a) jegliche Maßnahmen, deren Wirkung in der Ausweitung des Geschäfts der Gesellschaft bestehen soll, in Bezug auf

andere Aktivitäten als die von Zeit zu Zeit bestehende Inhaberschaft und Verwaltung der Anlage der Gesellschaft in
NRW HOLDCO und BW HOLDCO und deren jeweilige verbundene Unternehmen (vorausgesetzt, dass die Anlagen
in oder der Erwerb von zusätzlichem Kabeleigentum (einschließlich Tätigkeiten auf Ebene 4) oder Kommunikationsei-
gentum (einschließlich City-Trägern) in Deutschland lediglich der Mehrheit bedürfen, die in etwaigen Vereinbarungen
aller Gesellschafter festgelegt ist);

(b) die Einreichung oder die Genehmigung zur Einreichung von Konkurs-, Zwangsverwaltungs- oder Liquidationsver-

fahren oder sonstigen Gerichtsverfahren, die sich auf die Geltendmachung von Rechten der Gläubiger der Gesellschaft
als Ganzem beziehen;

(c) jegliche Maßnahmen, deren Wirkung in der Änderung des Rechtsstatutes der Gesellschaft bestehen soll, außer

Maßnahmen, die laut Festlegung in einem Vertrag zwischen allen Gesellschaftern einer anderen Mehrheit bedürfen.

Jegliche Maßnahmen, deren Wirkung in der Änderung des Gründungszuständigkeitsbereichs der Gesellschaft beste-

hen soll, sind von den Gesellschaftern einstimmig zu beschließen.

10507

Jegliche Maßnahmen zum Zwecke der Änderung dieser Satzung oder der Auflösung der Gesellschaft bedürfen der Ja-

Stimme der Inhaber von insgesamt 75% der ausgegebenen Geschäftsanteile der Gesellschaft.

Art. 17. Beschlüsse, die außerhalb von Versammlung mit körperlicher Anwesenheit gefaßt werden
Anstelle einer Verabschiedung während der Gesellschafterversammlungen können die Beschlüsse der Gesellschafter

auch schriftlich gefaßt werden; dabei gilt die Voraussetzung, dass derart gefaßte Beschlüsse von allen stimmberechtigten
Gesellschaftern einstimmig verabschiedet und von jedem Gesellschafter unterzeichnet werden.

Art. 18. Protokoll
Von jeder Gesellschafterversammlung wird unter Angabe des Ortes und des Datums der Versammlung, der Anwe-

senden sowie der Tagesordnung ein Protokoll angefertigt, in dem die Beratungen zusammengefaßt und die von den Ge-
sellschaftern gefassten Beschlüsse aufgeführt werden.

Protokolle der Gesellschafterversammlungen werden von mindestens zwei Gesellschaftern unterzeichnet.
Die Gesellschaft wird in dem notwendigen Ausmaß dafür sorgen, dass zusätzlich zu der englischsprachigen Fassung

der Protokolle jeder Gesellschafterversammlung eine Übersetzung jedes Protokolls in die französische Sprache ange-
fertigt und in die Akten aufgenommen wird. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und französischen
Fassung ist die englische Fassung maßgeblich.

Kopien oder Auszüge, die bei Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom Geschäftsführer un-

terzeichnet.

Eine Anwesenheitsliste mit den Namen der Gesellschafter und der Anzahl der von ihnen jeweils gehaltenen Ge-

schäftsanteile ist von jedem dieser Gesellschafter oder von deren Stimmrechtsbevollmächtigten vor Beginn der Gesell-
schafterversammlungen zu unterzeichnen.

Kapitel VI. Entscheidungsprozess bezüglich HOLDCO

Art. 19. Umfang
Jede zwischen den Gesellschaftern von Zeit zu Zeit oder zu beliebigen Zeiten schriftlich geschlossene Vereinbarung

kann spezifische Verfahren und Regelungen beinhalten, die sich auf die Ausübung aller Herrschaftsrechte der Gesell-
schaft in H NRW HOLDCO und/oder BW HOLDCO beziehen.

Kapitel VII. Bestände und Jahresabschlüsse - Wirtschaftsprüfer

Art. 20. Geschäftsjahr- Feststellung der Jahresabschlüsse
1. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. August und endet am 31. Juli des darauffolgenden Jahres.
2. Der Geschäftsführer wird die Geschäftsbücher der Gesellschaft zum letzten Tag eines jeden Geschäftsjahres schlie-

ßen, und die Gesellschaft wird die Jahresabschlüsse bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und
den zugehörigen Erläuterungen so schnell wie möglich danach, in jedem Fall aber innerhalb von 60 Tagen danach erstel-
len und den Gesellschaftern innerhalb dieser Frist vorlegen. Die Gesellschaft wird den Gesellschaftern die zugrundelie-
genden Dokumente am eingetragenen Geschäftssitz der Gesellschaft zur Einsicht zur Verfügung stellen.

Der Geschäftsführer wird innerhalb der vorgenannten Frist einen Jahresbericht erstellen.
3. Der Geschäftsführer sorgt dafür, dass die Jahresabschlüsse, die Jahresberichte und die gemäß Sektion XIII des Ge-

setzes zu ergänzenden Einzelheiten ab dem Datum der Einberufung für die Gesellschafterversammlung, bei der diese
Angelegenheiten Gegenstand sein sollen, am eingetragenen Geschäftssitz zur Verfügung stehen. Die Gesellschafter sind
befugt, diese Dokumente jederzeit einzusehen und kostenlose Kopien davon anzufertigen.

4. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen hat jeder Gesellschafter das Recht, nach angemessener Benachrich-

tigung des Geschäftsführers sämtliche Geschäftsbücher, Dokumente und Korrespondenzunterlagen der Gesellschaft zu
prüfen.

5. Die Gesellschafterversammlung nimmt die Genehmigung und Annahme der Jahresabschlüsse vor. Diese Genehmi-

gung und Annahme stellt die Entlastung des Geschäftsführers und des Wirtschaftsprüfers von deren Verbindlichkeiten
in Bezug auf sämtliche Handlungen dar, die aus diesen Dokumenten hervorgehen oder deren Ergebnis in diesen Unter-
lagen dargelegt ist, es sei denn, es wurden ausdrücklich Vorbedingungen oder dementsprechendes festgelegt; diese Be-
stimmung gilt unbeschadet der bestehenden oder zukünftigen gesetzlichen Vorkehrungen zu diesem Thema.

Art. 21. Wirtschaftsprüfer
Die Geschäftsbücher und -unterlagen der Gesellschaft werden von einer Wirtschaftsprüferfirma geprüft, die von der

Gesellschafterversammlung ausgewählt wird.

Kapitel VIII. Auflösung, Abwicklung

Art. 22. Abwicklung
Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft aus beliebigen Gründen und zu beliebigen Zeiten wird die Abwicklung von

einem oder mehreren Abwicklern vorgenommen, die von der Gesellschafterversammlung bestellt werden; soweit diese
Bestellung nicht erfolgt, gilt der Geschäftsführer als Liquidator.

Dem Geschäftsführer stehen zu diesem Zweck die weitestgehenden kraft Gesetz verliehenen Vollmachten zu.
Die Gesellschafterversammlung bestimmt die Vergütung des/der Liquidators/en.

Art. 23. Ausschüttung
Nach der Kapitalrückzahlung wird die Ausschüttung nach Auflösung gemäß Artikel 6 vorgenommen.

Kapitel IX. Verschiedenes

Art. 24. Mitteilungen
Für die Zwecke dieser Satzung sind Mitteilungen persönlich zu übergeben oder per Telegramm, elektronischer Post,

Übernachtkurier, Einschreiben oder Telefax mit Empfangsbestätigung zuzustellen.

10508

Art. 25. U.S.-Steuerbehandlung
Die Gesellschaft hat die Absicht, für die Zwecke der U.S.-Besteuerung fristgerecht für die Klassifizierung als steuerlich

transparente (d.h. «pass-through») Körperschaft mit Wirkung für das erste besteuerbare Jahr zu sorgen. In diesem Zu-
sammenhang ist der Manager sowie jede andere Person, die kraft Beschluss der Gesellschafter bevollmächtigt wurde,
befugt, die entsprechenden Wahlmaßnahmen der Gesellschaft zu unterzeichnen und einzureichen. Die Gesellschafter
werden zur Durchsetzung dieser Wahl in zumutbarer Art und Weise mitarbeiten.

<i>Sixième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d’y intégrer les changements mentionnés

ci-dessus et d’accorder tout pouvoir à tout avocat ou employé de BEGHIN &amp; FEIDER en association avec ALLEN &amp;
OVERY afin de procéder au nom de la Société à l’enregistrement des Parts Sociales nouvellement émises dans le registre
des associés de la Société.

<i>Evaluation

Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de 2.232.800.-EUR est évalué à 90.070.929,- LUF.
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, à environ 1.100.000,-
LUF.

Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes, à Hesperange.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des parties comparantes, le présent acte

est établi en anglais, suivi d’une version française et comprenant des statuts en allemand. A la requête de ces mêmes
parties comparantes, et en cas de distorsions entre la version anglaise et française/allemande, la version anglaise prévau-
dra.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, le représentant du bureau a signé le présent acte avec

le notaire.

Signé: G. Origer, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 17 septembre 2001, vol. 131S, fol. 63, case 10. – Reçu neuf cent mille sept cent neuf

francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61435/220/1159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

CALLAHAN INVESTCO GERMANY 2, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61437/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.741. 

Following the annual general meeting held on 28 June, 2001, the board of directors is comprised as follows:

<i>Board of directors:

- Thomas G. Wattles
- Jonathan Duck
- Dean Jernigan
- A. Richard Moore Jr.
The Company is bound by the sole signature of any director.

Enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61391/250/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Hesperange, le 27 septembre 2001.

G. Lecuit.

Luxembourg, le 27 septembre 2001.

G. Lecuit.

<i>On behalf of ACCESS SELF-STORAGE HOLDINGS S.A.
Signature
<i>Director

10509

SURIA HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.975. 

<i>Extrait des décisions du gérant du 30 mai 2001

«... En vertu de cette autorisation, le gérant prend les résolutions suivantes:
1. Il est décidé de supprimer la valeur nominale des parts sociales.
2. Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 modifiant la loi du 10 août 1915, il est décidé de

convertir, avec effet au 1

er

 janvier 2001, le capital social, actuellement exprimé en LUF, en euros. Ainsi, le capital social

s’établit à EUR 24.838,93.

3. Il est décidé de modifier l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 24.838,93 (vingt quatre mille huit cent trente huit euros et quatre vingt treize

cents), représenté par 501 (cinq cent une) parts sociales sans désignation de valeur nominale.»

4. Il est décidé de donner mandat au gérant ainsi qu’à Monsieur Pierre Lentz, agissant individuellement, afin de pro-

céder aux écritures comptables qui s’imposent, de procéder aux inscriptions dans les registres sociaux et d’établir des
statuts coordonnés suite aux résolutions de la présente. ...»

Luxembourg, le 9 août 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 10 août 2001, vol. 556, fol. 72, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(61343/200/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SURIA HOLDINGS, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 62.975. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61344/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

TANAFORM S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 72.164. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 septembre 2001, vol. 558, fol. 32, case 5, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1

er

octobre 2001.

(61346/587/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

AFIB S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 41.055. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 10 septembre 2001

Au siège de la société:
Les actionnaires approuvent, à l’unanimité:
- Les bilans et comptes de pertes et profits aux 31 décembre 1997, 31 décembre 1998, et 31 décembre 1999.
- Les rapports des administrateurs et du commissaire aux comptes,
- La décharge des administrateurs et du commissaire aux comptes pour les années terminées jusqu’au 31 décembre

1999.

- La réélection pour un terme de 3 ans des administrateurs de la société.
- La continuation de l’activité de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 21 septembre 2001, vol. 558, fol. 2, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(61394/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 octobre 2001.

Pour extrait conforme
P. Lentz

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

F. Baden.

WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO S.A.
Signature

10510

SYSTEL S.A. SOPARFI, Société Anonyme,

(anc. S.L.C.N. SA SOPARFI).

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 71.823. 

L’an deux mille un, le six septembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme S.L.C.N. SA SOPARFI, avec

siège à Livange, route de Bettembourg, inscrite au registre de commerce de et à Luxembourg, section B numéro 71.823,

constituée par acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, en date du 22 septembre

1999, publié au Mémorial C de 1999, page 44390

L’assemblée est présidée par Madame Marie Monique Costa, chef d’entreprise, demeurant à F-54580 Saint-Ail, 16,

rue de Verneville.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Didier Kazenas, expert-comptable, demeurant au 6, rue Georges

Brassens à F-57700 Marspich.

L’assemblée appelle aux fonctions de scrutateur Monsieur Didier Ossemond, Gérant de sociétés, demeurant à F-

Bronvaux, 11, rue de la Fontaine.

Le bureau ainsi constitué, dresse la liste de présence laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires

présents et le mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumis à la formalité du timbre et
de l’enregistrement.

Le président déclare et demande au notaire d’acter ce qui suit:
Que la présente assemblée a été convoquée par lettre recommandée adressée aux actionnaires le 30 août 2001, tou-

tes les actions de la société étant nominatives.

Que suivant liste de présence en annexe, il résulte que sur les 1.000 actions en circulation, 850 actions sont dûment

représentées à la présente assemblée.

Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points

portés à l’ordre du jour.

Que la présente assemblée a pour ordre du jour les points suivants:
1. Changement du nom de la société: abandon de S.L.C.N. SA SOPARFI au profit de SYSTEL S.A. SOPARFI.
2. Transfert du siège social: transfert de L-3378 Livange, Z.I. Le 2000, route de Bettembourg à L-3391 Peppange, 1,

rue de l’Eglise.

3. Modification de l’objet tel que libellé à l’article 4 des statuts, savoir:
«L’installation de travaux de: télécommunications, éclairage, détection incendie, alarme, climatisation, informatique et

tous travaux d’électricité.

Toute opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son
développement.

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou société créées ou à créer pouvant se rattacher

à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles d’apports, commandites, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de
location gérance.

Le traitement des tâches administratives quotidienne de ses filiales.
4. Nomination d’un second administrateur délégué en la personne de Monsieur Didier Ossemond.
L’assemblée des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président, et se considérant comme dûment consti-

tuée et convoquée, a délibéré et pris par vote unanime la décision suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la société de son nom actuel de S.L.C.N.

SA SOPARFI en SYSTEL S.A. SOPARFI, et par là de modifier l’article 1

er

 des statuts pour lui donner la nouvelle teneur

suivante:

Art. 1

er

. Il existe une société anonyme sous la dénomination de SYSTEL S.A. SOPARFI.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à L-3378 Livan-

ge, Z.I. Le 2000, route de Bettembourg à L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise et de modifier en conséquence la première
phrase de l’article 2 des statuts afin de lui donner la nouvelle teneur suivante:

«Art. 2. Première phrase. Le siège social de la société est établi à Peppange.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée des actionnaires décide de modifier l’objet social de la société et par là, de modifier l’article 4 des statuts

de la société pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 4. La société a pour objet l’installation de travaux de: télécommunication, éclairage, détection incendie, alarme,

climatisation, informatique et tous travaux d’électricité ainsi que toute opérations industrielles, commerciales et finan-
cières, mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement.

10511

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou société créées ou à créer pouvant se rattacher

à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles d’apports, commandites, souscription ou rachat
de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêt économique ou de
location gérance.

Le traitement des tâches administratives quotidienne de ses filiales.»

<i>Quatrième résolution

Monsieur Didier Ossemond ayant déjà été nommé administrateur, il n’est pas pris de résolution par rapport au der-

nier point à l’ordre du jour, la délégation de la gestion journalière incombant au Conseil d’Administration.

L’assemblée autorise ce Conseil d’Administration à désigner Monsieur Didier Ossemond comme délégué à la gestion

journalière en application de l’article 60-1 de la loi sur les sociétés.

<i>Clôture

Le notaire instrumentant a attiré l’attention des comparants que la société nécessite l’obtention d’une autorisation à

faire le commerce au Ministère des Classes Moyennes avant de commencer une quelconque activité commerciale avec
un tel nouvel objet.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: M.M. Costa, D. Kazenas, D. Ossemond, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 septembre 2001, vol. 131S, fol. 51, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61335/208/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SYSTEL S.A. SOPARFI, Société Anonyme.

Siège social: L-3391 Peppange, 1, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 71.823. 

Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 6 septembre 2001, acté sous le n

°

669/2001 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61345/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SILVER TONGUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.828. 

L’an deux mille un, le dix-huit septembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

A comparu:

Monsieur Emile Dax, clerc de notaire, demeurant à Garnich.
agissant en sa qualité de mandataire de la société anonyme SILVER TONGUE S.A., avec siège social à L-2311 Luxem-

bourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, section B numéro 77.828,
constituée aux termes d’un acte reçu par décision du conseil d’administration prise en sa réunion du 1

er

 septembre

2000, publié au Mémorial C numéro 141 du 23 février 2001,

en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration prise en sa réunion du 18 septembre 2001,

duquel procès-verbal de réunion un exemplaire est annexé au présent acte.

Lequel comparant, agissant ès qualités, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclara-

tions et constatations:

a) que le capital actuel de la société est fixé à trente et un mille Euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille

(3.100) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune, 

b) que le capital autorisé de la société est fixé à trois cent dix mille Euros (310.000,-) ainsi qu’il résulte de l’article 4.

quatrième alinéa des statuts, dont la teneur est la suivante:

«Le capital autorisé est fixé à trois cent dix mille Euros (EUR 310.000,-), représenté par trente et un mille (31.000)

actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.

Le conseil d’administration est, pendant une période de cinq (5) ans à partir de la date de publication du présent acte,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé. Ces aug-

Luxembourg, le 18 septembre 2001.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

10512

mentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission ainsi qu’il
sera déterminé par le conseil d’administration. Ces augmentations peuvent être réalisées moyennant apport en espèces
ou en nature ainsi que par incorporation de réserves.

Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires

antérieurs un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.»

Que dans sa prédite réunion, le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter le capital social à concurrence d’un

montant de sept mille deux cent quarante euros (EUR 7.240,-) pour porter le montant actuel du capital social de trente
et un mille Euros (EUR 31.000,-) à trente-huit mille deux cent quarante Euros (EUR 38.240,-), par l’émission de sept
cent vingt-quatre (724) actions nouvelles ayant une valeur nominale de dix euros (EUR 10,-) chacune, à un prix d’émis-
sion de trois cent huit euros (EUR 308,-) pour chaque action, résultant dans le paiement d’une prime d’émission totale
égale à deux cent quinze mille sept cent cinquante-deux euros (EUR 215.752,-), chaque action jouissant des mêmes
droits et avantages que les actions anciennes.

Que le Conseil d’Administration a accepté la souscription de toutes les actions nouvelles et que le détail de cette

souscription résulte des bulletins de souscription annexés au présent acte.

Toutes les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de deux cent

vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-douze Euros (EUR 222.992,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément.

Suite à cette augmentation de capital, l’article 5.- premier alinéa des statuts a désormais la teneur suivante:

«Art. 5. Premier alinéa. Le capital social est fixé à trente-huit mille deux cent quarante Euros (EUR 38.240,-), re-

présenté par trois mille huit cent vingt-quatre (3.824) actions d’une valeur nominale de dix Euros (EUR 10,-) chacune.» '

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué à trois mille deux cent soixante
euros (EUR 3.260,-).

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions prévues à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette en l’étude, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous, notaire le présent acte.
Signé: E. Dax, F. Kesseler.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 25 septembre 2001, vol. 872, fol. 25, case 5. – Reçu 89.955 francs.

<i>Le Receveur (signé): Ries.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des So-

ciétés et Associations.

(61332/219/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

SILVER TONGUE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 77.828. 

Statuts coordonnés suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis Kesseler, en date du 18

septembre 2001,

déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(61333/219/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1

er

 octobre 2001.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2001.

F. Kesseler.

Esch-sur-Alzette, le 27 septembre 2001.

F. Kesseler.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

BCP Investimentos International S.A.

European Engineering &amp; Environment Corporation S.A. Holding

Intercoiffure La Coiffe, S.à r.l.

International Cruising S.A.

International Wood Trading, S.à r.l.

Konsolida S.A.

Konsolida S.A.

Lloyds Americas Asset Management, Sicav

LCF Rothschild Fund

Luxco Investments Holdings S.A.

Monlux, S.à r.l.

Les Résidences du Golf S.A.

Mario Holding S.A.

Quartz Finance S.A.

Marine Resources Inc.

Marine Resources Inc.

Micaze S.A.

Marita S.A.

Maxad Oil &amp; Gas, S.à r.l.

Meline Développements S.A.

Molene Financière Holding S.A.

Monet Group S.A.

M.R.I. Investments S.A.

Movida Contemporain, S.à r.l.

Movida Contemporain, S.à r.l.

Moutarderie de Luxembourg, S.à r.l.

Netway

NGI

Novalux S.A.

Schumann-Lavedrine Finance S.A.

ODD Investments S.A.

ODD Investments S.A.

Parnuk S.A.H.

Parnuk S.A.H.

Nukol S.A.

ÖkoVision Lux S.A.

Opacco Holding S.A.

Phipe Holding S.A.

Abatel S.A.

Piquemal, S.à r.l.

Platy Finance S.A.

PNA S.A.

Prémaman-Luxembourg S.A.

Refinancing &amp; Investments S.A.

Richemont S.A.

RLT S.A.

RLT S.A.

Motorway-Luxembourg S.A.

Motorway-Luxembourg S.A.

Rolinsky Holding S.A.

Salorix Holding S.A.

RSL S.A.

Salros S.A.

Scala International S.A.

Scala International S.A.

S.I.I., Société d’Investissement Internationaux S.A.

Sheen Asia Enterprise S.A.

Sinpar Holding S.A.

Sodiphar, S.à r.l.

V2 Holding

Sofiac S.A.

Spa Trans, S.à r.l.

Stratego Trust S.A.

ACM/EFM Emerging Markets Umbrella Funds

Stemel Holding S.A.

Stemel Holding S.A.

Callahan InvestCo Germany 2, S.à r.l.

Callahan InvestCo Germany 2, S.à r.l.

Callahan InvestCo Germany 2, S.à r.l.

Access Self-Storage Holdings S.A.

Suria Holdings

Suria Holdings

Tanaform S.A.

AFIB S.A.

Systel S.A. Soparfi

Systel S.A. Soparfi

Silver Tongue S.A.

Silver Tongue S.A.