logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

54145

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1129

7 décembre 2001

S O M M A I R E

Agence AAZ S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54171

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54181

Alderamin Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . .

54171

Chemlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

54174

Altrans S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54178

Chemlux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

54174

Anteria S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54178

Colotel Holding, S.à r.l., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

54171

Arastro, S.à r.l., Steinfort  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54178

Com Center S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

54175

Arc Constructions S.A., Kehlen  . . . . . . . . . . . . . . . .

54178

Comiplant S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54175

Asha S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54180

Complus Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

54175

AXA World Funds, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . .

54178

Connection International Company S.A., Bavigne 

54173

Axe Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54180

Cortenbergh Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

54176

Axe Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54180

Damire International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

54182

Axe Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54181

Damire International S.A., Luxembourg . . . . . . . . 

54182

Axe Management S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

54181

Dawning International S.A.H., Luxembourg . . . . . 

54184

B.I.R.S.,  Bureau  International de  Réglement de 

Deltatank AG, Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54186

Sinistres, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54182

Deminor Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . 

54176

Bago Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

54183

Designer Holding S.A.H., Strassen . . . . . . . . . . . . . 

54186

Bago Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

54183

Divemi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54168

Bago Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . .

54184

Dixième S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54176

Bellatrix Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

54179

EIF Investment & Finance S.A., Luxembourg . . . . 

54174

Bellatrix Holding, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .

54179

EIM  Participations  Luxembourg  S.A.,  Luxem- 

Bellombre S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .

54172

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54175

Benilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54180

Fimiproperties S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . 

54187

Benilux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54180

Finholding Participations S.A.H., Luxembourg . . . 

54191

Beschuetzung S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

54167

Finholding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54191

Bioinventor Holding S.A., Mamer  . . . . . . . . . . . . . .

54182

Folio S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54176

Blumenfeld S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

54183

G-Rentinfix, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . 

54186

BNP Portfolio, Sicav, Luxembourg  . . . . . . . . . . . . .

54187

Heco S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54190

Bonamare International S.A., Luxembourg  . . . . . .

54183

I.B.D., Industrie du Bois Diekirch S.A., Diekirch . . 

54188

C.I.M. Services S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . .

54174

Lux Marie S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

54188

Cafés Link S.A., Kehlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54184

Martur Finance S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . 

54185

Caravelle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54173

Moynesque Vignoble S.A., Luxembourg  . . . . . . . . 

54188

Caravelle S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54173

Partners Funds Management S.A., Luxembourg  . 

54146

Carbofin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54185

Partners Funds Management S.A., Luxembourg  . 

54147

Carlson Promoter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

54172

Pletor Holding S.A., Luxembourg-Strassen . . . . . . 

54189

Carlson Promoter S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . .

54172

Prodin S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54192

Cartera Finance Partners (Luxembourg) S.A., Lu- 

Quadriga Global Consolidated Trust, Sicav, Sen- 

xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54172

ningerberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54147

Casares S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54173

Sapaci S.A.H., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

54187

Catalina S.C.I., Kockelscheuer  . . . . . . . . . . . . . . . . .

54177

Solissimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . 

54192

Caves St Martin S.A., Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54189

Spareplan S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . 

54190

Ceresole Reale Immobilière S.A., Luxembourg . . .

54185

Stonehenge Participations S.A.H., Luxembourg. . 

54191

Charles Square Finance Company, S.à r.l., Luxem- 

Stonehenge S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . 

54192

54146

PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.947. 

In the year two thousand and one, on the twenty-second day of August.
Before Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A. (the «Cor-

poration»), a société anonyme having its registered office in Luxembourg, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
incorporated by deed of M

e

 Edmond Schroeder on, 27th July 2000, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations of 26th August 2000.

The meeting was presided by Gilles Hauben, maître en droit, residing in Luxembourg.
There was appointed as secretary Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, residing in Arlon and scrutineer Michele Os-

weiler, maître en droit, residing in Luxembourg.

The Board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record that:

I. The agenda of the meeting is as follows: Amendment of the first paragraph of article three of the Articles of Incor-

poration, so as to be read as follows:

«The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of collective investment undertak-

ings (each a «Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship
interests in the Fund.»

II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown

on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed.

III. The whole corporate capital of the Corporation being represented and the shareholders having had prior knowl-

edge of the agenda of this meeting, no convening notice was necessary.

IV. The resolution requires a quorum of 50% of the outstanding shares and the vote of a majority of two-thirds of

the shares represented at the meeting.

V. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted any may validly deliberate on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:

<i>Single resolution

It is resolved to amend the first paragraph of article three of the Articles of Incorporation, so as to read as follows:
«The purpose of the Corporation is the creation, administration and management of collective investment undertak-

ings (each a «Fund») and the issue of certificates or statements of confirmation evidencing undivided coproprietorship
interests in the Fund.»

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Corporation as

a result of the present deed are estimated at approximately thirty thousand luxembourg francs (30,000.- LUF).

There being no further item on the agenda, the meeting was adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; ion request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
On the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

Christian names, civil status and residences, the said persons signed together with us, the notary, the present original
deed.

Suit la version française du texte qui précède 

L’an deux mille un, le vingt-deuxième jour d’août.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

S’est réunie une assemblée extraordinaires actionnaires de la société PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A. (la

«Société»), une société anonyme, ayant son siège à 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, constituée suivant acte
du notaire M

e

 Edmond Schroeder du 27 juillet 2000 publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du 26 août

2000.

L’assemblée fût présidée par Gilles Hauben, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
A été nommé secrétaire Jean-Pierre Mernier, licencié en droit, demeurant à Arlon et scrutateur Michele Osweiler,

maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d’acter

que:

I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
Modification du premier paragraphe de l’article trois des statuts, de manière à ce qu’il ait la teneur suivante:
«L’objet de la Société est la constitution, l’administration et la gestion d’organismes de placement collectif (chacun un

«Fonds»), et l’émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de copropriété indi-
vise dans les Fonds.»

54147

II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont décrits sur une

liste de présence; la liste de présence signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire ins-
trumentant restera annexée au présent acte.

III. Le capital social de la Société étant entièrement représenté et les actionnaires ayant eu connaissance préalable de

l’ordre du jour, aucune convocation n’était nécessaire.

IV. La résolution requiert un quorum de 50% des actions en circulation et le vote d’une majorité des deux tiers des

actions représentées à l’assemblée.

V. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer

sur l’ordre du jour.

VI. Après délibération, l’assemblée a pris la résolution suivante à l’unanimité:

<i>Résolution unique

Il est décidé de modifier le premier paragraphe de l’article trois des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«L’objet de la Société est la constitution, l’administration et la gestion d’organismes de placement collectif (chacun un

«Fonds»), et l’émission de certificats ou de confirmations représentant ou documentant des parts de copropriété indi-
vise dans les Fonds.»

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de cet acte sont

estimés à environ trente mille francs luxembourgeois (30.000,- LUF).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu’à la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivie d’une traduction française. Il est spécifié qu’en cas de divergences avec le texte
français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire instrumentant le présent acte.

Signé: G. Hauben, J-P. Mernier, M. Osweiler, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 27 août 2001, vol. 419, fol. 16, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57684/228/95) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

PARTNERS FUNDS MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 47, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 76.947. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(57685/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 septembre 2001.

QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable,

(anc. QUADRIGA CONSOLIDATED TRUST).

Registered office: L-1736 Senningerberg, 1A, Heienhaff.

R. C. Luxembourg B 30.813. 

In the year two thousand and one, on the 22nd of October.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, having its

registered office in Strassen, registered under number B 54.921 in the Register of Commerce at Luxembourg. The Com-
pany was incorporated by a deed before Maître Schwachtgen, residing in Luxembourg on May 20th, 1996, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of June 28th, 1996, number 316 and amended by a deed before
Maître Schwachtgen on September 22nd, 1998, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C of
December 9th, number 891.

The meeting is opened at 11.00 a.m. and is presided by Mr Emmanuel Bégat, directeur, residing in Rumelange. The

chairman appoints as secretary Mrs Sylvie Becker, employée privée, residing in Luxembourg. The meeting elects as scru-
tineer Mr Grégory Fourez, employé privé, residing in Neuvillers (Belgium).

The chairman declares that a first extraordinary meeting with the same agenda than today’s meeting had been con-

vened for September 17, 2001 which however, could not deliberate validly as less than half of the shares were present
or represented to vote on the proposed agenda. Therefore this second the extraordinary general meeting had to be
convened, which can deliberate validly with no quorum of presence is required.

The chairman declares and requests the notary to state that:

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

Mersch, le 10 septembre 2001.

E. Schroeder.

54148

I.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list; this attendance list having been signed by the shareholders present, the proxy-
holders representing shareholders, the members of the board of the meeting and the undersigned notary, shall stay af-
fixed to these minutes with which it will be registered. The proxies given by the represented shareholders after having
been initialled ne varietur by the members of the board of the meeting and the undersigned notary shall stay affixed in
the same manner to these minutes.

II.- That the present meeting has been convened by publications containing the agenda and published in the «Luxem-

burger Wort», the «Letzebuerger Journal», the «Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C» and in Austria in
«Der Standard» on the 21st of September 2001 and on 12th of October 2001.

The related copies of the said publications are deposited on the desk of the bureau of the meeting.
III.- It appears from the attendance list, that out of 29,038.3107 outstanding shares, 189.9104 shares are present or

duly represented at this meeting.

IV.- That the meeting may deliberate and decide without quorum of presence of the presented or represented share-

holders and that it has been convened properly so that the it may deliberate and decide and all the points of the agenda.
The decisions on the points of the agenda have to be adopted by a two third majority of the present or represented
shareholders.

V.- That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

Approval of the amendments of the Articles of Incorporation:
1. So that the name of the Company will change to QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, and subse-

quent amendment of Article 1.

2. So that the registered office is situated at 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, and subsequent amendment of Ar-

ticles 4 and 10.

3. So that in Article 5, paragraph 2 the words «six months following the registration of the Company as a Sicav» are

deleted.

4. So that a new definition of the umbrella structure such as defined in the Law of 30th March 1988 as amended re-

lating to undertakings for collective investment is integrated in the Articles and so that any reference to «class of shares»
respectively to «sub-fund» is replaced by a reference to «Sub-Fund», and subsequent amendment of Articles 5, 6, 8, 9,
11, 21, 22, 23, 24, 26, 27 and 28.

5. So that the registered shares, unless investors specify the contrary, will not be represented by certificates of share-

holding and that bearer shares will be represented by global certificates and subsequent amendment of Articles 6, 8, and
21.

6. So that in Article 6, paragraph 8 the words «or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore»

are added.

7. So that in Article 7, paragraph 1 the words «including a bond delivered by an insurance company but without re-

striction thereto» are deleted.

8. So that in Article 16, paragraph 2 the words «may be determined by the Board» are replaced by «described in any

prospectus relating to the offer of shares».

9. So that the last paragraph of Article 16 is deleted.
10. So that in Article 17, paragraph 3 the words «GERALD LTD» are replaced by «the asset manager, the asset ad-

ministrator, the asset advisor or any subsidiary thereof».

11. So that in Article 19 «GLOBAL COMMODITIES WARENHANDELS Ges.m.b.H.» is replaced by «QUADRIGA

ASSET MANAGEMENT Ges.m.b.H.».

12. So that in Article 20 the word a «réviseur» is replaced by «an auditor».
13. In order to add a provision so that in the case a redemption request would have as a consequence that the total

holding of a shareholder falls below a certain minimum such as the Board may determine for any Sub-Fund, this request
would be treated as a redemption request for the total holding of that investor, and subsequent amendment of Article
21.

14. In order to define the Valuation Day as a day where the banks in Luxembourg are opened for business and sub-

sequent amendment of paragraph 1 in Article 22.

15. So that in Article 23, point A, after number 4 is added following text: «The valuation of the futures contracts and/

or options is based on information (including without limitation, position reports, confirmation statement, recap ledgers,
etc.) which is available at the time of such valuation with respect to all open futures, forward and option positions and
accrued interest income, accrued management, incentive and service fees, and accrued brokerage commissions. Except
in case of manifest error, the valuation is conclusive and no adjustments will be made with respect to investors or the
Company. The valuation will not be audited nor adjusted.»

16. So that in Article 23 the point C is modified and replaced by following:
«C. For the purpose of valuation under this Article:
(a) Shares to be redeemed and to be issued shall be treated as existing and taken into account until immediately after

the closing of the Valuation on which the redemption or subscription order has been accepted and until paid or received
the price therefore shall be deemed to be a liability respectively a receivable of the Sub-Fund;

(b) effect shall be given on any Valuation date to any purchase or sales of securities contracted for by the Company

on such Valuation Date, to the extent practicable.»

17. So that point D in Article 23 is deleted.
18. In order to delete the provision in Article 25 that annual accounts and the notice to the Annual General Meeting

have to be sent to registered shareholders, and subsequent amendment of Article 25, paragraph 2.

54149

19. So that the different orthographical or style mistakes are corrected. 
20. In accordance with point 1 up to 19, the Articles of Incorporation will be drawn up in a new co-ordinated version.
After approval of the statements of the chairman and having verified that it was regularly convened, the meeting after

deliberation, unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

To change the name of the Company to QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST and to amend Article 1

accordingly.

<i>Second resolution

To change the address of the registered office to 1A Heienhaff, L-1736 Senningerberg and to amend Articles 4 and

10 accordingly.

<i>Third resolution

To delete in Article 5, paragraph 2 the words «six months following the registration of the Company as a Sicav».

<i>Forth resolution

To amend Articles 5, 6, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 so that new definition of the umbrella structure such as

defined in the Law of 30th March 1988 as amended relating to undertakings for collective investment is integrated and
to replace any reference to «class of shares» respectively to «sub-fund» by a reference to «Sub-Fund». 

<i>Fifth resolution

To amend Articles 6, 8 and 21 so that registered shares, unless investors specify the contrary, will be represented by

certificates of shareholding and so that bearer shares will be represented by global certificates.

<i>Sixth resolution

To add in Article 6, paragraph 8 the words «or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore».

<i>Seventh resolution

To delete in Article 7, paragraph 1 the words «including a bond delivered by an insurance company but without re-

striction thereto».

<i>Eighth resolution

To replace in Article 16, paragraph 2 the words «may be determined by the board» by «described in any prospectus

relating to the offer of shares».

<i>Ninth resolution

To delete the last paragraph of Article 16.

<i>Tenth resolution

To replace in Article 17, paragraph 3 the words GERALD LTD» by «the asset manager, the asset administrator, the

asset advisor or any subsidiary thereof».

<i>Eleventh resolution

To replace in Article 19 the words GLOBAL COMMODITIES WARENHANDELS Ges.m.b.H. by QUADRIGA AS-

SET MANAGEMENT Ges.m.b.H.

<i>Twelfth resolution

To replace in Article 20 the word a «réviseur» by «an auditor».

<i>Thirteenth resolution

To amend Article 21 in order to add a provision so that, in the case a redemption request would have as a conse-

quence that the total holding of a shareholder falls below a certain minimum, such as the Board may determine for any
Sub-Fund, this would be treated as a redemption request for the total holding of that investor.

<i>Fourteenth resolution

To amend Article 22 in order to define the Valuation Day as a day where the banks in Luxembourg are opened for

business.

<i>Fifteenth resolution

To add in Article 23, point A after number 4 the following text:
«The valuation of the futures contracts and/or options is based on information (including without limitation, position

reports, confirmation statement, recap ledgers, etc.) which is available at the time of such valuation with respect to all
open futures, forward and option positions and accrued interest income, accrued management, incentive and service
fees, and accrued brokerage commissions. Except in case of manifest error, the valuation is conclusive and no adjust-
ments will be made with respect to investors or the Company. The valuation will not be audited nor adjusted.»

<i>Sixteenth resolution

To replace the point C of Article 23 by following paragraph:
«C. For the purpose of valuation under this Article:
(a) Shares to be redeemed and to be issued shall be treated as existing and taken into account until immediately after

the closing of the Valuation on which the redemption or subscription order has been accepted and until paid or received
the price therefore shall be deemed to be a liability respectively a receivable of the Sub-Fund;

54150

(b) effect shall be given on any Valuation date to any purchase or sales of securities contracted for by the Company

on such Valuation Date, to the extent practicable.»

<i>Seventeenth resolution

To delete point D in Article 23.

<i>Eighteenth resolution

To delete the provision in Article 25 that annual accounts and the notice to the Annual General Meeting have to be

sent to registered shareholders, and to amend paragraph 2 of Article 25 accordingly.

<i>Nineteenth resolution

To correct the different orthographical or style mistakes in the Articles of Incorporation.

<i>Twentieth resolution

In accordance with the resolutions under 1 to 19, the general meeting resolves to restate completely the Articles of

Incorporation and to give them following wording:

Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a Company in the form

of a limited company («société anonyme») qualifying as a société d’investissement à capital variable («Sicav») under the
name of QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST.

Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.

Art. 3. The exclusive object of the Company is to place the funds available in futures on commodities or financial

instruments and in options with the purpose of spreading investment risk and affording its shareholders the results of
the management of its portfolio.

The Company takes any measures and carries out any operation which it may deem useful in the accomplishment

and development of its purpose to the full extent permitted by Part II of the law of 30th March, 1988 regarding collective
investment undertakings or any legislative replacements or amendments thereof (the «Law»).

Art. 4. The registered office of the Company is established at Senningerberg, in the Grand-Duchy of Luxembourg.

Branches or other office may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the
Board of Directors (the «Board»).

In the event that the Board determines that extraordinary political or military events have occurred or are imminent

that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communica-
tion between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the com-
plete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the
Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

Art. 5. The capital of the Company shall, be represented by shares of no par value (the «Shares») and shall at any

time be equal to the total net assets of the Company as defined hereafter.

The minimum capital of the Company shall be not less than the equivalent in Dollars of the United States of America

(«USD») of fifty million Luxembourg Francs (50,000,000.- LUF).

The Board is authorised without limitation to issue Shares at any time at an issue price per Share (the «Issue Price»)

of the relevant Sub-Fund, as defined in Article 24, without reserving the existing shareholders a preferential right to
subscription to the shares to be issued.

The Board may delegate to any duly authorized director of the Company (a «Director») or officer of the Company

or to any other duly authorised person, the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for
such shares.

Such new shares may, as the Board of Directors shall determine, be of different Sub-Funds (hereinafter referred to

as the «Sub-Funds») and the proceeds of the issue of each Sub-Fund of shares shall be invested, pursuant to Article 3
hereof, in securities or other assets such as futures corresponding to such geographical areas, industrial sectors or mon-
etary zones, or to such specific types of derivatives instruments, as the Board of Directors shall from time to time de-
termine in respect of each Sub-Fund.

The Board of Directors may reduce the capital of the Company by closing one or several Sub-Funds: the shares of

the respective Sub-Fund shall be cancelled and the value of such shares shall be refunded to the shareholders of such
Sub-Fund. The termination and merger of one or several Sub-Funds shall be described in article 28.

Art. 6. The Director shall issue Shares in registered or bearer form at the option of the Shareholders in respect of

each Sub-Fund. If a bearer shareholder requests the exchange into registered Shares, no cost will be charged to him in
relation to such exchange. Registered shares will be issued in non-certificated or certificated form. Unless investors
specify to the contrary they will receive noncertificated shares. Bearer shares will be represented by global certificates
which may be deposited in clearing systems such as CLEARSTREAM or EUROCLEAR.

Share certificates shall be signed by two Directors or by a Director and an official duly authorised by the Board for

such purpose. Signatures of the Directors may be either manual or printed or by facsimile. The signature of the author-
ised official shall be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board may from
time to time determine.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the price as set forth in

Article 24 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive Share certificates or, subject as
aforesaid, a confirmation of his shareholding.

Payments of dividends, if any, will be made in respect of registered Shares, to the holders of Shares, at their mandated

addresses in the Register of Shareholders or to such other address as given to the Directors in writing.

54151

All issued Shares of the Company other than bearer Shares shall be recorded in the Register of Shareholders, which

shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefore by the Company and such Register shall
contain the name of each holder of registered Shares, his residence or elected domicile so far as notified to the Company
and the number of Shares held by him in the respective Sub-Fund. Every transfer of a Share other than a bearer Share
shall be entered in the Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved by
the Directors for registering any other document relating to or affecting the title to any Share.

The Company shall be free of all responsibility or liability to third parties in dealing with such Shares and shall be

justified in considering any right, interest or claim of any other person in or upon such Shares to be nonexisting, provided
that the foregoing shall deprive no person of any right which it might properly have to demand the registration to a
change in the registration of registered Shares.

Shares shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Company.
Transfer of bearer Shares shall be effected by delivery of the relevant bearer Share certificates or Certificate repre-

senting them and if applicable with all unmatured coupons attached thereto. Transfer of registered Shares shall be ef-
fected by way of a notice of the transfer to be entered in the Register of Shareholders of the Company by such
shareholder, or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

Every registered shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements

from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint hold-
ers of Shares, only one address will be inserted and any notice will be sent to that address only.

In the event that the shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to

be entered in the Register of Shareholders and the shareholder’s address will be deemed to be at the registered office
of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address
shall be provided to the Company by such shareholder. The Shareholder may, at any time, change his address as entered
in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such
other address as may be set by the Company from time to time.

Art. 7. If any shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid,

mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guar-
antees, as the Company may determine. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that
it is a duplicate, the original Share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

The Company may, at its election, charge the shareholder any exceptional out-of-pocket expenses incurred in issuing

a duplicate or a new Share certificate in substitution for one mislaid, mutilated or destroyed.

Art. 8. The Company may restrict or prevent the ownership of Shares by any person, firm or corporate body, name-

ly any person in breach of any law or requirement of any country or governmental authority and any person which is
not qualified to hold such shares by virtue of such law or requirement or if, as a result of the person owning such Shares
the Company would suffer taxation or other pecuniary disadvantage which it would not otherwise do or, if the Board
so decides and discloses in the current prospectus hereof, a United States Person as defined hereinafter (all together
defined as «Restricted Person») and for such purpose the Company may:

(a) decline to issue any Share or to register any transfer of Shares where it appears to it that such issue or registry

would or might result in beneficial ownership of such Shares by a Restricted Person, and

(b) at any time require any person whose name is entered in, or any person seeking to register the transfer of Shares

on, the Register to furnish it with any information which it may consider necessary for the purpose of determining
whether or not beneficial ownership of such shareholder’s Shares rests or will rest in a Restricted Person, and

(c) where it appears to the Company that any Restricted Person, either alone or in conjunction with any other per-

son, is a beneficial owner of Shares, compulsorily redeem from such shareholder all Shares held by him in the following
manner:

1. The Company shall serve a notice (hereinafter called the «Purchase Notice») upon the shareholder appearing in

the Register as the owner of the Shares to be purchased, specifying the Shares to be purchased as aforesaid, the price
to be paid for such Shares, and the place where the purchase price in respect of such Shares is payable. Any such notice
may be served upon such shareholders by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to the share-
holder at his last address known to or appearing in the books of the Company. The said shareholder shall thereupon
forthwith be obliged to deliver to the Company the Certificate or Certificates, if any, relating to the Shares specified in
the Purchase Notice. Immediately after the close of business on the date specified in the Purchase Notice, such Share-
holder shall cease to be the owner of the Shares specified in such notice and his name shall be removed from the Reg-
ister.

2. The price at which the Shares specified in any Purchase Notice shall be purchased (herein called «the Purchase

Price») shall be an amount equal to the per Share Net Asset Value, determined in accordance with Article 23 hereof.

3. Payment of the Purchase Price will be made to the owner of such Shares in the reference currency of the respective

Sub-Fund, except during periods of currency exchange restrictions with respect thereto, and will be deposited by the
Company in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Purchase Notice) for payment to such owner upon surrender
of the Certificate(s), if any issued, relating to the Shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid
no person interested in the Shares specified in such Purchase Notice shall have any further interest in such Shares or
any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the person appearing
as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) upon effective surrender of the Certificate or
Certificates, if issued, as aforesaid.

4. The exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any

case, on the grounds that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true own-

54152

ership of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any purchase Notice, provided that
in such case the said powers were exercised by the Company in good faith; and

(d) decline to accept the vote of any Restricted Person at any meeting of shareholders of the Company.
Whenever used in these Articles, the term «United States Person» or «U.S. Person» shall mean a citizen or resident

of the United States of America, a partnership organised or existing in any state, territory or possession of the United
States of America, a corporation organised under the laws of the United States of America or of any state, territory or
possession thereof, or any estate or trust.

Art. 9. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company or of a Sub-Fund represents the entire

body of shareholders of the Company or of the shareholders of a Sub-Fund as the case may be. Its resolutions shall be
binding upon all shareholders of the Company or of the relevant Sub-Fund. It shall have the broadest powers to order,
carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

Art. 10. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, at the reg-

istered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, at
the first Monday in May at 11.00 a.m. If such day is not a bank business day in Luxembourg the annual general meeting
shall be held on the next following bank business day in Luxembourg. The annual meeting may be held abroad if, in the
absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

Art. 11. The quorums and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of share-

holders of the Company, unless otherwise provided herein.

Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any

meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or telefax
message.

Except as otherwise required by law or as otherwise provided herein, resolutions at a meeting of shareholders duly

convened will be passed by a simple majority of those present and voting. A corporation may execute a proxy under
the hand of a duly authorised officer.

The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any

meeting of shareholders.

As long as the share capital is divided into different Sub-Funds, any resolution of the general meeting of shareholders

of the Company, affecting the rights of the holders of shares of any Sub-Fund vis-à-vis the rights of the holders of shares
of any other Sub-Fund, shall be subject to a resolution of the general meeting of shareholders of such Sub-Fund or Sub-
Funds in compliance with Article 68 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 12. Shareholders will meet upon call by the Board, pursuant to a notice setting forth the agenda, sent at least

8 days prior to the meeting to each shareholders at the shareholders’ address in the Register of Shareholders, provided
the Company shall not be bound to evidence the accomplishment of such notice, if the convening notice is as well pub-
lished in accordance with Luxembourg law.

As long as bearer Shares are in issue notice shall, in addition, be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés

et Associations, in a Luxembourg newspaper and in such other newspaper as the Board may decide.

However, if all shareholders are present or represented at a shareholders meeting and if they declare themselves to

be fully informed of its agenda, the meeting may be held without notice or publicity having been given or made.

Art. 13. The Company shall be managed by a Board composed of not less than three members; members of the

Board need not be shareholders of the Company.

Subject as provided below, the directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, for a period ending

at the next annual general meeting and until their successors are elected and have accepted such appointment or, if later,
ending at the date of such election and acceptance, provided, however, that a director may be removed with or without
cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. In the event of a vacancy in the office of
director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect by way of co-
optation, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 14. The Board may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members one

or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not be a Director, who shall be responsible for keep-
ing the minutes of the meetings of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by any two Di-
rectors, at the place indicated in the notice of meeting.

If a chairman is appointed, he shall preside over all meetings of shareholders and at the Board, but failing a chairman

or in his absence the shareholders or the Board may appoint any person as chairman pro tempore by vote of the ma-
jority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all Directors at least 24 hours in advance of the hour

set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set
forth in the notice of meeting.

This notice may be waived by the consent in writing of by cable, telegram, telex or telefax of each Director. Separate

notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the Board.

Any Director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by cable, telegram, telex or telefax

another Director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by cable, telegram, telex or telefax mes-
sage.

54153

The Directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their

individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.

The Board can deliberate or act validly only if at least a majority of Directors are present (which may be by the way

of a conference telephone call) or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be take by a majority of the
votes of the Directors present or represented at such meeting. The elected chairman shall have a casting vote.

Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms which may be

signed on one or more counterparts by telex, telegram or telecopier message (in each such case confirmed in writing)
by all the Directors.

The Board may from time to time appoint the officers of the Company, including a General Manager, a secretary, and

any assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Company.

Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be Directors or shareholders of

the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties
given them by the Board.

The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to

carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any com-
mittee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as its thinks fit.

Art. 15. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by any person who presided over such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by

such chairman, or by the secretary, or by two Directors.

Art. 16. The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the meeting of the share-
holders are in the competence of the Board.

The Board shall have the power to do all things on behalf of the Company which are not expressly reserved to the

shareholders in general meeting by these Articles and shall, without limiting the generality of the aforegoing, have the
power to determine the corporate and investment policy for investments based on the principle of spreading of risks,
subject to such investment restrictions as may be imposed by the Law or by regulations or as described in any prospec-
tus relating to the offer of shares.

The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to

carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board, acting under the supervision of the Board. 

Art. 17. No contract or other transaction between the Company and any other Company or firm shall be affected

or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company are interested in, or is a
Director, associates, officers or employees of such other company or firm. Any Director or officer of the Company
who serves as a Director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or oth-
erwise engage in business shall not by reason of such affiliation with such other company or firm but subject as herein-
after provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or
other business.

In the event any Director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Com-

pany, such Director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on
any such transaction, and such transaction, and such Director’s or officer’s interest therein, shall be reported to the
next succeeding meeting of shareholders.

The term «personal interest», as used in the preceding subparagraph, shall not include any relationship with or inter-

est in any matter, position or transaction involving the asset manager, the asset administrator, the asset advisor or any
subsidiary thereof, or such other corporation or entity as may from time to time be determined by the Board at its
discretion.

Art. 18. The Company may indemnify any Director or officer, and his heirs, executors and administrators, against

expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a Director or officer of the Company or, at its request of any other company of
which the Company is a shareholder or creditor or from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall
be indemnified in all circumstances, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or wilful misconduct; in the event of a settlement, indemnification
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised
by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnifica-
tion shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 19. The Company will be bound by the joint signatures of any two Directors of which one must be a represent-

ative of BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. and the other one being a representative of QUADRIGA ASSET
MANAGEMENT Ges.m.b.H.

Art. 20. The general meeting of shareholders of the Company shall appoint an auditor, («réviseur d’entreprises

agréé») who shall carry out the duties prescribed by the Law.

Art. 21. Any shareholder may at any time ask for the redemption of his shares.
As is more specifically hereinbelow, the Company has the power to redeem its own Shares at any time within the

sole limitations set forth by law. The redemption price of each share is equal to the net asset value per share of the
respective Sub-Fund as determined by the Company.

54154

Any redemption request having as a consequence that the total holding of a shareholder falls below the minimum

such as may be decided by the Board of Directors for any Sub-Fund will be treated as a redemption request for the total
holding of that investor.

Any shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company, provided that the Company

shall not be bound to redeem on any Valuation Date (as hereafter defined) more than 10 per cent of the number of
Shares relating, to any Sub-Fund then in issue.

Such limitation will apply to all shareholders having tendered their shares in such Sub-Fund for redemption on such

valuation date pro rata of the shares in such Sub-Fund tendered by them for redemption.

Redemption may be deferred by the Company for not more than seven valuation dates after the date of receipt of

the redemption request (but always subject to the foregoing limit). In case of deferral of redemptions the relevant Shares
shall be redeemed at the Net Asset Value per Share prevailing at the date on which the redemption is effected.

For this purpose conversions are considered as redemptions.
The Redemptions Price shall be paid normally within five bank business days after the relevant Valuation Date or on

the date the share certificates (if issued) have been received by the Company, if later, and shall be based on the Net
Asset Value per Share determined in accordance with the provisions of Article 23 hereof less a redemption charge as
may be decided by the Board from time to time.

If in exceptional circumstances the liquidity of the portfolio of assets maintained in respect of the shares of a Sub-

Fund being redeemed is not sufficient to enable the payment to be made within such a period, such payment shall be
made as soon as reasonably practicable thereafter, but without interest.

Any such request must be filed or confirmed by such shareholder in written form at the registered office of the Com-

pany in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of Shares.
The certificates if issued, for such Shares in proper form and accompanied by proper evidence of transfer or assignment
must be received by the Company or its agent appointed for that purpose before the Redemption Price may be paid.

Shares redeemed by the Company shall be cancelled.

Art. 22. The net asset value per Share (the «Net Asset Value») and the Issue and Redemption Prices of Shares of

any Sub-Fund shall be determined by the Company not less than once monthly, as the Board by resolution may direct
(every such day or time for determination thereof being referred to herein as a «Valuation Date»), but so that no day
observed as a holiday by banks in Luxembourg be a Valuation Date.

The Company may suspend the determination of the Net Asset Value, and the issue, redemption and conversion of

the Shares of any Sub-Fund:

(a) during any period when any market or stock exchange, on which a substantial portion of a Sub-Fund’s investments

are quoted or dealt in, is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings are restricted or sus-
pended; or

(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valua-

tion of the Company’s assets attributable to any Sub-Fund is not reasonably practical or without seriously prejudicing
the interest of the shareholders of the Company; or

(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price or value of

any of the investments attributable to any Sub-Fund or the current prices on any market or stock exchange; or

(d) during any period when remittance of moneys which will or may be involved in the realisation of, or in the pay-

ment for, any of the investments attributable to any Sub-Fund is not possible or cannot be effected at normal prices or
rates or exchange; or

(e) during any period where in the opinion of the Directors there exist unusual circumstances where it would be

impracticable or unfair towards the shareholders to continue dealing with Shares of any Sub-Fund; or

(f) in case of a decision to liquidate the Company, on or after the day of publication of the first notice convening the

general meeting of shareholders for this purpose.

(g) upon the suspension of trading in accordance with article 27.
Shareholders having requested redemption of their Shares shall be notified of any such suspension within seven days

of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension.

The suspension as to any Sub-Fund will have no effect on the calculation of Net Asset Value and the issue, conversion

and redemption of the Shares of any other Sub-Fund.

Art. 23. The Net Asset Value of each Share of each Sub-Fund shall be expressed in the relevant Dealing Currency

of each Sub-Fund as a per Share figure and shall be determined in respect of any Valuation Date by dividing the net assets
attributable to this Sub-Fund less the liabilities attributable to the respective Sub-Fund by the number of outstanding
Shares in such Sub-Fund.

The valuation of the Net Asset value of Shares of each Sub-Fund shall be made in the following manner:
A. The assets in each Sub-Fund of the Company shall be deemed to include: 
(a) all cash and cash equivalents in hand receivable or on deposit, including accrued interest;
(b) all bills and notes on demand and any amounts due (including the proceeds of securities sold but not collected);
(c) all securities, shares, bonds, debentures, options, subscription rights, warrants, the market value of all open posi-

tions and other investments and securities belonging to the Company;

(d) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company (the

Company may, however, adjust the valuation by fluctuations in the market value of securities due to trading practices
such as trading ex-dividends or ex-rights);

(e) all accrued interest on any interest-bearing securities held by the Company, except to the extent such interest is

comprised in the principal amount of such security;

54155

(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off, provided that such pre-

liminary expenses may be written off directly from the capital of the Company; and

(g) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses. 
The value of such assets shall be determined as follows:
1. The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,

cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full amount
thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be
arrived at after making such discount as the Directors may consider appropriate in such case to reflect the true value
thereof;

2. Portfolio securities which are listed on an official stock exchange or traded on a regulated or organised market will

be determined on the basis of the last available price on which such securities are traded, as furnished by a pricing service
approved by the Directors. If such prices are not representative of their fair market value, such securities, as well as any
of the portfolio securities which are not so listed or traded will be valued on the reasonable foreseeable sales prices
determined prudently in good faith by and under the direction of the Directors;

3. The value of futures contracts and/or options which are quoted or dealt in on any exchange or another regulated

respectively organised market is based on the last available price quoted on an authorised information system (i.e.
REUTERS, Telerate, Telekurs) on the applicable valuation date.

In the event that any of the securities, the futures contracts or options held in the Sub-Fund’s portfolio on the relevant

day are not quoted or dealt in on any exchange or other regulated respectively organized market or if, with respect to
securities, futures contracts or options quoted or dealt in on any exchange or dealt in on another regulated respectively
organized market, the price as determined pursuant to the preceding paragraph is not representative of the fair market
value of the relevant securities, the value of such securities, futures contracts or options will be determined based on
the reasonable foreseeable sales price determined prudently and in good faith.

The directors, at their discretion, may permit some other method of valuation to be used if they consider that such

valuation better reflects the fair value of any asset. The directors may rely on confirmation from the principal broker
and its affiliates in determining the value of assets held for the Company’s account. The Company’s income and expenses
will be determined on an accrual basis.

4. Any assets or liabilities in currencies other than the currency in which the net asset value of the relevant Sub-Fund

is expressed will be converted using the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination
of the Net Asset Value of Shares.

The valuation of the futures contracts and/or options is based on information (including without limitation, position

reports, confirmation statement, recap ledgers, etc.) which is available at the time of such valuation with respect to all
open futures, forward and option positions and accrued interest income, accrued management, incentive and service
fees, and accrued brokerage commissions. Except in case of manifest error, the valuation is conclusive and no adjust-
ments will be made with respect to investors or the Company. The valuation will not be audited nor adjusted.

B. The liabilities in any Sub-Fund of the Company shall be deemed to include:
(a) all borrowings, bills and other amounts due;
(b) the fees of the Custodian, Broker, Trading Managers, Trading Administrator, Trading Advisor, Registrar, Transfer

Agent, Domiciliary Corporate and Administrative Agent; other operational costs including, but not limited to, costs of
buying and selling underlying, securities, government charges, legal and auditing fees, interest, reporting expenses, pub-
lication of offering redemption prices, distribution of interim and annual reports, postage, telephone and telex, reason-
able marketing and promotional expenses; 

(c) all known liabilities due or not yet due, including the amount of dividends declared, if any, but unpaid;
(d) an appropriate amount set aside for taxes due on the date of valuation and other provisions or reserves author-

ised and approved by the Directors; and 

(e) all other liabilities of the Company of whatever kind due towards third parties;
(f) in the case where any liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Sub-Fund,

such liability shall be allocated to all the Sub-Funds pro rata to the net asset values of the Sub-Fund.

For the purposes of the valuation of its liabilities, the Company may duly take into account all administrative and other

expenses of a regular or periodical character by valuing them for the entire year or any other period and by dividing the
amount concerned proportionately for the relevant fractions of such period.

C. For the purpose of valuation under this Article:
(a) Shares to be redeemed and to be issued shall be treated as existing and taken into account until immediately after

the closing of the Valuation on which the redemption or subscription order has been accepted and until paid or received
the price therefore shall be deemed to be a liability respectively a receivable of the Sub-Fund;

(b) effect shall be given on any Valuation date to any purchase or sales of securities contracted for by the Company

on such Valuation Date, to the extent practicable.

Art. 24. Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall

be offered and sold, shall be based on the Net Asset Value per Share of the relevant Sub-fund, as hereinabove defined,
increased by a subscription fee (if and to the extent the Directors so decide) and any remuneration to agents active in
the placing of the Shares shall be paid out of the sales charge (which shall not exceed such amount as may be permitted
by all applicable laws), added thereto. The price so determined (the «Issue Price») shall be payable within a period as
determined by the Directors which shall not exceed four bank business days after the date on which the Shares were
allotted.

54156

The Issue Price may, upon approval of the Board, and subject to all applicable laws, namely with respect to a special

audit report confirming the value of any assets contributed in kind, be paid by contributing to the Company securities
acceptable to the Board, consistent with the investment policy and investment restrictions of the Company.

Art. 25. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall terminate

on the last day of December of the same year.

The accounts of the Company shall be expressed in USD.

Art. 26. The meeting of shareholders of the relevant Sub-Funds shall, upon the proposal of the board of directors

in respect of Sub-Fund determine how the annual results shall be disposed of. The results of the Company may be dis-
tributed, subject to the minimum capital of the Company as defined under Article 5 hereof being maintained.

Interim dividends may be paid out on the shares of any Sub-Fund upon decision of the board of directors.
The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant Sub-Fund is expressed or, excep-

tionally in such other currency as selected by the board of directors, and shall be paid at such places and times as may
be determined by the board of directors which may make a final determination of the rate of exchange applicable to
translate dividend funds into the currency of their payment.

Art. 27. Issues, redemptions and conversions in respect of one Sub-Fund will be suspended as soon as Sub-Fund

suffers trading losses which reduces its net asset value per share to less than 50% of its highest previous net asset value
per share. In such cases, all existing contracts and options will be liquidated and no further trading will occur until the
date of the shareholders’ meeting referred to in the paragraph below.

In the event of a trading suspension as a result of the foregoing provision, all shareholders of the concerned Sub-Fund

will be convened within forty days following the suspension date to a separate Sub-Fund meeting to decide by a three
quarter majority vote of the outstanding shares of such Sub-Fund on the possible closing of such Sub-Fund or its merger
with another Sub-Fund. In the case of non-liquidation or merger of the Sub-Fund as a result of the shareholders’ decision,
the suspension will be lifted immediately.

Art. 28. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators

(who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each Sub-
Fund shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares in proportion of their holding of shares in that Sub-
Fund.

Amounts which would not have been claimed by shareholders at the close of liquidation will be deposited in escrow

at the CAISSE ET CONSIGNATIONS. Amounts not claimed from escrow within the limitation period would be liable
to be forfeited in accordance with the provisions of Luxembourg law.

If the capital falls below two thirds of the minimum capital i.e. LUF 50,000,000.- the Directors are required by law to

submit to a general meeting of shareholders a resolution to consider the dissolution of the Company. The general meet-
ing will require no quorum and the resolution to wind up the Company will be passed by the simple majority of the
shares present or represented.

If the capital falls below on quarter of the minimum capital the Directors are further required by law to submit to a

General Meeting of Shareholders a resolution to consider the dissolution of the Company.

This General Meeting will require no quorum and the resolution to wind up the Company will be passed by 1/4 (one

fourth) of the shares of any Sub-Fund present or represented.

If for a period of 30 consecutive days for any reason the net asset value of any assets relating to any Sub-Fund is lower

than 1,000,000.- USD or in the case of a Sub-Fund denominated in a currency other than the USD, the equivalent in that
currency of such amount, or in case the board deems it appropriate because of changes in the economic or political
situation affecting a sub-fund, the board may, after giving thirty days’ prior notice to the shareholders concerned, redeem
all (but not some) of the shares of the relevant Sub-Fund on the next valuation day following the expiry of such notice
at the net asset value reflecting the anticipated realization and liquidation costs, but with no other redemption charge,
or merge that Sub-Fund with another Sub-Fund of the Company or with another Luxembourg undertaking for collective
investment (UCI).

Termination of a Sub-Fund with compulsory redemption of all relevant shares or its merger with another Sub-Fund

of the Company or with another Luxembourg UCI, in each case for other reasons than the minimum size of its assets
or the reasons of changes in the economic and political situation affecting the relevant sub-fund, may be effected only
upon, the prior approval by the shareholders of the sub-fund to be terminated or merged at a duly convened Sub-Fund
meeting which may be validly held without quorum and decide at a majority of 50 per cent of the shares present or
represented.

A merger so decided by the board or approved by the shareholders of the relevant sub-fund will be binding on the

holders of shares of the relevant sub-fund upon thirty days’ prior notice thereof given to them during which period
shareholders may redeem their shares without redemption charge. The Company shall inform holders of the bearer
shares, if any, by publication of a notice in newspapers to be determined by the board unless all such shareholders and
their addresses are known to the Company.

Any amounts not claimed by the shareholders at the termination of a Sub-Fund will be deposited with the custodian

for a period not exceeding six months from the date of closing of the liquidation operations. After such period the
amounts will be deposited with the CAISSE DES CONSIGNATIONS.

Art. 29. These Articles of Incorporation may be amended from time to time by a meeting of shareholders, subject

to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg.

54157

Art. 30. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the law

of 10th August, 1915 on commercial companies and amendments thereto and the Law.

There being no further business, the meeting is terminated.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appear-

ing persons, this deed is worded in English, followed by a German translation and that in case of any divergences between
the English and the German text, the English version shall be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names, sur-

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Follows the German translation of the hereabove minutes:

Im Jahre zweitausendundeins, dem 22. Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Schroeder, Notar mit Amtssitz in Mersch, wurde eine außerordentliche General-

versammlung der Aktionäre des GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, mit Gesellschaftssitz in Strassen, eingetragen im
Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg unter Nummer B 54.921 abgehalten. Die Gesellschaft wurde gegrün-
det gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Schwachtgen mit Amtswohnsitz in Luxembourg am 20. Mai 1996, ver-
öffentlicht im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 316 vom 28. Juni 1996. Die Satzung wurde
abgeändert gemäß Urkunden aufgenommen durch Notar Schwachtgen am 22. September 1998, veröffentlicht im Mé-
morial C, Nummer 891 vom 9. Dezember 1998.

Die Sitzung wird um 11.00 Uhr durch Herrn Emmanuel Bégat, Direktor, wohnhaft in Rumelange, eröffnet. Der Vor-

sitzende bestimmt Frau Sylvie Becker, Privatangestellte und wohnhaft in Luxembourg zum Schriftführer der Versamm-
lung. Die Versammlung wählt Herrn Grégory Fourez, Privatangestellter und wohnhaft in Neuvillers (Belgien), zum
Stimmzähler. 

Der Vorsitzende erklärt, daß eine erste Generalversammlung am 17. September 2001 mit der selben Tagesordnung

einberufen wurde, diese Versammlung war jedoch nicht beschlußfähig da weniger als die Hälfte der Aktien anwesend
oder vertreten waren um über die Tagesordnung abzustimmen. Daher mußte die heutige zweite Versammlung einbe-
rufen werden für welche keine Mindestanwesenheit erforderlich ist.

Der Vorsitzende ersucht den Notar folgendes zu beurkunden:
I. Daß die anwesenden oder die vertretenen Aktionäre, die Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre und die An-

zahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Liste, nachdem sie von den anwesenden Aktionä-
ren, den Vollmachtnehmern der vertretenen Aktionäre, den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem
unterzeichneten Notar unterschrieben wurde, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen, um mit derselben einregi-
striert zu werden. Die von den vertretenen Aktionären ausgestellten Vollmachten werden ne varietur paraphiert durch
die Mitglieder des Versammlungsvorstandes und den instrumentierenden Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde bei-
gebogen und mit derselben formalisiert.

II. Daß die gegenwärtige Versammlung mittels Veröffentlichungen einberufen wurde am 21. September und am 12.

Oktober 2001, im «Luxemburger Wort», im «Letzebuerger Journal» und im «Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations» und in Osterreich im «Der Standard» wie dies der Versammlung nachgewiesen wurde.

Die Kopien der Veröffentlichungen wurden den Versammlungsteilnehmern vorgelegt.
III. Daß von 29.038,3107 am heutigen Tag ausstehenden Aktien, 189,9104 Aktien an dieser Versammlung anwesend

oder vertreten sind, wie dies aus der angehefteten Anwesenheitsliste hervorgeht.

IV. Daß diese Versammlung befähigt ist ohne Mindestanwesenheit von anwesenden oder vertretenen Aktien zu be-

raten und abzustimmen und daß sie ordnungsgemäß einberufen wurde so daß diese Versammlung über die im nachhinein
genannte Tagesordnung beraten und beschließen kann. Die Beschlüsse über die Tagesordnungspunkte müssen mit einer
Mehrheit von zwei Drittel der anwesenden und vertretenen Aktien gefaßt werden.

V. Dass die Tagesordnung dieser Versammlung wie folgt ist:

<i>Tagesordnung:

Zustimmung der Änderungen der Satzung:
1. So dass, der Name der Gesellschaft auf QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST abgeändert wird. Dem-

gemäße Änderung von Artikel 1.

2. So dass, der Gesellschaftssitz auf 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg verlegt wird und demgemäße Änderung von

Artikel 4 und 10.

3. So dass, in Artikel 5, 2. Absatz die Wörter «sechs Monate nach der Eintragung der Gesellschaft als Sicav» gestrichen

werden.

4. So dass, eine neue Definition der Umbrella-Struktur sowie im Gesetz vom 30. März betreffend Organismen für

gemeinsame Anlagen, so wie abgeändert, in die jeweiligen Artikel eingefügt wird und dass jede Referenz auf die Wörter
«Sub-Fonds» durch Teilfonds ersetzt wird und demgemäße Änderung von Artikel 5, 6, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 27
und 28.

5. So dass, Namensaktien, außer vom Anleger angefordert, in nicht-verbriefter Form ausgegeben werden, und dass

Inhaberaktien durch Globalzertifikate verbrieft werden und demgemäße Änderung von Artikel 6, 8 und 21.

6. So dass, in Artikel 6, Absatz 8 die Wörter «oder durch hierzu ordnungsgemäß berechtigte Personen» hinzugefügt

werden. 

7. So dass, in Artikel 7, Absatz 1 die Wörter «einschließlich einer Obligation einer Versicherungsgesellschaft, aber

unter Ausschluss der Ausübung von Rechten hieraus» gestrichen werden.

54158

8. So dass, in Artikel 16, Absatz 2 die Wörter «durch die Bestimmung des Vorstandes» durch «wie im Verkaufspro-

spekt betreffend das Angebot von Aktien beschrieben» ersetzt werden.

9. So dass, der letzte Absatz von Artikel 16 gestrichen wird.
10. So dass, in Artikel 17, Absatz 3 die Wörter «GERALD LTD» durch «dem Anlagemanager, Anlageverwalter, An-

lageberater oder einer mit ihnen verbundenen Gesellschaft» ersetzt werden.

11. So dass, in Artikel 19 «GLOBAL COMMODITES WARENHANDELS Ges.m.b.H.» durch «QUADRIGA ASSET

MANAGEMENT Ges.m.b.H.» ersetzt werden.

12. So dass, in Artikel 20 das Wort «réviseur» durch «Wirtschaftsprüfer» ersetzt wird.
13. So dass, eine Bestimmung betreffend den Fall, wo ein Rücknahmeantrag welcher als Folge hätte, dass die Gesamt-

position eines Aktionärs unter einen Mindestbetrag, wie dieser Verwaltungsrat hinsichtlich eines jeden Teilfonds festge-
legt werden kann, fällt, dieser Rücknahmeantrag für die Gesamtposition dieses Anlegers behandelt wird, hinzugefügt
wird und demgemäße Änderung von Artikel 21.

14. Um den Bewertungstag als einen Tag zu definieren als jeden Tag der kein Bankfeiertag in Luxemburg ist und dem-

gemäße Änderung von Artikel 22, Absatz 1.

15. So dass, in Artikel 23, Punkt A nach Nummer 4 folgender Text hinzugefügt wird: «Die Bewertung der Termin-

kontrakte und/oder Optionen beruht auf Informationen (einschließlich, jedoch ohne Beschränkung, Positionsberichte,
Bestätigungen, Zusammenfassungen usw.), die zum Zeitpunkt dieser Bewertung hinsichtlich aller offenen Terminkon-
trakte, Optionen und aufgelaufener Zinserträge, aufgelaufenen Betriebs-, Incentive- und Dienstleistungsgebühren und
aufgelaufenen Maklergebühren vorliegen. Ausgenommen bei offensichtlichen Irrtümern ist die Bewertung endgültig und
es werden keine Berichtigungen für die Anleger oder die Gesellschaft zugelassen. Die Bewertung unterliegt keiner Prü-
fung oder Anpassung.»

16. So dass in Artikel 23, Punkt C abgeändert wird und durch folgenden Text ersetzt wird:
«C. Für den Zweck der Bewertung in diesem Artikel gilt folgendes: 
(a) Rückzunehmende und auszugebende Aktien sind als vorhanden anzusehen, und bis einschließlich nach dem Schluss

des Bewertungstages an dem die Rücknahme- und Zeichnungsanträge angenommen worden sind und bezahlt bzw. er-
halten wurden, ist der Preis hierfür als eine Verbindlichkeit bzw. eine Einnahme des jeweiligen Teilfonds anzusehen.

(b) Käufe und Verkäufe von Wertpapieren die von der Gesellschaft an einem Bewertungstag gehandelt werden, wer-

den soweit ausführbar berücksichtigt.»

17. So dass, Punkt D von Artikel 23 gestrichen wird.
18. So dass, die Bestimmung in Artikel 25 gestrichen wird, welche besagt, dass den Namensaktionären der Jahresbe-

richt sowie die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gesendet werden muss, und demgemäße Änderung von
Artikel 25, Absatz 2.

19. So dass verschieden Schreib- und Stillfehler verbessert werden.
20. In Übereinstimmung mit den Beschlüssen unter Punkt 1 bis 19 die Satzung neu zu fassen.
Nach Annahme der Erklärungen des Vorsitzenden und nachdem die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung zu dieser

Versammlung festgestellt wurde, faßt die Versammlung, nach eingehender Beratung, folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Der Name der Gesellschaft wird auf QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST abgeändert und demgemäße

Änderung von Artikel 1.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschaftssitz wird auf 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg verlegt und demgemäße Änderung von Artikel 4

und 10.

<i>Dritter Beschluss

Die Wörter «sechs Monate nach der Eintragung der Gesellschaft als Sicav» werden in Artikel 5, 2. Absatz gestrichen.

<i>Vierter Beschluss

Änderung von Artikel 5, 6, 8, 9, 11, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 so dass eine neue Definition der Umbrella-Struktur

sowie im Gesetz vom 30. März betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen, so wie abgeändert, in die jeweiligen
Artikel eingefügt wird und jede Referenz auf die Wörter «Sub-Fonds» durch «Teilfonds» ersetzt wird.

<i>Fünfter Beschluss

Änderung von Artikel 6, 8 und 21 so dass, außer vom Anleger angefordert, die Namensaktien in nicht-verbriefter

ausgegeben werden, und dass Inhaberaktien durch Globalzertifikate verbrieft werden.

<i>Sechster Beschluss

Änderung von Artikel 6, Absatz 8 um die Wörter «oder durch hierzu ordnungsgemäß berechtigte Personen» hinzu-

zufügen. 

<i>Siebter Beschluss

Änderung von Artikel 7, Absatz 1 um die Wörter «einschließlich einer Obligation einer Versicherungsgesellschaft,

aber unter Ausschluss der Ausübung von Rechten hieraus» zu streichen.

<i>Achter Beschluss

Änderung von Artikel 16, Absatz 2 um die Wörter «durch die Bestimmung des Vorstandes» durch «wie im Verkaufs-

prospekt betreffend das Angebot von Aktien beschrieben» zu ersetzen.

54159

<i>Neunter Beschluss

Streichung des letzten Absatzes von Artikel 16.

<i>Zehnter Beschluss

In Artikel 17, Absatz 3 werden die Wörter «GERALD Ltd» durch «dem Anlagemanager, Anlageverwalter, Anlagebe-

rater oder einer mit ihnen verbundenen Gesellschaft» ersetzt.

<i>Elfter Beschluss

In Artikel 19 werden die Wörter «GLOBAL COMMODITIES WARENHANDELS Ges.m.b.H.» durch «QUADRIGA

ASSET MANAGEMENT Ges.m.b.H.» ersetzt.

<i>Zwölfter Beschluss

In Artikel 20 wird das Wort «réviseur» durch «Wirtschaftsprüfer» ersetzt.

<i>Dreizehnter Beschluss

Änderung von Artikel 21 so dass, eine Bestimmung betreffend den Fall, wo ein Rücknahmeantrag welcher als Folge

hätte, dass die Gesamtposition eines Aktionärs unter einen Mindestbetrag, wie dieser Verwaltungsrat hinsichtlich eines
jeden Teilfonds festgelegt werden kann, fällt, dieser als Rücknahmeantrag für die Gesamtposition dieses Anlegers behan-
delt wird, hinzugefügt wird.

<i>Vierzehnter Beschluss

Änderung von Artikel 22 um den Bewertungstag als einen Tag zu definieren, als jeden Tag der kein Bankfeiertag in

Luxemburg.

<i>Fünfzehnter Beschluss

In Artikel 23, Punkt A, wird nach Nummer 4 folgender Text hinzugefügt: 
«Die Bewertung der Terminkontrakte und/oder Optionen beruht auf Informationen (einschließlich, jedoch ohne Be-

schränkung, Positionsberichte, Bestätigungen, Zusammenfassungen usw.), die zum Zeitpunkt dieser Bewertung hinsicht-
lich aller offenen Terminkontrakte, Optionen und aufgelaufener Zinserträge, aufgelaufenen Betriebs-, Incentive- und
Dienstleistungsgebühren und aufgelaufenen Maklergebühren vorliegen. Ausgenommen bei offensichtlichen Irrtümern ist
die Bewertung endgültig und es werden keine Berichtigungen für die Anleger oder die Gesellschaft zugelassen. Die Be-
wertung unterliegt keiner Prüfung oder Anpassung.»

<i>Sechzehnter Beschluss

In Artikel 23, wird Punkt C abgeändert und durch folgenden Text ersetzt:
«C. Für den Zweck der Bewertung in diesem Artikel gilt folgendes: 
(a) Rückzunehmende und auszugebende Aktien sind als vorhanden anzusehen, und bis einschließlich nach dem Schluss

des Bewertungstages an dem die Rücknahme- und Zeichnungsanträge angenommen worden sind und bezahlt bzw. er-
halten wurden, ist der Preis hierfür als eine Verbindlichkeit bzw. eine Einnahme des jeweiligen Teilfonds anzusehen.

(b) Käufe und Verkäufe von Wertpapieren die von der Gesellschaft an einem Bewertungstag gehandelt werden, wer-

den soweit ausführbar berücksichtigt.»

<i>Siebzehnter Beschluss

Punkt D von Artikel 23 wird gestrichen.

<i>Achtzehnter Beschluss

Streichung der Bestimmung in Artikel 25, welche besagt, dass den Namensaktionären der Jahresbericht sowie die Ein-

ladung zur ordentlichen Generalversammlung gesendet werden muss und demgemäße Änderung von Absatz 2 von Ar-
tikel 25.

<i>Neunzehnter Beschluss

Die verschieden Schreib- und Stillfehler werden verbessert.

<i>Zwanzigster Beschluss

In Folge der Beschlüsse unter 1- 19 beschließt die Versammlung die Satzung neu zu fassen und ihr folgenden Wortlaut

zu geben:

Art. 1. Zwischen den Unterzeichnern und jenen Personen, die zukünftig Aktien erwerben, besteht eine Gesellschaft

in Form einer Aktiengesellschaft («Société anonyme») mit der Berechtigung einer «Société d’investissement à capital
variable» («SICAV») unter dem Namen QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST.

Art. 2. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Zeit.

Art. 3. Ausschließlicher Gegenstand der Gesellschaft ist es, die ihr verfügbaren Mittel in Warentermingeschäften

oder Finanzinstrumenten sowie in Optionen anzulegen, um so das Investitionsrisiko zu streuen und ihren Aktionären
die durch die Portfolioverwaltung erwirtschafteten Gewinne zuteil werden zu lassen.

Die Gesellschaft ergreift alle Maßnahmen und führt alle Operationen aus die für die Erreichung und Umsetzung ihrer

Ziele notwendig sind und die gemäß Abschnitt II des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame
Anlagen bzw. gemäß den juristischen Ergänzungen und Änderungen dieses Gesetz (das «Gesetz») zulässig sind.

Art. 4. Der Firmensitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, im Grossherzogtum Luxemburg. Zweigniederlassungen

oder andere Geschäftsräume können durch Beschluss des Verwaltungsrates (der «Verwaltungsrat») entweder im Gros-
sherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

54160

Wenn nach Ermessen des Verwaltungsrates außergewöhnliche politische oder militärische Ereignisse, welche die

normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Firmensitz oder den Nachrichtenverkehr mit dem Ausland beein-
trächtigen, auftreten bzw. bevorstehen, so kann der Firmensitz vorübergehend ins Ausland verlegt werden, bis diese
außergewöhnlichen Umstände wieder zur Gänze beseitigt sind. Derlei vorübergehende Maßnahmen wirken sich nicht
auf die Nationalität der Gesellschaft aus, welche, unbeschadet einer solchen vorübergehenden Verlegung des Firmensit-
zes, eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.

Art. 5. Das Kapital der Gesellschaft wird durch nennwertlose Aktien (die «Aktien») dargestellt und entspricht je-

derzeit dem Gesamtnettovermögen der Gesellschaft, so wie nachstehend definiert.

Das Mindestkapital der Gesellschaft ist der Gegenwert in US-Dollar («USD») von fünfzig Millionen Luxemburgischen

Franken (50.000.000,- LUF).

Der Verwaltungsrat ist jederzeit ohne Einschränkung berechtigt, Aktien zu einem Ausgabepreis (der «Ausgabepreis»)

pro Aktie des jeweiligen Teilfonds, so wie in Artikel 24 definiert, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht
auf Zeichnung von Aktien einzuräumen, auszugeben.

Der Verwaltungsrat kann an jeden ordnungsgemäß bevollmächtigten Direktor der Gesellschaft («Direktor») oder

Angestellten der Gesellschaft sowie an jede andere ordnungsgemäß dazu bevollmächtigte Person die Aufgabe übertra-
gen, Zeichnungen zu akzeptieren sowie die Zahlung des Ausgabepreises und die Zahlung des Preises von solchen Aktien
vorzunehmen bzw. anzunehmen.

Diese neuen Aktien können, wie der Verwaltungsrat es bestimmt, verschiedenen Teilfonds (hiernach «Teilfonds» ge-

nannt) angehören, und die Gelder aus der Ausgabe eines jeden Teilfonds werden gemäß obenstehendem Artikel 3 in
Wertpapiere oder andere Vermögenswerte wie Termingeschäfte eines geographischen Gebietes, industriellen Sektors,
eines Währungsgebietes oder einer spezifischen Art von derivativen Finanzinstrumenten wie es der Verwaltungsrat hin-
sichtlich eines jeden Teilfonds bestimmt, angelegt.

Der Verwaltungsrat kann das Kapital der Gesellschaft herabsetzen in dem er einen oder mehrere Teilfonds schließt:

die Aktien des entsprechenden Teilfonds werden annulliert und der Gegenwert dieser Aktien wird den Aktionären die-
ses Teilfonds überwiesen. Die Auflösung und Fusion von einem oder mehreren Teilfonds wird in Artikel 28 beschrieben.

Art. 6. Der Verwaltungsrat begibt Aktien in Form von Namens- oder Inhaberaktien nach Wahl des Aktionärs hin-

sichtlich jedes Teilfonds. Verlangt ein Inhaberaktionär den Umtausch in Namensaktien, werden ihm für diesen Umtausch
keine Kosten in Rechnung gestellt. Namensaktien können in verbriefter oder nicht-verbriefter Form ausgegeben wer-
den. Sie werden in nicht-verbriefter Form ausgegeben außer ein Anleger verlangt die Ausgabe eines Zertifikates. Inha-
beraktien werden durch Globalzertifikate verbrieft, welche bei Abwicklungssysteme wie CLEARSTREAM oder
EUROCLEAR hinterlegt werden.

Aktienzertifikate sind von zwei Direktoren oder einem Direktor und einem vom Verwaltungsrat für solche Zwecke

rechtmäßig bevollmächtigten Vertreter zu unterzeichnen. Unterschriften von Direktoren können entweder eigenhändig
oder gedruckt bzw. per Faksimile erfolgen. Die Unterschrift eines bevollmächtigten Stellvertreters ist handschriftlich zu
leisten. Die Gesellschaft kann zeitweilige Aktienzertifikate in einer vom Verwaltungsrat gegebenenfalls festzulegenden
Form begeben.

Die Aktienausgabe erfolgt bei der Annahme der Zeichnung und vorbehaltlich der Bezahlung des Preises so wie in

Artikel 24 bestimmt. Dem Zeichnenden wird in einem angemessenen Zeitraum das definitive Aktienzertifikat bzw. ge-
mäß vorstehendem eine Bestätigung seines Aktienbesitzes übermittelt.

Dividendenausschüttungen erfolgen, im Falle von Namensaktien zugunsten des Aktienbesitzers, an dessen Mandats-

adresse im Aktionärsregister bzw. an eine andere den Direktoren schriftlich bekanntgegebenen Adresse.

Mit Ausnahme von Inhaberaktien werden alle Aktien der Gesellschaft im Aktionärsregister verzeichnet, welches

durch die Gesellschaft bzw. eine oder mehrere dafür von der Gesellschaft bestellte Person/en geführt wird. In diesem
Register sind die Namen der Besitzer von Namensaktien, deren ständiger Wohnort oder gewählter Wohnsitz, sofern
der Gesellschaft bekanntgegeben, sowie die Anzahl der erworbenen Aktien im jeweiligen Teilfonds angegeben. Alle Ak-
tienübertragungen, ausgenommen Inhaberaktien, werden im Aktionärsregister festgehalten, gegen Bezahlung einer dafür
üblichen und von den Direktoren für die Eintragung von allen anderen mit der Aktienberechtigungen verbundenen Do-
kumenten anerkannten Gebühr. 

Die Gesellschaft hat in Zusammenhang mit Aktientransaktionen gegenüber Dritten keinerlei Haftung oder Verpflich-

tungen und ist berechtigt, alle mit diesen Aktien verbundenen Rechte, Ansprüche oder Forderungen von Dritten als
nicht gegeben anzusehen, sofern die Gesellschaft niemandem ein Recht aberkennt, welcher dieser in Zusammenhang
mit der Eintragung einer Änderung im Aktienregister rechtmäßig zustünde.

Es gibt keine Einschränkung des Rechtes auf Übertragung von Aktien und kein Zurückbehaltungsrecht zugunsten der

Gesellschaft.

Die Übertragung von Inhaberaktien erfolgt durch Übergabe der entsprechenden Inhaberaktienzertifikate bzw. des

Zertifikates das diese verbrieft und falls anwendbar mit allen dazu gehörigen, noch nicht fälligen Kupons. Die Übertra-
gung von Namensaktien erfolgt durch eine diesbezügliche Mitteilung im Aktionärsregister der Gesellschaft durch den
Aktienbesitzer oder durch hierzu ordnungsgemäß berechtigte Personen.

Jeder Namensaktionär ist verpflichtet, der Gesellschaft eine Adresse bekanntzugeben, an welche alle Mitteilungen und

Bekanntmachungen der Gesellschaft gesandt werden können. Die jeweiligen Adressen werden in das Aktionärsregister
eingetragen. Im Falle von gemeinsamem Aktienbesitz wird lediglich eine Adresse verzeichnet und alle Mitteilungen er-
folgen ausschließlich an diese Adresse.

Gibt ein Aktionär im Aktionärsregister keine Adresse an, so kann die Gesellschaft gestatten, im Aktionärsregister

einen diesbezüglichen Vermerk anzubringen und es wird angenommen, dass die Adresse des Aktienbesitzers beim Fir-
mensitz der Gesellschaft oder an einer anderen von der Gesellschaft hierzu angegebenen Adresse ist und zwar so lange
bis der Aktienbesitzer der Gesellschaft eine neue Adresse bekanntgibt. Die Aktionäre können ihre im Aktionärsregister

54161

eingetragenen Adressen jederzeit mittels schriftlicher Mitteilung an den Firmensitz der Gesellschaft bzw. an die allenfalls
von der Gesellschaft hierzu festgelegten Adresse ändern.

Art. 7. Ist ein Aktionär in der Lage, in einem für die Gesellschaft befriedigendem Masse nachzuweisen, dass sein Ak-

tienzertifikat verlegt, verunstaltet oder zerstört wurde, so kann auf sein Verlangen ein Aktienzertifikat in 2. Ausfertigung
ausgestellt werden, und zwar unter den von der Gesellschaft bestimmten Bedingungen und Garantien. Nach Übergabe
des neuen, mit dem Wort «Duplikat» zu versehenden Aktienzertifikates, wird das original Aktienzertifikat, andessen
Stelle das neue ausgestellt wurde, ungültig.

Die Gesellschaft hat das Recht, einem Aktionär für die Ausstellung eines Duplikats oder eines neuen Aktienzertifika-

tes,(wenn das alte verlegt, verunstaltet oder zerstört wurde, angefallene Sonder-Barauslagen nach eigenem Ermessen
zu verrechnen.

Art. 8. Die Gesellschaft kann den Besitz von Aktien durch bestimmte natürliche oder juristische Personen einschrän-

ken oder verbieten, insbesondere wenn es sich um eine Person handelt, die gegen das Gesetz bzw. gesetzliche Auflagen
eines Staates oder einer Staatsbehörde verstoßen hat oder die Kraft eines Gesetzes oder gesetzlicher Auflagen für den
Besitz von Aktien nicht qualifiziert ist, oder wenn wegen der Person des Aktienbesitzers der Gesellschaft eine Besteue-
rung oder ein anderer finanzieller Nachteil erwachsen würden, welcher sonst nicht gegeben wäre, oder wenn der Ver-
waltungsrat dies entscheidet und im aktuellen Prospekt bekanntgibt, dass es sich um eine wie unten näher angeführte
Person der Vereinigten Staaten von Amerika (insgesamt definiert als «Unbefugte Person») handelt. In diesen Fällen kann
die Gesellschaft:

(a) die Ausgabe, oder die Registrierung einer Übertragung von Aktien ablehnen, wenn sie der Meinung ist, dass eine

solche Ausgabe oder Registrierung der Übertragung zum Besitz von Aktien durch eine Unbefugte Person führt und

(b) jederzeit von allen Personen, deren Namen im Register verzeichnet sind oder die eine Aktienübertragung regi-

strieren lassen möchten, sämtliche Angaben verlangen, welche die Gesellschaft als notwendig erachtet, um feststellen
zu können, ob der wirtschaftlich Berechtigte dieser Aktien eine Unbefugte Person ist oder hierdurch werden könnte
und 

(c) wenn es sich herausstellt, dass eine Unbefugte Person (ob alleine oder gemeinsam mit einem Dritten) Aktien be-

sitzt, wird die Gesellschaft diese Aktien auf folgende Art und Weise zwingend rückkaufen:

1. Die Gesellschaft macht eine Ankündigung (im weiteren genannt Kaufankündigung) über den Aktienbesitzer, wel-

cher im Register als Besitzer zu erwerbender Aktien angeführt ist und führt dabei die o.g. und zu erwerbenden Aktien,
deren Preis sowie den Zahlungsort an. Die Ankündigung wird dem Aktienbesitzer frankiert und eingeschrieben an des-
sen zuletzt genannte bzw. in den Verzeichnissen der Gesellschaft angeführte Adresse gesandt. Der besagte Aktionär
wird so aufgefordert, das Zertifikat oder mit der Aktie verbundene und in der Kaufsankündigung näher ausgeführte Zer-
tifikate, falls ausgestellt, umgehend der Gesellschaft zu übergeben. Unverzüglich nach Geschäftsschluss des in der
Kaufsankündigung genannten Tages erlischt der Aktienbesitz des in der Ankündigung bezeichneten Aktionärs und des-
sen Namen wird aus dem Register gestrichen.

2. Die für den Erwerb einer solchen Aktie in der Kaufsankündigung angeführte Summe (hier genannt «Kaufpreis»)

beläuft sich in Übereinstimmung mit Artikel 23 des vorliegenden Dokuments auf den Nettoinventarwert der entspre-
chenden Aktie.

3. Mit Ausnahme von Devisenbeschränkungszeiten erfolgt die Zahlung des Kaufpreises an den Aktienbesitzer in der

Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds. Der Kaufpreis wird bei der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem ande-
ren (in der Kaufsankündigung angeführten) Ort hinterlegt und dem Besitzer gegen Auslieferung des Zertifikates, falls
ausgegeben ausbezahlt. Bei Hinterlegung des Kaufpreises im oben angeführten Modus besteht für die in der Kaufsankün-
digung angeführten Personen kein weiterer Anspruch auf diese Aktien; sie haben gegenüber der Gesellschaft und deren
Vermögen keinerlei Ansprüche zu stellen und haben lediglich ein Anrecht auf die hinterlegte Summe (ohne Zinsen) als
Gegenleistung für die rechtswirksame Übergabe des Zertifikates bzw. der oben angeführten Zertifikate, falls ausgegeben.

4. Die Ausübung der der Gesellschaft in diesem Artikel verliehenen Vollmachten soll keinesfalls mit der Begründung,

dass der Besitz einer Aktie nicht ausreichend nachgewiesen werden konnte oder der tatsächliche Besitz einer Aktie von
dem durch die Gesellschaft zum Zeitpunkt der Kaufsankündigung angeführten Besitz abweicht, in Frage gestellt oder für
ungültig erklärt werden - vorausgesetzt, dass die besagten Vollmachten in einem solchen Fall von der Gesellschaft gut-
gläubig ausgeübt wurden; und

(d) einer Unbefugten Person bei Hauptversammlungen der Gesellschaft das Stimmrecht entziehen.
Die Bezeichnung «Person der Vereinigten Staaten von Amerika» oder U.S Person steht in der vorliegenden Satzung

für einen Staatsbürger oder Einwohner der Vereinigten Staaten von Amerika, für eine Gesellschaft in einem Bundesstaat,
auf dem Territorium oder in Besitz der USA, oder für nach dem Gesetz der Vereinigten Staaten von Amerika organi-
sierte, sich auf dortigem Territorium oder in Besitz der USA befindliche Körperschaften, Besitztümer oder Unterneh-
menszusammenschlüsse.

Art. 9. In ordentlich einberufenen Hauptversammlung der Gesellschaft oder eines Teilfonds sind alle Aktionäre der

Gesellschaft oder die Aktionäre eines Teilfonds vertreten. Hierbei gefasste Beschlüsse gelten für alle Aktionäre der Ge-
sellschaft oder des entsprechenden Teilfonds als verbindlich. Die Hauptversammlung verfügt über weitestgehende Voll-
machten zur Anordnung, Durchführung oder Ratifizierung von Verordnungen in geschäftlichen Belangen der
Gesellschaft.

Art. 10. Die Jahresversammlung wird in Übereinstimmung mit dem Luxemburgischen Gesetz im Grossherzogtum

Luxemburg am Firmensitz der Gesellschaft oder an einem in der Einberufung angeführten anderen Ort, jeweils am er-
sten Montag im Monat Mai um 11.00 Uhr vormittags abgehalten. Ist dieser Tag in Luxemburg kein Bankarbeitstag, so
findet die Jahreshauptversammlung an dem darauffolgendem Bankarbeitstag in Luxemburg statt. Die Jahreshauptver-

54162

sammlung kann auch im Ausland durchgeführt werden, wenn dies gemäß absoluter und endgültiger Entscheidung des
Verwaltungsrates aufgrund von außergewöhnlichen Umständen notwendig erscheint.

Ort und Zeit anderer Aktionärsversammlungen werden gemäß Angaben in den entsprechenden Einberufungen

durchgeführt.

Art. 11. Für die Ankündigung und Durchführung von Aktionärsversammlungen der Gesellschaft gelten bezüglich Fri-

sten und Beschlussfähigkeit die gesetzlichen Regeln, sofern im vorliegenden Dokument nichts anderes festgelegt ist.

Jede Aktie verbrieft ein Stimmrecht, vorbehaltlich der in dieser Satzung verfügten Beschränkungen. Ein Aktionär ist

berechtigt, in schriftlicher Form, telegrafisch, via Telegramm, Telex oder Telefax für Aktionärsversammlungen an seiner
Stelle einen Stimmrechtsbevollmächtigten zu ernennen.

Wenn nicht gesetzlich oder in der vorliegenden Satzung anders bestimmt, erfolgt die Beschlussfassung bei rechtmäßig

einberufenen Aktionärsversammlungen durch eine einfache Mehrheit der anwesenden und stimmberechtigten Aktionä-
re. Eine Gesellschaft kann durch Unterschrift eines dazu befugten Amtsinhabers einen Stellvertreter ernennen.

Der Verwaltungsrat bestimmt alle weiteren Voraussetzungen für die Teilnahme von Aktionären an Aktionärsver-

sammlungen.

Solange das Kapital zwischen verschiedenen Teilfonds aufgeteilt ist, und ein Beschluss einer Generalversammlung der

Aktionäre der Gesellschaft, die Rechte der Aktieninhaber eines Teilfonds gegenüber den Rechten der Aktieninhaber
eines anderen Teilfonds berührt, unterliegt einem Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre eines solchen oder
der solchen Teilfonds in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Artikel 68 des Gesetzes vom 10. August 1915
betreffend Handelsgesellschaft, einschließlich Änderungen.

Art. 12. Versammlungen der Aktionäre werden durch den Verwaltungsrat einberufen, mittels Einberufungsschreiben

das die Tagesordnung bekanntgibt und jedem Aktionär an dessen Adresse aus dem Aktionärsverzeichnis spätestens 8
Tage vor der Versammlung zugesandt wird. Die Gesellschaft muss jedoch eine solche Mitteilung nicht nachweislich
durchführen, wenn die Einberufung gemäß Luxemburgischem Gesetz auch veröffentlicht worden ist.

Solange Inhaberaktien in Umlauf sind, wird die Einberufung zusätzlich im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations, in einer luxemburgischen Zeitung und in einer weiteren Zeitung nach Beschluss des Verwaltungsrates veröf-
fentlicht werden.

Wenn jedoch bei einer Versammlung alle Aktionäre oder deren Stellvertreter anwesend sind und angeben dass sie

die Tagesordnung kennen, kann eine Versammlung ohne vorhergehende Mitteilung oder Veröffentlichung abgehalten
werden.

Art. 13. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch den Verwaltungsrat, der sich aus mindestens drei Mit-

gliedern zusammensetzt. Verwaltungsratsmitglieder müssen nicht Aktionäre der Gesellschaft sein.

Wie unten näher ausgeführt, erfolgt die Wahl des Verwaltungsrates durch die Aktionäre im Rahmen einer Hauptver-

sammlung für die Zeit bis zur darauffolgenden Jahreshauptversammlung und bis ihre Nachfolger gewählt worden sind
und ihre Ernennung angenommen haben, oder - wenn zu einem späteren Zeitpunkt - bis zum Ende einer solchen Wahl
und Annahme derselben. Vorausgesetzt, dass ein Direktor mit oder ohne Angabe von Gründen jederzeit auf Beschluss
der Aktionäre abgesetzt oder ersetzt werden kann. Wird die Stelle eines Direktors durch Tod, Pension oder anderes
frei, so sollen die anderen Direktoren zusammentreffen und in einer Ergänzungswahl mit einfacher Mehrheit diesen Po-
sten bis zur nächsten Aktionärsversammlung wieder nachbesetzen.

Art. 14. Der Verwaltungsrat kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden wählen und unter seinen Mitgliedern

einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende ernennen. Der Verwaltungsrat kann zudem einen Schriftführer wäh-
len, der nicht Direktor sein muss und der bei Versammlungen des Verwaltungsrates und der Aktionäre für die Proto-
kollführung zuständig ist. Auf Verlangen von zwei Direktoren hat der Verwaltungsrat an einem in der
Versammlungsmitteilung angeführten Ort zusammenzutreffen.

Ist ein Vorsitzender ernannt, hat dieser bei allen Aktionärsversammlungen und Verwaltungsratssitzungen den Vorsitz

zu übernehmen. Ist kein Vorsitzender ernannt bzw. anwesend, so können die Aktionäre oder der Verwaltungsrat eine
beliebige Person pro tempore durch Mehrheitswahl aller an einer Versammlung teilnehmenden Personen zum Vorsit-
zenden wählen.

Eine schriftliche Einladung hat zumindest 24 Stunden vor einer Verwaltungsratssitzung an alle Direktoren zu ergehen.

Dies gilt nicht für äußerst dringliche Fälle, wobei dann diese Umstände in der Versammlungsankündigung zu erläutern
sind.

Von diesem Einladungsschreiben kann bei Einverständnis aller Direktoren (schriftlich, telegrafisch, per Telegramm,

Telex oder Telefax) Abstand genommen werden. Für einzelne Versammlungen, deren Zeit und Ort im vorhinein durch
Verwaltungsratsbeschluss in schriftlicher Form festgelegt wurden, ist keine eigene Einladung mehr erforderlich.

Direktoren können sich bei jeder Verwaltungsratssitzung schriftlich, telegrafisch per Telegramm, Telex oder Telefax

einen anderen Direktor zu ihrer Vertretung bestellen. Außerdem steht es Direktoren zu, ihre Stimme schriftlich, tele-
grafisch, durch Telegramm, Telex oder Telefax abzugeben.

Die Direktoren sind nur bei ordnungsgemäß einberufenen Verwaltungsratssitzungen handlungsfähig. Einzelne Ent-

scheidungen der Direktoren sind für die Gesellschaft nicht bindend, es sei denn, sie werden durch einen Beschluss des
Verwaltungsrates gebilligt.

Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrates sind nur dann rechtsgültig, wenn zumindest die Mehrheit der

Direktoren anwesend ist (was durch eine Konferenzschaltung telefonisch auch gegeben sein kann) bzw. sich vertreten
lässt. Entscheidungen werden durch Mehrheitswahl der bei einem solchen Treffen anwesenden oder vertretenen Direk-
toren getroffen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

54163

Beschlüsse des Verwaltungsrats können auch danach zustande kommen, dass zustimmende Erklärungen gleichen In-

halts auf ein- oder mehrfacher Ausfertigung durch Telex, Telegramm oder Telefax (in jedem dieser Fälle schriftlich be-
stätigt) von allen Direktoren unterschrieben werden.

Der Verwaltungsrat kann auf Zeit Führungskräfte der Gesellschaft ernennen, unter ihnen den Generaldirektor, Ge-

schäftsführern sowie deren Stellvertreter und weitere leitende Funktionäre, die für die Durchführung und Leitung der
Gesellschaft notwendig sind. Alle Ernennungen dieser Art können durch den Verwaltungsrat jederzeit wieder aufgeho-
ben werden. Leitende Kräfte müssen nicht Direktoren oder Aktionäre der Gesellschaft sein. Die ernannten leitenden
Funktionäre erhalten die ihnen vom Verwaltungsrat zugeteilten Vollmachten und Pflichten, sofern in der vorliegenden
Satzung nichts anderes bestimmt ist.

Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten im Bereich der täglichen Geschäftsführung und für allgemeine Angele-

genheiten der Gesellschaft, sowie jene zur Förderung der Belange und Ziele der Gesellschaft physischen Personen oder
Rechtspersönlichkeiten, die keine Verwaltungsratsmitglieder sein müssen, übertragen. Der Verwaltungsrat kann weiter
alle Vollmachten, Vertretungskompetenzen und Entscheidungsgewalten jedem Komitee übertragen, dessen Mitglieder
(gleich ob Verwaltungsratsmitglieder oder nicht) ihnen als dazu geeignet erscheinen.

Art. 15. Das Protokoll jeder einzelnen Versammlung ist von der Person, die dabei den Vorsitz inne hatten, zu un-

terschreiben.

Kopien oder Auszüge aus solchen Protokollen, die in Gerichtsverfahren oder anderswo vorgelegt werden, sind vom

Vorsitzenden, Geschäftsführer oder von zwei Direktoren zu signieren.

Art. 16. Der Verwaltungsrat ist mit weitestgehenden Vollmachten zur Ausübung aller im Interesse der Gesellschaft

liegenden administrativen und dispositionellen Schritte ausgestattet. Alle nicht ausdrücklich kraft Gesetz oder kraft vor-
liegender Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Vollmachten liegen im Zuständigkeitsbereich
des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat hat das Recht, im Namen der Gesellschaft alle Schritte zu unternehmen, welche nicht durch die

vorliegende Satzung den Aktionären in einer Hauptversammlung vorbehalten sind und hat - ohne die Allgemeingültigkeit
des vorher Gesagten einzuschränken - die Befugnis, die Firmen- und Investitionspolitik für die Anlagen zu bestimmen,
welche auf dem Prinzip der Risikostreuung basieren, vorbehaltlich jener Investitionsbeschränkungen, die von Gesetzes
wegen oder durch Regulierungen oder wie im Verkaufsprospekt betreffend das Angebot von Aktien zu beachten sind.

Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten zur Leitung täglicher Geschäfte und Angelegenheiten der Gesellschaft

sowie zur Umsetzung von Schritten zur Förderung der Politik und Ziele der Gesellschaft physische Personen oder Kör-
perschaften übertragen, welche nicht Mitglieder des Verwaltungsrates sein müssen und welche der Oberaufsicht des
Verwaltungsrates unterstehen.

Art. 17. Vertragsabschlüsse und sonstige Transaktionen zwischen der Gesellschaft und anderen Unternehmen bzw.

Firmen dürfen nicht durch die Tatsache, dass einer oder mehrere der Direktoren oder Funktionäre der Gesellschaft ein
Interesse an diesem anderen Unternehmen bzw. dieser anderen Firma haben oder dort Direktoren, Funktionäre, Teil-
haber oder Angestellte sind, beeinflusst werden oder als ungültig erklärt werden. Direktoren oder leitende Kräfte der
Gesellschaft, die Direktoren, leitende Funktionäre oder Angestellte einer anderen Gesellschaft oder Firma sind, mit der
die Gesellschaft einen Vertrag oder anderweitige Geschäfte abschliessen soll, sind aufgrund einer solchen Verschmel-
zung mit einer anderen Gesellschaft oder Firma nicht daran zu hindern, Angelegenheiten in bezug auf solche Verträge
oder Geschäfte zu überprüfen und darüber abzustimmen.

Hat ein Direktor oder leitender Funktionär der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Ge-

sellschaft, so hat er diesen Interessenkonflikt dem Verwaltungsrat bekanntzugeben und an der Prüfung und Abstimmung
solcher Transaktionen nicht teilzunehmen. Solche Transaktionen sind unter Bekanntgabe des befangenen Direktors
oder leitenden Funktionärs bei der darauffolgenden Hauptversammlung der Aktionäre vorzubringen.

Die im vorhergehendem Unterabschnitt verwendete Bezeichnung «persönliches Interesse» bezieht sich nicht auf Ge-

schäftsbeziehungen zu oder das Interesse an Angelegenheiten, Posten oder Transaktionen mit dem Anlagemanager, An-
lageverwalter, Anlageberater oder einer mit ihnen verbundenen Gesellschaft oder sonstige gegebenenfalls vom
Verwaltungsrat der Gesellschaft nach seinem Ermessen bestimmten Körperschaften oder Rechtspersönlichkeiten.

Art. 18. Die Gesellschaft ist befugt, Direktoren oder leitende Funktionäre sowie deren Rechtsnachfolger, Nach-

lassverwalter und Administratoren für Ausgaben schadlos zu halten, welche ihnen in Verbindung mit Strafverfahren, Pro-
zessen oder Rechtsstreitigkeiten aufgrund ihrer Tätigkeit als Direktor oder leitender Funktionär bei der Gesellschaft
oder auf Verlangen derselben bei einer anderen Gesellschaft erwachsen sind, von welcher die Gesellschaft Aktienbesit-
zer oder Gläubiger ist oder von der sie sich nicht schadlos halten können. Die Schadloshaltung einer solchen Person
erfolgt unter allen Umständen mit Ausnahme von jenen Strafverfahren, Prozessen oder Rechtsstreitigkeiten, bei denen
sie wegen grober Fahrlässigkeit oder schwerer Dienstverfehlung rechtskräftig verurteilt wird; im Falle einer Beilegung
wird die Entschädigung nur hinsichtlich Angelegenheiten, die von der Beilegung betroffen sind gezahlt und über welche
die Gesellschaft von ihrem Rechtsberater beraten worden ist, daß die zu entschädigende Person nicht eine solche
Pflichtverletzung begangen hat. Das oben angeführte Recht auf Schadloshaltung schließt andere Rechte der betreffenden
Person nicht aus.

Art. 19. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Direktoren gebunden: eine von einem

Stellvertreter der BANQUE COLBERT (LUXEMBOURG) S.A. und eine von einem Stellvertreter der QUADRIGA AS-
SET MANAGEMENT Ges.m.b.H.

Art. 20. In der Hauptversammlung der Aktionäre ist ein Wirtschaftsprüfer zu ernennen, welcher die gesetzlich fest-

gelegten Pflichten zu erfüllen hat.

Art. 21. Jeder Aktionär hat das Recht, jederzeit die Rücknahme seiner Aktien zu verlangen.

54164

Wie im folgenden näher erläutert, hat die Gesellschaft mit Ausnahme einzelner gesetzlich geregelter Einschränkungen

die Macht, ihre eigenen Aktien jederzeit zurückzunehmen. Der Rücknahmepreis einer jeden Aktie ist gleich dem von
der Gesellschaft festgesetzten Nettoinventarwert pro Aktie des jeweiligen Teilfonds.

Jeder Rücknahmeantrag welcher als Folge hätte, dass die Gesamtposition eines Aktionärs unter einen Mindestbetrag,

wie dieser Verwaltungsrat hinsichtlich eines jeden Teilfonds festgelegt werden kann, fällt, wird als Rücknahmeantrag für
die Gesamtposition dieses Anlegers behandelt.

Ein Aktionär kann die Rücknahme aller oder eines Teiles seiner Aktien durch die Gesellschaft verlangen, vorausge-

setzt, die Gesellschaft muss an einem Bewertungstag (wie im folgenden definiert) nicht mehr als 10 Prozent der bege-
benen Aktien eines Teilfonds zurücknehmen.

Eine derartige Beschränkung gilt für alle Aktionäre, die ihre Aktien in einem Teilfonds und einem Bewertungstag zur

Rücknahme angeboten haben anteilsmäßig an den zur Rücknahme angebotenen Aktien an diesem Teilfonds.

Die Gesellschaft kann die Rücknahme für höchstens sieben Bewertungstage nach Eingang des Rücknahmeantrages auf-

schieben (jedoch immer unter Berücksichtigung der oben angeführten Beschränkung). Im Falle einer Rücknahmeauf-
schiebung werden die entsprechenden Aktien zum Nettoinventarwert pro Aktie am Tag der Durchführung der
Rücknahme zurückgekauft.

Für diesen Zweck werden Umwandlungen als Rücknahmen betrachtet. 
Der Rücknahmepreis, berechnet auf den Nettoinventarwert pro Aktie, sowie im nachstehenden Artikel 23 bestimmt,

abzüglich einer vom Verwaltungsrat festgelegten Rücknahmegebühr, ist im Normalfall innerhalb von fünf Bankgeschäfts-
tagen nach dem entsprechenden Bewertungstag oder, wenn zu einem späteren Zeitpunkt, am Tag des Erhaltes der Ak-
tienzertifikate (falls welche ausgestellt wurden) zu bezahlen.

Wenn in außergewöhnlichen Umständen, die Liquiditäten eines Portfoliovermögens eines Teilfonds, für den Rück-

nahmeanträge eingegangen ist, nicht genügend sind um die Zahlung des Rücknahmepreises vorzunehmen, so wird diese
Zahlung zum nächtsmöglichen Termin jedoch, ohne Zinsen, vorgenommen.

Rücknahmeanträge sind vom Aktionär in schriftlicher Form beim Firmensitz der Gesellschaft in Luxemburg oder bei

von der Gesellschaft dafür ernannten Dritten oder Körperschaften, welche als Stellvertreter für die Rücknahme von
Aktien fungieren, vorzulegen. Das Zertifikat bzw. die Zertifikate, falls ausgegeben, für die entsprechenden Aktien sind
in angemessener Form und zusammen mit einem stichhaltigen Beweis über die Übertragung bzw. Abtretung an die Ge-
sellschaft oder an einen für diesen Zweck ernannten Stellvertreter zu übermitteln und erst dann erfolgt die Zahlung des
Rücknahmepreises. 

Von der Gesellschaft zurückgenommene Aktien verfallen.

Art. 22. Der Nettoinventarwert pro Aktie («Nettoinventarwert») und Ausgabe- sowie Rücknahmepreis einer Aktie

des jeweiligen Teilfonds werden von der Gesellschaft mindestens ein Mal pro Monat festgesetzt, was per Beschluss des
Verwaltungsrates angeordnet werden kann (der Tag oder Zeitpunkt für eine solche Festsetzung wird hierin als «Bewer-
tungstag» bezeichnet), jedoch so, dass kein Tag der ein Bankfeiertag in Luxemburg ist ein Bewertungstag ist.

Die Gesellschaft ist befugt, die Festsetzung des Nettoinventarwertes sowie die Ausgabe, Umwandlung oder die Rück-

nahme von Aktien eines Teilfonds in folgenden Fällen einzustellen:

(a) wenn ein Markt oder eine Börse, an der ein wesentlicher Teil der Anlagen eines Teilfonds notiert oder gehandelt

wird, an anderen als den landesüblichen Feiertagen geschlossen ist, oder der Geschäftsverkehr an solchen Tagen einge-
schränkt bzw. zur Gänze eingestellt wird; oder 

(b) bei Auftreten eines Notfalls, in deren Folge die Übertragung der Vermögenswerte der Gesellschaft eines Teilfonds

nicht unter zumutbaren Bedingungen und ohne dabei die Interessen der Aktionäre der Gesellschaft zu verletzen möglich
ist; oder

(c) wenn die Kommunikationsmittel versagen, welche für die Festsetzung des Preises oder Wertes der Anlagen eines

Teilfonds oder für die Festsetzung der aktuellen Preise an den Börsen bzw. Wertpapierbörsen notwendig sind; oder

(d) wenn die Überweisung von Geldern im Zusammenhang mit dem Verkauf von oder Zahlung von, Anlagen eines

Teilfonds nicht möglich ist oder nicht zu den üblichen Preisen oder Wechselkursen möglich ist; oder

(e) nach Meinung der Direktoren ungewöhnlichen Bedingungen, in denen es unmöglich oder gegenüber den Aktio-

nären nicht vertretbar wäre, den Handel mit Aktien eines Teilfonds fortzusetzen; oder

(f) im Falle eines Beschlusses, die Gesellschaft aufzulösen, ab (einschließlich) dem Tag der Veröffentlichung der ersten

Ankündigung zur Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre zu diesem Zwecke;

(g) bei Einstellung der Handelstätigkeit gemäß Artikel 27. 
Aktionäre, welche die Rücknahme ihrer Aktien beantragt haben, werden von einer solchen Suspendierung innerhalb

sieben Tage nach Stellung ihres Antrages unterrichtet und von der Aufhebung derselben unverzüglich in Kenntnis ge-
setzt.

Eine solche Suspendierung eines Teilfonds hat keinerlei Auswirkungen auf die Berechnung des Nettoinventarwertes

sowie auf Ausgabe, Umwandlung oder Rücknahme von Aktien eines anderen Teilfonds.

Art. 23. Der Nettoinventarwert einer Aktie wird in der entsprechenden Bewertungswährung eines jeden Teilfonds

als eine pro Aktien Zahl angegeben und an jedem Bewertungstag dadurch ermittelt, dass das Vermögen der Gesellschaft,
welches dem jeweiligen Teilfonds zuzuordnen ist, abzüglich der diesem Teilfonds zuzuordnenden Verbindlichkeiten
durch die Anzahl der ausgegebenen Aktien dieses Teilfonds dividiert wird.

Der Nettoinventarwert einer Aktie eines jeden Teilfonds wird wie folgt ermittelt:
A. Die Vermögenswerte jedes Teilfonds der Gesellschaft umfassen:
(a) sämtliches Bargeld und alle in bar ausstehenden Forderungen oder Guthaben, einschließlich aufgelaufener Zinsen;
(b) sämtliche Wechsel und Zahlungsforderungen sowie alle fälligen Beträge (einschließlich der Erträge aus verkauften,

aber noch nicht bezahlten Wertpapieren);

54165

(c) alle Wertpapiere, Aktien, Schuldverschreibungen, Obligationen, Bezugsrechte, Pfandscheine, der Marktwert aus

allen offenen Posten und anderen Kapitalanlagen und Wertpapieren, die der Gesellschaft gehören;

(d) alle Dividenden und Gewinne, die der Gesellschaft in bar oder Naturalien zustehen in der von der Gesellschaft

bekannten Höhe (die Gesellschaft kann jedoch die Bewertung den Fluktuationen des Börsenkurses von Wertpapieren
infolge von Handelspraktiken wie dem Handel mit Ex-Dividenden oder Ex-Rechten anpassen);

(e) alle aufgelaufenen Zinsen aus verzinslichen Wertpapieren der Gesellschaft mit Ausnahme der im Hauptbetrag sol-

cher Wertpapiere eingeschlossenen Zinsen;

(f) vorläufige Ausgaben der Gesellschaft, sofern diese noch nicht abgeschrieben worden sind und unter der Voraus-

setzung, dass solche vorläufigen Ausgaben direkt vom Kapital der Gesellschaft abgeschrieben werden können; und

(g) alle anderen Vermögenswerte aller Art einschließlich vorausbezahlter Ausgaben.
Der Wert dieser Vermögenswerte wird folgendermaßen ermittelt:
1. Der Wert von Barbeständen, Guthaben, Wechseln und Zahlungsforderungen, Forderungen, im voraus bezahlten

Ausgaben, Barausschüttungen und wie o.a. deklarierten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht
dem jeweiligen Nennwert, außer es erscheint unwahrscheinlich, daß der Nennwert ganz bezahlt oder erzielt werden
kann, in welchem Fall vom Nennwert ein solcher Betrag abzuziehen ist, daß nach Einschätzung des Verwaltungsrates der
wahre Wert zum Ausdruck kommt.

2. An einer offiziellen Wertpapierbörse notierte oder an einem geregelten und organisierten Markt gehandelte Wert-

papiere werden mittels eines seitens der Direktoren genehmigten Preisinformationsdienstes auf Basis des zuletzt ver-
fügbaren Preises festgesetzt. Entsprechen solche Preise jedoch nicht dem Verkehrswert, werden solche Wertpapiere
so wie die nicht notierten oder gehandelten Wertpapiere, gemäß den dafür angemessenen und voraussehbaren Ver-
kaufspreisen, sorgfältig nach Treu und Glauben unter Aufsicht der Direktoren, bewertet.

3. Der Wert von Terminkontrakten und/oder Optionen, die auf einer Wertpapierbörse bzw. einem anderen gere-

gelten oder organisierten Markt notiert oder gehandelt werden, basiert auf dem zuletzt verfügbaren von einem autori-
sierten Preisinformationsdienst (wie beispielsweise REUTERS, Telerate, Telekurs) angegebenen Preis am
entsprechenden Bewertungstag.

Für den Fall, dass von einem Teilfonds gehaltene Wertpapiere, Terminkontrakte oder Optionen am entsprechenden

Tag nicht an einer Wertpapierbörse oder anderen geregelten bzw. organisierten Markt notiert oder gehandelt werden
oder wenn Wertpapiere, Terminkontrakte oder Optionen, welche an einer Wertpapierbörse oder an einer anderen
geregelten bzw. organisierten Markt notiert oder gehandelt werden und der gemäß vorgehendem Absatz festgesetzte
Preis gegenüber dem Verkehrswert der jeweiligen Wertpapiere nicht repräsentativ ist, so wird der Wert solcher Wert-
papiere, Terminkontrakte oder Optionen auf der Basis eines dafür angemessenen vorhersehbaren und sorgfältig nach
Treu und Glauben festgelegten Verkaufspreises bestimmt.

Die Direktoren können nach ihrem eigenen Ermessen die Anwendung einer anderen Bewertungsmethode erlauben,

wenn sie der Meinung sind, dass diese dem Verkehrswert eines Vermögensgegenstandes eher entspricht. Die Direkto-
ren können sich bei der Bestimmung des Wertes von Vermögensgegenständen auf die Bestätigung des Hauptmaklers
und dessen Partner verlassen. Die Festsetzung der Einnahmen und Ausgaben der Gesellschaft erfolgt mittels Aufwands-
und Ertragsrechnung.

4. Alle Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten, die nicht in derselben Währung wie der Nettoinventarwert

des entsprechenden Teilfonds angegeben sind, werden mittels des Marktkurses bzw. mittels des Börsenkurses gültig am
Tag und zum Zeitpunkt der Festsetzung des Nettoinventarwertes der Aktien umgerechnet.

Die Bewertung der Terminkontrakte und/oder Optionen beruht auf Informationen (einschließlich, jedoch ohne Be-

schränkung, Positionsberichte, Bestätigungen, Zusammenfassungen usw.), die zum Zeitpunkt dieser Bewertung hinsicht-
lich aller offenen Terminkontrakte, Optionen und aufgelaufener Zinserträge, aufgelaufenen Betriebs-, Incentive- und
Dienstleistungsgebühren und aufgelaufenen Maklergebühren vorliegen. Ausgenommen bei offensichtlichen Irrtümern ist
die Bewertung endgültig und es werden keine Berichtigungen für die Anleger oder die Gesellschaft zugelassen. Die Be-
wertung unterliegt keiner Prüfung oder Anpassung.

B. Die Verbindlichkeiten eines Teilfonds der Gesellschaft enthalten:
(a) sämtliche Schulden, Wechsel und andere fällige Beträge; 
(b) die Honorare der Depotbank, Wertpapierhändlern, Handelsleitern, Handelsadministratoren, Handelsberatern,

Registerführern, Transferagenten, Verwaltungs- und Domizilierungstellen; andere innerbetriebliche Kosten, einschließ-
lich aber nicht ausschließlich, der Kosten für den An- und Verkauf von Wertpapieren, staatliche Gebühren, Honorare
der Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer, Zinsen, Berichterstattungskosten, Ausgaben für die Veröffentlichung von an-
gebotenen Rücknahmepreisen, Verteilung von Zwischen- und Jahresberichten, Porto, Telefon und Telex, angemessene
Marketing- und Werbekosten;

(c) alle der Gesellschaft bekannten fälligen oder noch nicht fälligen Verbindlichkeiten einschließlich angekündigter,

aber noch nicht ausgezahlter Dividenden;

(d) ein entsprechender, rückgestellter Betrag für am Bewertungstag fällige Steuern sowie andere von den Direktoren

zugelassene und genehmigte Rückstellungen und Reserven; und

(e) aller weiteren Verbindlichkeiten der Gesellschaft aller Art gegenüber Dritten;
(f) im Falle wo eine Verbindlichkeit der Gesellschaft nicht einem bestimmten Teilfonds zugeschrieben werden kann,

wird diese Verbindlichkeit allen Teilfonds verhältnismäßig zum Nettoinventarwert der jeweiligen Teilfonds zugeschrie-
ben.

Für die Bewertung der Verbindlichkeiten kann die Gesellschaft alle regulär oder periodisch anfallenden Verwaltungs-

oder andere Kosten für das gesamte Jahr bzw. einen anderen Zeitraum veranschlagen und dann auf den entsprechenden
Berechnungszeitraum proportional verteilen.

C. Für den Zweck der Bewertung in diesem Artikel gilt folgendes:

54166

(a) Rückzunehmende und auszugebende Aktien sind als vorhanden anzusehen, und bis einschließlich nach dem Schluss

des Bewertungstages an dem die Rücknahme- und Zeichnungsanträge angenommen worden sind und bezahlt bzw. er-
halten wurden, ist der Preis hierfür als eine Verbindlichkeit bzw. eine Einnahme des jeweiligen Teilfonds anzusehen.

(b) Käufe und Verkäufe von Wertpapieren die von der Gesellschaft an einem Bewertungstag gehandelt werden, wer-

den soweit ausführbar berücksichtigt.

Art. 24. Bei Zeichnung von Aktien der Gesellschaft basiert der Angebots- und Verkaufspreis einer Aktie - wie oben

ausgeführt - auf dem Nettoinventarwert pro Aktie des betreffenden Teilfonds zuzüglich einer Zeichnungsgebühr (die
Entscheidung darüber und über die Höhe derselben liegt beim Verwaltungsrat) und dem Honorar, das den an der Ak-
tienausgabe aktiv beteiligten Personen aus den Verkaufsumsätzen zu bezahlen ist (welches die in den entsprechenden
Gesetzen vorgesehenen Beträge nicht überschreiten soll). Der so ermittelte Preis (Ausgabepreis) ist in einer von den
Direktoren festgesetzten Zeitspanne zahlbar, die nicht länger als vier Bankwerktage nach Zuteilung der Aktien sein darf.

Der Ausgabepreis kann, nach Genehmigung durch den Verwaltungsrat und unter Einhaltung aller hierbei anwendba-

ren Gesetzen sowie unter Bezugnahme auf einen speziellen Prüferbericht, in welchem der Wert aller Vermögenspasten
bestätigt wird, auch durch Einbringung von solchen Sachwerten in den Aktienbestand der Gesellschaft bezahlt werden,
die vom Verwaltungsrat im Einklang mit den Anlagestrategien und -beschränkungen der Gesellschaft hierfür akzeptiert
werden.

Art. 25. Das Rechnungsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am ersten Tag des Monats Januar des betreffenden Jah-

res und endet am letzten Tag des Monats Dezember desselben Jahres.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD erstellt.

Art. 26. Auf Vorschlag des Verwaltungsrates ist im Rahmen einer Aktionärsversammlung des jeweiligen Teilfonds zu

entscheiden, wie der Jahresertrag des jeweiligen Teilfonds verwendet werden soll. Die Gesellschaftserträge können un-
ter Beibehaltung des in Artikel 5 der vorliegenden Satzung näher ausgeführten Mindestkapitals der Gesellschaft ausge-
schüttet werden.

Auf Beschluss des Verwaltungsrates können auf Aktien eines Teilfonds Zwischendividenden ausgezahlt werden.
Die angekündigten Dividenden werden im Normalfall in der Währung des entsprechenden Teilfonds ausgezahlt oder

aber in einer vom Verwaltungsrat entsprechend gewählten Währung. Ort und Zeit der Auszahlung wird von den Ver-
waltungsratsmitgliedern bestimmt. Die Direktoren legen weiter den Wechselkurs für die Übertragung der Dividenden
in die entsprechende Währung endgültig fest.

Art. 27. Ausgabe, Rücknahme und Umwandlung von Aktien eines Teilfonds werden sofort eingestellt, wenn der be-

treffende Teilfonds Handelsverluste erleidet, bei denen der Nettoinventarwert einer Aktie dieses Teilfonds um mehr
als 50% des zuletzt höchsten Nettoinventarwertes fällt. In solchen Fällen werden bis zur Abhaltung der im folgendem
Absatz beschriebenen Aktionärsversammlung alle bestehenden Kontrakte und Optionen liquidiert und jede weitere
Handelstätigkeit eingestellt.

Kommt es infolge einer solchen Maßnahme zu einer Suspendierung der Geschäfte, so werden alle Aktionäre des be-

treffenden Teilfonds innerhalb von 40 Tagen nach dieser Suspendierung zu einer Sondersitzung einberufen, um mit einer
3/4 Mehrheit der ausgegebenen Aktien des Teilfonds über eine mögliche Schließung oder Verschmelzung desselben mit
einem anderen Teilfonds zu entscheiden. Wird von den Aktionären ein Weiterbestehen bzw. eine Verschmelzung be-
schlossen, so erfolgt die unmittelbare Aufhebung der Suspendierung.

Art. 28. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren

(welche physische oder juristische Personen sein können), welche im Rahmen einer Aktionärsversammlung ernannt
werden und deren Vollmachten und Honorare hierbei festzulegen sind. Der Nettoerlös aus der Liquidation eines be-
stimmten Teilfonds ist durch die Liquidatoren an die Aktionäre im Verhältnis ihres Aktienbesitzes am entsprechenden
Teilfonds zu verteilen. 

Beträge, die von den Aktionären bis zum Ende des Liquidationsverfahrens nicht beansprucht werden, sind treuhändig

bei der CAISSE DES CONSIGNATIONS zu hinterlegen. Entsprechend den Bestimmungen des Luxemburgischen Rechts
verfallen die vom Treuhänder nicht fristgerecht geforderten Summen.

Unterschreitet das Kapital die zweidrittel des Mindestkapitals (LUF 50.000.000,-), so sind die Direktoren gesetzlich

verpflichtet, der Hauptversammlung einen Beschluss zu unterbreiten, wonach über die Auflösung der Gesellschaft zu
entscheiden ist. Bei einer solchen Versammlung ist keine Mindestanwesenheit erforderlich und der Beschluss zur Auf-
lösung der Gesellschaft kann mit einer einfachen Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien gefasst werden.

Fällt das Kapital der Gesellschaft auf unter ein Viertel des Mindestkapitals, sind die Direktoren gesetzlich angehalten,

der Hauptversammlung der Aktionäre einen Beschluss über eine mögliche Auflösung der Gesellschaft zu unterbreiten.

Bei einer solchen Hauptversammlung ist keine Mindestanwesenheit erforderlich und der für eine Auflösung der Ge-

sellschaft notwendiger Beschluss kann mit einer 1/4 (ein Viertel) Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktien
eines Teilfonds gefasst werden.

Wenn über einen Zeitraum von 30 aufeinanderfolgenden Tagen aus irgendeinem Grund der Nettoinventarwert eines

Teilfonds unter USD 1.000.000,- fällt, oder wenn der nicht in USD angegebene Nettoinventarwert eines Teilfonds die-
sen Grenzwert in einer anderen Währung unterschreitet, bzw. wenn der Verwaltungsrat aufgrund von Änderungen der
wirtschaftlichen oder politischen Situation, welche den Teilfonds betreffen, es als angemessen betrachtet, so kann dieser
nach einer 30 Tage vorher erfolgten Ankündigung an die Aktionäre, alle Aktien (und nicht nur ein Teil) des betreffenden
Teilfonds am nächsten Bewertungstag nach Ende der Frist der o.g. Ankündigung zum Nettoinventarwert einschließlich
der voraussichtlichen Veräußerung- und Liquidationskosten ohne zusätzliche Rücknahmegebühr zurücknehmen oder
aber den entsprechenden Teilfonds mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft bzw. mit einem anderen luxemburgi-
schen Organismus für gemeinsame Anlagen verschmelzen.

54167

Die Auflösung eines Teilfonds mit zwingendem Rückkauf aller betroffenen Aktien des Teilfonds oder dessen Ver-

schmelzung mit einem anderen Teilfonds der Gesellschaft bzw. mit einem anderen luxemburgischen Organismus für ge-
meinsame Anlagen auf Grundlage von anderen Faktoren als die Mindestgrösse der Vermögenswerte oder Veränderung
der wirtschaftlichen und politischen Situationen, welche den entsprechenden Teilfonds betrifft, kann nur durch die vor-
her von den Aktionären des jeweiligen Teilfonds im Rahmen einer rechtmäßig einberufenen Versammlung erfolgen, wel-
che ohne Mindestanwesenheitsbestimmung abgehalten werden kann und mit einer Mehrheit von 50 Prozent der
anwesenden oder vertretenen Aktien entscheiden kann.

Eine Fusion welche durch Beschluss des Verwaltungsrates und Annahme der Aktionäre des entsprechenden Teil-

fonds, ist 30 Tage ab Ankündigung derselben für alle Besitzer von Aktien des betroffenen Teilfonds bindend. In diesem
Zeitraum können Aktienbesitzer ihre Aktien ohne zusätzliche Gebühr zur Rücknahme einreichen. Sofern der Gesell-
schaft nicht sämtliche Aktionäre und deren Adresse bekannt sind, hat die Gesellschaft die Besitzer von Inhaberaktien
(falls vorhanden) durch Veröffentlichung einer Ankündigung in einer vom Verwaltungsrat zu bestimmender Zeitung zu
informieren.

Beträge die bei der Auflösung eines Teilfonds nicht von den Aktionären angefordert worden sind werden ab dem

Datum der Schließung der Auflösungsoperationen bei der Depotbank für einen Zeitraum von nicht mehr als sechs Mo-
nate hinterlegt ab. Nach diesem Zeitraum werden die Beträge bei der CAISSE DE CONSIGNATIONS hinterlegt.

Art. 29. Die vorliegende Satzung kann im Rahmen einer Aktionärsversammlung unter Einhaltung des nach luxem-

burgischem Recht erforderlichen Mindestanwesenheits und der Mehrheitsbestimmungen bei Bedarf abgeändert werden.

Art. 30. Alle in dieser Satzung nicht erfassten Belange sind in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August

1915 über Handelsgesellschaften samt dessen Novellen und sonstigen geltendem Recht zu behandeln.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, schließt der Vorsitzende die Sitzung.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, erklärt, daß auf Anfrage der hier anwesenden Personen

die gegenwärtige Urkunde in Englisch verfaßt wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Anfrage derselben
hier anwesenden Personen, und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist der
englische Text maßgebend.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Senningerberg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem amtierenden Notar nach Namen, Vornamen, so-

wie Stand und Wohnort bekannt, haben die Mitglieder des Versammlungsvorstandes gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.

Gezeichnet: E. Bégat, S. Becker, G. Fourez, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 26 octobre 2001, vol. 419, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations zwecks Veröffentlichung erteilt.

(78092/228/1261) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2001.

BESCHUETZUNG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 65.985. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg en date du 6 juin 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1998 et 1999.

Madame Régina Rocha Melanda est nommée administrateur en remplacement de Madame Frie Van de Wouw, admi-

nistrateur démissionnaire, pour une durée de une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
de l’exercice clôturant au 31 décembre 2000. 

en tant qu’administrateurs ainsi que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été re-

nouvelés pour une durée de une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice
clôturant au 31 décembre 2000.

Le capital social a été converti avec effet au 1

er

 janvier 2001, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998. Le mon-

tant du nouveau capital social est de EUR 30.986,70, représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36342/800/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Mersch, den 12. November 2001.

E. Schroeder.

Les mandats de

Madame Nathalie Carbotti
Monsieur Daniel Timbal

<i>Pour la société
Signature

54168

DIVEMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

STATUTS

L’an deux mille un, le huit octobre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1.- FIDCORP LIMITED, ayant son siège social à Gibraltar, Watergardens 6, Suite 24,
ici représentée par Madame Vania Baravini, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette, spécialement mandatée

à cet effet par procuration en date du 5 octobre 2001;

2.- Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen, agissant en son nom personnel;
3.- Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern, agissant en son nom per-

sonnel.

Les prédites procurations, paraphées ne varietur par tous les comparants et le notaire instrumentant, resteront an-

nexées aux présentes avec lesquelles elles seront soumises à la formalité de l’enregistrement.

Lesquels comparants, ès qualités qu’ils agissent, ont arrêté ainsi qu’il suit les statuts d’une société anonyme qu’ils vont

constituer entre eux.

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1

er

. Entre les personnes ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient dans la suite propriétaire des ac-

tions ci-après créées, il est formé une société anonyme sous la dénomination de DIVEMI S.A.

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg-Ville.
Par simple décision du conseil d’administration, la société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges

administratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Sans préjudice des règles du droit commun en matière de résiliation contractuelle, au cas où le siège de la société est

établi par contrat avec des tiers, le siège de la société pourra être transféré sur simple décision du conseil d’administra-
tion à tout autre endroit de la commune du siège. Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du pays
par décision de l’assemblée.

Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l’acti-

vité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger, se sont produits ou seront imminents,
le siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances anor-
males, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce trans-
fert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l’engager pour les actes de gestion courante et journalière.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un por-

tefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au con-
trôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garan-
ties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à EUR 80.000,- (quatre-vingt mille euros) représenté par 8.000 (huit mille) actions

d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de EUR 1.000.000,- (un million d’euros) qui sera

représenté par 100.000 (cent mille) actions d’une valeur nominale de EUR 10,- (dix euros) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

En outre, le conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans, prenant fin le 8 octobre 2006, à

augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après. Le conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions
sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.

54169

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.

Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,

il fera adapter le présent article.

Le conseil d’administration est encore autorisé à émettre des emprunts obligataires ordinaires, avec bons de sous-

cription ou convertibles, sous forme d’obligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et paya-
bles en quelque monnaie que ce soit, étant entendu que toute émission d’obligations, avec bons de souscription ou
convertibles, ne pourra se faire que dans le cadre des dispositions légales applicables au capital autorisé, dans les limites
du capital autorisé ci-dessus spécifié et dans le cadre des dispositions légales, spécialement de l’article 32-4 de la loi sur
les sociétés. Le conseil d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de
remboursement et toutes autres conditions y ayant trait.

Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Administration - Surveillance

Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d’une place d’administrateur nommé par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi

nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, pro-
cède à l’élection définitive.

Art. 7. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président. En cas d’empêchement du président, l’ad-

ministrateur désigné à cet effet par les administrateurs présents, le remplace.

Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou sur la demande de deux administrateurs.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente

ou représentée, le mandat entre administrateurs étant admis sans qu’un administrateur ne puisse représenter plus d’un
de ses collègues.

Les administrateurs peuvent émettre leur vote sur les questions à l’ordre du jour par lettre, télégramme, télex ou

téléfax, ces trois derniers étant à confirmer par écrit.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 8. Toute décision du conseil est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de

partage, la voix de celui qui préside la réunion du conseil est prépondérante.

Art. 9. Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration sont signés par les membres présents aux séan-

ces.

Les copies ou extraits seront certifiés conformes par un administrateur ou par un mandataire.

Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration

et de disposition qui rentrent dans l’objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l’assemblée générale.

Art. 11. Le conseil d’administration pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de gestion journalière à des ad-

ministrateurs ou à des tierces personnes qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. La délégation
à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale.

Art. 12. Vis-à-vis des tiers, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux ad-

ministrateurs ou par la signature individuelle d’un délégué du conseil dans les limites de ses pouvoirs. La signature d’un
seul administrateur sera toutefois suffisante pour représenter valablement la société dans ses rapports avec les admi-
nistrations publiques.

Art. 13. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l’assemblée

générale qui fixe leur nombre et leur rémunération.

La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Assemblée générale

Art. 14. L’assemblée générale réunit tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des af-

faires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

Art. 15. L’assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l’endroit indiqué dans la convo-

cation, le dernier vendredi du mois de septembre à 14.00 heures.

Si la date de l’assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

Art. 16. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d’administration ou par le(s)

commissaire(s). Elle doit être convoquée sur la demande écrite d’actionnaires représentant le cinquième du capital so-
cial.

Art. 17. Chaque action donne droit à une voix.
La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. Si une action de la société est détenue par plusieurs proprié-

taires en propriété indivise, la société aura le droit de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une
seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

54170

Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le conseil d’administration établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.
Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l’assemblée générale or-

dinaire au(x) commissaire(s).

Art. 19. Sur le bénéfice net de l’exercice, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légale; ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration pourra verser des acomptes sur dividendes sous l’observation des règles y relatives.
L’assemblée générale peut décider que les bénéfices et réserves distribuables seront affectés à l’amortissement du

capital sans que le capital exprimé soit réduit.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs.

Disposition générale

Art. 21. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas

été dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre

2001. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2002.

Les premiers administrateurs et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l’assemblée générale extraordinaire des

actionnaires suivant immédiatement la constitution de la société.

Par dérogation à l’article 7 des statuts, le premier président du conseil d’administration est désigné par l’assemblée

générale extraordinaire désignant le premier conseil d’administration de la société.

<i>Souscription et paiement

Les actions ont été souscrites comme suit par: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de EUR

80.000,- (quatre-vingt mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

La preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné qui le reconnaît.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ LUF 85.000,-.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Le nombre d’administrateurs est fixé à trois.
Sont appelés aux fonctions d’administrateurs, leur mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le premier

exercice:

1) Monsieur Thierry Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer;
2) Monsieur Luc Hansen, licencié en administration des affaires, demeurant à Kehlen;
3) Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern.
L’assemblée générale extraordinaire nomme Monsieur John Seil aux fonctions de président du conseil d’administra-

tion.

<i>Deuxième résolution

Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes, son mandat expirant à l’assemblée générale statuant sur le

premier exercice: AUDIEX S.A., ayant son siège à Luxembourg.

Souscripteurs Nombre 

d’actions

 Montant souscrit et libéré en EUR

1. FIDCORP LIMITED préqualifiée  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7.998

79.980

2. M. Luc Hansen, prénommé  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 1

10

3. M. John Seil, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

10

Totaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 8.000

 80.000

54171

<i>Troisième résolution

Le siège social de la société est fixé au 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée autorise le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion journalière à un ou plusieurs de

ses membres.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom, état et demeure, les comparants

ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. Baravini, L. Hansen, J. Seil, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 12 octobre 2001, vol. 10CS, fol. 20, case 2. – Reçu 32.272 francs.

<i>Le Receveur (signé): Muller.

Pour copie conforme délivrée, sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(69297/208/194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 2001.

AGENCE AAZ S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2175 Luxembourg, 13, rue Alfred Musset.

R. C. Luxembourg B 33.871. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36315/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

ALDERAMIN HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 70.492. 

Le bilan de la société au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 28 mai 2001, vol. 553, fol. 52, case 6, a été

déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36316/595/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

COLOTEL HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 65.512. 

EXTRAIT

Il résulte des délibérations du Conseil de Gérance en date du 28 mai 2001 que, sur base du contrat de transfert

d’actions signé en date du 1

er

 mars 2000, le Conseil de Gérance a accepté à l’unanimité que les actions de la société de

FRF 1.000,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36372/724/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Luxembourg, le 26 octobre 2001.

J. Delvaux.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Un mandataire

Désignation de l’actionnaire

Nombre

d’actions

COLONY FRANCE III L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.499

COLONY FRANCE SHAREHOLDER III L.L.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.500

R. P. Pels / D. C. Oppelaar
<i>Gérant / Gérant

54172

BELLOMBRE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 19.519. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 100, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001

L’assemblée reconduit les mandats d’administrateur de Madame Denise Vervaet et Monsieur Pierre Schill ainsi que

celui du commissaire aux comptes pour une période venant à échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes de l’exercice 2001.

Elle appelle Madame Joëlle Lietz, employée privée, 18A, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, aux fonctions

d’administrateur pour une même période.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36337/506/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CARLSON PROMOTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 50.886. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36357/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CARLSON PROMOTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 50.886. 

L’assemblée générale ordinaire du 28 mai 2001 a décidé  d’affecter le bénéfice de l’exercice se clôturant le 31

décembre 2000 comme suit:

Enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36358/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CARTERA FINANCE PARTNERS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 54.726. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordnaire du 1

er

 juin 2001 que:

- Le mandat des administrateurs actuels, M. Roeland P. Pels, M. Dirk C. Oppelaar et Mlle Anne Compère est

renouvelé pour une période de six ans. Leur mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.

- Le mandat du Commissaire aux Comptes actuel, ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l. est renouvelé

pour une période de six ans. Son mandat prendra fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’an 2007.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36359/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature

M. J. Kuylenstierna
<i>Le Responsable de la domiciliation de CARLSON PROMOTER S.A.

Bénéfice à reporter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.205.049,- LUF

M. J. Kuylenstierna
<i>Le Responsable de la domiciliation de CARLSON PROMOTER S.A.

Pour extrait conforme
R. P. Pels

54173

CARAVELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.642. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36360/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CARAVELLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.642. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36361/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CASARES S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 51.590. 

<i>Extraits des résolutions prises lors de la réunion du conseil d’administration tenue en date du 8 mai 2001

Il résulte d’une lettre adressée à la société en date du 8 mai 2001 que Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé,

demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, démissinne de ses fonctions d’administrateur avec effet im-
médiat.

En date du 8 mai 2001, le Conseil d’Administration coopte en remplacement la société LUX BUSINESS MANAGE-

MENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg.

Le Conseil d’Administration soumettra cette cooptation à l’assemblée générale, lors de sa première réunion pour

qu’elle procède à l’élection définitive.

Le Conseil d’Administration se compose dès lors comme suit:
- Madame C.-E. Cottier Johansson, employée privée, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Monsieur Johan Dejans, employé privé, demeurant 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- La société LUX BUSINESS MANAGEMENT, S.à r.l., ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxem-

bourg.

Luxembourg, le 8 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 22 mai 2001, vol. 553, fol. 36, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36362/595/26) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CONNECTION INTERNATIONAL COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9635 Bavigne, 9, Duerfstross.

R. C. Luxembourg B 69.107. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36378/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

<i>Pour CARAVELLE S.A.
Signature

<i>Pour CARAVELLE S.A.
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Bavigne, le 8 juin 2001.

Signature.

54174

CHEMLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.440. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36365/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CHEMLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.440. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36366/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

C.I.M. SERVICES S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 48.826. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 31 mai 2001, vol. 553, fol. 68, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36367/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

EIF INVESTMENT &amp; FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.

R. C. Luxembourg B 72.490. 

EXTRAIT

L’assemblée générale extraordinaire réunie à Luxembourg, le 31 mai 2001, a pris à l’unanimité les résolutions suivan-

tes:

1. L’assemblée prend acte de la démission du Commissaire aux comptes en la personne de Monsieur Christophe Der-

mine et nomme en son remplacement la société CeDerLux-SERVICES, S.à r.l., avec siège social à 4, rue Marché-aux-
Herbes, L-1728 Luxembourg avec effet immédiat.

2. L’assemblée prend également acte de la démission de deux administrateurs en la personne de Messieurs Jean Hof-

fmann et Marc Koeune et nomme en leur remplacement Monsieur Sébastian Coyette et Madame Laetitia Vandegaer,
tous les deux domiciliés professionnellement à 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Décharge pleine et entière a été accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes sortant pour leurs

mandats et gestion jusqu’à ce jour.

En outre, le siège social a été transféré à 4, rue du Marché-aux-Herbes,L-1728 Luxembourg.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36396/693/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CHEMLUX, S.à r.l.
Signatures

CHEMLUX, S.à r.l.
Signatures

J. Kuylenstierna
<i>Le liquidateur de C.I.M. SERVICES S.A. (en liquidation)

Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateur

54175

COM CENTER S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 51.122. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i>tenue à Luxembourg en date du 29 mai 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour les exercices 1998 et 1999.

Mademoiselle Regina Rocha Melanda a été nommée administrateur en remplacement de Madame Frie Van de Wouw

jusq’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Les mandats de Monsieur Brunello Donati et de Mademoiselle Anne-Françoise Fouss en tant qu’administrateurs ainsi

que celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes de la société ont été renouvelés pour un terme
d’une année, jusqu’à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2000.

Le capital social a été converti en euro avec effet au 1

er

 janvier 2001, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998.

Le capital social est de EUR 30.986,69 représenté par 1.250 actions sans désignation de valeur nominale.

Luxembourg, le 29 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36373/800/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

COMIPLANT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 69.912. 

EXTRAIT

Monsieur Nico Schaeffer, docteur en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la

Porte-Neuve, a démissinné de son poste d’administrateur avec effet immédiat.

Luxembourg, le 1

er

 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36374/535/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

COMPLUS HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1370 Luxembourg, 74, Val Sainte Croix.

R. C. Luxembourg B 45.647. 

<i>Extrait des décisions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordnaire du 5 janvier 2001

La nomination de M. Wolfgang Doering en qualité  d’administrateur-délégué (Managing Director) avec pouvoir de

signature individuel, conformément aux articles 9 et 10 des statuts, est acceptée.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36377/587/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

EIM PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 52.297. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36397/239/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

Pour extrait
<i>Pour COMPLUS HOLDING S.A.
WOOD, APPLETON, OLIVER &amp; CO. S.A.
Signature

Belvaux, le 5 juin 2001.

J.-J. Wagner.

54176

CORTENBERGH HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe.

R. C. Luxembourg B 50.786. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 7, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001. 

<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale du 23 mai 2001

1) Le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes est renouvelé jusqu’à la prochaine Assemblée Gé-

nérale Ordinaire.

2) L’assemblée a décidé, en application de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales, qu’il n’y a pas lieu à

dissolution anticipée de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36379/280/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

DEMINOR LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.

R. C. Luxembourg B 72.337. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue à Luxembourg en date du 6 juin 2001

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2000.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 2, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36385/800/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

DIXIEME S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 66.950. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(36391/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

FOLIO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R. C. Luxembourg B 29.960. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 100, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 5 juin 2001

L’assemblée reconduit le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour une période venant à

échéance à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2001.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 2001

L’assemblée décide de convertir le capital social en Euros avec effet au 1

er

 janvier 2002, en conformité avec la loi du

10 décembre 1998. Le montant du nouveau capital est de EUR 619.733,81, représenté par 23.562 actions sans désigna-
tions de valeur nominale. La conversion du capital en Euros a donné un montant de EUR 619.733,81.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36421/506/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

Signature.

<i>Pour la société
Signature

<i>Pour la société
Signature

54177

CATALINA, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 21, rue de la Ferme.

STATUTS

L’an deux mille un, le premier juin à Kockelscheuer.
1. Monsieur Marc Wolwert, industriel, né à Luxembourg, le 25.08.1959, demeurant à L-1898 Kockelscheuer, 21 rue

de la Ferme,

2. Madame Ouafa Akil, épouse de Monsieur Marc Wolwert, née à Tebessa / Algérie, le 23.02.1964, demeurant à

L-1898 Kockelscheuer, 21 rue de la Ferme,

déclarent constituer entre eux une société civile, dont ils ont arrêté les statuts comme suit:

Art. 1

er

. La société a pour objet la gestion, l’administration, l’exploitation, la mise en valeur, par vente, échange, lo-

cation, construction ou de toute autre manière de tous biens immobiliers ou mobiliers. La société pourra effectuer tou-
tes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet de nature
à en faciliter la réalisation, pourvu qu’elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au caractère exclusivement civil
de l’activité sociale.

Art. 2. La société prend la dénomination de CATALINA, Société Civile Immobilière.

Art. 3. La société est constituée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dissoute anticipativement par déci-

sion de l’assemblée générale extraordinaire des associés décidant à la majorité des voix et des participations.

Art. 4. Le siège social est établi à L-1898 Kockelscheuer, 21 rue de la Ferme.

Art. 5. Le capital social est fixé à soixante mille francs (60.000) représentée par soixante parts sociales (60) d’une

valeur nominale de mille francs (1.000,-) chacune.

Ces parts sociales ont été réparties comme suit:
1. Monsieur Marc Wolwert, trente (30) parts sociales.
2. Madame Ouafa Akil, trente (30) parts sociales.
Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

soixante mille francs (60.000,-) se trouve dés-à-présent à la libre disposition de la société.

Art. 6. La cession des parts s’opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l’article 1690

du Code Civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non associés qu’avec l’agrèment des décidants à l’unanimité.

Art. 7. La société ne sera dissoute par le décès d’un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les survi-

vants et les héritiers de l’associé ou des associés décédés. L’interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou le décon-
fiture d’un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à la société qui continuera entre les autres associés,  à
l’exclusion du et des associés en état d’interdiction, de faillite, de liquidation judiciaire ou de déconfiture. Chaque part
est indivisible à l’égard de la société. Les copropriétaires indivis sont tenus, pour l’exercice de leurs droits, de se faire
représenter auprès de la société par un seul d’entre eux ou par un mandataire commun pris par les autres associés. Les
droits et obligations attachés à chaque part la suivent dans quelque main qu’elle passe. La propriété d’une part emporte
de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l’assemblée générale.

Art. 8. Chaque part donne droit dans la propriété de l’actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommé par l’assemblée des associés

à la majorité des parts sociales.

Art. 10. Les décisions modifiant les statuts sont prises à la majorité des trois quarts (3/4) de toutes les parts exis-

tantes.

Art. 11. Les articles 1832 et 1872 du Code Civil trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par les

présents statuts.

<i>Assemblée générale extraordinaire

A l’instant, les comparants se sont réunis en assemblée extraordinaire, à laquelle ils se considèrent comme dûment

convoqués. A l’unanimité, ils prennent les résolutions suivantes:

1.- La société est gérée et administrée conjointement par Monsieur Marc Wolwert et par Madame Ouafa Akil, pré-

qualifiés.

2.- Pour tous les actes de disposition de droits réels concernant les immeubles appartenant à la société, la société

n’est valablement engagée que par la signature conjointe de deux associés gérants et de tous les autres associés non
gérants.

Signé: M. Wolwert, O Akil.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 8 juin 2001, vol. 320, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(36306/000/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

54178

ALTRANS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 61.203. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 1, a été déposé au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(36319/000/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

ANTERIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 52.354. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36320/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

ARASTRO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8421 Steinfort, 23, rue de Hagen.

R. C. Luxembourg B 37.502. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, vol. 553, fol. 60, case 1, a été déposé au registre de com-

merce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 juin 2001.

(36321/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

ARC CONSTRUCTIONS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8283 Kehlen, 2A, rue Gaessel.

R. C. Luxembourg B 46.923. 

Le bilan et l’annexe légale au 31 décembre 2000, enregistrés à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 90, case 11,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36322/664/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

AXA WORLD FUNDS, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R. C. Luxembourg B 63.116. 

Le bilan au 31 décembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 94, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(36325/014/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour réquisition
Signature
<i>Un mandataire

<i>Pour ANTERIA S.A.
Signature

ARASTRO, S.à r.l.
Signature

Kehlen, le 8 juin 2001.

Signature.

<i>On behalf of AXA WORLD FUNDS SICAV
CITIBANK INTERNATIONAL plc (LUXEMBOURG BRANCH)
Signature

54179

BELLATRIX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.446. 

<i>Extrait des contrats de cession de parts daté du 21 décembre 2000

- En vertu des résolutions prises par l’associé unique le 21 décembre 2000, devant Maître Lecuit, notaire à Hespé-

range: 

GIRARD HOLDING S.A., ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg, a transféré une partie de ses

parts (510.000) détenues dans la société, à 

CASSIOPEA HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg.
- En vertu des résolutions prises par l’associé unique le 21 décembre 2000, devant Maître Lecuit, notaire à Hespé-

range:

GIRARD HOLDING S.A., ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg, a transféré une partie de ses

parts (245.000) détenues dans la société, à

LYRAE HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg.
- En vertu des résolutions prises par l’associé unique le 21 décembre 2000, devant Maître Lecuit, notaire à Hespé-

range:

GIRARD HOLDING S.A., ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg, a transféré une partie de ses

parts (245.000) détenues dans la société, à

ASTEROPE HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg.
Les actionnaires actuels de la société sont:
CASSIOPEA HOLDING, S.à r.l. 510.000 parts
LYRAE HOLDING, S.à r.l. 245.000 parts
ASTEROPE HOLDING, S.à r.l. 245,000 parts

Luxembourg, le 13 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36335/710/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

BELLATRIX HOLDING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 79.446. 

<i>Extrait des contrats de cession de parts datés du 29 mars 2001

En vertu du:
- contrat de cession de parts daté du 29 mars 2001,
CASSIOPEA HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 9 rue Schiller, L-2519 Luxembourg, a transféré une partie

de ses parts (14.230) détenues dans la société, à

M. Marco Salomoni, résidant au 14 via Domenichino, Milan, Italie;
- contrat de cession de parts daté du 29 mars 2001,
LYRAE HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg, a transféré une partie de ses

parts (14.230) détenues dans la société, à 

M. Marco Salomoni, résidant au 14 via Domenichino, Milan, Italie;
- contrat de cession de parts daté du 29 mars 2001,
ASTEROPE HOLDING, S.à r.l., ayant son siège social au 9 rue Schiller L-2519 Luxembourg, a transféré une partie de

ses parts (14.230) détenues dans la société, à 

M. Marco Salomoni, résidant au 14 via Domenichino, Milan, Italie.
Les actionnaires actuels de la société sont:
CASSIOPEA HOLDING, S.à r.l. 495.770 parts
LYRAE HOLDING, S.à r.l. 230.770 parts
ASTEROPE HOLDING, S.à r.l. 230.770 parts
Mr Marco Salomoni 42.690 parts

Luxembourg, le 11 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 553, fol. 64, case 6. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36336/710/30) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Signature
<i>Agent Domiciliataire

Signature
<i>Agent Domiciliataire

54180

ASHA S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 29.042. 

The balance sheet as at December 31, 2000, registered in Luxembourg on June 8, 2001, vol. 554, fol. 3, case 8, has

been deposited at Trade Register of Luxembourg on June 11, 2001.

For publication in Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, June 11, 2001.

(36324/695/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

BENILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.149. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36338/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

BENILUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 65.149. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 87, case 5, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36339/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

AXE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 57.792. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 93, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36327/710/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

AXE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 57.792. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 28 mai 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de AXE MANAGEMENT S.A., ('la société'), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1998;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1998;
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:
Prenant en considération les pertes reportées, le résultat net au 31 décembre 1998 est une perte de 120.529,- LUF

qui sera allouée comme suit:

D’allouer la perte de l’exercice de 120.529,- LUF dans le compte perte à reporter
- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1998;

BENILUX, S.à. r.l.
Signatures

BENILUX, S.à. r.l.
Signatures

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

54181

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36328/710/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

AXE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 57.792. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 93, case 11, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36329/710/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

AXE MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2519 Luxembourg, 9, rue Schiller.

R. C. Luxembourg B 57.792. 

<i>Extrait des minutes de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 28 mai 2001

A l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de AXE MANAGEMENT S.A., ('la société'), il a été décidé com-

me suit:

- d’approuver le rapport de gestion et le rapport du Commissaire aux Comptes au 31 décembre 1999;
- d’approuver le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999;
- d’allouer comme suit le profit de l’exercice:

- d’accorder décharge pleine et entière aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour toutes opérations

effectuées à la date du 31 décembre 1999;

Luxembourg, le 28 mai 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 93, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36330/710/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CHARLES SQUARE FINANCE COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: DEM 25.000,-.

Siège social: L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi.

R. C. Luxembourg B 80.348. 

EXTRAIT

Il résulte des résolutions des associés en date du 14 mai 2001 que:
- M. Barry Porter a démissionné de ses fonctions de gérants de la société avec effet au 10 mai 2001,
- M. Kendall Young, General Manager, ayant son domicile au 10 Martin-Behaim Strasse, D-63263 Neu-Isenburg,

Frankfort, Allemagne, a été nommé comme nouveau gérant de la société à compter du 10 mai 2001.

Luxembourg, juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 99, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36364/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

CITCO (LUXEMBOURG) S.A.

- la réserve légale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6.624,- LUF

- le report à nouveau du profit . . . . . . . . . . . . . . . . 

125.856,- LUF

LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A.
Signatures
<i>Administrateur-Délégué

Pour extrait conforme
ERNST &amp; YOUNG, Société Anonyme
Signature

54182

BIOINVENTOR HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 61.773. 

EXTRAIT

Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 1

er

 juin 2001, les décisions suivantes

ont été prises:

- la démission d’EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., en tant qu’administrateur de la société est acceptée. Dé-

charge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant sur les comp-
tes annuels 2000.

- la société F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A., a été élue aux fonctions d’administra-

teur de la société jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2000. 

- la démission d’EQUITY TRUST (LUXEMBOURG) S.A., en tant que commissaire aux comptes de la société est ac-

ceptée. Décharge pour son mandat sera demandée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant
sur les comptes 2000.

- la société HARBOUR TRUST AND MANAGEMENT S.A., a été élue comme nouveau commissaire aux comptes de

la société jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels 2000. 

- ces quatre résolutions ont effet immédiat.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 3, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36345/695/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

B.I.R.S., BUREAU INTERNATIONAL DE REGLEMENT DE SINISTRES

Siège social: L-1651 Luxembourg, 13A, avenue Guillaume.

R. C. Luxembourg B 31.783. 

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 2000

Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux administrateurs

et au commissaire aux comptes pour l’exercice de leurs mandats jusqu’à ce jour ainsi que pour la non-tenue de l’As-
semblée à la date statutaire. Les mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire à tenir en l’an
2004.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 99, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36346/565/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

DAMIRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.509. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 17, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(36380/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

DAMIRE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. Luxembourg B 56.509. 

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 17, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 8 juin 2001.

(36381/065/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

<i>Pour la société
Signature
F. VAN LANSCHOT TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

Certifié conforme
K. Jacobs
<i>Administrateur-délégué

54183

BLUMENFELD S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R. C. Luxembourg B 76.782. 

<i>Extrait du rapport de la réunion du Conseil d’Administration du 30 mars 2001

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société du 4-6, avenue de la Gare, L-1610, Luxembourg, au 8, rue Dicks, L-1417

Luxembourg, avec effet immédiat;

2. Divers.

<i>Résolutions:

Après discussion pleine et entière, le conseil d’administration a pris les résolutions suivantes:
1. Le Conseil d’Administration décide le transfert du siège social de la société au 8, rue Dicks, L-1417 Luxembourg,

avec effet immédiat.

Aucun autre point n’étant à l’ordre du jour, la réunion a été close à 11.30 heures.

Enregistré à Luxembourg, le 7 juin 2001, vol. 553, fol. 95, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36347/000/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

BONAMARE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2636 Luxembourg, 12, rue Léon Thyes.

R. C. Luxembourg B 63.084. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 21 mai 2001 que:
1. La démission du Commissaire aux Comptes, VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., est acceptée et décharge lui est accor-

dée pour le reste de son mandat;

2. Election d’un nouveau Commissaire aux Comptes, ELPERS &amp; CO REVISEURS D’ENTREPRISES, S.à r.l., boulevard

du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Il terminera le mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’assemblée générale or-
dinaire de l’an 2003.

Enregistré à Luxembourg, le 5 juin 2001, vol. 553, fol. 82, case 7. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36348/724/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

BAGO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.897. 

Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Il résulte d’une décision prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2001 que les mandats des adminis-

trateurs, Mme M.P. Van Waelem, Mme L. Zenners et FIDIGA S.A., et du commissaire aux comptes S.R.E. REVISION,
SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH S.à r.l., expirent lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exer-
cice 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36331/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

BAGO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.897. 

Le bilan au 30 septembre 2000, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Il résulte d’une décision prise lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 mai 2001:
Sont réélus aux postes d’administrateur, leurs mandats se terminant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant

sur l’exercice 2006

- Madame M.P. van Waelem, demeurant à Luxembourg

Pour publication
Signature
<i>Un mandataire

Luxembourg, le 21 mai 2001.

D.-C. Oppelaar.

Signature.

54184

- Madame L. Zenners, demeurant à Ingeldorf
- FIDIGA S.A., avec siège social à Luxembourg
est nommé au poste de commissaire aux comptes, son mandat se terminant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur l’exercice 2006, en remplacement de S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l.,
commissaire aux comptes démissionnaire, 

- UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., avec siège social à Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36332/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

BAGO HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 40.897. 

Constituée par acte reçu par Maître Tom Metzler, notaire de résidence  à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 13

juillet 1992, publié au Mémorial C n

°

 528 du 16 novembre 1992,

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue en date du 3 mai 2001, que:
- a été nommé en tant que commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l’Assemblée Générale Ordinaire

statuant sur l’exercice 2006, UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A., avec siège social à 124, route d’Arlon, L-1150 Luxem-
bourg en remplacement de S.R.E. REVISION, SOCIETE DE REVISION CHARLES ENSCH, S.à r.l., commissaire aux
comptes démissionnaire.

Enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 85, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36333/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CAFES LINK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.

R. C. Luxembourg B 11.392. 

Acte constitutif publié à la page n

°

 10611 du Mémorial C, n

°

 216 du 6 décembre 1973

Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 553, fol. 98, case 10, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(36354/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

DAWNING INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 58.889. 

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 1

er

 juin 2001 que Mademoiselle Martine

Schaeffer, maître en droit, avec adresse professionnelle à L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte-Neuve, a été
cooptée en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Nico Schaeffer, démissionnaire.

L’élection définitive de Mademoiselle Martine Schaeffer sera soumise à la plus prochaine assemblée générale.

Luxembourg, le 6 juin 2001.

Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36382/535/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Signature.

modifié suivant acte reçu par le même notaire en date du 9 avril 1993, acte publié au Mémorial C n

°

 318 du

5 juillet 1993

Pour extrait conforme
Signature

Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d’administration
Signatures

54185

CARBOFIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 12, rue Goethe.

R. C. LuxembourgB 47.207. 

<i>Extraits des résolutions prises dans le cadre de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

<i> tenue de façon extraordinaire en date du 17 mai 2001

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de remplacer les anciennes administrateurs de la société en cooptant les Administrateurs

suivants:

<i>Administrateurs:

- M. Ravano Giovanni, administrateur de société, demeurant à Genova (Italie);
- M. Alberto RAvano, administrateur de sociétés, demeurant à Genova (Italie);
- M. Daniele Luigi Severoni, consultant, demeurant à Vezia (Suisse);
et décide de renouveler le mandat au Commissaire aux Comptes:
ERNST &amp; YOUNG S.A., rue Richard Coudenhove-Kalergi, L-1359 Luxembourg. 
Le mandat des administrateurs et du Commissaire aux Comptes prendra fin lors de l’Assemblée Générale statuant

sur l’exercice 2002.

L’Assemblée, pour autant que besoin, ratifie tous actes passés par les anciennes administrateurs jusqu’au présent

renouvellement.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 8 juin 2001, vol. 554, fol. 1, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(36356/065/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

CERESOLE REALE IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 64.252. 

Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 6 juin 2001, vol. 553, fol. 89, case 9, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juin 2001.

(36363/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 juin 2001.

MARTUR FINANCE S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Siège social: Luxemburg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

H. R. Luxemburg B 29.516. 

Hiermit informieren wir die Aktionäre, dass sich ein Irrtum in die Anzeige vom 1. Dezember eingeschlichen hat, die wie 

folgt lauten soll:

Die Aktionäre werden hiermit zur

AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der Gesellschaft eingeladen, die am <i>21. Dezember 2001 um 12.00 Uhr in Luxemburg, am Gesellschaftssitz mit folgender
Tagesordnung stattfindet:

<i>Tagesordnung:

1. Vorübergehende Annulierung des Aktiennennwertes.
2. Umwandlung des Gesellschaftskapitals von LUF in EURO mit Wirkung ab dem 1. Januar 2001 zum Kurs von 1,-

EURO für 40,3399 LUF, so dass sich das Kapital künftig auf EURO achthundertneunundachtzigtausendsechshun-
dervierzehn und drei Cents (EURO 898.614,03)

3. Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft um siebentausendsechshundertfünfunddreissig EURO und neunund-

siebzig Cents (EURO 7.635,97), so dass dieses von seinem derzeitigen Betrag in Höhe von EURO
achthundertneunundachtzigtausendsechshundertvierzehn und drei Cents (EURO 898.614,03) auf EURO neun-
hundertsechstausendzweihundertfünfzig (EUR 906.250,-) erhöht wird. Die Kapitalerhöhung wird durch entspre-
chende Einbeziehung der Gewinnvorträge durchgeführt.

4. Wiederherstellung des Aktiennennwertes und Festlegung eines neuen Aktiennennwertes in Höhe von EURO fünf-

undzwanzig (EURO 25,-). Jede Aktie geniesst die gleichen Rechte und Vorteile wie die vorher annulierten Aktien.

5. Beseitigung in der Satzung von jeglicher Referenz zum fällig gewordenen genehmigten Kapital.
6. Abänderung des Gegenstandes der Gesellschaft wie folgt:  

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist die Zeichnung, die übernahme von Beteiligungen, die Finanzierung
und die finanzielle Beteiligung in jeglicher Form an beliebigen Gesellschaften, Beteiligungsgesellschaften, Konsortien

<i>Pour CERESOLE REALE IMMOBILIERE S.A.
Signature

54186

oder Firmen zusammenschlüssen luxemburgischer oder ausländischer Staatsangehörigkeit, ebenso wie die Verwal-
tung der Mittel, die ihr zu Verfügung gestellt werden, sowie die Kontrolle, Verwaltung und Verwertung ihrer Be-
teiligungen. Die Gesellschaft darf Geschäfte betreffend Mobilien und Immobilien sowie kommerzielle und
finanzielle Vorgänge vornehmen, die einen direkten oder indirekten Zusammenhang zu ihrem Unternehmensge-
genstand aufweisen.

7. Zukommende Abänderungen der Artikel 4. und 5. der Satzung.

Die Teilnahme oder die Vertretung an dieser Versammlung obliegen der Hinterlegung der Aktien durch die Aktionäre

5 Werktage vor der Versammlung.
(05043/755/34) 

<i>Der Verwaltungsrat.

DELTATANK AG, Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.

H. R. Luxemburg B 75.218. 

Sie werden hiermit zu einer 

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

 der Aktionäre der DELTATANK A.G. welche am <i>27. Dezember 2001 um 14.00 am Gesellschaftssitz mit der nachfol-
genden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

<i>Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars.
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31. Dezember 2000.
3. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars.
4. Neuwahlen.
5. Verschiedenes.

(05032/000/16) 

<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

G-RENTINFIX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2951 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 37.063. 

<i>Echéance de G-RENTINFIX - COMPARTIMENT N

°

<i> 22 «BEF et LUF 30-11-2001»

Conformément aux dispositions du prospectus de vente et aux conditions d’émission, ce compartiment est arrivé à

échéance le 30 novembre 2001 (date valeur 6 décembre 2001) et est entré de plein droit en liquidation.

Au vu de l’objectif poursuivi de faire récupérer par l’actionnaire le montant minimum à l’échéance de EUR 413,93

(BEF 16.698) par rapport à sa mise de fonds initiale de EUR 247,89 (BEF 10.000), le montant obtenu est supérieur au
montant minimum prévu.

Le prix de remboursement s’élève à EUR 413,97 (BEF 16.700) par action, soit un rendement à l’échéance de 67,00%

ou un return annualisé de 7,60%.

A partir du 6 décembre 2001, les actionnaires dudit compartiment sont invités à présenter leurs actions aux guichets

des établissement suivants:

- En Belgique: FORTIS BANQUE
- au Grand-Duché de Luxembourg: BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. 
Le remboursement sera effectué, sans frais (hormis la taxe de bourse). 

(05048/584/19)

<i>Le Conseil d’Administration.

DESIGNER HOLDING S.A.H., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-8020 Strassen, 20, rue de la Solidarité.

H. R. Luxemburg B 42.224. 

Die Herren Aktieninhaber sind hiermit eingeladen, der

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am <i>2 Januar 2002 um 15.00 Uhr am Gesellschaftssitz stattfindet, beizuwohnen.

<i>Tagesordnung:

1. Lagebericht des Verwaltungsrates und Bericht des Aufsichtskommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, sowie Ergebniszuweisungen per 31.

Dezember 1998

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates und des Aufsichtskommissars.
4. Verschiedenes.

I (05041/698/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

54187

BNP PORTFOLIO, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R. C. Luxembourg B 47.390. 

Nous vous prions de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au 5 rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, le jeudi <i>27 décembre 2001 à 11.00 heures et qui aura l’ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

«Décision de convertir le capital social en Euro et d’adapter en conséquence les articles des statuts impactés par ce

changement.»

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 relative à la conversion par les sociétés commerciales

de leur capital en Euro, l’Assemblée délibérera valablement quelle que soit la partie du capital représentée et les points
de l’ordre du jour seront approuvés à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés.

La présente convocation et une formule de procuration sont envoyées au moins 8 jours avant l’Assemblée, à tout

propriétaire d’actions nominatives à son adresse porté au registre des actionnaires.

Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette Assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont

priés de déposer leurs titres, cinq jours francs avant l’Assemblée aux guichets de BNP PARIBAS LUXEMBOURG, 10A,
boulevard Royal, L-2093 Luxembourg où des formules de procuration sont disponibles.

Le projet de texte des statuts coordonnés comprenant les changements proposés est à la disposition des actionnaires

au siège de la Société.
I (05035/755/23) 

<i>Le Conseil d’Administration.

SAPACI S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le <i>7 janvier 2002 à 16.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
L’assemblée générale ordinaire du 17 septembre 2001 n’a pas pu délibérer sur le point 5 de l’ordre du jour, étant

donné que celui-ci ne figurait pas à l’ordre du jour.
I (05036/534/12) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIMIPROPERTIES S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.505. 

La première Assemblée Générale Extraordinaire convoquée pour le lundi 3 décembre 2001 à 11.45 heures n’ayant

pu délibérer sur les points de l’ordre du jour faute de quorum de présence,

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le lundi<i> 21 janvier 2002 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Suppression transitoire de la valeur nominale des actions.
2. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs belges en Euros avec effet au 1

er

janvier 2001 au cours de 1 Euro pour 40,3399 BEF, le nouveau capital de la société s’élevant à sept cent quatre-
vingt-treize mille deux cent cinquante-neuf Euros et vingt-huit cents (793.259,28 EUR).

3. Augmentation du capital de la société pour le porter de son montant actuel de sept cent quatre-vingt-treize mille

deux cent cinquante-neuf Euros et vingt-huit cents (793.259,28 EUR) à huit cent mille Euros (800.000 EUR) par
l’incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de six mille sept cent quarante Euros et soixante-
douze cents (6.740,72 EUR).

4. Restauration de la valeur nominale des actions, du capital social et fixation de celle-ci à deux cent cinquante Euros

(250 EUR) par action, chacune jouissant des mêmes droits et avantages que les actions précédemment supprimées.

5. Fixation du nouveau montant du capital autorisé d’un montant à dix millions d’euros (10.000.000 EUR). Le capital

social de la société pourra être porté de son montant actuel à dix millions d’Euros (10.000.000,- EUR) par la créa-
tion et l’émission d’actions nouvelles d’une valeur nominale de deux cent cinquante Euros (250 EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes. Autorisation au Conseil d’Administration pour
procéder à l’émission d’actions nouvelles, à libérer par voie de versements en espèces, d’apports en nature, par
incorporation de créances en capital ou encore, avec l’approbation de l’assemblée générale, par voie d’incorpora-
tion de bénéfices ou réserves au capital.

54188

6. Modification afférentes de l’article 5 des statuts.

Cette seconde Assemblée Générale Extraordinaire pourra délibérer valablement quelle que soit la proportion du ca-

pital présente ou représentée à cette Assemblée.

Pour assister ou être représentés à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires sont priés de déposer leurs titres

cinq jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (05047/755/34) 

<i>Le Conseil d’Administration.

I.B.D., INDUSTRIE DU BOIS DIEKIRCH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9250 Diekirch, 46, rue de l’Industrie.

R. C. Diekirch B 166. 

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE

des Actionnaires qui aura lieu le <i>27 décembre 2001 à 18.00 heures à Luxembourg, 32, rue J.P. Brasseur, pour délibérer
sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes au 31 décembre 2000; affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux administrateurs et commissaire aux comptes.
4. Divers.

Pour prendre part à l’assemblée, les actionnaires sont priés de déposer au siège social cinq jours francs avant la date

fixée pour l’assemblée leurs actions ou un certificat de blocage de leurs actions émis par un établissement bancaire de
droit luxembourgeois.

De même les actionnaires qui souhaiteront se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire de-

vront déposer leur(s) procuration(s) au siège social cinq jours avant l’assemblée.

Les documents visés à l’article 73 de la loi sur les sociétés commerciales sont à la disposition des actionnaires au siège

de la société quinze jours avant l’assemblée générale.
I (05040/000/22) 

<i>Le Conseil d’Administration.

LUX MARIE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2952 Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 32.072. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi <i>27 décembre 2001 à 10.00 heures au 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapport du liquidateur, Monsieur Pierre Schill,
– Nomination du Commissaire à la liquidation

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
I (05045/755/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

MOYNESQUE VIGNOBLE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R. C. Luxembourg B 69.811. 

 Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>17 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social.

<i>Ordre du jour:

1. Démission de deux membres du Conseil d’Administration et nomination de deux nouveaux membres du Conseil

d’Administration.

2. Transfert du siège social.
3. Divers.

II (04943/595/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

54189

PLETOR HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Luxembourg-Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R. C. Luxembourg B 52.731. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>17 décembre 2001 à 14.00 heures au siège social dans les bureaux de la FIDUCIAIRE JEAN REUTER, avec
l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Vote sur la ratification du report de l’assemblée générale;
2. Lecture du bilan 2000 et des rapports des administrateurs et commissaire;
3. Vote sur le bilan 2000;
4. Vote sur la cooptation des administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires;
5. Vote sur la décharge aux administrateurs et commissaire;
6. Vote sur la nomination d’un commissaire et sur la durée des mandats des nouveaux organes;
7. Vote sur l’article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant la continuation de la société;
8. Vote sur le passage à l’euro et la transformation du capital social de LUF 16.000.000 en EUR 396.629,64, représenté

par des actions sans désignation de valeur nominale et adaptation des statuts.

Cette Assemblée délibérera valablement, quelque soit le nombre d’actions présentes ou représentés, et votera à la

majorité simple.

Les actionnaires sont priés de déposer leurs titres au plus tard 5 jours francs avant la date de l’Assemblée auprès de

la KREDIETBANK S.A. à son siège à Luxembourg.

II (04948/000/27) 

CAVES St MARTIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Remich.

R. C. Luxembourg B 5.220. 

Nous avons l’honneur de convoquer Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui aura lieu mercredi <i>19 décembre 2001 à 14.30 heures en l’étude de M

e

 Alphonse Lentz, notaire à Remich.

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois (LUF) en euros (EUR).
2. Augmentation du capital social pour le porter de son montant actuel à un million d’euros (EUR 1.000.000,-) par

incorporation au capital de réserves libres à due concurrence, sans émission d’actions nouvelles.

3. Modification de l’article six des statuts:

«Art. 6. Le capital social est fixé à un million d’euros (EUR 1.000.000,-), représenté par quatre mille (4.000) actions
sans désignation de valeur, entièrement libérées.»

4. Modification de l’article vingt et un des statuts:

«Art. 21. Chaque action donne droit à une voix. Tous les actionnaires ont le droit de vote par eux-mêmes ou par
mandataires, en se conformant aux règles des présents statuts. Les procurations devront être déposées au siège
social au plus tard le troisième jour ouvrable avant celui fixé pour l’assemblée générale.
Le conseil d’administration a le droit de proroger, séance tenante, l’assemblée de quatre semaines. Il doit le faire
sur la demande d’actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social. Cette prorogation annule toute
décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement.»

5. Modification de l’article vingt-trois des statuts:

«Art. 23. L’exercice social s’étend du premier janvier au trente et un décembre.
Il est tenu annuellement au siège social le premier mardi du mois de juillet, à onze heures du matin, une assemblée
générale dans laquelle l’inventaire, les comptes annuels et les rapports du conseil d’administration et des commis-
saires sont soumis à l’examen et à l’approbation des actionnaires. Dans le cas où le premier mardi du mois de juillet
coïncide avec un jour férié, l’assemblée générale sera reportée au lendemain.
En vue de l’assemblée générale, l’administration établit au 31 décembre de l’exercice écoulé l’inventaire, le bilan,
ainsi que le compte de profits et pertes et l’annexe en se conformant aux prescriptions légales. L’inventaire est
accompagné d’une annexe contenant en résumé tous les engagements de la société, ainsi que les dettes des direc-
teurs, administrateurs et commissaires envers la société.
L’administration remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois avant l’assemblée gé-
nérale, aux commissaires qui doivent faire un rapport, contenant leurs propositions.»
Les actionnaires sont priés de présenter leurs actions au siège de la société à Remich (coupon 2 et suivants atta-
chés) aux fins d’estampillage.

<i>Pour le Conseil d’Administration
J. Reuter
<i>administrateur-délégué

54190

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale extraordinaire, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de se

conformer à l’article 22 des statuts et de déposer leurs actions au plus tard le 12 décembre 2001 au siège social de la
société à Remich ou aux guichets de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard le 14 décembre 2001.

II (04951/000/42) 

<i>Le conseil d’administration.

SPAREPLAN S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 22, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 10.216. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi <i>19 décembre 2001 à 10.00 heures au siège social pour

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de francs luxembourgeois en euros avec

effet au 1

er

 janvier 2000 au cours de 1,- EUR pour 40,3399 LUF, le nouveau capital de la société s’élevant à trente

mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-neuf cents (30.986,69 EUR).

2. Remplacement des mille deux cent cinquante (1.250) actions existantes de mille francs luxembourgeois (1.000,-

LUF) chacune par mille deux cent cinquante (1.250) actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, jouis-
sant des mêmes droits et avantages.

3. Modifications afférentes de l’article 3 des statuts.
4. Modification de l’alinéa 5 de l’article 1

er

 des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée.»

5. Suppression de l’article 11 des statuts relatif à la garantie des administrateurs et commissaires et renumérotation

des articles subséquents.

6. L’article 13 aura désormais la teneur suivante: 

«L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.»

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04959/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

HECO S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 14.566. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le mardi <i>18 décembre 2001 à 11.30 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

1. Adoption de la langue française comme langue régissant les présents statuts.
2. Modification du troisième paragraphe de l’article 1

er

 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«La durée de la société est illimitée.»

3. Changement de la monnaie d’expression du capital social de la société de NLG en EUR avec effet rétroactif au 1

er

janvier 2001, au cours de 1,- EUR pour 2,20371 NLG, le nouveau capital de la société s’élevant à deux millions cinq
cent quarante et un mille cent soixante-neuf euros et vingt et un cents (EUR 2.541.169,21).

4. Augmentation du capital social de la société pour le porter de son montant de deux millions cinq cent quarante et

un mille cent soixante-neuf euros et vingt et un cents (EUR 2.541.169,21) à deux millions cinq cent cinquante mille
euros (2.550.000,- EUR) par incorporation d’une partie des résultats reportés à concurrence de huit mille huit cent
trente euros et soixante-dix-neuf cents (8.830,79 EUR).

5. Suppression de l’article 7 des statuts relatif au cautionnement des administrateurs et du commissaire.
6. Modification de l’article 8 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

«L’année sociale commence le premier janvier et finit et trente et un décembre.»

7. Refonte complète des statuts en tenant compte de l’adoption de la langue française et des modifications apportées.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (04960/755/26) 

<i>Le Conseil d’Administration.

Remich, le 19 novembre 2001.

54191

STONEHENGE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 38.113. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>18 décembre 2001 à 10.30 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph
II, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Conversion du capital social en euro.
6. Nomination statutaire.
7. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
II (04961/550/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINHOLDING PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 27.980. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>18 décembre 2001 à 11.30 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph
II, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Conversion du capital social en euro.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
II (04962/550/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FINHOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.519. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>18 décembre 2001 à 14.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph
II, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Conversion du capital social en euro.
6. Nominations statutaires.
7. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
II (04963/550/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

54192

STONEHENGE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 57.539. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires qui aura lieu le <i>18 décembre 2001 à 15.00 heures à Luxembourg, au siège social, 40, boulevard Joseph
II, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 2000.
3. Affectation des résultats.
4. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
5. Conversion du capital social en euro.
6. Nomination statutaire.
7. Divers.

Les Actionnaires qui désirent assister à cette assemblée sont priés de déposer leurs parts sociales cinq jours francs

avant l’assemblée au siège social de la société.
II (04964/550/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

PRODIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 1, rue Philippe II.

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du <i>18 décembre 2001 à 9.00 heures, au siège social, pour délibérer sur l’ordre du jour ci-après:

<i>Ordre du jour:

1. dissolution de la société
2. nomination d’un liquidateur

II (04985/000/13) 

SOLISSIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R. C. Luxembourg B 52.917. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires de notre société sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, place de Nancy, L-2212 Luxembourg, le lundi <i>17 décembre 2001 à 11.00 heures pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Litige Solissimmo / Consultation (New Creastyle);
2. Situation financière;
3. Démission des membres du Conseil d’Administration et du Commissaire aux comptes, décharge, nominations en

remplacement;

4. Questions diverses.

II (04998/592/16) 

<i>Le Conseil d’Administration
Signature

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, Zone Industrielle Am Bann, L-3372 Leudelange


Document Outline

Sommaire

Partners Funds Management S.A.

Partners Funds Management S.A.

Quadriga Global Consolidated Trust, Sicav

Beschuetzung S.A.

Divemi S.A.

Agence AAZ S.A.

Alderamin Holding S.A.

Colotel Holding, S.à r.l.

Bellombre S.A.

Carlson Promoter S.A.

Carlson Promoter S.A.

Cartera Finance Partners (Luxembourg) S.A.

Caravelle S.A.

Caravelle S.A.

Casares S.A.

Connection International Company S.A.

Chemlux, S.à r.l.

Chemlux, S.à r.l.

C.I.M. Services S.A.

EIF Investment &amp; Finance S.A.

Com Center S.A.

Comiplant S.A.

Complus Holding S.A.

EIM Participations Luxembourg S.A.

Cortenbergh Holding

Deminor Luxembourg S.A.

Dixième S.A.

Folio S.A.

Catalina Société Civile Immobilière

Altrans S.A.

Anteria S.A.

Arastro, S.à r.l.

Arc Constructions S.A.

AXA World Funds, Sicav

Bellatrix Holding, S.à r.l.

Bellatrix Holding, S.à r.l.

Asha S.A.

Benilux, S.à r.l.

Benilux, S.à r.l.

Axe Management S.A.

Axe Management S.A.

Axe Management S.A.

Axe Management S.A.

Charles Square Finance Company, S.à r.l.

Bioinventor Holding S.A.

B.I.R.S., Bureau International de Réglement de Sinistres

Damire International S.A.

Damire International S.A.

Blumenfeld S.A.

Bonamare International S.A.

Bago Holding S.A.

Bago Holding S.A.

Bago Holding S.A.

Cafés Link S.A.

Dawning International S.A.

Carbofin S.A.

Ceresole Reale Immobilière S.A.

Martur Finance S.A.

Deltatank AG

G-Rentinfix

Designer Holding S.A.H.

BNP Portfolio

Sapaci S.A.

Fimiproperties S.A.

I.B.D., Industrie du Bois Diekirch S.A.

Lux Marie S.A.H.

Moynesque Vignoble S.A.

Pletor Holding S.A.

Caves St Martin S.A.

Spareplan S.A.H.

Heco S.A.

Stonehenge Participations S.A.

Finholding Participations S.A.

Finholding S.A.

Stonehenge S.A.

Prodin S.A.

Solissimmo S.A.