logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

27073

MEMORIAL

MEMORIAL

Amtsblatt

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L

 

D E S

 

S O C I E T E S

 

E T

 

A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 565

24 juillet 2001

S O M M A I R E

CASA STYLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 66, rue de Hollerich.

R. C. Luxembourg B 43.619. 

<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 23 octobre 2000

- Liste des comparants:
1. Monsieur Anibal Marques Simões demeurant à Luxembourg,
2. Monsieur Anibal Manuel Coimbra Marques demeurant à Bereldange,
3. Monsieur Gilberto Coimbra Marques demeurant à Steinsel.
- Changement d’adresse/siège de la société.
Les comparants et seuls associés de la société CASA STYLE, S.à r.l., ont décidé de transférer à partir du 1

er

 novembre

2000, l’adresse et le siège de la société à:

Nouvelle adresse/siège
66, rue de Hollerich
L-1740 Luxembourg. 

Luxembourg, le 23 octobre 2000. 

Enregistré à Luxembourg, le 5 janvier 2001, vol. 548, fol. 5, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01781/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Accenture Minority III Norway 1 S.C.A., Luxem- 

Lloyds TSB International Liquidity, Sicav, Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27074

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27101

Accenture Minority III Norway 2 S.C.A., Luxem- 

Lloyds TSB International Liquidity, Sicav, Luxem- 

bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27087

bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27105

Arbi, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27114

Lux International Finance S.A.H., Luxembourg . . 

27116

Beniga Holding S.C.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .

27119

Midwest Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . 

27105

Casa Style, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . .

27073

Monblan Holding S.A., Luxemburg. . . . . . . . . . . . . 

27110

Castor et Pollux, Sicav, Luxembourg. . . . . . . . . . . .

27115

Narcando Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . 

27115

Chamelle S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .

27118

Prontofund, Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27116

Exa Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . .

27115

Richemont S.A.H., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . 

27119

Fiver S.A.H., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27117

Rocagest S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27118

Geneimmo S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . .

27120

Socapar S.A.H., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . 

27118

Golf Financial Investment S.A.H., Luxembourg . . .

27116

Talanta Holding S.A., Luxembourg  . . . . . . . . . . . . 

27117

Immo-Royal, Sicav, Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .

27118

Theis Luxembourg, S.à r.l., Grevenmacher . . . . . . 

27105

Jumi S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27117

A. Marques Simões / A. M. Coimba Marques / G. Coimba Marques
<i>Associés

27074

ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-third of May.
Before Us, Maître Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Anne Cecilie Fagerlie, residing at Sofies Plass 2, 0169 Oslo (Norway),
2. Anne Foss Abrahamsen, residing at President Harbitzgt. 19, 0259 Oslo (Norway),
3. Anne Steen, residing at Arnulf Øverlandsvei 187, 0764 Oslo (Norway),
4. Arne Henning Ramstad, residing at Haugenlia 23, 2020 Skedsmokorset (Norway),
5. Arve Sogn Andersen, residing at Bjørnehiet 1, 0387 Oslo (Norway), 
6. Bente Svensson, residing at Kodalsveien 12, 1386 Asker (Norway),
7. Bjørn Boberg, residing at Jomfrubråtveien 29C, 0259 Oslo (Norway),
8. Bjørn Ivar Danielsen, residing at Snipermyrlia 6, 1273 Oslo (Norway),
9. Bjørn Tore Holte, residing at Buskogen 82,1675 Kråkerø (Norway),
10. Cato Willy Rindal, residing at Båtstøjordet 95, 1363 Høvik (Norway),
11. Christian Selmer, residing at Vågedalsstien 4e, 4002 Stavanger (Norway),
12. Eivind Gjemdal, residing at Lybekkveien 10e, 0772 Oslo (Norway),
13. Eivind Roald, residing at Sundbakken 7, 1394 Nesbru (Norway),
14. Erik Fjornes, residing at Bygdøy Allé 117a, 0273 Oslo (Norway),
15. Espen Simensen, residing at Bjerkehagevn. 22b, 1405 Langhus (Norway), 
16. Geir Bårdstu, residing at Amund Tvetensvei 81, 3944 Porsgrunn (Norway),
17. Gustav Heiberg, residing at Stovnerbakken 8E, 0980 Oslo (Norway),
18. Halvar Traa, residing at Skyttaveien 48, 1481 Hagan (Norway),
19. Hans Otto Hilsen, residing at Snarøyveien 101b, 1367 Snarøya (Norway),
20. Henning Normann, residing at Neptunveien 25R, 0493 Oslo (Norway),
21. Henrik Hansen, residing at Myrerskogvn. 19, 0495 Oslo (Norway),
22. Henrik Lund-Hanssen, residing at Øvre Nygård 6A, 1482 Nittedal (Norway),
23. Håkon Breda-Ruud, residing at Bj. Bjørnsonsvei 62, 1412 Sofiemyr (Norway),
24. Håkon Jacobsen, residing at Ekebergvn. 190p, 1162 Oslo (Norway), 
25. Idar Ytterdal, residing at Haugerkroken 9, 1352 Kolsås (Norway), 
26. Ingemar Karlsson, residing at Myrvollvn. 5, 1363 Høvik (Norway),
27. Jan Åge Rønnestad, residing at Høyfjellsåsen 6, 1315 Nesøya (Norway),
28. Joe Taralrud, residing at Nordjordet 1b, 1359 Eiksmarka (Norway),
29. Just Erik Naess, residing at Framnesveien 7, 1501 Moss (Norway),
30. Ketil Thorsen, residing at Vestre Greverud Terrasse 20, 1415 Oppegård (Norway),
31. Kim Zimmer, residing at Terrasseveien 36a, 1363 Høvik (Norway), 
32. Kjetil Gudmundsen, residing at Bjørndalsvn. 11b, 1476 Rasta (Norway),
33. Kristian Kvam, residing at Barnålvn. 12, 0198 Oslo (Norway), and 
34. Kristian Larsen, residing at Bølumkollen B, 3073 Galleberg (Norway),
35. Leif Arne Rones, Diakonveien 3, 0370 Oslo (Norway),
36. Martin Fuhr Bolstad, residing at Nadderudvn. 157, 1359 Eiksmarka (Norway),
37. Nils Øveraas, residing at Hiltonåsen 107, 1312 Slependen (Norway),
38. Olav Skjaeveland, residing at Øygardvn. 12b, 1357 Bekkestua (Norway),
39. Olav Storli Ulvund, residing at Hofftunet 15, 0379 Oslo (Norway),
40. Paul Arne Kristensen, residing at Olav Aukrustvei 11c, 0390 Oslo (Norway),
41. Per Erik Strømsø, residing at Bloksbergstien 1a, 1360 Nesbru (Norway),
42. Per Ingvald Fredriksen, residing at Stordamsnaret 48, 0671 Oslo (Norway),
43. Petter Hesselberg, residing at Diakonveien 3, 0370 Oslo (Norway),
44. Petter-Idar Jenssen, residing at Ekrekroken 41, 1356 Bekkestua (Norway),
45. Pål K. Fevang, residing at Strandvejen 348, DK-298 Kokkedal (Norway),
46. Randi Arneberg Solli, residing Capralhaugen 60, 1358 Jar (Norway),
47. Rolf Kragerud, residing at Slemdalsveien 81C, 0370 Oslo (Norway),
48. Roy Grønli, residing at Anna Hagmannsgt. 7m, 1511 Moss (Norway), 
49. Sam Juul, residing at Strømstangvn. 16, 1367 Snarøya (Norway),
50. Sigurd Fristad, residing at Jansveien 16, 1354 Baerums Verk (Norway), 
51. Sigurd Skjaeveland, residing at Åsengvn. 29, 1312 Slependen (Norway),
52. Stein Erik Moe, residing at Tjernåslia 10b, 1315 Nesøya (Norway),
53. Svein Olsen, residing at Åsbyfaret 127, 1392 Vettre (Norway),
54. Sverre Ruth, residing at Hundsundvn 3, 1367 Snarøya (Norway),
55. Thorleif Paus, residing at Rådyrfaret 14, 1362 Hosle (Norway),
56. Thron Ivar Berg, residing at Snaret 23a, 1359 Eiksmarka (Norway),
57. Tor Hauge, residing at Øvre Goslia 5, 1350 Lommedalen (Norway), 
58. Tor Krattebøl, residing at Øvre Goslia 5, 1350 Lommedalen (Norway),

27075

59. Tor Mesøy, residing at Storengveien 63A, 1368 Stabekk (Norway), 
60. Tore Alm, residing at Kirkeveien 147E, 0361 Oslo (Norway),
61. Tore Magnussen, residing at Jerpefaret 4b, 0393 Oslo (Norway),
62. Torunn Brandt, residing at Veita 5, 0880 Oslo (Norway),
63. Trond Berntsen, residing at Bestumvn. 46, 0281 Oslo (Norway),
64. Trond Moberg, residing at Trudvangveien 2, 1358 Jar (Norway),
65. Trygve Langholm, residing at Ekebergveien 273B, 1166 Oslo (Norway),
66. Witold Sitek, residing at Båtstøjordet 17, 1363 Høvik (Norway),
67. Øystein Wiborg, residing at Bølerveien 21, 0690 Oslo (Norway), and
68. Øyvind Stangeby, residing at Arnulf Øverlandsvei 187, 0764 Oslo (Norway),
and
69. ACCENTURE MINORITY III, LTD, incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63

Line Wallroad, PO Box 199, Gibraltar.

Each of the appearing parties, as listed hereabove from 1) to 69), is hereby represented by Jean-François Bouchoms,

lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in on May 23, 2001.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall re-

main attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to record the fol-

lowing articles of incorporation (hereafter the «Articles») of a company which they declare to establish as follows:

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Form 
There exists among ACCENTURE MINORITY III, LTD, incorporated under the laws of Gibraltar and having its cur-

rent registered office at 57/63 Line Wallroad, PO Box 199, Gibraltar, being the general partner (gérant commandité)
(the «General Partner») of the Company, and the current limited partners (associés commanditaires) of the Company
and all those persons or entities who may become limited partners (associés commanditaires) of the Company in the
future a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of ACCENTURE MINORITY
III NORWAY 1 SCA (hereinafter referred to as the «Company»).

Hereinafter the limited partners and the General Partner will be referred to, where the context so requires, individ-

ually as a «Shareholder» and collectively as the «Shareholders».

Art. 2. Term 
The Company is incorporated for an unlimited period of time. However, the Company shall come to an end, by an-

ticipation, in the event of the occurrence of the first of the following events: (i) the resignation, dissolution or bankruptcy
or insolvency of the General Partner or (ii) a resolution to dissolve the Company adopted at the a meeting of Share-
holders deciding in compliance with the conditions of quorum and majority required for amendments to the Articles of
Association.

Art. 3. Purposes
The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, admin-
istration, development and management of its participations and of its asset portfolio. 

The Company may carry on any commercial, industrial and financial activity or maintain a commercial establishment

open to the public. The Company may participate directly and/or indirectly in the establishment and development of
any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and it may render them every assistance,
whether of a financial nature or not, such as, without limitation, the granting of loans or advances, guarantees for their
benefit or other forms of assistance. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and
notes whether or not convertible or exchangeable in shares of the Company or into shares of other companies.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

for the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or

other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the General Partner.

In the event that the General Partner determines that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent that interfere or are likely to interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg partnership limited by shares.

Art. 5. Capital 
5.1 The subscribed and issued capital of the Company is set at EUR 5,308,748.75 (five million three hundred and eight

thousand seven hundred and forty-eight Euros and seventy-five cents) divided into 4,246,989 (four million two hundred
and forty-six thousand nine hundred and eighty-nine) limited shares with a par value of one Euro and twenty-five cents
(EUR 1.25) each held by the limited partners (the «Limited Shares») (Actions de Commanditaires) and 10 (ten) unlimited
shares held by the General Partner (the «Unlimited Shares») (Actions de Commandités) with a par value of one Euro
and twenty-five cents (EUR 1.25) each.

27076

The issued capital of the Company may be increased or reduced by a decision of a meeting of Shareholders deliber-

ating in the manner provided for amendments to the Articles of Association.

The General Partner’s Shares and the Limited Shares will be individually referred to as a 'Share' and collectively as

the «Shares». 

5.2 The Shares are issued as redeemable shares to which the terms of article 49-8 of the Luxembourg Companies’

Act dated August 10, 1915, as amended (the «Law») shall apply.

Art. 6. Shares
6.1 The Company recognises only one holder per Share; in case a Share is held by more than one person, the Com-

pany has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed or
designated by the joint holders as the sole owner in relation to the Company.

6.2 The Limited Shares and the General Partner’s Shares of the Company are and they continue to stay in registered

form. The Shares are not certificated but a certificate (certificat d’inscription nominative) witnessing the registration of
the relevant Shareholder in the share register of the Company and the number of Shares held by him/it shall be issued
by the Company on request of the Shareholder.

6.3 A share register shall be kept at the registered office of the Company and, to the extent the General Partner shall

so decide, with a transfer agent and registrar. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers.

6.4 Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding Shares may be called at any time at the discretion of the General

Partner, provided however that calls shall be made on all the Shares in the same proportion and at the same time. Any
sum, the payment of which is in arrear, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten per
cent per year calculated from the date when the payment was due until the date of the actual payment.

6.5 The transfer of the shares is subject to a right of first refusal to be exercised by the other Shareholders pro rata

to their shareholding in the Company.

Art. 7. Redemption of Shares 
The Company is authorised to redeem its shares within the limits and conditions set by article 49-8 of the Law. A

redemption of Shares must be approved by a resolution at a meeting of Shareholders passed by a two thirds majority
of the Shares represented at the meeting including the consent of the General Partner.

Art. 8. Liability of Shareholders 
The holders of Limited Shares are only liable up to the amount of their capital contribution made to the Company.
The General Partner’s liability shall be unlimited.

Art. 9. Meetings of Shareholders
The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the fifth day of November at 10.00 a.m. If such day is a bank holiday in the city of Luxembourg, the annual general
meeting shall be held on the next following Luxembourg business day.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

All meetings of Shareholders shall be chaired by the General Partner.

Art. 10. Notice, quorum, proxies, majority 
The notice periods and quorum rules required by the Law shall apply with respect to the meetings of Shareholders

of the Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.

Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another per-

son, whether a Shareholder or not, as his proxy in writing whether in original or by telefax, cable, telegram or telex. 

Except as otherwise required by the Law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders

will be passed by a simple majority of those present and voting with the consent of the General Partner.

Art. 11. Convening notice
Shareholders’ meetings shall be convened by the General Partner or by the Supervisory Board, pursuant to a notice

setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the
Shareholder’s address on record in the share register of the Company or by a publication in the Luxembourg press and
in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial).

If all the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The General Partner may determine all reasonable conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to par-

ticipate in any meeting of Shareholders.

Art. 12. Powers of the meeting of Shareholders 
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders

of the Company. It may only resolve on any item generally whatsoever only with the consent of the General Partner. 

Art. 13. Management 
The Company shall be managed by the General Partner who shall be the liable partner (associé - gérant - commandité)

and who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of
the assets of the Company.

27077

The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Company’s interest which are not expressly reserved by the Law or by these Articles of Association to the meeting of
Shareholders or to the Supervisory Board.

The General Partner shall, subject to the terms of Article 16 hereof, namely have the power on behalf and in the

name of the Company to carry out any and all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into
and perform all contracts and other undertakings that it may deem necessary, advisable or useful or incidental thereto.
Except as otherwise expressly provided, the General Partner shall have, and shall have full authority in its discretion to
exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the
purposes of the Company.

Art. 14. Authorised signature
The Company shall be bound by the corporate signature of the General Partner or by the individual or joint signa-

tures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the General Partner
shall determine in its discretion.

Art. 15. No remuneration of General Partner
The General Partner and the members or employees of the General Partner shall receive no remuneration from the

Company for their duties.

Art. 16. Supervisory Board 
The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised

by a supervisory board composed of at least three members (herein referred to as the «Supervisory Board»).

The Supervisory Board shall be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may de-

termine and it shall authorise any actions of the General Partner that may, pursuant to the Law or under these Articles
of Association, exceed the powers of the General Partner.

The members of the Supervisory Board may be Shareholders, other than the General Partner, or not. The members

of the Supervisory Board are appointed by a simple majority vote of the meeting of Shareholders for a maximum term
of six years, which shall be renewable. The members of the Supervisory Boards may be dismissed at any time and at the
sole discretion of the meeting of Shareholders.

Retiring members of the Supervisory Board are eligible for re-election.
In the event of a vacancy on the Supervisory Board because of death, retirement or otherwise, the remaining mem-

bers of the Supervisory Boards may meet and may elect by a majority vote a member of the Supervisory Board to fill
such vacancy until the next meeting of Shareholders.

If the majority of the members of the Supervisory Boards vacates the office a meeting of the Shareholders shall be

convened in order to appoint a new Supervisory Board.

The general meeting of Shareholders shall determine the remuneration of the Supervisory Board.
The Supervisory Board shall be convened by its chairman (appointed by the Supervisory Board from amongst its

members) or by the General Partner.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board with

at least eight days prior notice, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing, whether in original
or by cable, telegram, telefax or telex of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board. If all the
members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of Supervisory Board, and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing, whether in original or by cable,

telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-

sented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such
meeting. Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members.

Art. 17. Minutes of the Supervisory Board 
The minutes of a meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore or by two members of the Super-
visory Board.

Art. 18. Accounting year - Accounts 
The accounting year of the Company shall begin on September 1 and it shall terminate on August 31 of each year.
The accounts of the Company shall be stated in Euro.
The accounts of the Company shall be audited by an external auditor who shall be appointed for a term to be deter-

mined from time to time by a simple majority vote of the general meeting of the Shareholders.

Art. 19. Allocation of profits 
From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve as required by

the Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the
nominal issued share capital of the Company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.

The Shareholders of the Company shall have equal dividend rights on a per share basis.
The General Partner shall determine how the annual net profits shall be disposed of and it shall decide to pay divi-

dends from time to time, as it, in its discretion, believes to suit best the corporate purpose and policy of the Company.

27078

The general meeting of Shareholders shall have to approve the General Partner’s decision to pay dividends as well as
the profit allocation proposed by the General Partner.

The dividends may be paid in Euro or in any other currency determined by the General Partner and they may be paid

at such places and times as shall be determined by the General Partner.

The General Partner may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the

Law.

Art. 20. Dissolution and liquidation
The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the meeting of Shareholders with the consent of the

General Partner or upon the occurrence of one of the events indicated in Article 2 above.

The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)

named, by the meeting of Shareholders which shall also determine their powers and their remuneration.

Art. 21. Amendments 
These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quo-

rum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to the consent of the General Partner.

Art. 22. Applicable law 
All matters not governed by these Articles of Association shall be determined by application of the provisions of Lux-

embourg law, and, in particular, of the Law.

<i>Subscription

The appearing parties hereby declare to subscribe to the 4,246,999 shares issued by the Company as follows:
- ACCENTURE MINORITY III LTD, subscribes to 10 unlimited shares, and pays them up by a contribution in cash

of an aggregate amount of EUR 12.5;

and
- the other appearing parties subscribe to 4,246,989 limited shares (as detailed hereafter) and pay them up by way of

a contribution in kind, namely:  

Name of Contributor

Number of

Interests in NOK per

Aggregate nominal

Limited Shares

Class of Interests

value of the limited

subscribed

held in Accenture

shares subscribed in

ANS to be

EUR

contributed

35 Anne Cecilie Fagerlie  . . . . . . . . . . . . . . . .

 55,236

 177,901

69,045

35 Anne Foss Abrahamsem . . . . . . . . . . . . . .

38,990

125,577

48,737.5

35 Anne Steen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501,50

195

35 Arne Henning Ramstad . . . . . . . . . . . . . . .

38,990

125,577

48,737.5

35 Arve Sogn Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . .

 296,766

955,810

370,957.5

35 Bente Svensson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 32,492

104,649

40,615

35 Bjørn Boberg   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

35 Bjørn Ivar Danielsen  . . . . . . . . . . . . . . . . .

305,559

984,130

 381,948.8

35 Bjørn Tore Holte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

35 Cato Willy Rindal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

35 Christian Selmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32,492

 104,649

40,615

35 Eivind Gjemdal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

1. Eivind Roald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,990

125,577

48,737.5

2. Erik Fjornes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,990

125,577

48,737.5

3. Espen Simensen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

4. Geir Bårdstu   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

5. Gustav Heiberg   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

6. Halvar Traa   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

7. Hans Otto Hilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

8. Henning Normann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 156

501.50

195

9. Henrik Hansen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 229,799

740,126

287,248.8

10. Henrik Lund-Hanssen   . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

11. Håkon Breda-Ruud   . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

12. Håkon Jacobsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42,239

136,041

52,798.75

13. Idar Ytterdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 48,737

156,970

 60,921.25

14. Ingemar Karlsson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48,737

156,970

60,921.25

15. Jan Åge Rønnestad . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 294,180

947,481

367,725

16. Joe Taralrud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

 195

17. Just Erik Naess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239,292

 770,700

299,115

18. Ketil Thorsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 156

501.50

195

19. Kim Zimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 289,164

931,326

361,455

20. Kjetil Gudmundsen   . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

27079

The total contribution made to the Company of the Subsidiary’s Interests is to be recorded in accordance with the

valuation of the management and to be allocated in an amount of EUR 5,308,736.50 to the nominal share capital account
of the Company.

The above contribution in cash has been hereby certified to the undersigned notary by a certificate of Bank of Amer-

ica dated May 23, 2001 and the above contribution in kind has been hereby certified to the undersigned notary by a
valuation report issued for the purpose of article 26-1 of the Law by FIDUCIAIRE BILLON, Réviseur d’entreprises, dated
May 23, 2001, the conclusion of which reads as follows:

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the

contribution, which consists in a total number of 13,678,464 «interests» held in Accenture ANS, a Norwegian partner-
ship, and the contribution of which «interests» are at least equal to the nominal value of the shares to be issued.»

It results furthermore from a certificate dated May 23, 2001, issued by the Managing Director (or equivalent) of Ac-

centure ANS (the «Subsidiary») that:

«I, Bjørn Ivar Danielsen, being a Director (or equivalent) of the Subsidiary hereby certify that as at the date hereof

and based on my review of the Subsidiary’s records (to the exclusion of any other documents):

1. on April 18th 2001 I have been granted powers of attorney by the interestholders of the Subsidiary to act on their

behalf;

2. the Interests contributed by the Interests’ holders of the Subsidiary represent approximately half of the Subsidiary’s

paid in capital, and that the Interests are proportionnate to the number of shares issued to the partners as consideration.

3. the Interests are in registered form;
4. the Interests are fully paid-up;
5. the interestholders are solely entitled to the Interests and have the power to dispose of the Interests;
6. none of the Interests is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no right to

acquire any pledge or usufruct on the Interests and none of the Interests are subject to any attachment;

7. there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Interests be transferred to him;

21. Kristian Kvam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 239,292

770,700

 299,115

22. Kristian Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42,239

136,042

 52,798.75

23. Leif Arne Rones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

 501.50

195

24. Martin Fuhr Bolstad . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 86,644

279,059

 108,305

25. Nils Øveraas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

243,342

 783,743

 304,177.5

26. Olav Skjaeveland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

 195

27. Olav Storli Ulvund   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 156

501.50

195

28. Paul Arne Kristensen   . . . . . . . . . . . . . . . 

 156

501.50

195

29. Per Erik Strømsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

282,037

908,371

352,546.3

30. Per Ingvald Fredriksen . . . . . . . . . . . . . . . 

156

 501.50

195

31. Petter Hesselberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

32. Petter-Idar Jenssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

 195

33. Pål K. Fevang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

243,829

785,313

304,786.3

34. Randi Arneberg Solli  . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

35. Rolf Kragerud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

36. Roy Grønli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38,990

 125,577

48,737.5

37. Sam Juul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

321,088

1,034,145

401,360

38. Sigurd Fristad   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

 501.50

195

39. Sigurd Skjaeveland . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55,236

 177,901

69,045

40. Stein Erik Moe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42,239

136,041

52,798.75

41. Svein Olsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

 195

42. Sverre Ruth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

246,065

 792,514

 307,581.3

43. Thorleif Paus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

 501.50

195

44. Thron Ivar Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

 195

45. Tor Hauge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

46. Tor Krattebøl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38,990

125,577

48,737.5

47. Tor Mesøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42,239

136,041

52,798.75

48. Tore Alm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 156

501.50

 195

49. Tore Magnussen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209,344

 674,245

261,680

50. Torunn Brandt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

 501.50

195

51. Trond Berntsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

 195

52. Trond Moberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

53. Trygve Langholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

54. Witold Sitek   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38,990

501.50

48,737.5

55. Øystein Wiborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 156

501.50

195

56. Øyvind Stangeby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4,246,989

13,552,885.50

 5,308,736.50

27080

8. according to the law of Norway and the partnership agreement of the Subsidiary, the Interests are freely transfer-

able provided that all partners give their approval, and such approval has been given in form of a unanimous vote in a
meeting of all partners; and

9. all formalities required in Norway subsequent to the contribution in kind of the Interests of the Subsidiary to the

incorporation of ACCENTURE MINORITY NORWAY 1 SCA have been or will be effected upon receipt of a certified
copy of the notarial deed from the notary officiating in Luxembourg, documenting the said contribution in kind;»

The said certificate and valuation report, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing

party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Transitional provisions

The first business year begins today and ends on August 31, 2001. The first annual meeting will be held on November

5, 2001.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the law of 10th August, 1915

as amended on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The approximate amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to

the company as a result of its formation, is approximately evaluated at two million three hundred thousand francs.

<i>Extraordinary General Meeting of Shareholders

The appearing parties, representing the entirety of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders and having stated that the Meeting
is regularly constituted, have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of the members of the Supervisory Board is set at three and that of the statutory auditor at one.
2. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board of the Company:
- Michael L. Emmons, attorney-at-law, residing at 15 Vida Descanda, Orinda 94563, California, U.S.A.;
- Vernon J. Ellis, consultant, residing at Chester Row 44, London SWI W8JP, United Kingdom;
- Michael G. McGrath, company director, residing at Adobe Lane, Los Altos Hill 25440, 94022 California, U.S.A.
3. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office at 400, route d’Esch in L-1471 Luxembourg is appoint-

ed as statutory auditor of the Company.

4. The Company’s registered office shall be at 58, rue Charles Martel, in L-2134 Luxembourg.
5. The term of office of the members of the Supervisory Board of the Company shall end at the Annual General Meet-

ing to be held in 2002.

6. The term of office of the statutory auditor shall end at the Annual General Meeting to be held 2002.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing
persons in case of divergences between English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède: 

L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Sont apparus:

1. Anne Cecilie Fagerlie, demeurant à Sofies Plass 2, 0169 Oslo (Norway),
2. Anne Foss Abrahamsen, demeurant à President Harbitzgt. 19, 0259 Oslo (Norway),
3. Anne Steen, demeurant à Arnulf Øverlandsvei 187, 0764 Oslo (Norway),
4. Arne Henning Ramstad, demeurant à Haugenlia 23, 2020 Skedsmokorset (Norway),
5. Arve Sogn Andersen, demeurant à Bjørnehiet 1, 0387 Oslo (Norway),
6. Bente Svensson, demeurant à Kodalsveien 12, 1386 Asker (Norway), 
7. Bjørn Boberg, demeurant à Jomfrubråtveien 29C, 0259 Oslo (Norway),
8. Bjørn Ivar Danielsen, demeurant à Snipermyrlia 6, 1273 Oslo (Norway),
9. Bjørn Tore Holte, demeurant à Buskogen 82,1675 Kråkerø (Norway),
10. Cato Willy Rindal, demeurant à Båtstøjordet 95, 1363 Høvik (Norway),
11. Christian Selmer, demeurant à Vågedalsstien 4e, 4002 Stavanger (Norway),
12. Eivind Gjemdal, demeurant à Lybekkveien 10e, 0772 Oslo (Norway), 
13. Eivind Roald, demeurant à Sundbakken 7, 1394 Nesbru (Norway),
14. Erik Fjornes, demeurant à Bygdøy Allé 117a, 0273 Oslo (Norway),
15. Espen Simensen, demeurant à Bjerkehagevn 22b, 1405 Langhus (Norway),
16. Geir Bårdstu, demeurant à Amund Tvetensvei 81, 3944 Porsgrunn (Norway),
17. Gustav Heiberg, demeurant à Stovnerbakken 8E, 0980 Oslo (Norway),
18. Halvar Traa, demeurant à Skyttaveien 48, 1481 Hagan (Norway),
19. Hans Otto Hilsen, demeurant à Snarøyveien 101b, 1367 Snarøya (Norway),
20. Henning Normann, demeurant à Neptunveien 25R, 0493 Oslo (Norway),
21. Henrik Hansen, demeurant à Myrerskogvn. 19, 0495 Oslo (Norway), 

27081

22. Henrik Lund-Hanssen, demeurant à Øvre Nygård 6A, 1482 Nittedal (Norway),
23. Håkon Breda-Ruud, demeurant à Bj. Bjørnsonsvei 62, 1412 Sofiemyr (Norway),
24. Håkon Jacobsen, demeurant à Ekebergvn. 190p, 1162 Oslo (Norway),
25. Idar Ytterdal, demeurant à Haugerkroken 9, 1352 Kolsås (Norway),
26. Ingemar Karlsson, demeurant à Myrvollvn. 5, 1363 Høvik (Norway),
27. Jan Åge Rønnestad, demeurant à Høyfjellsåsen 6, 1315 Nesøya (Norway),
28. Joe Taralrud, demeurant à Nordjordet 1b, 1359 Eiksmarka (Norway),
29. Just Erik Naess, demeurant à Framnesveien 7, 1501 Moss (Norway), 
30. Ketil Thorsen, demeurant à Vestre Greverud Terrasse 20, 1415 Oppegård (Norway),
31. Kim Zimmer, demeurant à Terrasseveien 36a, 1363 Høvik (Norway),
32. Kjetil Gudmundsen, demeurant à Bjørndalsvn. 11b, 1476 Rasta (Norway),
33. Kristian Kvam, demeurant à Barnålvn. 12, 0198 Oslo (Norway), and
34. Kristian Larsen, demeurant à Bølumkollen B, 3073 Galleberg (Norway),
35. Leif Arne Rones, Diakonveien 3, 0370 Oslo (Norway),
36. Martin Fuhr Bolstad, demeurant à Nadderudvn. 157, 1359 Eiksmarka (Norway),
37. Nils Øveraas, demeurant à Hiltonåsen 107, 1312 Slependen (Norway),
38. Olav Skjaeveland, demeurant à Øygardvn. 12b, 1357 Bekkestua (Norway),
39. Olav Storli Ulvund, demeurant à Hofftunet 15, 0379 Oslo (Norway),
40. Paul Arne Kristensen, demeurant à Olav Aukrustvei 11c, 0390 Oslo (Norway),
41. Per Erik Strømsø, demeurant à Bloksbergstien 1a, 1360 Nesbru (Norway),
42. Per Ingvald Fredriksen, demeurant à Stordamsnaret 48, 0671 Oslo (Norway),
43. Petter Hesselberg, demeurant à Diakonveien 3, 0370 Oslo (Norway),
44. Petter-Idar Jenssen, demeurant à Ekrekroken 41, 1356 Bekkestua (Norway),
45. Pål K. Fevang, demeurant à Strandvejen 348, DK-298 Kokkedal (Norway),
46. Randi Arneberg Solli, demeurant à Capralhaugen 60, 1358 Jar (Norway),
47. Rolf Kragerud, demeurant à Slemdalsveien 81C, 0370 Oslo (Norway),
48. Roy Grønli, demeurant à Anna Hagmannsgt. 7m, 1511 Moss (Norway),
49. Sam Juul, demeurant à Strømstangvn. 16, 1367 Snarøya (Norway),
50. Sigurd Fristad, demeurant à Jansveien 16, 1354 Baerums Verk (Norway),
51. Sigurd Skjaeveland, demeurant à Åsengvn. 29, 1312 Slependen (Norway),
52. Stein Erik Moe, demeurant à Tjernåslia 10b, 1315 Nesøya (Norway),
53. Svein Olsen, demeurant à Åsbyfaret 127, 1392 Vettre (Norway),
54. Sverre Ruth, demeurant à Hundsundvn 3, 1367 Snarøya (Norway),
55. Thorleif Paus, demeurant à Rådyrfaret 14, 1362 Hosle (Norway),
56. Thron Ivar Berg, demeurant à Snaret 23a, 1359 Eiksmarka (Norway),
57. Tor Hauge, demeurant à Øvre Goslia 5, 1350 Lommedalen (Norway),
58. Tor Krattebøl, demeurant à Øvre Goslia 5, 1350 Lommedalen (Norway),
59. Tor Mesøy, demeurant à Storengveien 63A, 1368 Stabekk (Norway),
60. Tore Alm, demeurant à Kirkeveien 147E, 0361 Oslo (Norway),
61. Tore Magnussen, demeurant à Jerpefaret 4b, 0393 Oslo (Norway), 
62. Torunn Brandt, demeurant à Veita 5, 0880 Oslo (Norway),
63. Trond Berntsen, demeurant à Bestumvn. 46, 0281 Oslo (Norway),
64. Trond Moberg, demeurant à Trudvangveien 2, 1358 Jar (Norway),
65. Trygve Langholm, demeurant à Ekebergveien 273B, 1166 Oslo (Norway),
66. Witold Sitek, demeurant à Båtstøjordet 17, 1363 Høvik (Norway),
67. Øystein Wiborg, demeurant à Bølerveien 21, 0690 Oslo (Norway), and
68. Øyvind Stangeby, demeurant à Arnulf Øverlandsvei 187, 0764 Oslo (Norway),
et
69. ACCENTURE MINORITY III, LTD, constituée sous le droit de l’Etat de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63

Line Wallroad, PO Box 199, Gibraltar.

Chacune des parties comparantes, énumérées ci-dessus sous les numéros 1) à 69), sont représentées par Jean-Fran-

çois Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée le 23 mai 2001.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le no-

taire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, ès-qualité en vertu de laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter

les statuts (ci-après les «Statuts») d’une société qu’ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination sociale - Siège social - Durée - Objet 

Art. 1

er

. Forme juridique 

Il est établi entre ACCENTURE MINORITY III, LTD, constituée en vertu du droit de Gibraltar et ayant son siège

social à 57/63 Line Wallroad, PO Box 199, Gibraltar, le gérant commandité («Gérant Commandité») et les associés
commanditaires actuels de la Société et toutes les personnes (physiques ou morales) qui deviendront dans le futur des
associés commanditaires de la société, il est formé ACCENTURE SCA, une société en commandite par actions (ci-après
dénommée la «Société»).

Ci-après, les associés commanditaires et le Gérant Commandité seront chacun dénommé un Actionnaire et ensemble

des Actionnaires.

27082

Art. 2. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée. Toutefois, la Société prendra fin, par anticipation, dans le cas où

surviendrait le premier des événements suivants: (i) la démission, dissolution ou la faillite ou carence du Gérant Com-
mandité ou (ii) une décision de dissoudre la Société adoptée par l’assemblée des Actionnaires délibérant conformément
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications des Statuts.

Art. 3. Objet 
L’objet de la société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que la cession par
voie de vente, d’échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de billets et autres valeurs mobilières de
toute nature, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de ses participations et de son portefeuille
d’actifs.

La société peut exercer toute activité commerciale, financière ou industrielle ou conserver un établissement com-

mercial ouvert au public. La société peut participer directement ou indirectement à l’établissement et au développement
de toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales au Luxembourg et à l’étranger et peut leur prêter toute
assistance, de nature financière ou non, comme notamment l’octroi de prêts ou d’avances, de garanties à leur avantage
ou toute autre forme d’assistance. La société peut emprunter sous toute forme et peut procéder à l’émission d’obliga-
tions et de billets, qu’ils soient ou non convertibles ou échangeables contre des actions de la société ou des actions de
toutes autres sociétés.

De manière générale, elle peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et exercer toute opération

qu’elle peut juger utile à la réalisation et au développement de ses objets.

Art. 4. Siège Social
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg. Des succursales ou autres

implantations peuvent être établies soit au Luxembourg soit à l’étranger sur décision du Gérant Commandité.

Dans le cas où le Gérant Commandité décide que des circonstances politiques, économiques ou sociales exception-

nelles, déclarées ou imminentes, entravent ou sont susceptibles d’entraver les activités normales de la Société dans les
locaux de son siège social, de perturber les communications entre ledit siège social et les personnes se trouvant à
l’étranger, le siège social peut être momentanément transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circons-
tances exceptionnelles; ce type de mesure provisoire n’affectera pas la nationalité de la Société qui, nonobstant le trans-
fert provisoire de son siège social, demeurera une société en commandite par actions luxembourgeoise.

Art. 5. Capital 
5.1 Le capital souscrit et émis de la Société est fixé à EUR 5.308.748,75 (cinq millions trois cent huit mille sept cent

quarante-huit Euros et soixante-quinze cents), réparti en 4.246.989 (quatre millions deux cent quarante-six mille neuf
cent quatre-vingt-neuf) actions de commanditares ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25)
chacune, détenues par les Associés Commanditaire(s) («Actions de Commanditaires») et 10 (dix) actions de comman-
dité détenues par le Gérant Commandité («Actions de Commandité») ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-
cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Le capital émis par la Société peut faire l’objet d’augmentations ou de réductions sur décision d’une assemblée des

Actionnaires selon le mode de délibération requis en cas de modification des Statuts.

Les actions de Commandité et les Actions de Commanditaires seront désignées individuellement par l’«Action» et

collectivement par les «Actions».

5.2 Les Actions sont émises en tant qu’actions rachetables par la Société auxquelles s’appliquent les dispositions de

l’article 49-8 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 6. Actions
6.1 La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par Action; dans le cas où une Action est détenue par plus d’une

personne, la Société se réserve le droit de suspendre l’exercice de l’ensemble des droits attachés à cette Action jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée par la communauté des détenteurs de l’Action comme son propriétaire ex-
clusif devant la Société.

6.2 Les Actions de Commanditaires et les Actions de Commandités de la Société sont et resteront des actions no-

minatives. Les Actions ne sont pas matérialisées par un certificat mais la Société émettra, à la demande de l’Actionnaire,
un certificat d’inscription nominatif attestant de l’inscription au registre des actionnaires de l’Actionnaire concerné ainsi
que du nombre d’Actions par lui détenu.

6.3 Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société et, dans la mesure où le Gérant Commandité

le décidera, par un agent chargé de la tenue des registres. Ledit registre fera mention du nom de chaque Actionnaire,
de son lieu de résidence ou domicile élu, du nombre d’actions qu’il détient, du montant de l’apport versé pour chaque
action, ainsi que des cessions d’actions et des dates desdites cessions.

6.4 Les éventuels montants non libérés au titre des Actions émises et en circulation peuvent être appelés à tout mo-

ment et ce, à l’appréciation du Gérant Commandité, à la condition cependant que les appels de fonds soient effectués
sur l’ensemble des Actions, dans la même proportion et au même moment. Toute somme dont le payement est effectué
avec retard génère automatiquement des intérêts de retard en faveur de la Société au taux de dix pour cent l’an, calculés
à partir de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’à la date du payement effectif de la somme due.

6.5 La cession d’actions est soumise à l’exercice du droit de premier refus devant être exercé by les autre Action-

naires au pro rata de leurs actions dans la Société.

27083

Art. 7. Rachat d’actions 
La Société est autorisée à procéder au rachat de ses propres actions dans les limites et conditions fixées par l’Article

49-8 de la Loi. Le rachat d’Actions doit être approuvé par une résolution de l’assemblée des Actionnaires adoptée à une
majorité des deux tiers des Actions représentées lors de l’assemblée, et doit recueillir le consentement du Gérant Com-
mandité.

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires 
Les propriétaires d’Actions de Commanditaires sont responsables uniquement à hauteur de leur apport au capital de

la Société.

La responsabilité du Gérant Commandité est illimitée.

Art. 9. Assemblées des Actionnaires 
L’assemblée générale annuelle des Actionnaires aura lieu, conformément à la législation en vigueur au Luxembourg,

au siège social de la Société à Luxembourg, ou en un autre endroit au Luxembourg qui sera indiqué dans la lettre de
convocation, le 5 novembre 2001 à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié pour la ville de Luxembourg, l’assemblée
générale annuelle se tiendra le jour ouvré suivant.

D’autres assemblées des Actionnaires peuvent être tenues aux lieux, dates et heures qui seront indiqués dans les

lettres de convocation respectives auxdites assemblées.

Toutes les assemblées des Actionnaires seront présidées par le Gérant Commandité.

Art. 10. Avis de convocation, quorum, représentation, majorité 
Les périodes des avis de convocation et les règles de quorum exigés par la loi s’appliquent aux assemblées des ac-

tionnaires de la société, ainsi qu’à la tenue de ces assemblées, sauf disposition contraire des présentes.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une

autre personne par écrit (sous la forme d’un original, ou par télécopie, câble, télégramme ou télex) que cette personne
soit ou non un actionnaire, pour être son représentant.

Sauf disposition contraire de la Loi ou disposition stipulation contraires des présents Statuts, les résolutions d’une

assemblée des actionnaires seront adoptées à la majorité simple des actions représentées et votant à l’assemblée, et
avec l’accord du Gérant Commandité.

Art. 11. Avis de convocation
Les Assemblées des Actionnaires seront convoquées par le Gérant Commandité ou par le Conseil de Surveillance,

sous la forme d’un avis indiquant l’ordre du jour et envoyé par courrier recommandé au moins huit jours avant la date
fixée pour l’Assemblée à chaque Actionnaire, à l’adresse figurant au registre des actionnaires de la Société ou par voie
d’annonce dans la presse luxembourgeoise et dans le Mémorial.

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des Actionnaires et s’ils déclarent avoir

été informés de l’ordre du jour de la réunion, l’assemblée peut avoir lieu sans avis de convocation préalable. 

Le Gérant Commandité peut déterminer les conditions légitimes auxquelles doivent se conformer les Actionnaires

afin de pouvoir prendre part à toutes les assemblées d’Actionnaires.

Art. 12. Pouvoirs de l’assemblée des Actionnaires 
Toute Assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente la totalité de la masse des Ac-

tionnaires de la Société. Elle ne peut généralement adopter des résolutions sur quelque point que ce soit qu’avec le
consentement du Gérant Commandité. 

Art. 13. Gestion 
La Société sera gérée par le Gérant Commandité qui sera le gérant associé responsable et qui sera donc personnel-

lement, conjointement et individuellement responsable au nom de la Société de tout passif auquel l’actif de la Société
ne permettra pas de faire face.

Le Gérant Commandité est investi des pouvoirs les plus étendus qui lui permettent d’effectuer tous les actes d’admi-

nistration et de décision dans l’intérêt de la Société et qui ne sont pas expressément réservés, d’après la Loi ou d’après
les présents Statuts, à l’assemblée des Actionnaires ou au Conseil de Surveillance.

Le Gérant Commandité aura notamment, sous réserve des dispositions de l’Article 16 ci-dessous, le pouvoir, au nom

et pour le compte de la Société, de mener à bien toutes les missions, d’exécuter tous les actes, de conclure et d’exécuter
tous les contrats et autres opérations réputés nécessaires, opportuns, utiles ou accessoires à cet effet. Sauf dispositions
expresses contraires, le Gérant Commandité aura, et aura tout pouvoir d’exercer selon sa propre appréciation, tous
les droits et pouvoirs nécessaires ou opportuns pour mener à bien les objectifs de la Société.

Art. 14. Signataires autorisés 
La Société sera engagée par la signature du Gérant Commandité ou encore par la signature individuelle ou les signa-

tures conjointes et solidaires des autres personnes auxquelles le Gérant Commandité aura délégué le pouvoir de signa-
ture. Le Gérant Commandité prendra cette décision selon sa propre appréciation.

Art. 15. Non rémunération du Gérant Commandité 
Le Gérant Commandité ainsi que les membres ou les salariés de l’entité désignée comme tel ne recevront aucune

rémunération de la part de la Société en contrepartie des tâches effectuées.

Art. 16. Conseil de Surveillance 
Les affaires internes de la Société ainsi que sa situation financière et en particulier ses registres et livres comptables

seront contrôlés par un comité de surveillance composé d’au moins trois membres (désigné dans le présent document
par le «Conseil de Surveillance»).

27084

Le Conseil de Surveillance sera consulté sur certains points par le Gérant Commandité en tant que de besoin et ainsi

que ce dernier en aura décidé. Le Conseil de Surveillance autorisera le Gérant Commandité à engager toutes les actions
qui, selon la Loi ou en vertu des présents Statuts, outrepassent les pouvoirs du Gérant associé.

Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être ou non des Actionnaires, autre que le Gérant Commandité.

Les membres du Conseil de Surveillance sont désignés par un vote à la majorité relative de l’assemblée des Actionnaires,
pour une période maximale de six ans renouvelable. Les membres du Conseil de Surveillance sont susceptibles d’être
démis de leurs fonctions à tout moment et à la seule discrétion de l’assemblée des Actionnaires.

Les membres sortants du Conseil de Surveillance sont rééligibles.
Dans l’éventualité où un siège au Conseil de Surveillance se trouverait vacant pour cause de décès, de départ à la

retraite ou pour toute autre raison, les membres restants du Conseil de Surveillance peuvent se réunir et élire par un
vote à la majorité un nouveau membre afin de pourvoir le siège vacant jusqu’à la prochaine assemblée des Actionnaires.

Si la majorité des membres du Conseil de Surveillance abandonne la charge, une assemblée des Actionnaires sera

convoquée afin de mettre en place un nouveau Conseil de Surveillance.

L’assemblée des Actionnaires fixera le montant de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président (désigné par le Conseil parmi ses membres) ou par le

Gérant Commandité.

Toute réunion du Conseil de Surveillance fera l’objet d’une convocation écrite adressée à tous ses membres avec un

préavis minimal de huit jours, excepté dans les cas d’urgence dont la nature sera alors précisée dans la convocation à
l’assemblée. Ce préavis peut être annulé après acceptation écrite (soit par courrier original, par télégramme, télex ou
télécopie) de chacun des membres. Un avis de convocation distinct ne sera pas nécessaire pour les assemblées ayant
fait l’objet d’un calendrier précisant les dates et lieux auxquels sera tenues chacune d’entre elles et adopté par une ré-
solution du Conseil de Surveillance. Si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à une
réunion du Conseil de Surveillance et s’ils déclarent avoir été dûment informés de l’ordre du jour de la réunion, la réu-
nion peut être tenue sans autre forme de préavis.

Tout membre peut se faire représenter par un autre membre à une réunion du Conseil de Surveillance en lui donnant

un pouvoir écrit (par courrier original, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique).

Le Conseil de Surveillance peut procéder à des délibérations et exercer valablement ses fonctions uniquement si au

moins la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions seront approuvées si elles sont adoptées
à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion. Des résolutions peuvent également être
adoptées sous forme d’un ou de plusieurs documents écrits officiels signés par tous les membres.

Art. 17. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance 
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance seront signées par son président ou, en l’absence de

celui-ci, par le président pro tempore qui aura présidé une réunion par intérim. Les copies ou extraits de ces minutes
destinés à être produits dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de tout autre action juridique devront être signés
par le président ou par le président pro tempore ou encore par deux membres du Conseil de Surveillance.

Art. 18. Exercice comptable - Comptabilité 
L’exercice comptable de la Société débutera le 1

er 

septembre et se terminera le 31 août de chaque année.

Les comptes de la Société seront établis en Euros.
Les comptes de la Société seront vérifiés par un auditeur extérieur qui sera désigné pour une période fixée périodi-

quement par un vote à la majorité relative de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 19. Affectation des bénéfices 
Cinq pour cent (5 %) du bénéfice net annuel de la Société sera affecté à la réserve légale conformément à la Loi. Cette

affectation cessera d’être exigée dès que le montant de la réserve légale sera égal à dix pour cent (10 %) du capital social
nominal émis de la Société tel que défini à l’Article 5 ci-dessus et en fonction des augmentations et réductions de capital
périodiques.

Les Actionnaires de la Société possèdent des droits à dividendes par action égaux.
Le Gérant Commandité déterminera la manière dont sera réparti le bénéfice net annuel. Il décidera, en fonction de

sa propre appréciation, de procéder à la distribution périodique de dividendes selon sa conviction de servir au mieux
les objectifs et les principes directeurs de la Société. L’Assemblée Générale des Actionnaires devra approuver la décision
de verser des dividendes prise par le Gérant Commandité ainsi que l’affectation des bénéfices que celui-ci aura proposée.

Les dividendes peuvent être versés en Euros ou en toute autre monnaie sur décision du Gérant Commandité. Le

Gérant Commandité déterminera également les dates et lieux auxquels seront effectués ces versements.

Le Gérant Commandité peut décider de verser des acomptes sur dividendes dans les conditions et limites fixées par

la Loi.

Art. 20. Dissolution et liquidation 
La Société peut faire l’objet d’une dissolution volontaire prononcée par résolution de l’assemblée des Actionnaires

et assortie du consentement du Gérant Commandité ou en cas de survenance de l’un des événements mentionnés à
l’Article 2 ci-dessus.

La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou personnes morales) nommés par

l’assemblée des Actionnaires qui fera également leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 21. Modifications 
Les présents Statuts peuvent faire l’objet de modifications périodiques adoptées lors d’une assemblée des Actionnai-

res, sous réserve du respect des exigences de quorum et de majorité définies par la législation luxembourgeoise et sous
réserve d’accord du Gérant Commandité.

27085

Art. 22. Juridiction compétente
Les questions non régies par les présents Statuts seront réglées par l’application des dispositions contenues dans la

législation luxembourgeoise et, en particulier, dans la Loi.

<i>Souscription

Les parties comparantes déclarent souscrire les 4.246.999 actions émises par la Société, de la façon suivante:
- ACCENTURE MINORITY III LTD souscrit à 10 Actions de Commandité et les paie par un apport en numéraire

d’un montant total de EUR 12,50;

et
- les autres parties comparantes souscrivent à 4.246.989 Actions de Commanditaire (détaillés ci-dessous) et les paient

par les apports en nature suivants: 

Nom des partenaires

Nombre d’Actions

Valeur des

Valeur des Actions

de

participations

de Commanditaire

Commanditaires

détenues dans

souscrites

souscrites

Accenture ANS

35 Anne Cecilie Fagerlie  . . . . . . . . . . . . . . . . 

 55.236

 177.901

69.045

35 Anne Foss Abrahamsem   . . . . . . . . . . . . . 

38.990

125.577

48,737.5

35 Anne Steen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

35 Arne Henning Ramstad. . . . . . . . . . . . . . . 

38.990

125.577

48,737.5

35 Arve Sogn Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 296.766

955.810

370.957,5

35 Bente Svensson   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 32.492

104.649

40.615

35 Bjørn Boberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

35 Bjørn Ivar Danielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . 

305.559

984.130

 381.948,8

35 Bjørn Tore Holte  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

35 Cato Willy Rindal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

35 Christian Selmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.492

 104.649

40.615

35 Eivind Gjemdal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

1. Eivind Roald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.990

125.577

48.737,5

2. Erik Fjornes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.990

125.577

48.737,5

3. Espen Simensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

4. Geir Bårdstu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

5. Gustav Heiberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

6. Halvar Traa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

7. Hans Otto Hilsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

8. Henning Normann   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 156

501.50

195

9. Henrik Hansen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 229.799

740.126

287.248,8

10. Henrik Lund-Hanssen  . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

11. Håkon Breda-Ruud  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

12. Håkon Jacobsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.239

136.041

52.798,75

13. Idar Ytterdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 48.737

156.970

 60.921,25

14. Ingemar Karlsson   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48.737

156.970

60.921,25

15. Jan Åge Rønnestad   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 294.180

947.481

367.725

16. Joe Taralrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

 195

17. Just Erik Naess   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

239.292

 770.700

299.115

18. Ketil Thorsen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 156

501.50

195

19. Kim Zimmer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 289.164

931.326

361.455

20. Kjetil Gudmundsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

21. Kristian Kvam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 239.292

770.700

 299.115

22. Kristian Larsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42.239

136.042

 52.798,75

23. Leif Arne Rones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

 501.50

195

24. Martin Fuhr Bolstad . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 86.644

279.059

 108,305

25. Nils Øveraas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

243.342

 783.743

 304,177.5

26. Olav Skjaeveland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

 195

27. Olav Storli Ulvund   . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 156

501.50

195

28. Paul Arne Kristensen   . . . . . . . . . . . . . . . 

 156

501.50

195

29. Per Erik Strømsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

282.037

908.371

352.546,3

30. Per Ingvald Fredriksen . . . . . . . . . . . . . . . 

156

 501.50

195

31. Petter Hesselberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

32. Petter-Idar Jenssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

 195

33. Pål K. Fevang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

243.829

785.313

304.786,3

34. Randi Arneberg Solli  . . . . . . . . . . . . . . . . 

156

501.50

195

27086

L’apport total des participations de ACCENTURE ANS à faire à la Société doit être comptabilisé selon l’évaluation

de la gérance et affecté d’un montant de EUR 5.308.736,50 versé sur le compte capital social de la Société.

L’apport en numéraire a été certifié au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par Bank of America

en date du 23 mai 2001 et les apports en nature ont été certifiés par le notaire instrumentaire par un rapport d’évalua-
tion émis par la FIDUCIAIRE BILLON, réviseur d’entreprises, en date du 23 mai 2001, en conformité avec l’article 26-
1 de la Loi, lequel conclut comme suit:

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the

contribution, which consists in a total number of 13,678,464 «interests» held in ACCENTURE ANS, a Norwegian part-
nership, and the contribution of which «interests» are at least equal to the nominal value of the shares to be issued.» 

Il résulte également d’un certificat en date du 23 mai 2001, émis par le représentant légal de la société ACCENTURE

ANS (la «Filiale») que:

«Je, soussigné, Bjørn Ivar Danielsen, directeur (ou équivalent) de la Filiale, certifie ci-dessous, que à ce jour et sur base

des documents de la Filiale (à l’exclusion de tout autre document):

1. J’ai reçu procuration le 18 avril 2001 des partenaires de la Filiale, afin d’agir en leur nom.
2. Les Participations contribuées par les partenaires de la Filiale représentent approximativement la moitié du capital

de la Filiale et que les Participations sont proportionnelles au nombre d’actions souscrites par les partenaires de la Fi-
liales dans le capital de la Société.

3. Les Participations sont dûment inscrites au nom des partenaires. 
4. Les Participations ont été entièrement libérées.
5. Les partenaires sont propriétaires des Participations et ont la capacité pour disposer des Participations.
6. Les Participations ne font l’objet d’aucune limitation ou d’une restriction et ne sont grevées d’aucun gage ou d’autre

droit limitant leur transférabilité ou réduisant leur valeur.

7. Il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels toute personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Participations lui soit transférées.

8. Conformément à la loi norvégienne et à la convention de partenariat de la Filiale, les Participations sont librement

cessibles, à condition que les partenaires donnent leur approbation, laquelle approbation a été accordée sous la forme
d’un vote unanime lors d’une réunion de tous les partenaires; et

9. Toutes les formalités requises par la Norvège intervenant après la contribution en nature des Participations des

partenaires à la constitution de ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA ont été ou seront effectuées après ré-
ception d’une copie certifiée conforme du présent acte notarié document ladite contribution en nature.»

Le dit certificat et le rapport d’évaluation, après signature ne variatur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 août 2001. La première assemblée annuelle se tiendra

le 5 novembre 2001.

<i>Déclaration - Frais

Le notaire chargé de l’exécution du présent contrat déclare que les conditions prescrites par l’article 26 de la Loi du

10 Août 1915 et ses modifications relatives aux sociétés commerciales ont été respectées et il en atteste expressément.

35. Rolf Kragerud   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

36. Roy Grønli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.990

 125.577

48.737,5

37. Sam Juul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

321.088

1.034.145

401.360

38. Sigurd Fristad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

 501.50

195

39. Sigurd Skjaeveland. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.236

 177.901

69.045

40. Stein Erik Moe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.239

136.041

52.798,75

41. Svein Olsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

 195

42. Sverre Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246.065

 792.514

 307.581,3

43. Thorleif Paus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

 501.50

195

44. Thron Ivar Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

 195

45. Tor Hauge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

46. Tor Krattebøl   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.990

125.577

48.737.5

47. Tor Mesøy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.239

136.041

52.798,75

48. Tore Alm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 156

501.50

 195

49. Tore Magnussen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209.344

 674.245

261.680

50. Torunn Brandt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

 501.50

195

51. Trond Berntsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

 195

52. Trond Moberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

53. Trygve Langholm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

54. Witold Sitek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.990

501.50

48.737,5

55. Øystein Wiborg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 156

501.50

195

56. Øyvind Stangeby   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

156

501.50

195

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.246.989

13.552.885,50

 5.308.736,50

27087

Le montant approximatif des coûts, dépenses, salaires ou charges, sous quelque forme que ce soit imputés ou facturés

à la Société à l’occasion de sa constitution est estimé à environ deux millions trois cent mille francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires 

Les parties comparantes, représentant la totalité du capital souscrit, considérant qu’elles ont été dûment convoquées,

ont tenu une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et, ayant déclaré l’Assemblée régulièrement consti-
tuée, ont adopté les résolutions suivantes à l’unanimité:

1. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois et le nombre de Commissaires aux Comptes

est fixé à un.

2. Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du Conseil de Surveillance de la Société:
- Michael L. Emmons, attorney-at-law, demeurant à 15 Vida Descanda, Orinda 94563, California, U.S.A.;
- Vernon J. Ellis, consultant, demeurant à Chester Row 44, London SW1 W8JP, United Kingdom;
- Michael G. McGrath, company director, demeurant à Adobe Lane, Los Altos Hill 25440, 94022 California, U.S.A.
3. La société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l, dont le siège social est situé 400, route d’Esch à L-1014 Luxembourg,

est nommée Commissaire aux Comptes de la Société.

4. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg.
5. Le mandat des membres du Conseil de Surveillance de la Société prendra fin à l’occasion de l’Assemblée Générale

Annuelle qui se tiendra en 2002.

6. Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’occasion de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra

en 2002.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’Anglais déclare que, sur requête des parties présentes ci-dessus men-

tionnées, le présent acte a été rédigé en Anglais et sera suivi d’une version française. A la demande des mêmes parties
présentes, en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra. 

Lecture du document ayant été donnée aux personnes présentes, dont les nom, prénom, état civil et domicile res-

pectif sont connus du notaire, lesdites personnes présentes ont devant notaire signé ensemble le présent acte.

Signé: J.F. Bouchoms, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 9CS, fol. 28, case 9. – Reçu 2.141.544 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37277/211/872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

ACCENTURE MINORITY III NORWAY 2 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Registered office: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

STATUTES

In the year two thousand, on the twenty-third of May.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.

There appeared:

1. Anne Cecilie Fagerlie, residing at Sofies Plass 2, 0169 Oslo (Norway), 
2. Anne Foss Abrahamsen, residing at President Harbitzgt. 19, 0259 Oslo (Norway),
3. Anne Steen, residing at Arnulf Øverlandsvei 187, 0764 Oslo (Norway),
4. Arne Henning Ramstad, residing at Haugenlia 23, 2020 Skedsmokorset (Norway),
5. Arve Sogn Andersen, residing at Bjørnehiet 1, 0387 Oslo (Norway), 
6. Bente Svensson, residing at Kodalsveien 12, 1386 Asker (Norway),
7. Bjørn Boberg, residing at Jomfrubråtveien 29C, 0259 Oslo (Norway),
8. Bjørn Ivar Danielsen, residing at Snipermyrlia 6, 1273 Oslo (Norway),
9. Bjørn Tore Holte, residing at Buskogen 82,1675 Kråkerø (Norway),
10. Cato Willy Rindal, residing at Båtstøjordet 95, 1363 Høvik (Norway),
11. Christian Selmer, residing at Vågedalsstien 4e, 4002 Stavanger (Norway),
12. Eivind Gjemdal, residing at Lybekkveien 10e, 0772 Oslo (Norway),
13. Eivind Roald, residing at Sundbakken 7, 1394 Nesbru (Norway),
14. Erik Fjornes, residing at Bygdøy Allé 117a, 0273 Oslo (Norway),
15. Espen Simensen, residing at Bjerkehagevn. 22b, 1405 Langhus (Norway), 
16. Geir Bårdstu, residing at Amund Tvetensvei 81, 3944 Porsgrunn (Norway),
17. Gustav Heiberg, residing at Stovnerbakken 8E, 0980 Oslo (Norway),
18. Halvar Traa, residing at Skyttaveien 48, 1481 Hagan (Norway),
19. Hans Otto Hilsen, residing at Snarøyveien 101b, 1367 Snarøya (Norway),
20. Henning Normann, residing at Neptunveien 25R, 0493 Oslo (Norway),
21. Henrik Hansen, residing at Myrerskogvn. 19, 0495 Oslo (Norway),
22. Henrik Lund-Hanssen, residing at Øvre Nygård 6A, 1482 Nittedal (Norway),
23. Håkon Breda-Ruud, residing at Bj. Bjørnsonsvei 62, 1412 Sofiemyr (Norway),
24. Håkon Jacobsen, residing at Ekebergvn. 190p, 1162 Oslo (Norway), 
25. Idar Ytterdal, residing at Haugerkroken 9, ,1352 Kolsås (Norway), 
26. Ingernar Karlsson, residing at Myrvollvn. 5, 1363 Høvik (Norway),

Luxembourg, le 12 juin 2001.

J. Elvinger.

27088

27. Jan Åge Rønnestad, residing at Høyfjellsåsen 6, 1315 Nesøya (Norway),
28. Joe Taralrud, residing at Nordjordet 1b, 1359 Eiksmarka (Norway),
29. Just Erik Naess, residing at Framnesveien 7, 1501 Moss (Norway),
30. Ketil Thorsen, residing at Vestre Greverud Terrasse 20, 1415 Oppegård (Norway),
31. Kim Zimmer, residing at Terrasseveien 36a, 1363 Høvik (Norway), 
32. Kjetil Gudmundsen, residing at Bjørndalsvn. 11b, 1476 Rasta (Norway),
33. Kristian Kvam, residing at Barnålvn. 12, 0198 Oslo (Norway), and 
34. Kristian Larsen, residing at Bølumkollen B, 3073 Galleberg (Norway),
35. Leif Arne Rones, Diakonveien 3, 0370 Oslo (Norway),
36. Martin Fuhr Bolstad, residing at Nadderudvn. 157, 1359 Eiksmarka (Norway),
37. Nils Øveraas, residing at Hiltonåsen 107, 1312 Slependen (Norway),
38. Olav Skjaeveland, residing at Øygardvn. 12b, 1357 Bekkestua (Norway),
39. Olav Storli Ulvund, residing at Hofftunet 15, 0379 Oslo (Norway),
40. Paul Arne Kristensen, residing at Olav Aukrustvei 11c, 0390 Oslo (Norway),
41. Per Erik Strømsø, residing at Bloksbergstien 1a, 1360 Nesbru (Norway),
42. Per Ingvald Fredriksen, residing at Stordamsnaret 48, 0671 Oslo (Norway),
43. Petter Hesselberg, residing at Diakonveien 3, 0370 Oslo (Norway),
44. Petter-Idar Jenssen, residing at Ekrekroken 41, 1356 Bekkestua (Norway),
45. Pål K. Fevang, residing at Strandvejen 348, DK-298 Kokkedal (Norway),
46. Randi Arneberg Solli, residing Capralhaugen 60, 1358 Jar (Norway),
47. Rolf Kragerud, residing at Slemdalsveien 81C, 0370 Oslo (Norway),
48. Roy Grønli, residing at Anna Hagmannsgt. 7m, 1511 Moss (Norway), 
49. Sam Juul, residing at Strømstangvn. 16, 1367 Snarøya (Norway),
50. Sigurd Fristad, residing at Jansveien 16, 1354 Baerums Verk (Norway), 
51. Sigurd Skjaeveland, residing at Åsengvn. 29, 1312 Slependen (Norway),
52. Stein Erik Moe, residing at Tjernåslia 10b, 1315 Nesøya (Norway),
53. Svein Olsen, residing at Åsbyfaret 127, 1392 Vettre (Norway),
54. Sverre Ruth, residing at Hundsundvn 3, 1367 Snarøya (Norway),
55. Thorleif Paus, residing at Rådyrfaret 14, 1362 Hosle (Norway),
56. Thron Ivar Berg, residing at Snaret 23a, 1359 Eiksmarka (Norway),
57. Tor Hauge, residing at Øvre Goslia 5, 1350 Lommedalen (Norway), 
58. Tor Krattebøl, residing at Øvre Goslia 5, 1350 Lommedalen (Norway),
59. Tor Mesøy, residing at Storengveien 63A, 1368 Stabekk (Norway), 
60. Tore Alm, residing at Kirkeveien 147E, 0361 Oslo (Norway),
61. Tore Magnussen, residing at Jerpefaret 4b, 0393 Oslo (Norway),
62. Torunu Brandt, residing at Veita 5, 0880 Oslo (Norway),
63. Trond Berntsen, residing at Bestumvn. 46, 0281 Oslo (Norway),
64. Trond Moberg, residing at Trudvangveien 2, 1358 Jar (Norway),
65. Trygve Langholm, residing at Ekebergveien 273B, 1166 Oslo (Norway),
66. Witold Sitek, residing at Båtstøjordet 17, 1363 Høvik (Norway),
67. Øystein Wiborg, residing at Bølerveien 21, 0690 Oslo (Norway), and
68. Øyvind Stangeby, residing at Arnulf Øverlandsvei 187, 0764 Oslo (Norway),
and
69. ACCENTURE MINORITY III, LTD, incorporated under the laws of Gibraltar, having its registered office at 57/63

Line Wallroad, PO Box 199, Gibraltar.

Each of the appearing parties, as listed hereabove from 1) to 69), is hereby represented by Jean-François Bouchoms,

lawyer, residing in Luxembourg by virtue of a proxy given in on May 23, 2001.

The said proxies, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, shall re-

main attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, acting in their respective capacities, have requested the officiating notary to record the fol-

lowing articles of incorporation (hereafter the «Articles») of a company which they declare to establish as follows:

Name - Registered office - Duration - Object

Art. 1. Form
There exists among ACCENTURE MINORITY III, LTD, incorporated under the laws of Gibraltar and having its cur-

rent registered office at 57/63 Line Wallroad, PO Box 199, Gibraltar, being the general partner (gérant commandité)
(the «General Partner») of the Company, and the current limited partners (associés commanditaires) of the Company
and all those persons or entities who may become limited partners (associés commanditaires) of the Company in the
future a partnership limited by shares (société en commandite par actions) under the name of ACCENTURE MINORITY
III NORWAY 2 SCA (hereinafter referred to as the «Company»).

Hereinafter the limited partners and the General Partner will be referred to, where the context so requires, individ-

ually as a «Shareholder» and collectively as the «Shareholders».

Art. 2. Term 
The Company is incorporated for an unlimited period of time. However, the Company shall come to an end, by an-

ticipation, in the event of the occurrence of the first of the following events: (i) the resignation, dissolution or bankruptcy
or insolvency of the General Partner or (ii) a resolution to dissolve the Company adopted at the a meeting of Share-

27089

holders deciding in compliance with the conditions of quorum and majority required for amendments to the Articles of
Association.

Art. 3. Purposes
The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg

and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, admin-
istration, development and management of its participations and of its asset portfolio. 

The Company may carry on any commercial, industrial and financial activity or maintain a commercial establishment

open to the public. The Company may participate directly and/or indirectly in the establishment and development of
any financial, industrial or commercial enterprises in Luxembourg and abroad and it may render them every assistance,
whether of a financial nature or not, such as, without limitation, the granting of loans or advances, guarantees for their
benefit or other forms of assistance. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds and
notes whether or not convertible or exchangeable in shares of the Company or into shares of other companies.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful

for the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Registered office
The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. Branches or

other offices may be established either in Luxembourg or abroad by a resolution of the General Partner.

In the event that the General Partner determines that extraordinary political, economic or social developments have

occurred or are imminent that interfere or are likely to interfere with the normal activities of the Company at its reg-
istered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary
measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg partnership limited by shares.

Art. 5. Capital 
5.1 The subscribed and issued capital of the Company is set at EUR 5,308,678.75 (five million three hundred and eight

thousand six hundred seventy-eight Euros and seventy-five cents) divided into 4,246,940 (four million two hundred and
forty-six thousand nine hundred and forty) limited shares with a par value of one Euro and twenty-five cents (EUR 1.25)
each held by the limited partners (the «Limited Shares») (Actions de Commanditaires) and 3 (three) unlimited shares
held by the General Partner (the «Unlimited Shares») (Actions de Commandités) with a par value of one Euro and twen-
ty-five cents (EUR 1.25) each.

The issued capital of the Company may be increased or reduced by a decision of a meeting of Shareholders deliber-

ating in the manner provided for amendments to the Articles of Association.

The General Partner’s Shares and the Limited Shares will be individually referred to as a «Share» and collectively as

the «Shares». 

5.2 The Shares are issued as redeemable shares to which the terms of article 49-8 of the Luxembourg Companies’

Act dated August 10, 1915, as amended (the «Law») shall apply.

Art. 6. Shares
6.1 The Company recognises only one holder per Share; in case a Share is held by more than one person, the Com-

pany has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed or
designated by the joint holders as the sole owner in relation to the Company.

6.2 The Limited Shares and the General Partner’s Shares of the Company are and they continue to stay in registered

form. The Shares are not certificated but a certificate (certificat d’inscription nominative) witnessing the registration of
the relevant Shareholder in the share register of the Company and the number of Shares held by him/it shall be issued
by the Company on request of the Shareholder.

6.3 A share register shall be kept at the registered office of the Company and, to the extent the General Partner shall

so decide, with a transfer agent and registrar. Such register shall set forth the name of each Shareholder, his residence
or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares
and the dates of such transfers.

6.4 Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding Shares may be called at any time at the discretion of the General

Partner, provided however that calls shall be made on all the Shares in the same proportion and at the same time. Any
sum, the payment of which is in arrear, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of ten per
cent per year calculated from the date when the payment was due until the date of the actual payment.

6.5 The transfer of the shares is subject to a right of first refusal to be exercised by the other Shareholders pro rata

to their shareholding in the Company.

Art. 7. Redemption of Shares
The Company is authorised to redeem its shares within the limits and conditions set by article 49-8 of the Law. A

redemption of Shares must be approved by a resolution at a meeting of Shareholders passed by a two thirds majority
of the Shares represented at the meeting including the consent of the General Partner.

Art. 8. Liability of Shareholders. 
The holders of Limited Shares are only liable up to the amount of their capital contribution made to the Company.
The General Partner’s liability shall be unlimited.

27090

Art. 9. Meetings of Shareholders 
The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the

registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting,
on the fifth day of November at 10.00 a.m. If such day is a bank holiday in the city of Luxembourg, the annual general
meeting shall be held on the next following Luxembourg business day.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

All meetings of Shareholders shall be chaired by the General Partner.

Art. 10. Notice, quorum, proxies, majority
The notice periods and quorum rules required by the Law shall apply with respect to the meetings of Shareholders

of the Company, as well as with respect to the conduct of such meetings, unless otherwise provided herein.

Each Share is entitled to one vote. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another per-

son, whether a Shareholder or not, as his proxy in writing whether in original or by telefax, cable, telegram or telex. 

Except as otherwise required by the Law or by these Articles of Association, resolutions at a meeting of Shareholders

will be passed by a simple majority of those present and voting with the consent of the General Partner.

Art. 11. Convening notice 
Shareholders’ meetings shall be convened by the General Partner or by the Supervisory Board, pursuant to a notice

setting forth the agenda and sent by registered mail at least eight days prior to the meeting to each Shareholder at the
Shareholder’s address on record in the share register of the Company or by a publication in the Luxembourg press and
in the Luxembourg Official Gazette (Mémorial).

If all the Shareholders are present or represented at a meeting of Shareholders, and if they state that they have been

informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The General Partner may determine all reasonable conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to par-

ticipate in any meeting of Shareholders.

Art. 12. Powers of the meeting of Shareholders
Any regularly constituted meeting of Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders

of the Company. It may only resolve on any item generally whatsoever only with the consent of the General Partner. 

Art. 13. Management
The Company shall be managed by the General Partner who shall be the liable partner (associé - gérant - commandité)

and who shall be personally, jointly and severally liable with the Company for all liabilities which cannot be met out of
the assets of the Company.

The General Partner is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Company’s interest which are not expressly reserved by the Law or by these Articles of Association to the meeting of
Shareholders or to the Supervisory Board.

The General Partner shall, subject to the terms of Article 16 hereof, namely have the power on behalf and in the

name of the Company to carry out any and all of the purposes of the Company and to perform all acts and enter into
and perform all contracts and other undertakings that it may deem necessary, advisable or useful or incidental thereto.
Except as otherwise expressly provided, the General Partner shall have, and shall have full authority in its discretion to
exercise, on behalf of and in the name of the Company, all rights and powers necessary or convenient to carry out the
purposes of the Company.

Art. 14. Authorised signature
The Company shall be bound by the corporate signature of the General Partner or by the individual or joint signa-

tures of any other persons to whom authority shall have been delegated by the General Partner as the General Partner
shall determine in its discretion.

Art. 15. No remuneration of General Partner
The General Partner and the members or employees of the General Partner shall receive no remuneration from the

Company for their duties.

Art. 16. Supervisory Board
The affairs of the Company and its financial situation including particularly its books and accounts shall be supervised

by a supervisory board composed of at least three members (herein referred to as the «Supervisory Board»).

The Supervisory Board shall be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner may de-

termine and it shall authorise any actions of the General Partner that may, pursuant to the Law or under these Articles
of Association, exceed the powers of the General Partner.

The members of the Supervisory Board may be Shareholders, other than the General Partner, or not. The members

of the Supervisory Board are appointed by a simple majority vote of the meeting of Shareholders for a maximum term
of six years, which shall be renewable. The members of the Supervisory Boards may be dismissed at any time and at the
sole discretion of the meeting of Shareholders.

Retiring members of the Supervisory Board are eligible for re-election.
In the event of a vacancy on the Supervisory Board because of death, retirement or otherwise, the remaining mem-

bers of the Supervisory Boards may meet and may elect by a majority vote a member of the Supervisory Board to fill
such vacancy until the next meeting of Shareholders.

If the majority of the members of the Supervisory Boards vacates the office a meeting of the Shareholders shall be

convened in order to appoint a new Supervisory Board.

The general meeting of Shareholders shall determine the remuneration of the Supervisory Board.

27091

The Supervisory Board shall be convened by its chairman (appointed by the Supervisory Board from amongst its

members) or by the General Partner.

Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board with

at least eight days prior notice, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing, whether in original
or by cable, telegram, telefax or telex of each member. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Supervisory Board. If all the
members of the Supervisory Board are present or represented at a meeting of Supervisory Board, and if they state that
they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Any member may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing, whether in original or by cable,

telegram, telex, telefax or other electronic transmission another member as his proxy.

The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or repre-

sented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the members present or represented at such
meeting. Resolutions may also be taken in one or several written instruments signed by all the members.

Art. 17. Minutes of the Supervisory Board 
The minutes of a meeting of the Supervisory Board shall be signed by its chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore who chaired such meeting. Copies or extracts of such minutes which are to be produced in judicial pro-
ceedings or otherwise shall be signed by the chairman or the chairman pro tempore or by two members of the Super-
visory Board.

Art. 18. Accounting year - Accounts 
The accounting year of the Company shall begin on September 1 and it shall terminate on August 31 of each year.
The accounts of the Company shall be stated in Euro.
The accounts of the Company shall be audited by an external auditor who shall be appointed for a term to be deter-

mined from time to time by a simple majority vote of the general meeting of the Shareholders.

Art. 19. Allocation of profits 
From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve as required by

the Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10 %) of the
nominal issued share capital of the Company as stated in Article 5 hereof as increased or reduced from time to time.

The Shareholders of the Company shall have equal dividend rights on a per share basis.
The General Partner shall determine how the annual net profits shall be disposed of and it shall decide to pay divi-

dends from time to time, as it, in its discretion, believes to suit best the corporate purpose and policy of the Company.
The general meeting of Shareholders shall have to approve the General Partner’s decision to pay dividends as well as
the profit allocation proposed by the General Partner.

The dividends may be paid in Euro or in any other currency determined by the General Partner and they may be paid

at such places and times as shall be determined by the General Partner.

The General Partner may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the

Law.

Art. 20. Dissolution and liquidation
The Company may be voluntarily dissolved by a resolution of the meeting of Shareholders with the consent of the

General Partner or upon the occurrence of one of the events indicated in Article 2 above.

The liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities)

named, by the meeting of Shareholders which shall also determine their powers and their remuneration.

Art. 21. Amendments 
These Articles of Association may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quo-

rum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg, and subject to the consent of the General Partner.

Art. 22. Applicable law
All matters not governed by these Articles of Association shall be determined by application of the provisions of Lux-

embourg law, and, in particular, of the Law.

<i>Subscription

The appearing parties hereby declare to subscribe to the 4,246,943 shares issued by the Company as follows:
- ACCENTURE MINORITY III LTD, subscribes to 3 unlimited shares, and pays them up by a contribution in cash of

an aggregate amount of EUR 3.75;

and
- the other appearing parties subscribe to 4,246,940 limited shares (as detailed hereafter) and pay them up by way of

a contribution in kind, namely:  

Name of Contributor

 Number of Limited

 Interests in NOK per

Aggregate nominal

Shares subscribed  Class of Interests held

value of the limited

in Accenture ANS to

shares subscribed in

be contributed

EUR

- Anne Cecilie Fagerlie  . . . . . . . . . . . . . . . . .

55,235

177,898

69,043.75

- Anne Foss Abrahamsem . . . . . . . . . . . . . . .

38,990

125,577

48,737.5

- Anne Steen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

 193.75

27092

- Anne Henning Ramstad . . . . . . . . . . . . . . . 

 38,990

 125,577

48,737.5

- Arve Sogn Andersen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

296,765

 955,806

370,956.25

- Bente Svensson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32,491

104,645

40,613.75

- Bjørn Boberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Bjørn Ivar Danielsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

305,558

984,127

381,947.5

- Bjørn Tore Holte   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Cato Willy Rindal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Christian Selmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32,491

104,645

40,613.75

- Eivind Gjemdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

 498.5

193.75

- Eivind Roald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 38,990

125,577

48,737.5

- Erik Fjornes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38,990

125,577

48,747.5

- Espen Simensen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Geir Bårdstu   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Gustav Heiberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Halvar Traa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Hans Otto Hilsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

 498.5

193.75

- Henning Normann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Henrik Hansen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

229,799

 740,126

287,248.75

- Henrik Lund-Hanssen. . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Håkon Breda-Ruud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Håkon Jacobsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42,239

136,041

 52,798.75

- Idar Ytterdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48,737

156,970

 60,921.25

1. Ingemar Karlsson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

48,737

156,970

60,921.25

2. Jan Åge Rønnestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

294,179

947,478

 367,723.75

3. Joe Taralrud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

4. Just Erik Naess  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

239,291

 770,697

299,113.75

5. Ketil Thorsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

6. Kim Zimmer   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

289,164

931,326

361,455

7. Kjetil Gudmundsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

 193.75

8. Kristian Kvam   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

239,291

770,697

299,113.75

9. Kristian Larsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42,239

136,041

52,798.75

10. Leif Arne Rones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

11. Martin Fuhr Bolstad  . . . . . . . . . . . . . . . . 

86,644

279,059

108,305

12. Nils Øveraas   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 243,341

783,741

304,176.25

13. Olav Skjaeveland   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

14. Olav Storli Ulvund  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

 193.75

15. Paul Arne Kristensen . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

 193.75

16. Per Erik Strømsø  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

282,037

 908,371

352,546.25

17. Per Ingvald Fredriksen  . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

18. Petter Hesselberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

 193.75

19. Petter-Idar Jenssen   . . . . . . . . . . . . . . . . 

 155

498.5

193.75

20. Pål K. Fevang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 243,829

785,313

 304,786.25

21. Randi Arneberg Solli  . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

22. Rolf Kragerud   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

23. Roy Grønli  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38,990

125,577

 48,737.5

24. Sam Juul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 321,087

1,034,142

401,358.75

25. Sigurd Fristad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

26. Sigurd Skjaeveland  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

55,235

177,898

69,043.75

27. Stein Erik Moe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 42,239

136,041

 52,798.75

28. Svein Olsen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

29. Sverre Ruth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

246,065

792,514

307,581.25

30. Thorleif Paus   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

31. Thron Ivar Berg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

32. Tor Hauge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

33. Tor Krattebøl   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38,990

125,577

48,737.5

34. Tor Mesøy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

42,239

136,041

52,798.75

35. Tore Alm  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

36. Tore Magnussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

209,343

674,242

 261,678.75

37. Torunn Brandt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

38. Trond Berntsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

39. Trond Moberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

27093

The total contribution made to the Company of the Subsidiary’s Interests is to be recorded in accordance with the

valuation of the management and to be allocated in an amount of EUR 5,308,675 to the nominal share capital account
of the Company.

The above contribution in cash has been hereby certified to the undersigned notary by a certificate of Bank of Amer-

ica dated May 23, 2001 and the above contribution in kind has been hereby certified to the undersigned notary by a
valuation report issued for the purpose of article 26-1 of the Law by FIDUCIAIRE BILLON, Réviseur d’entreprises, dated
May 23, 2001, the conclusion of which reads as follows:

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the

contribution, which consists in a total number of 13,678,314 «interests» representing 49.99 % of the total number of
«interests» held in Accenture ANS, a Norwegian partnership, and the contribution of which «interests» are at least
equal to the nominal value of the shares to be issued.»

It results furthermore from a certificate dated May 23, 2001, issued by the Managing Director (or equivalent) of Ac-

centure ANS (the «Subsidiary») that:

«I, Bjørn Ivar Danielsen, being a Director (or equivalent) of the Subsidiary hereby certify that as at the date hereof

and based on my review of the Subsidiary’s records (to the exclusion of any other documents):

1. on April 18th 2001 I have been granted powers of attorney by the interestholders of the Subsidiary to act on their

behalf;

2. the Interests contributed by the Interests’ holders of the Subsidiary represent approximately half of the Subsidiary’s

paid in capital, and that the Interests are proportionnate to the number of shares issued to the partners as consideration;

3. the Interests are in registered form;
4. the Interests are fully paid-up;
5. the interestholders are solely entitled to the Interests and have the power to dispose of the Interests;
6. none of the Interests is encumbered with any pledge, lien, usufruct or other encumbrance, there exists no right to

acquire any pledge or usufruct on the Interests and none of the Interests are subject to any attachment;

7. there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Interests be transferred to him;

8. according to the law of Norway and the partnership agreement of the Subsidiary, the Interests are freely transfer-

able provided that all partners give their approval, and such approval has been given in form of a unanimous vote in a
meeting of all partners; and

9. all formalities required in Norway subsequent to the contribution in kind of the Interests of the Subsidiary to the

incorporation of ACCENTURE MINORITY III NORWAY 2 SCA have been or will be effected upon receipt of a certi-
fied copy of the notarial deed from the notary officiating in Luxembourg, documenting the said contribution in kind;»

The said certificate and valuation report dated as per May 23, 2001 attached hereto, after having been signed ne va-

rietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain attached to the present deed
in order to be registered with it.

<i>Transitional provisions

The first business year begins today and ends on August 31, 2001. The first annual meeting will be held on November

5, 2001.

<i>Statement - Costs

The notary executing this deed declares that the conditions prescribed by article 26 of the law of 10th August, 1915

as amended on commercial companies have been fulfilled and expressly bears witness to their fulfilment.

The approximate amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to

the company as a result of its formation, is approximately evaluated at two million three hundred thousand francs.

<i>Extraordinary General Meeting of Shareholders

The above named parties, representing the entirety of the subscribed capital, considering themselves to be duly con-

vened, have proceeded to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders and having stated that the Meeting
is regularly constituted, have passed the following resolutions by unanimous vote:

1. The number of the members of the Supervisory Board is set at three and that of the statutory auditor at one.
2. The following persons are appointed as members of the Supervisory Board of the Company:
- Michael L. Emmons, attorney-at-law, residing at 15 Vida Descanda, Orinda 94563, California, U.S.A.;
- Vernon J. Ellis, consultant, residing at Vernon James Ellis, residing at Chester Row 44, London SWI W8JP, United

Kingdom;

- Michael G. McGrath, company director, residing at Adobe Lane, Los Altos Hill 25440, 94022 California, U.S.A.
3. PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., having its registered office at 400, route d’Esch in L-1471 Luxembourg is appoint-

ed as statutory auditor of the Company.

4. The Company’s registered office shall be at 58, rue Charles Martel, in L-2134 Luxembourg.
5. The term of office of the members of the Supervisory Board of the Company shall end at the Annual General Meet-

ing to be held in 2002.

40. Trygve Langholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

41. Witold Sitek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38,990

125,577

 48,737.5

42. Øystein Wiborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

 498.5

193.75

43. Øyvind Stangeby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,246,940

13,678,313

5,308,675

27094

6. The term of office of the statutory auditor shall end at the Annual General Meeting to be held 2002.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above ap-

pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing
persons in case of divergences between English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-trois mai.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.

Sont apparus:

1. Anne Cecilie Fagerlie, demeurant à Sofies Plass 2, 0169 Oslo (Norway),
2. Anne Foss Abrahamsen, demeurant à President Harbitzgt. 19, 0259 Oslo (Norway),
3. Anne Steen, demeurant à Arnulf Øverlandsvei 187, 0764 Oslo (Norway),
4. Arne Henning Ramstad, demeurant à Haugenlia 23, 2020 Skedsmokorset (Norway),
5. Arve Sogn Andersen, demeurant à Bjørnehiet 1, 0387 Oslo (Norway),
6. Bente Svensson, demeurant à Kodalsveien 12, 1386 Asker (Norway), 
7. Bjørn Boberg, demeurant à Jomfrubråtveien 29C, 0259 Oslo (Norway),
8. Bjørn Ivar Danielsen, demeurant à Snipermyrlia 6, 1273 Oslo (Norway),
9. Bjørn Tore Holte, demeurant à Buskogen 82, 1675 Kråkerø (Norway),
10. Cato Willy Rindal, demeurant à Båtstøjordet 95, 1363 Høvik (Norway),
11. Christian Selmer, demeurant à Vågedalsstien 4e, 4002 Stavanger (Norway),
12. Eivind Gjemdal, demeurant à Lybekkveien 10e, 0772 Oslo (Norway), 
13. Eivind Roald, demeurant à Sundbakken 7, 1394 Nesbru (Norway),
14. Erik Fjornes, demeurant à Bygdøy Allé 117a, 0273 Oslo (Norway),
15. Espen Simensen, demeurant à Bjerkehagevn. 22b, 1405 Langhus (Norway),
16. Geir Bårdstu, demeurant à Amund Tvetensvei 81, 3944 Porsgrunn (Norway),
17. Gustav Heiberg, demeurant à Stovnerbakken 8E, 0980 Oslo (Norway),
18. Halvar Traa, demeurant à Skyttaveien 48, 1481 Hagan (Norway),
19. Hans Otto Hilsen, demeurant à Snarøyveien 101b, 1367 Snarøya (Norway),
20. Henning Normann, demeurant à Neptunveien 25R, 0493 Oslo (Norway),
21. Henrik Hansen, demeurant à Myrerskogvn. 19, 0495 Oslo (Norway), 
22. Henrik Lund-Hanssen, demeurant à Øvre Nygård 6A, 1482 Nittedal (Norway),
23. Håkon Breda-Ruud, demeurant à Bj. Bjørnsonsvei 62, 1412 Sofiemyr (Norway),
24. Håkon Jacobsen, demeurant à Ekebergvn. 190p, 1162 Oslo (Norway),
25. Idar Ytterdal, demeurant à Haugerkroken 9, ,1352 Kolsås (Norway),
26. Ingernar Karlsson, demeurant à Myrvollvn. 5, 1363 Høvik (Norway),
27. Jan Åge Rønnestad, demeurant à Høyfjellsåsen 6, 1315 Nesøya (Norway),
28. Joe Taralrud, demeurant à Nordjordet 1b, 1359 Eiksmarka (Norway),
29. Just Erik Naess, demeurant à Framnesveien 7, 1501 Moss (Norway), 
30. Ketil Thorsen, demeurant à Vestre Greverud Terrasse 20, 1415 Oppegård (Norway),
31. Kim Zimmer, demeurant à Terrasseveien 36a, 1363 Høvik (Norway),
32. Kjetil Gudmundsen, demeurant à Bjørndalsvn. 11b, 1476 Rasta (Norway),
33. Kristian Kvam, demeurant à Barnålvn. 12, 0198 Oslo (Norway), and
34. Kristian Larsen, demeurant à Bølumkollen B, 3073 Galleberg (Norway),
35. Leif Arne Rones, Diakonveien 3, 0370 Oslo (Norway),
36. Martin Fuhr Bolstad, demeurant à Nadderudvn. 157, 1359 Eiksmarka (Norway),
37. Nils Øveraas, demeurant à Hiltonåsen 107, 1312 Slependen (Norway),
38. Olav Skjaeveland, demeurant à Øygardvn. 12b, 1357 Bekkestua (Norway),
39. Olav Storli Ulvund, demeurant à Hofftunet 15, 0379 Oslo (Norway),
40. Paul Arne Kristensen, demeurant à Olav Aukrustvei 11c, 0390 Oslo (Norway),
41. Per Erik Strømsø, demeurant à Bloksbergstien 1a, 1360 Nesbru (Norway),
42. Per Ingvald Fredriksen, demeurant à Stordamsnaret 48, 0671 Oslo (Norway),
43. Petter Hesselberg, demeurant à Diakonveien 3, 0370 Oslo (Norway),
44. Petter-Idar Jenssen, demeurant à Ekrekroken 41, 1356 Bekkestua (Norway),
45. Pål K. Fevang, demeurant à Strandvejen 348, DK-298 Kokkedal (Norway),
46. Randi Arneberg Solli, residing Capralhaugen 60, 1358 Jar (Norway),
47. Rolf Kragerud, demeurant à Slemdalsveien 81C, 0370 Oslo (Norway),
48. Roy Grønli, demeurant à Anna Hagmannsgt. 7m, 1511 Moss (Norway),
49. Sam Juul, demeurant à Strømstangvn. 16, 1367 Snarøya (Norway),
50. Sigurd Fristad, demeurant à Jansveien 16, 1354 Baerums Verk (Norway),
51. Sigurd Skjaeveland, demeurant à Åsengvn. 29, 1312 Slependen (Norway),
52. Stein Erik Moe, demeurant à Tjernåslia 10b, 1315 Nesøya (Norway),
53. Svein Olsen, demeurant à Åsbyfaret 127, 1392 Vettre (Norway),

27095

54. Sverre Ruth, demeurant à Hundsundvn 3, 1367 Snarøya (Norway),
55. Thorleif Paus, demeurant à Rådyrfaret 14, 1362 Hosle (Norway),
56. Thron Ivar Berg, demeurant à Snaret 23a, 1359 Eiksmarka (Norway),
57. Tor Hauge, demeurant à Øvre Goslia 5, 1350 Lommedalen (Norway),
58. Tor Krattebøl, demeurant à Øvre Goslia 5, 1350 Lommedalen (Norway),
59. Tor Mesøy, demeurant à Storengveien 63A, 1368 Stabekk (Norway),
60. Tore Alm, demeurant à Kirkeveien 147E, 0361 Oslo (Norway),
61. Tore Magnussen, demeurant à Jerpefaret 4b, 0393 Oslo (Norway), 
62. Torunu Brandt, demeurant à Veita 5, 0880 Oslo (Norway),
63. Trond Berntsen, demeurant à Bestumvn. 46, 0281 Oslo (Norway),
64. Trond Moberg, demeurant à Trudvangveien 2, 1358 Jar (Norway),
65. Trygve Langholm, demeurant à Ekebergveien 273B, 1166 Oslo (Norway),
66. Witold Sitek, demeurant à Båtstøjordet 17, 1363 Høvik (Norway),
67. Øystein Wiborg, demeurant à Bølerveien 21, 0690 Oslo (Norway), and
68. Øyvind Stangeby, demeurant à Arnulf Øverlandsvei 187, 0764 Oslo (Norway),
et
69. ACCENTURE MINORITY III, LTD, constituée sous le droit de l’Etat de Gibraltar, ayant son siège social à 57/63

Line Wallroad, PO Box 199, Gibraltar.

Chacune des parties comparantes, énumérées ci-dessus sous les numéros 1) à 69), sont représentées par Jean-Fran-

çois Bouchoms, avocat, demeurant à Luxembourg en vertu d’une procuration donnée le 23 mai 2001.

Lesdites procurations, après avoir été paraphées et signées ne varietur par le mandataire des comparantes et le no-

taire instrumentaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lesquelles comparantes, ès-qualité en vertu de laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d’arrêter

les statuts (ci-après les «Statuts») d’une société qu’ils déclarent constituer comme suit:

Dénomination sociale - Siège social - Durée - Objet

Art. 1

er

. Forme juridique 

Il est établi entre ACCENTURE MINORITY III, LTD, constituée en vertu du droit de Gibraltar et ayant son siège

social à 57/63 Line Wallroad, PO Box 199, Gibraltar, le gérant commandité («Gérant Commandité») et les associés
commanditaires actuels de la Société et toutes les personnes (physiques ou morales) qui deviendront dans le futur des
associés commanditaires de la société, il est formé Accenture SCA, une société en commandite par actions (ci-après
dénommée la «Société».

Ci-après, les associés commanditaires et le Gérant Commandité seront chacun dénommé un Actionnaire et ensemble

des Actionnaires.

Art. 2. Durée 
La Société est constituée pour une durée illimitée. Toutefois, la Société prendra fin, par anticipation, dans le cas où

surviendrait le premier des événements suivants: (i) la démission, dissolution ou la faillite ou carence du Gérant Com-
mandité ou (ii) une décision de dissoudre la Société adoptée par l’assemblée des Actionnaires délibérant conformément
aux conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications des Statuts.

Art. 3. Objet 
L’objet de la société est la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembour-

geoises et étrangères, l’acquisition par voie d’achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que la cession par
voie de vente, d’échange ou de toute autre manière d’actions, d’obligations, de billets et autres valeurs mobilières de
toute nature, et la propriété, l’administration, le développement et la gestion de ses participations et de son portefeuille
d’actifs.

La société peut exercer toute activité commerciale, financière ou industrielle ou conserver un établissement com-

mercial ouvert au public. La société peut participer directement ou indirectement à l’établissement et au développement
de toutes entreprises financières, industrielles ou commerciales au Luxembourg et à l’étranger et peut leur prêter toute
assistance, de nature financière ou non, comme notamment l’octroi de prêts ou d’avances, de garanties à leur avantage
ou toute autre forme d’assistance. La société peut emprunter sous toute forme et peut procéder à l’émission d’obliga-
tions et de billets, qu’ils soient ou non convertibles ou échangeables contre des actions de la société ou des actions de
toutes autres sociétés.

De manière générale, elle peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et exercer toute opération

qu’elle peut juger utile à la réalisation et au développement de ses objets.

Art. 4. Siège Social 
Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg. Des succursales ou autres

implantations peuvent être établies soit au Luxembourg soit à l’étranger sur décision du Gérant Commandité.

Dans le cas où le Gérant Commandité décide que des circonstances politiques, économiques ou sociales exception-

nelles, déclarées ou imminentes, entravent ou sont susceptibles d’entraver les activités normales de la Société dans les
locaux de son siège social, de perturber les communications entre ledit siège social et les personnes se trouvant à
l’étranger, le siège social peut être momentanément transféré à l’étranger jusqu’à la cessation complète de ces circons-
tances exceptionnelles; ce type de mesure provisoire n’affectera pas la nationalité de la Société qui, nonobstant le trans-
fert provisoire de son siège social, demeurera une société en commandite par actions luxembourgeoise.

27096

Art. 5. Capital 
5.1 Le capital souscrit et émis de la Société est fixé à EUR 5.308.678,75 (cinq millions trois cent huit mille six cent

soixante-dix-huit Euros et soixante-quinze cents), réparti en 4.246.940 (quatre millions deux cent quarante-six mille neuf
cent quarante-six mille neuf cent quarante) actions de commanditaires ayant une valeur nominale d’un Euro et vingt-
cinq cents (EUR 1,25) chacune, détenues par les Associés Commanditaire(s) («Actions de Commanditaires») et 3 (trois)
actions de commandité détenues par le Gérant Commandité («Actions de Commandité») ayant une valeur nominale
d’un Euro et vingt-cinq cents (EUR 1,25) chacune.

Le capital émis par la Société peut faire l’objet d’augmentations ou de réductions sur décision d’une assemblée des

Actionnaires selon le mode de délibération requis en cas de modification des Statuts.

Les actions de Commandité et les Actions de Commanditaires seront désignées individuellement par l’«Action» et

collectivement par les «Actions».

5.2 Les Actions sont émises en tant qu’actions rachetables par la Société auxquelles s’appliquent les dispositions de

l’article 49-8 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la «Loi»).

Art. 6. Actions 
6.1 La Société ne reconnaît qu’un seul propriétaire par Action; dans le cas où une Action est détenue par plus d’une

personne, la Société se réserve le droit de suspendre l’exercice de l’ensemble des droits attachés à cette Action jusqu’à
ce qu’une seule personne ait été désignée par la communauté des détenteurs de l’Action comme son propriétaire ex-
clusif devant la Société.

6.2 Les Actions de Commanditaires et les Actions de Commandités de la Société sont et resteront des actions no-

minatives. Les Actions ne sont pas matérialisées par un certificat mais la Société émettra, à la demande de l’Actionnaire,
un certificat d’inscription nominatif attestant de l’inscription au registre des actionnaires de l’Actionnaire concerné ainsi
que du nombre d’Actions par lui détenu.

6.3 Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société et, dans la mesure où le Gérant Commandité

le décidera, par un agent chargé de la tenue des registres. Ledit registre fera mention du nom de chaque Actionnaire,
de son lieu de résidence ou domicile élu, du nombre d’actions qu’il détient, du montant de l’apport versé pour chaque
action, ainsi que des cessions d’actions et des dates desdites cessions.

6.4 Les éventuels montants non libérés au titre des Actions émises et en circulation peuvent être appelés à tout mo-

ment et ce, à l’appréciation du Gérant Commandité, à la condition cependant que les appels de fonds soient effectués
sur l’ensemble des Actions, dans la même proportion et au même moment. Toute somme dont le payement est effectué
avec retard génère automatiquement des intérêts de retard en faveur de la Société au taux de dix pour cent l’an, calculés
à partir de la date d’exigibilité de la facture et jusqu’à la date du payement effectif de la somme due.

6.5 La cession d’actions est soumise à l’exercice du droit de premier refus devant être exercé by les autre Action-

naires au pro rata de leurs actions dans la Société.

Art. 7. Rachat d’actions
La Société est autorisée à procéder au rachat de ses propres actions dans les limites et conditions fixées par l’Article

49-8 de la Loi. Le rachat d’Actions doit être approuvé par une résolution de l’assemblée des Actionnaires adoptée à une
majorité des deux tiers des Actions représentées lors de l’assemblée, et doit recueillir le consentement du Gérant Com-
mandité.

Art. 8. Responsabilité des Actionnaires 
Les propriétaires d’Actions de Commanditaires sont responsables uniquement à hauteur de leur apport au capital de

la Société.

La responsabilité du Gérant Commandité est illimitée.

Art. 9. Assemblées des Actionnaires 
L’assemblée générale annuelle des Actionnaires aura lieu, conformément à la législation en vigueur au Luxembourg,

au siège social de la Société à Luxembourg, ou en un autre endroit au Luxembourg qui sera indiqué dans la lettre de
convocation, le 5 novembre 2001 à 10.00 heures. Si ce jour est un jour férié pour la ville de Luxembourg, l’assemblée
générale annuelle se tiendra le jour ouvré suivant.

D’autres assemblées des Actionnaires peuvent être tenues aux lieux, dates et heures qui seront indiqués dans les

lettres de convocation respectives auxdites assemblées.

Toutes les assemblées des Actionnaires seront présidées par le Gérant Commandité.

Art. 10. Avis de convocation, quorum, représentation, majorité 
Les périodes des avis de convocation et les règles de quorum exigés par la loi s’appliquent aux assemblées des ac-

tionnaires de la société, ainsi qu’à la tenue de ces assemblées, sauf disposition contraire des présentes.

Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut agir à toute assemblée des actionnaires en désignant une

autre personne par écrit (sous la forme d’un original, ou par télécopie, câble, télégramme ou télex) que cette personne
soit ou non un actionnaire, pour être son représentant.

Sauf disposition contraire de la Loi ou disposition stipulation contraires des présents Statuts, les résolutions d’une

assemblée des actionnaires seront adoptées à la majorité simple des actions représentées et votant à l’assemblée, et
avec l’accord du Gérant Commandité.

Art. 11. Avis de convocation 
Les Assemblées des Actionnaires seront convoquées par le Gérant Commandité ou par le Conseil de Surveillance,

sous la forme d’un avis indiquant l’ordre du jour et envoyé par courrier recommandé au moins huit jours avant la date
fixée pour l’Assemblée à chaque Actionnaire, à l’adresse figurant au registre des actionnaires de la Société ou par voie
d’annonce dans la presse luxembourgeoise et dans le Mémorial.

27097

Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des Actionnaires et s’ils déclarent avoir

été informés de l’ordre du jour de la réunion, l’assemblée peut avoir lieu sans avis de convocation préalable. 

Le Gérant Commandité peut déterminer les conditions légitimes auxquelles doivent se conformer les Actionnaires

afin de pouvoir prendre part à toutes les assemblées d’Actionnaires.

Art. 12. Pouvoirs de l’assemblée des Actionnaires
Toute Assemblée des Actionnaires de la Société régulièrement constituée représente la totalité de la masse des Ac-

tionnaires de la Société. Elle ne peut généralement adopter des résolutions sur quelque point que ce soit qu’avec le
consentement du Gérant Commandité. 

Art. 13. Gestion
La Société sera gérée par le Gérant Commandité qui sera le gérant associé responsable et qui sera donc personnel-

lement, conjointement et individuellement responsable au nom de la Société de tout passif auquel l’actif de la Société
ne permettra pas de faire face.

Le Gérant Commandité est investi des pouvoirs les plus étendus qui lui permettent d’effectuer tous les actes d’admi-

nistration et de décision dans l’intérêt de la Société et qui ne sont pas expressément réservés, d’après la Loi ou d’après
les présents Statuts, à l’assemblée des Actionnaires ou au Conseil de Surveillance.

Le Gérant Commandité aura notamment, sous réserve des dispositions de l’Article 16 ci-dessous, le pouvoir, au nom

et pour le compte de la Société, de mener à bien toutes les missions, d’exécuter tous les actes, de conclure et d’exécuter
tous les contrats et autres opérations réputés nécessaires, opportuns, utiles ou accessoires à cet effet. Sauf dispositions
expresses contraires, le Gérant Commandité aura, et aura tout pouvoir d’exercer selon sa propre appréciation, tous
les droits et pouvoirs nécessaires ou opportuns pour mener à bien les objectifs de la Société.

Art. 14. Signataires autorisés 
La Société sera engagée par la signature du Gérant Commandité ou encore par la signature individuelle ou les signa-

tures conjointes et solidaires des autres personnes auxquelles le Gérant Commandité aura délégué le pouvoir de signa-
ture. Le Gérant Commandité prendra cette décision selon sa propre appréciation.

Art. 15. Non rémunération du Gérant Commandité 
Le Gérant Commandité ainsi que les membres ou les salariés de l’entité désignée comme tel ne recevront aucune

rémunération de la part de la Société en contrepartie des tâches effectuées.

Art. 16. Conseil de Surveillance 
Les affaires internes de la Société ainsi que sa situation financière et en particulier ses registres et livres comptables

seront contrôlés par un comité de surveillance composé d’au moins trois membres (désigné dans le présent document
par le «Conseil de Surveillance»).

Le Conseil de Surveillance sera consulté sur certains points par le Gérant Commandité en tant que de besoin et ainsi

que ce dernier en aura décidé. Le Conseil de Surveillance autorisera le Gérant Commandité à engager toutes les actions
qui, selon la Loi ou en vertu des présents Statuts, outrepassent les pouvoirs du Gérant associé.

Les membres du Conseil de Surveillance peuvent être ou non des Actionnaires, autre que le Gérant Commandité.

Les membres du Conseil de Surveillance sont désignés par un vote à la majorité relative de l’assemblée des Actionnaires,
pour une période maximale de six ans renouvelable. Les membres du Conseil de Surveillance sont susceptibles d’être
démis de leurs fonctions à tout moment et à la seule discrétion de l’assemblée des Actionnaires.

Les membres sortants du Conseil de Surveillance sont rééligibles.
Dans l’éventualité où un siège au Conseil de Surveillance se trouverait vacant pour cause de décès, de départ à la

retraite ou pour toute autre raison, les membres restants du Conseil de Surveillance peuvent se réunir et élire par un
vote à la majorité un nouveau membre afin de pourvoir le siège vacant jusqu’à la prochaine assemblée des Actionnaires.

Si la majorité des membres du Conseil de Surveillance abandonne la charge, une assemblée des Actionnaires sera

convoquée afin de mettre en place un nouveau Conseil de Surveillance.

L’assemblée des Actionnaires fixera le montant de la rémunération des membres du Conseil de Surveillance.
Le Conseil de Surveillance sera convoqué par son président (désigné par le Conseil parmi ses membres) ou par le

Gérant Commandité.

Toute réunion du Conseil de Surveillance fera l’objet d’une convocation écrite adressée à tous ses membres avec un

préavis minimal de huit jours, excepté dans les cas d’urgence dont la nature sera alors précisée dans la convocation à
l’assemblée. Ce préavis peut être annulé après acceptation écrite (soit par courrier original, par télégramme, télex ou
télécopie) de chacun des membres. Un avis de convocation distinct ne sera pas nécessaire pour les assemblées ayant
fait l’objet d’un calendrier précisant les dates et lieux auxquels sera tenues chacune d’entre elles et adopté par une ré-
solution du Conseil de Surveillance. Si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à une
réunion du Conseil de Surveillance et s’ils déclarent avoir été dûment informés de l’ordre du jour de la réunion, la réu-
nion peut être tenue sans autre forme de préavis.

Tout membre peut se faire représenter par un autre membre à une réunion du Conseil de Surveillance en lui donnant

un pouvoir écrit (par courrier original, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique).

Le Conseil de Surveillance peut procéder à des délibérations et exercer valablement ses fonctions uniquement si au

moins la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions seront approuvées si elles sont adoptées
à la majorité des voix des membres présents ou représentés lors de la réunion. Des résolutions peuvent également être
adoptées sous forme d’un ou de plusieurs documents écrits officiels signés par tous les membres.

Art. 17. Procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance 
Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance seront signées par son président ou, en l’absence de

celui-ci, par le président pro tempore qui aura présidé une réunion par intérim. Les copies ou extraits de ces minutes

27098

destinés à être produits dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de tout autre action juridique devront être signés
par le président ou par le président pro tempore ou encore par deux membres du Conseil de Surveillance.

Art. 18. Exercice comptable - Comptabilité
L’exercice comptable de la Société débutera le 1

er 

septembre et se terminera le 31 août de chaque année.

Les comptes de la Société seront établis en Euros.
Les comptes de la Société seront vérifiés par un auditeur extérieur qui sera désigné pour une période fixée périodi-

quement par un vote à la majorité relative de l’Assemblée Générale des Actionnaires.

Art. 19. Affectation des bénéfices 
Cinq pour cent (5 %) du bénéfice net annuel de la Société sera affecté à la réserve légale conformément à la Loi. Cette

affectation cessera d’être exigée dès que le montant de la réserve légale sera égal à dix pour cent (10 %) du capital social
nominal émis de la Société tel que défini à l’Article 5 ci-dessus et en fonction des augmentations et réductions de capital
périodiques.

Les Actionnaires de la Société possèdent des droits à dividendes par action égaux.
Le Gérant Commandité déterminera la manière dont sera réparti le bénéfice net annuel. Il décidera, en fonction de

sa propre appréciation, de procéder à la distribution périodique de dividendes selon sa conviction de servir au mieux
les objectifs et les principes directeurs de la Société. L’Assemblée Générale des Actionnaires devra approuver la décision
de verser des dividendes prise par le Gérant Commandité ainsi que l’affectation des bénéfices que celui-ci aura proposée.

Les dividendes peuvent être versés en Euros ou en toute autre monnaie sur décision du Gérant Commandité. Le

Gérant Commandité déterminera également les dates et lieux auxquels seront effectués ces versements.

Le Gérant Commandité peut décider de verser des acomptes sur dividendes dans les conditions et limites fixées par

la Loi.

Art. 20. Dissolution et liquidation 
La Société peut faire l’objet d’une dissolution volontaire prononcée par résolution de l’assemblée des Actionnaires

et assortie du consentement du Gérant Commandité ou en cas de survenance de l’un des événements mentionnés à
l’Article 2 ci-dessus.

La liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou personnes morales) nommés par

l’assemblée des Actionnaires qui fera également leurs pouvoirs et leur rémunération.

Art. 21. Modifications 
Les présents Statuts peuvent faire l’objet de modifications périodiques adoptées lors d’une assemblée des Actionnai-

res, sous réserve du respect des exigences de quorum et de majorité définies par la législation luxembourgeoise et sous
réserve d’accord du Gérant Commandité.

Art. 22. Juridiction compétente 
Les questions non régies par les présents Statuts seront réglées par l’application des dispositions contenues dans la

législation luxembourgeoise et, en particulier, dans la Loi.

<i>Souscription

Les parties comparantes déclarent souscrire les 4.246.943 actions émises par la Société, de la façon suivante:
- ACCENTURE MINORITY III LTD souscrit à 3 Actions de Commandité et les paie par un apport en numéraire d’un

montant total de EUR 3,75;

et
- les autres parties comparantes souscrivent à 4.246.940 Actions de Commanditaire (détaillés ci-dessous) et les paient

par les apports en nature suivants: 

Noms des partenaires

 Nombre d’Actions

 Valeur des

Valeur des Actions

de Commanditaires

 participations

de Commanditaire

souscrites

détenues dans

souscrites

Accenture ANS

EUR

- Anne Cecilie Fagerlie   . . . . . . . . . . . . . . . . 

55.235

177.898

69.043,75

- Anne Foss Abrahamsem  . . . . . . . . . . . . . . 

38.990

125.577

48.737,5

- Anne Steen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

 193.75

- Anne Henning Ramstad . . . . . . . . . . . . . . . 

 38.990

 125.577

48.737,5

- Arve Sogn Andersen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

296.765

 955.806

370.956,25

- Bente Svensson  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.491

104.645

40.613,75

- Bjørn Boberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Bjørn Ivar Danielsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 

305.558

984.127

381.947,5

- Bjørn Tore Holte   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Cato Willy Rindal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Christian Selmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32.491

104.645

40.613,75

- Eivind Gjemdal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

 498.5

193.75

- Eivind Roald  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 38.990

125.577

48.737,5

- Erik Fjornes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

38.990

125.577

48.747,5

- Espen Simensen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Geir Bårdstu   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

- Gustav Heiberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

155

498.5

193.75

27099

L’apport total des participations de Accenture ANS à faire à la Société doit être comptabilisé selon l’évaluation de la

gérance et affecté d’un montant de EUR 5.308.675 versé sur le compte capital social de la Société.

L’apport en numéraire a été certifié au notaire instrumentaire par un certificat de blocage émis par Bank of America

en date du 23 mai 2001 et les apports en nature ont été certifiés par le notaire instrumentaire par un rapport d’évalua-
tion émis par la FIDUCIAIRE BILLON, réviseur d’entreprises, en date du 23 mai 2001, en conformité avec l’article 26-
1 de la Loi, lequel conclut comme suit:

«On the basis of the work performed, as outlined above, we have no comments to make on the total value of the

contribution, which consists in a total number of 13,678,314 «interests», representing 49,99 % of the total number of

- Halvar Traa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

- Hans Otto Hilsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

 498.5

193.75

- Henning Normann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

- Henrik Hansen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

229.799

 740.126

287.248,75

- Henrik Lund-Hanssen . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

 498.5

193.75

- Håkon Breda-Ruud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

- Håkon Jacobsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.239

 136.041

 52.798,75

- Idar Ytterdal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.737

156.970

 60.921,25

1. Ingemar Karlsson   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48.737

156.970

60.921,25

2. Jan Åge Rønnestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

294.179

947.478

 367.723,75

3. Joe Taralrud   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

4. Just Erik Naess   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239.291

 770.697

299.113,75

5. Ketil Thorsen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

6. Kim Zimmer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

289.164

931.326

361.455

7. Kjetil Gudmundsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

 193.75

8. Kristian Kvam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

239.291

770.697

299.113,75

9. Kristian Larsen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.239

136.041

52.798,75

10. Leif Arne Rones   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

11. Martin Fuhr Bolstad   . . . . . . . . . . . . . . . .

86.644

279.059

108.305

12. Nils Øveraas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 243.341

783.741

304.176,25

13. Olav Skjaeveland  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

14. Olav Storli Ulvund . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

 193.75

15. Paul Arne Kristensen . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

 193.75

16. Per Erik Strømsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

282.037

 908.371

352.546,25

17. Per Ingvald Fredriksen   . . . . . . . . . . . . . .

155

 498.5

193.75

18. Petter Hesselberg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

 193.75

19. Petter-Idar Jenssen  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 155

 498.5

193.75

20. Pål K. Fevang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 243.829

785.313

 304.786,25

21. Randi Arneberg Solli  . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

22. Rolf Kragerud  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

23. Roy Grønli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.990

125.577

 48.737,5

24. Sam Juul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 321.087

1.034.142

401.358,75

25. Sigurd Fristad   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

26. Sigurd Skjaeveland . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55.235

177.898

69.043,75

27. Stein Erik Moe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 42.239

136.041

 52.798,75

28. Svein Olsen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

29. Sverre Ruth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246.065

792.514

307.581,25

30. Thorleif Paus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

31. Thron Ivar Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

32. Tor Hauge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

33. Tor Krattebøl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.990

125.577

48.737,5

34. Tor Mesøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42.239

136.041

52.798,75

35. Tore Alm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

36. Tore Magnussen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

209.343

674.242

 261.678,75

37. Torunn Brandt   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

38. Trond Berntsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

39. Trond Moberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

40. Trygve Langholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

41. Witold Sitek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38.990

125.577

 48.737,5

42. Øystein Wiborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

 498.5

193.75

43. Øyvind Stangeby  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

155

498.5

193.75

Total:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.246.940

13.678.313

5.308,675

27100

«interests» held in Accenture ANS, a Norwegian partnership, and the contribution of which «interests» are at least
equal to the nominal value of the shares to be issued.»

Il résulte également d’un certificat en date du 23 mai 2001, émis par le représentant légal de la société Accenture

ANS (la «Filiale») que:

«Je, soussigné, Bjørn Ivar Danielsen, directeur (ou équivalent) de la Filiale, certifie ci-dessous, que à ce jour et sur base

des documents de la Filiale (à l’exclusion de tout autre document):

1. J’ai reçu procuration le 18 avril 2001 des partenaires de la Filiale, afin d’agir en leur nom.
2. Les Participations contribuées par les partenaires de la Filiale représentent approximativement la moitié du capital

de la Filiale et que les Participations sont proportionnelles au nombre d’actions souscrites par les partenaires de la Filiale
dans le capital de la Société.

3. Les Participations sont dûment inscrites au nom des partenaires. 
4. Les Participations ont été entièrement libérées.
5. Les partenaires sont propriétaires des Participations et ont la capacité pour disposer des Participations.
6. Les Participations ne font l’objet d’aucune limitation ou d’une restriction et ne sont grevées d’aucun gage ou d’autre

droit limitant leur transférabilité ou réduisant leur valeur.

7. Il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu desquels toute personne serait autorisée à de-

mander qu’une ou plusieurs Participations lui soit transférées.

8. Conformément à la loi norvégienne et à la convention de partenariat de la Filiale, les Participations sont librement

cessibles, à condition que les partenaires donnent leur approbation, laquelle approbation a été accordée sous la forme
d’un vote unanime lors d’une réunion de tous les partenaires; et

9. Toutes les formalités requises par la Norvège intervenant après la contribution en nature des Participations des

partenaires à la constitution de ACCENTURE MINORITY III NORWAY 1 SCA ont été ou seront effectuées après ré-
ception d’une copie certifiée conforme du présent acte notarié document ladite contribution en nature.»

Le dit certificat et le rapport d’évaluation, après signature ne variatur par le mandataire des parties comparantes et

le notaire instrumentant, resteront annexés aux présentes pour être enregistrés avec elles.

<i>Dispositions transitoires

Le premier exercice social commence aujourd’hui et finit le 31 août 2001. La première assemblée annuelle se tiendra

le 5 novembre 2001.

<i>Déclaration - Frais

Le notaire chargé de l’exécution du présent contrat déclare que les conditions prescrites par l’article 26 de la Loi du

10 août 1915 et ses modifications relatives aux sociétés commerciales ont été respectées et il en atteste expressément.

Le montant approximatif des coûts, dépenses, salaires ou charges, sous quelque forme que ce soit imputés ou facturés

à la Société à l’occasion de sa constitution est estimé à environ deux millions trois cent mille francs.

<i>Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires

Les parties comparantes, représentant la totalité du capital souscrit, considérant qu’elles ont été dûment convoquées,

ont tenu une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et, ayant déclaré l’Assemblée régulièrement consti-
tuée, ont adopté les résolutions suivantes à l’unanimité:

1. Le nombre des membres du Conseil de Surveillance est fixé à trois et le nombre de Commissaires aux Comptes

est fixé à un.

2. Les personnes dont les noms suivent sont nommées membres du Conseil de Surveillance de la Société:
- Michael L. Emmons, attorney-at-law, demeurant à 15 Vida Descanda, Orinda 94563, California, U.S.A.;
- Vernon J. Ellis, consultant, demeurant à Chester Row 44, London SW1 W8JP, United Kingdom;
- Michael G. McGrath, company director, demeurant à Adobe Lane, Los Altos Hill 25440, 94022 California, U.S.A.
3. La société PricewaterhouseCoopers, S.à r.l, dont le siège social est situé 400, route d’Esch à L-1014 Luxembourg,

est nommée Commissaire aux Comptes de la Société.

4. Le siège social de la Société est établi au 58, rue Charles Martel à L-2134 Luxembourg.
5. Le mandat des membres du Conseil de Surveillance de la Société prendra fin à l’occasion de l’Assemblée Générale

Annuelle qui se tiendra en 2002.

6. Le mandat du Commissaire aux Comptes prendra fin à l’occasion de l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra

en 2002.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’Anglais déclare que, sur requête des parties présentes ci-dessus men-

tionnées, le présent acte a été rédigé en anglais et sera suivi d’une version française. A la demande des mêmes parties
présentes, en cas de divergence entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra. 

Lecture du document ayant été donnée aux personnes présentes, dont les nom, prénom, état civil et domicile res-

pectifs sont connus du notaire, lesdites personnes présentes ont devant notaire signé ensemble le présent acte.

Signé: J.F. Bouchoms, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 30 mai 2001, vol. 9CS, fol. 28, case 11. – Reçu 2.141.516 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(37278/211/890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 juin 2001.

Luxembourg, le 12 juin 2001.

J. Elvinger.

27101

LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.813.

In the year two thousand one, on the twenty-eigth of June.
Before Us, Maître Marthe Thyes-Walch, notaire, residing in Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, a

société d’investissement à capital variable (SICAV), established in L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller, R.C. Luxembourg,
section B number 29.813, incorporated under the name of LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITY by deed, on the
27th of January 1989, published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 77 of the 28th
of March 1989, the Articles of Incorporation of which have been amended for the last time by deed, on the 14th of May
2001, deposited on the 1st of June 2001 at the greffe du registre du commerce et des sociétés in Luxembourg with the
view to its publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mr Marc De Leye, bank clerk, residing in Pétange.
The chairman appointed as secretary Mrs Marie-Christine Piasta, bank clerk, residing in Yutz (France).
The meeting elected as scrutineer Mrs Suzanne Dos Santos, bank clerk, residing in Lintgen.
The chairman declared and requested the notary to act:
I. That the agenda of the meeting is the following:

- Article 1. paragraph 1: Modification of the definition of a «settlement» day as follows:
«Settlement day» or «Value Date» means the latest day on which cash in relation to a subscription or redemption of

shares in any Fund must be paid to or by the Company in its account held with the Custodian Bank, or in relation to
conversion of shares of a Fund into shares to another Fund, the day on which the transfer of the relative cash between
the Funds will be effective».

- Article 13. paragraph 7. point b) adding a last point as follows:
«reasonable publicity and marketing expenses incurred for the Company’s promotion».

- «Article 14. paragraph 1 modified as follows: 
«Subject to the provisions of the law and as in these Articles provided, any shareholder shall have the right to request

the redemption of all or any Shares of any class held by him and the Company shall upon receipt by it or its duly author-
ised agent of notice (in such form as the Directors may time to time determine) from a shareholder requesting the re-
demption of all or any Shares of any class held by him, redeem such Shares for an amount equal to the current
Redemption Price for Shares of that class payable on the applicable Settlement Day after the relevant day on which the
Shares are redeemed. The redemption of Shares pursuant hereto shall be effected and shall take effect on the relevant
Dealing Day».

- «Article 14. paragraph 5 modified as follows:
«Without prejudice to the provisions of Article 16., if there fall to be redeemed (pursuant to requests for redemption

or conversion) on any Dealing Day more than ten per cent of the number of Shares of the class concerned then in issue,
the Directors may declare that such redemptions are deferred for a period from then until a Dealing Day being not
more than ten Dealing Days thereafter and the Company shall not be bound to redeem any shares of the class con-
cerned before that Dealing Day. On that Dealing Day or if, in the case of a request for conversion, such day is not a
Dealing Day for both classes of shares concerned (hereinafter referred to as «qualifying day») the next following quali-
fying day (or such earlier Dealing Day or qualifying day, as the case may be, as the Directors may determine) requests
for redemption or conversion which have been deferred (and not effectively withdrawn) shall be complied with in pri-
ority to later requests and shall not be the subject of another deferral pursuant to this paragraph. If a request is deferred
pursuant to this paragraph the relevant Dealing Day shall be the day on which such request is complied with and the
request shall be deemed to have been received at the opening of business of that day».

- Article 16. adding a new paragraph f:
«f) in any period where a material portion of the assets of a Fund are invested in open-ended investment funds and

the calculation of the net asset value of such investment funds is suspended;»

- Article 25. current Article 25 cancelled and replaced by the following paragraphs:
«1. The Directors are vested with all powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s

object. All powers not expressly reserved by the Law or by the present Articles to the general meeting of shareholders
are in the competence of the Directors.

2. The Directors shall have in particular the power to determine the corporate and investment policy and the course

of conduct of the management and business affairs of the company, based upon the principle of spreading of risks and
shall similarly fix all the policies and restrictions which shall be applicable to the investments of the Company.

3. The Directors shall have discretionnary powers to determine any further restrictions on borrowings or on the

pledging of the Company’s assets.»

II.- That the present extraordinary general meeting has been convened by registered letters containing the agenda

and sent on the 8th of June, 2001, to the shareholders, all of them being registered shareholders.

III. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list,

signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will
be registered with this minute.

27102

IV. That it appears from the attendance list, that from nine million four hundred and two thousand five hundred sev-

enty-two (9.402.572) shares, representing the whole capital of the corporation, eight million two hundred forty-nine
thousand four hundred seventy-five (8.249.475) shares are represented at the present extraordinary general meeting.

V. That in accordance with article 67-1 (2) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, the present

meeting is regularly constituted and can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to modify the definition of a «settlement day» in the paragraph 1 of Article 1 of the Articles of

Incorporation as follows: 

«Settlement day» or «Value Date» means the latest day on which cash in relation to a subscription or redemption of

shares in any Fund must be paid to or by the Company in its account held with the Custodian Bank, or in relation to
conversion of shares of a Fund into shares to another Fund, the day on which the transfer of the relative cash between
the Funds will be effective.»

<i>Second resolution

The meeting decides to add a last point to the point b) of paragraph 7 of Article 13 of the Articles of Incorporation,

which will read as follows:

«- reasonable publicity and marketing expenses incurred for the Company’s promotion.»

<i>Third resolution

The meeting decides to modify the paragraph 1 of Article 14 of the Articles of Incorporation, which will read as fol-

lows:

«Subject to the provisions of the law and as in these Articles provided, any shareholder shall have the right to request

the redemption of all or any Shares of any class held by him and the Company shall upon receipt by it or its duly author-
ised agent of notice (in such form as the Directors may time to time determine) from a shareholder requesting the re-
demption of all or any Shares of any class held by him, redeem such Shares for an amount equal to the current
Redemption Price for Shares of that class payable on the applicable Settlement Day after the relevant day on which the
Shares are redeemed. The redemption of Shares pursuant hereto shall be effected and shall take effect on the relevant
Dealing Day.»

<i>Fourth resolution

The meeting decides to modify the paragraph 5 of Article 14 of the Articles of Incorporation, which will read as fol-

lows:

«Without prejudice to the provisions of Article 16., if there fall to be redeemed (pursuant to requests for redemption

or conversion) on any Dealing Day more than ten per cent of the number of Shares of the class concerned then in issue,
the Directors may declare that such redemptions are deferred for a period from then until a Dealing Day being not
more than ten Dealing Days thereafter and the Company shall not be bound to redeem any shares of the class con-
cerned before that Dealing Day. On that Dealing Day or if, in the case of a request for conversion, such day is not a
Dealing Day for both classes of shares concerned (hereinafter referred to as «qualifying day») the next following quali-
fying day (or such earlier Dealing Day or qualifying day, as the case may be, as the Directors may determine) requests
for redemption or conversion which have been deferred (and not effectively withdrawn) shall be complied with in pri-
ority to later requests and shall not be the subject of another deferral pursuant to this paragraph. If a request is deferred
pursuant to this paragraph the relevant Dealing Day shall be the day on which such request is complied with and the
request shall be deemed to have been received at the opening of business of that day.»

<i>Fifth resolution

The meeting decides to add a new paragraph f) to Article 16 of the Articles of Incorporation, which will read as fol-

lows:

«f) in any period where a material portion of the assets of a Fund are invested in open-ended investment funds and

the calculation of the net asset value of such investment funds is suspended;»

<i>Sixth resolution

The meeting decides to cancel the current Article 25 of the Articles of Incorporation and to replace it by the following

paragraphs:

«1. The Directors are vested with all powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s

object. All powers not expressly reserved by the Law or by the present Articles to the general meeting of shareholders
are in the competence of the Directors.

2. The Directors shall have in particular the power to determine the corporate and investment policy and the course

of conduct of the management and business affairs of the company, based upon the principle of spreading of risks and
shall similarly fix all the policies and restrictions which shall be applicable to the investments of the Company.

3. The Directors shall have discretionnary powers to determine any further restrictions on borrowings or on the

pledging of the Company’s assets.»

There being no further business, the meeting is terminated.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

27103

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French version, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, the said persons appearing signed together with us, the

notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille un, le vingt-huit juin.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société  d’investissement  à capital variable

(SICAV) LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, ayant son siège social à L-2519 Luxembourg, 1, rue Schiller, ins-
crite au registre du commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 29.813, constituée sous la dé-
nomination de LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITY suivant acte reçu en date du 27 janvier 1989, publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 77 du 28 mars 1989 et dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 14 mai 2001, déposé en date du 1

er 

juin 2001 au greffe du registre du

commerce et des sociétés à Luxembourg en vue de sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’assemblée est présidée par Monsieur Marc De Leye, employé de banque, demeurant à Pétange.
Monsieur le président désigne comme secrétaire Madame Marie-Christine Piasta, employée de banque, demeurant à

Yutz (France).

L’assemblée choisit comme scrutatrice Madame Suzanne Dos Santos, employée privée, demeurant à Lintgen.
Monsieur le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que la présente assemblée a pour ordre du jour:

- Article 1

er

, paragraphe 1: Modification de la définition du «jour de transaction» comme suit:

«Jour de paiement» ou «Jour de valeur» correspond au dernier jour lors duquel les fonds en relation avec une sous-

cription ou un rachat d’actions dans tout Fonds doivent être payés à, ou par, la Société auprès de ses comptes auprès
de la Banque Dépositaire ou, en relation avec les conversions d’actions d’un Fonds dans des actions d’un autre Fonds,
le jour où le transfert relatif des fonds entre les Fonds sera effectif.»

- Article 13. paragraphe 7, point b) ajout d’un dernier point comme suit:
«- frais raisonnables de publicité et de marketing encourus pour la promotion de la Société.»

- Article 14. paragraphe 1 modifié comme suit:
«Sous réserve des dispositions de la loi et des présents statuts, chaque actionnaire aura le droit de demander le rem-

boursement de l’ensemble de toutes ou d’une partie des actions de toute classe détenue par lui et la Société rembour-
sera ces actions pour un montant égal au prix de rachat courant offert pour des actions de cette classe suite à la
réception par elle ou par son agent autorisé d’une notification (dans une forme que les administrateurs détermineront
de temps à autre) de la part de l’actionnaire demandant le remboursement de l’ensemble de toutes ou d’une partie des
actions de n’importe quelle classe détenue par lui et payable au Jour de paiement applicable suivant le jour auquel le
remboursement des actions est effectué. Un tel remboursement d’actions sera effectué et prendra effet lors du Jour de
transaction applicable.»

- Article 14. paragraphe 5 modifié comme suit:
«Sans préjudice des dispositions de l’article 16, si, (suite à des demandes de remboursement ou de conversion), lors

d’un Jour de transaction plus de 10 pour cent du nombre d’actions du fonds concerné en circulation sont à rembourser,
les administrateurs peuvent décider que ces remboursements sont différés pour une période allant jusqu’à un Jour de
transaction ultérieur, sans que ce délai ne dépasse dix Jours de transaction et la Société ne sera pas tenue de rembourser
des actions du Fonds concerné avant un tel Jour de transaction. Lors d’un tel Jour de transaction ou si, en cas de de-
mande de conversion, un tel jour n’est pas un Jour de transaction pour les deux Fonds concernés (lequel sera désigné
ci-après comme «jour utile») le prochain jour utile (ou le Jour de transaction ou le jour utile antérieur, selon le cas, tel
que décidé par les administrateurs) les demandes de remboursement ou de conversion qui auront été différées (et qui
n’auront pas été effectivement retirées) seront exécutées en priorité à des demandes ultérieures et ne seront pas su-
jettes à une autre décision de report conformément au présent paragraphe. Si l’exécution d’une demande doit être re-
portée conformément au présent paragraphe, le Jour de transaction alors applicable sera le jour lors duquel la demande
sera exécutée et la demande sera censée avoir été reçue à l’ouverture des bureaux de ce jour-là».

- Article 16, ajout d’un nouveau paragraphe f):
«f) pendant toute période durant laquelle une part importante des actifs d’un fonds est investie dans des fonds de

placement de type ouvert et que le calcul de la valeur nette d’inventaire de ces fonds est suspendue.»

- Article 25: l’actuel article 25 est annulé et remplacé par les paragraphes suivants:
«1. Les administrateurs sont investis de tous pouvoirs pour accomplir tout acte nécessaire ou utile à l’accomplisse-

ment du but de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence des administrateurs.

2. Les administrateurs auront en particulier le pouvoir de déterminer la politique sociale, la politique d’investissement

et la conduite à suivre pour l’administration et les affaires de la Société, sur la base du principe de la répartition des
risques et fixeront également toutes les politiques et restrictions qui seront applicables aux investissements de la Socié-
té.

3. Les administrateurs auront le pouvoir discrétionnaire de décider des restrictions supplémentaires en matière d’em-

prunts ou d’affectation en gage des actifs de la Société.»

27104

II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées à la poste conte-

nant l’ordre du jour, adressées aux actionnaires, tous nominatifs, en date du 8 juin 2001.

III. Que les actionnaires présents ou représentés et les actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de pré-

sence, signée ne varietur par les membres du bureau et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les pro-
curations, resteront annexées au présent acte pour être soumises en même temps aux formalités de l’enregistrement.

IV. Qu’il résulte de ladite liste de présence que sur les neuf millions quatre cent deux mille cinq cent soixante-douze

(9.402.572) actions actuellement en circulation, représentant l’intégralité du capital social, huit millions deux cent qua-
rante-neuf mille quatre cent soixante quinze (8.249.475) actions sont dûment représentées à la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire.

V. Que conformément à l’article 67-1 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente

assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour.

Ces faits ayant été exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, a pris à l’unanimité

la résolution unique suivante:

<i>Première résolution

L’assemblée décide de modifier la définition du «jour de transaction» figurant au premier paragraphe de l’article 1

er

des statuts, laquelle aura désormais la teneur suivante: 

«Jour de paiement» ou «Jour de valeur» correspond au dernier jour lors duquel les fonds en relation avec une sous-

cription ou un rachat d’actions dans tout Fonds doivent être payés à, ou par, la Société auprès de ses comptes auprès
de la Banque Dépositaire ou, en relation avec les conversions d’actions d’un Fonds dans des actions d’un autre Fonds,
le jour où le transfert relatif des fonds entre les Fonds sera effectif.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée décide d’ajouter au point b) du septième paragraphe de l’article 13 des statuts, un dernier point ayant la

teneur suivante:

«- frais raisonnables de publicité et de marketing encourus pour la promotion de la Société.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 14 des statuts pour lui donner désormais la teneur

suivante: 

«Sous réserve des dispositions de la loi et des présents statuts, chaque actionnaire aura le droit de demander le rem-

boursement de l’ensemble de toutes ou d’une partie des actions de toute classe détenue par lui et la Société rembour-
sera ces actions pour un montant égal au prix de rachat courant offert pour des actions de cette classe suite à la
réception par elle ou par son agent autorisé d’une notification (dans une forme que les administrateurs détermineront
de temps à autre) de la part de l’actionnaire demandant le remboursement de l’ensemble de toutes ou d’une partie des
actions de n’importe quelle classe détenue par lui et payable au Jour de paiement applicable suivant le jour auquel le
remboursement des actions est effectué. Un tel remboursement d’actions sera effectué et prendra effet lors du Jour de
transaction applicable.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée décide de modifier le cinquième paragraphe de l’article 14 des statuts pour lui donner désormais la te-

neur suivante:

«Sans préjudice des dispositions de l’article 10, si, (suite à des demandes de remboursement ou de conversion), lors

d’un Jour de transaction plus de 10 pour cent du nombre d’actions du fonds concerné en circulation sont à rembourser,
les administrateurs peuvent décider que ces remboursements sont différés pour une période allant jusqu’à un Jour de
transaction ultérieur, sans que ce délai ne dépasse dix Jours de transaction et la Société ne sera pas tenue de rembourser
des actions du Fonds concerné avant un tel Jour de transaction. Lors d’un tel Jour de transaction ou si, en cas de de-
mande de conversion, un tel jour n’est pas un Jour de transaction pour les deux Fonds concernés (lequel sera désigné
ci-après comme «jour utile») le prochain jour utile (ou le Jour de transaction ou le jour utile antérieur, selon le cas, tel
que décidé par les administrateurs) les demandes de remboursement ou de conversion qui auront été différées (et qui
n’auront pas été effectivement retirées) seront exécutées en priorité à des demandes ultérieures et ne seront pas su-
jettes à une autre décision de report conformément au présent paragraphe. Si l’exécution d’une demande doit être re-
portée conformément au présent paragraphe, le Jour de transaction alors applicable sera le jour lors duquel la demande
sera exécutée et la demande sera censée avoir été reçue à l’ouverture des bureaux de ce jour-là.»

<i>Cinquième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à l’article 16 des statuts un nouveau paragraphe f) ayant la teneur suivante:
«f) pendant toute période durant laquelle une part importante des actifs d’un fonds est investie dans des fonds de

placement de type ouvert et que le calcul de la valeur nette d’inventaire de ces fonds est suspendue.»

<i>Sixième résolution

L’assemblée décide de supprimer l’actuel article 25 des statuts et de le remplacer par les paragraphes suivants:
«1. Les administrateurs sont investis de tous pouvoirs pour accomplir tout acte nécessaire ou utile à l’accomplisse-

ment du but de la Société. Tous pouvoirs non expressément réservés par la loi ou par les présents statuts à l’assemblée
générale des actionnaires sont de la compétence des administrateurs.

2. Les administrateurs auront en particulier le pouvoir de déterminer la politique sociale, la politique d’investissement

et la conduite à suivre pour l’administration et les affaires de la Société, sur la base du principe de la répartition des
risques et fixeront également toutes les politiques et restrictions qui seront applicables aux investissements de la Socié-
té.

27105

3. Les administrateurs auront le pouvoir discrétionnaire de décider des restrictions supplémentaires en matière d’em-

prunts ou d’affectation en gage des actifs de la Société.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d’une version française; à la requête des comparants et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite, les comparants prémentionnés ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. De Leye, M.-C. Piasta, S. Dos Santos, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 29 juin 2001, vol. 130 S, fol. 13, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

(42739/233/280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 juillet 2001.

LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 29.813. 

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(43416/233/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 juillet 2001.

THEIS LUXEMBOURG, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-6776 Grevenmacher, Zone Industrielle Potaschberg.

H. R. Luxemburg B 57.131. 

<i>Auszug aus der Ausseordentlichen Versammlung vom 18. Dezember 2000

Laut Auftrag der Gesellschafter beschliesst der teschnicher Geschäftsführer:
- das Kapital von LUF in Euro umzuwandeln
- das Kapital um 1.685,18 Euro zu erhöhen um es von seinem jetzigen Betrag von 198.314,82 Euro auf 200.000,00

Euro heraufzusetzen durch Einbringungen von freien Rücklagen

- dementsprechend den Nominalwert der Aktien anzupassen
- dementsprechend den Absatz 5.- der Satzung wie folgt zu ändern:
«Das Gesellschaftskapital beträgt 200.000,00 Euro (zweihundertausend Euro). Es ist eingeteilt in 1.000 Aktien zu je

200,00 Euro (zweihundert Euro)»

Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 2000, vol. 547, fol. 80, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01650/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2001.

MIDWEST HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.

Registered office: L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

STATUTES

In the year two thousand, on the nineteenth of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

1.- Thierry Reisch, avocat à la Cour, residing in L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
2.- Shiva Mir Motahari, avocat, residing in L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II,
here represented by Thierry Reisch, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
The proxy will remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.
Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized

between themselves:

Title I: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organised a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be

MIDWEST HOLDING S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.

Luxembourg, le 2 juillet 2001.

M. Thyes.

Luxembourg, le 6 juillet 2001.

Luxemburg, den 18. Dezember 2000.

27106

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred,

or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, nothwithstanding

such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company is established for a duration of ninety-nine years.

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of interests in any form whatsoever in other Luxembourg

or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the management, supervision
and development of these interests.

It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived from or complemental to such pat-

ents, and participate in the organisation, development, transformation and supervision of any company, remaining how-
ever always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) represented by three hundred and

ten (310) shares of one hundred Euros (100.- EUR) each.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.
The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders

deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title II: Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved

and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.

The corporation shall be bound by the sole signature of the chairman of the board directors or by the collective signa-
ture of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law. 

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligible.

Title III: General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the company properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits. 

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the 20th of December at 11.00 a.m. in Luxembourg at

the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday, the meeting
will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at part of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

Title IV: Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

27107

Title V: General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

<i>Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the 31st of December

2001.

2.- The first annual general meeting will be held in 2002.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up in cash so that the amount of thirty-one thousand Euros (31,000.- EUR) is now

available to the company, evidence thereof having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

<i>Evaluation of the capital

For the purposes of registration, the share capital is evaluated at one million two hundred fifty thousand five hundred

and thirty-seven Luxembourg Francs (1,250,537.- LUF).

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately ninety thousand Luxem-
bourg Francs (90,000.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions:

1) The registered office of the company is L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-

pality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:
a.- Thierry Reisch, avocat à la Cour, residing in L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, Chairman.
b.- Shiva Mir Motahari, avocat, residing in L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
c.- Claude Pauly, avocat à la Cour, residing in L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

4) Is appointed as statutory auditor:
- Romain Schumacher, conseiller comptable et fiscal, residing in Olm.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2005.

6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the

present articles of incorporation, the general meeting authorizes the board of directors to delegate part of all of its
powers to one or more members of the board of directors.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the same appearing per-
sons and in case of divergences between the English and the French text, the English text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mersch, on the day named at the beginning of the document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed. 

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.

Ont comparu:

1.- Maître Thierry Reisch, avocat à la Cour, demeurant à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
2.- Maître Shiva Mir Motahari, avocat, demeurant à L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II,
ici représentée par Maître Thierry Reisch, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé.
La procuration restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

1.- Thierry Reisch, prenamed, three hundred and nine shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
2.- Shiva Mir Motahari, prenamed, one share   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: three hundred and ten shares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

27108

Lesquels comparants ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme holding qu’ils vont constituer entre

eux:

Titre I

er

: Dénomination, Siège social, Objet, Durée, Capital social

Art. 1

er

. Il est formé une société anonyme, sous la dénomination de MIDWEST HOLDING S.A.

Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être créé par simple décision du conseil d’administration des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Du-

ché de Luxembourg qu’à l’étranger.

Au cas où le conseil d’administration estime que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou

social, de nature à compromettre l’activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l’étranger se produi-
ront ou seront imminents, il pourra transférer le siège social provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de
ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la société, laquel-
le, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

La société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l’acquisition par achat, souscription du toute
autre manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces,
la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. Elle peut également acquérir et mettre en valeur toutes
marques ainsi que tous brevets et autres droits dérivant de ces brevets ou pouvant les compléter, participer à la cons-
titution, au développement, à la transformation et au contrôle de toutes sociétés, le tout en restant dans les limites de
la loi du trente et un juillet mil neuf cent vingt-neuf sur les sociétés holding.

Art. 3. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR), représenté par trois cent dix (310) actions

de cent euros (100,- EUR) chacune.

Toutes les actions sont au porteur, sauf dispositions contraires de la loi.
Le capital souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires

statuant comme en matière de modifications des statuts.

La société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites fixées par la loi.

Titre II: Administration, Surveillance

Art. 4. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés

pour un terme qui ne peut excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Art. 5. Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale. Le conseil d’administration
ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat entre
administrateurs, qui peut être donné par écrit, télex ou téléfax étant admis.

En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax. Une décision

prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision prise à
une réunion du conseil d’administration.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix.

Art. 6. Le conseil d’administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs administrateurs,

directeurs, gérants ou autres agents.

La société se trouve engagée soit par la signature individuelle du Président du Conseil d’Administration, soit par la

signature collective de deux administrateurs.

Art. 7. Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le conseil

d’administration agissant par son président ou deux administrateurs.

Art. 8. Le conseil d’administration est autorisé à procéder à des versements d’acomptes sur dividendes conformé-

ment aux conditions et suivant les modalités fixées par la loi.

Art. 9. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, ils sont nommés pour un terme qui

ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.

Titre III: Assemblée Générale et Répartition des bénéfices

Art. 10. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convoca-
tions pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lors-
que tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de
l’ordre du jour.

L’assemblée générale décide de l’affectation ou de la distribution du bénéfice net.

Art. 11. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit de plein droit au siège social ou à tout autre endroit

de la commune du siège indiqué dans l’avis de convocation, le 20 décembre à 11.00 heures. Si ce jour est férié, l’assem-
blée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 12. Par décision de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, tout ou partie des bénéfices et réser-

ves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l’amortissement du capital
par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d’une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans
que le capital exprimé ne soit réduit. Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui

27109

bénéficient des mêmes droits que les titres annulés, à l’exclusion du droit au remboursement de l’apport et du droit de
participation à la distribution d’un premier dividende attribué aux actions non amorties.

Titre IV: Exercice social, Dissolution

Art. 13. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, statuant suivant les modalités prévues

pour les modifications des statuts. 

Titre V: Disposition Générale

Art. 15. La loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et la loi du trente et un juillet mil neuf

cent vingt-neuf ainsi que leurs modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y est pas dérogé par
les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1.- Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2001.
2.- La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2002.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire aux actions du capital social com-

me suit: 

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente

et un mille euros (31.000,- EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la nouvelle société, ainsi qu’il en a été justifié
au notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire déclare avoir vérifié l’existence des conditions exigées par l’article 26 de la loi du dix août

mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Evaluation du capital

Pour les besoins de l’enregistrement le capital social est évalué à un million deux cent cinquante mille cinq cent trente-

sept francs luxembourgeois (1.250.537,- LUF).

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de quatre-vingt-dix mille
francs luxembourgeois (90.000,- LUF).

<i>Assemblée Générale Extraordinaire

Et à l’instant les comparants, ès qualités qu’ils agissent, se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à la-

quelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à
l’unanimité des voix, pris les résolutions suivantes:

1) L’adresse de la société est fixée à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.
L’assemblée autorise le conseil d’administration de fixer en tout temps une nouvelle adresse dans la localité du siège

social statutaire.

2) Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.

3) Sont nommés administrateurs:
a.- Maître Thierry Reisch, avocat à la cour, demeurant à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, Président.
b.- Maître Shiva Mir Motahari, avocat, demeurant à L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
c.- Maître Claude Pauly, avocat à la Cour, demeurant à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier.

4) Est nommé commissaire:
- Monsieur Romain Schumacher, conseiller comptable et fiscal, demeurant à Olm.

5) Les mandats des administrateurs et du commissaire expireront immédiatement après l’assemblée générale statu-

taire de 2005.

6) En vertu de l’article 60 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et en vertu de l’article six des

présents statuts, l’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à
une ou plusieurs personnes du conseil d’administration.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des comparants, le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en cas de diver-
gences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

1.- Maître Thierry Reisch, prénommé, trois cent neuf actions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
2.- Maître Shiva Mir Motahari, prénommée, une action   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Total: trois cent dix actions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

27110

Dont acte, fait et passé à Mersch, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: T. Reisch, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2000, vol. 416, fol. 39, case 2. – Reçu 12.505 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

(01704/228/260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

MONBLAN HOLDING S.A., Holdingaktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend, den achtzehnten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtswohnsitz in Mersch.

Sind erschienen:

1.- CITI TRUST S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, hier vertreten durch Herrn Egon Bentz,

Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungsrates mit Einzelzeichnungs-
recht.

2.- IMD S.A., mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II, hier vertreten durch Herrn Egon Bentz, vorge-

nannt, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verwaltungsrates mit Einzelzeichnungsrecht.

Vorgenannte Personen ersuchten den unterzeichneten Notar, die Satzungen einer von ihnen zu gründenden Aktien-

gesellschaft wie folgt zu beurkunden: 

I.- Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital

Art. 1. Es wird eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung MONBLAN HOLDING S.A. gegründet.
Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros so-

wohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch die-

ses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet
werden, so kann der Verwaltungsrat den Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung nor-
maler Verhältnisse ins Ausland verlegen; diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität
der Gesellschaft, die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.

Die Gesellschaft wird auf unbeschränkte Dauer errichtet.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung unter irgendeiner Form in andern luxemburgischen oder ausländi-

schen Unternehmen, alle anderen Anlagemöglichkeiten, der Erwerb von allen Arten von Wertpapieren durch Ankauf,
Zeichnung oder sonstwie, deren Veräusserung durch Verkauf, Abtretung oder Tausch, die Überwachung und die Ver-
wertung ihrer Beteiligungen.

Sie kann ebenfalls Fabrikmarken und Patente und alle mit diesen zusammenhängenden Rechte erwerben und verwer-

ten, an der Gründung, der Umänderung und der Kontrolle von Gesellschaften teilnehmen, das Ganze im Rahmen des
Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften. 

Art. 3. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt fünfhunderttausend US Dollar (USD 500.000,-), eingeteilt in fünfhun-

dert (500) Aktien mit einem Nominalwert von je eintausend US Dollar (USD 1.000,-).

Alle Aktien sind Inhaberaktien, es sei, dass das Gesetz es anders bestimmt. 
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-

ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderung zu fassen ist.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäss den darin festgelegten Bedingungen eigene Aktien erwer-

ben.

II.- Verwaltung - Überwachung

Art. 4. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht, die

keine Aktionäre sein müssen. Diese Verwaltungsratsmitglieder werden von der Generalversammlung für eine Dauer
ernannt, die am Ende der Generalversammlung in der sie benannt wurden, beginnt und dauert bis zum Ende der näch-
sten Generalversammlung. Die Verwaltungsratsmitglieder sind wiederwählbar.

Art. 5. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und

die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten; er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich
durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satzungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Der Verwaltungsrat
ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei ein Verwaltungsratsmit-
glied durch einen Kollegen vertreten werden kann (Vollmachten per Schreiben, Telex oder Telefax sind möglich). In
dringenden Fällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich oder telegraphisch
oder per Telefax abgeben. Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern genehmigt und

Mersch, le 8 janvier 2001. 

E. Schroeder.

27111

unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss. Die
Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit absoluter Stimmenmehrheit getroffen

Art. 6. Der Verwaltungsrat kann alle oder einen Teil seiner Befugnisse an einen oder mehrere Verwaltungsratsmit-

glieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere Bevollmächtigte übertragen.

Die Gesellschaft wird verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder

durch die Einzelunterschrift des Delegierten des Verwaltungsrates.

Art. 7. In sämtlichen Rechtssachen, sei es als Klägerin, sei es als Beklagte, wird die Gesellschaft vom Vorsitzenden

des Verwaltungsrates oder vom Delegierten des Verwaltungsrates vertreten.

Art. 8. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Interimdividenden zu zahlen unter den gesetzlich vorgeschriebenen Bedin-

gungen. 

Art. 9. Die Überwachung der Tätigkeit der Gesellschaft wird einem oder mehreren Kommissaren anvertraut; ihre

Amtszeit kann sechs Jahre nicht überschreiten. Sie sind wiederwählbar.

III.- Generalversammlung und Gewinnverteilung

Art. 10. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Befugnisse, um über die An-

gelegenheiten der Gesellschaft zu befinden.

Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss der Bestimmungen des Gesetzes. Eine Einberufung ist nicht

notwendig, wenn alle Aktionäre anwesend oder vertreten sind und sofern sie erklären den Inhalt der Tagesordnung im
Voraus gekannt zu haben.

Die Generalversammlung beschliesst über die Verwendung und Verteilung des Reingewinnes.

Art. 11. Die jährliche Generalversammlung findet am Gesellschaftssitz oder an jedem anderen in den Einberufungs-

schreiben genannten Ort in Luxemburg statt und zwar am zweiten Donnerstag des Monats Juni um 11.00 Uhr. Falls der
vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.

Art. 12. Durch Beschluss der Generalversammlung können ein Teil oder der ganze Gewinn oder aber ausschüt-

tungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung genutzt werden mittels Rückzahlung des Nominalwertes aller oder eines Teiles
der ausgegebenen Aktien; diese Aktien werden durch das Los bestimmt und das gezeichnete Kapital wird nicht herab-
gesetzt. Die zurückgezahlten Aktien werden annulliert und durch Genussscheine ersetzt welche die seIben Rechte wie
die annullierten Aktien besitzen, mit der Ausnahme des Rechtes der Rückzahlung des Nominalwertes und des Rechtes
auf die Zahlung einer ersten Dividende welche den nicht zurückgezahlten Aktien vorbehalten ist.

IV.- Geschäftsjahr - Auflösung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember jeden Jahres.

Art. 14. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher unter den glei-

chen Bedingungen gefasst werden muss wie bei Satzungsänderungen.

V.- Allgemeine Bestimmungen

Art. 15. Für alle nicht in dieser Satzung festgelegten Punkte, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Ge-

setzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.

<i>VI.- Vorübergehende Bestimmungen

1.- Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember 2000.
2.- Die erste Generalversammlung der Aktionäre findet statt im Jahre 2001.

<i>VII.- Kapitalzeichnung

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet: 

Alle Aktien wurden voll eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von USD 500.000,- zur Verfügung,

was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>VIII.- Bescheinigung

Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über

die Handelsgesellschaften erfüllt sind.

<i>IX.- Schätzung der Gründungskosten

Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlass gegenwär-

tiger Gründung erwachsen, auf dreihundertzwanzigtausend Luxemburger Franken (LUF 320.000,-). 

<i>Schätzung des Kapitals

Zum Zwecke der Erhebung der Einregistrierungsgebühren wird das Kapital der Gesellschaft geschätzt auf zwei-

undzwanzig Millionen vierhundertfünfundneunzigtausendeinhundertachtundvierzig Luxemburger Franken (LUF
22.495.148,-).

1.- CITI TRUST S.A., vorgenannt, zweihundertfünfzig Aktien

250

2.- IMD S.A., vorgenannt, zweihundertfünfzig Aktien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: fünfhundert Aktien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

27112

<i>X.- Ausserordentliche Generalversammlung

Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der die sich

als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:

1.- Die Anschrift der Gesellschaft lautet:
L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
Die Gründungsversammlung ermächtigt den Verwaltungsrat eine neue Anschrift der Gesellschaft innerhalb der Ort-

schaft des Gesellschaftssitzes zu wählen.

2.- Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf drei und diejenige der Kommissare auf einen festgesetzt.

3.- Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt:
- Herr Egon Bentz, Kaufmann, wohnhaft in Luxemburg, Vorsitzender des Verwaltungsrates;
- Herr Hermann-Josef Dupré, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg;
- Herr Götz Schöbel, Betriebswirt, wohnhaft in Luxemburg.

4.- Zum Kommissar für den gleichen Zeitraum wird ernannt: 
- LUXEMBOURG CONSULTING GROUP, mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.

5.- Die Mandate des Verwaltungsrates und dasjenige des Kommissars erfallen sofort nach der Generalversammlung

des Jahres 2006.

6.- Auf Grund von Artikel sechzig des Gesetzes vom zehnten August eintausendneunhundertfünfzehn über die Han-

delsgesellschaften und auf Grund von Artikel 6 gegenwärtiger Satzung ermächtigt die Versammlung den Verwaltungsrat
die tägliche Geschäftsführung an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder zu übertragen.

Der unterzeichnete Notar, der Deutsch versteht und spricht, hält hiermit fest, dass auf Wunsch der Komparenten

vorliegende Urkunde in deutscher Sprache verfasst ist mit einer Übersetzung ins Englische. Im Falle einer Unstimmigkeit
zwischen der deutschen und der englischen Fassung ist auf Wunsch der Komparenten die deutsche Fassung massgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und

Wohnort bekannt, haben alle mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Folgt die Übersetzung in englischer Sprache:

In the year two thousand, on the eighteenth day of December.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.

There appeared:

1.- CITI TRUST S.A., having its registered office in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
here represented by Mr Egon Bentz, businessman, residing in Luxembourg, acting in his quality of managing director

with power to represent the company by his sole signature.

2.- IMD S.A., having its registered office in L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II,
here represented by Mr Egon Bentz, prenamed, acting in his quality of managing director with power to represent

the company by his sole signature. 

Said appearing parties have established as follows the Articles of Incorporation of a holding company to be organized

between themselves:

Title I: Name, Registered Office, Object, Duration, Corporate Capital

Art. 1. There is hereby organized a holding company in the form of a société anonyme, the name of which shall be

MONBLAN HOLDING S.A.

Said company shall have its registered office in Luxembourg.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of

the Board.

In the event that the Board determines that extraordinary, political, economic or social developments have occured,

or are imminent, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between such
office and foreign countries, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation
of these abnormal circumstances.

Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the company which, nothwithstanding

such temporary transfer of the registered office, still remains of Luxembourg nationality.

The Company shall have an unlimited duration. 

Art. 2. The purposes of the company are the acquisition of participating interests in any form whatsoever in other

Luxembourg or foreign companies and any other investment form, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of securities of any kinds, the manage-
ment, supervision and development of these interests.

It may also acquire and license trade-marks and patents and other rights derived from or complemental to such pat-

ents, and participate in the organization, development, transformation and supervision of any company, remaining how-
ever always within the limits of the Law of July 31st, 1929 on holding companies.

Art. 3. The corporate capital is fixed at five hundred thousand US Dollars (USD 500,000.-), represented by five hun-

dred (500) shares of one thousand US Dollars (USD 1,000.-) each.

Unless otherwise specified by Law, the shares shall be in bearer form.

27113

The subscribed capital may be increased or reduced by a decision of an extraordinary general meeting of shareholders

deliberating in the same manner as for the amendment of the Articles of Incorporation.

The company may redeem its shares within the limits fixed by law.

Title II: Management and Supervision

Art. 4. The company shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members who need not

be shareholders of the company. Their term of office shall be maximum 6 years. The directors shall be re-eligible.

Art. 5. With the exception of the acts reserved to the general meeting of shareholders by law or by the Articles of

Incorporation, the Board of Directors may perform all acts necessary or useful to the achievement of the purposes of
the company. The Board of Directors may not deliberate or act validly unless a majority of its members are present or
represented, a proxy between directors, which may be given by letter, telex or telefax, being permitted.

In case of emergency, the directors may cast their vote by letter, telex or telefax. Resolutions in writing approved

and signed by all directors shall have the same effects as resolutions adopted at the directors’ meetings.

Resolutions of the Board of Directors shall be adopted by majority vote.

Art. 6. The Board of Directors may delegate all or part of its power to a director, officer, manager or other agent.

The corporation shall be bound by the sole signature of the chairman of the Board of Directors or by the collective
signature of two directors.

Art. 7. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the company by the Board of Di-

rectors represented by its chairman or its managing director.

Art. 8. The Board of Directors may decide to pay interim dividends within the limits and conditions fixed by law.

Art. 9. The supervision of the corporation shall be entrusted to one or more auditors, who are appointed for a term

not exceeding six years. They shall be re-eligble.

Title III: General Meeting and distribution of profits

Art. 10. The general meeting of the Gompany properly constituted represents the entire body of the shareholders.

It has the broadest powers to perform or ratify all acts which concern the company.

Convening notices of all general meetings shall be made in compliance with the legal provisions. If all the shareholders

are present or represented and if they declare that they have had knowledge of the agenda submitted to their consid-
eration, the general meeting may take place without previous convening notices.

The general meeting shall determine the allocation or distribution of the net profits.

Art. 11. The annual meeting of shareholders shall be held on the second Thursday in June at 11.00 a.m. in Luxem-

bourg at the registered office or at any other location designated in the convening notices. If said day is public holiday,
the meeting will be held the next following business day.

Art. 12. By a decision of the extraordinary general meeting of the shareholders, all or part of the net profit and the

distributable reserves may be assigned to redemption of the stock capital by way of reimbursement at par of all or part
of the shares which have to be determined by lot, without reduction of capital. The reimbursed shares are cancelled
and replaced by bonus shares which have the same rights as the cancelled shares, with the exception of the right of
reimbursement of the assets brought in and of the right to participate at the distribution of a first dividend allocated to
non-redeemed shares.

Title IV: Accounting year, Dissolution

Art. 13. The accounting year shall begin on the first of January and end on the thirty-first of December of each year.

Art. 14. The company may be dissolved by decision of the general meeting voting with the same quorum as for the

amendment of the articles of incorporation.

Title V: General Provisions

Art. 15. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law

of August 10th, 1915, as amended on commercial companies, the law of July 31st, 1929, on Holding Companies.

<i>Transitory provisions

1.- The first accounting year will start on the date of formation of the Company and will end on the thirty-first of

December 2000.

2.- The first annual general meeting will be held in 2001.

<i>Subscription and Payment

The shares have been subscribed as follows: 

The shares have all been fully paid up in cash so that USD 500,000.- are now available to the company, evidence there-

of having been given to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions set forth in Article 26 of the Law of Trading Companies have been

observed and expressly acknowledges their observation.

1.- CITI TRUST S.A., prenamed, two hundred fifty shares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

2.- IMD S.A., prenamed, two hundred fifty shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250

Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

27114

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever which the

company incurs or for which it is liable by reason of its organization amounts to approximately three hundred twenty
thousand Luxembourg Francs (LUF 320,000.-).

<i>Estimation of the share capital

For the purpose of registration, the share capital is evaluated at twenty-two millions four hundred ninety-five thou-

sand one hundred forty-eight Luxembourg Francs (LUF 22,495,148.-).

<i>Extraordinary General Meeting

Here and now, the above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as

duly convened, have decided to hold an extraordinary general meeting and, having stated that it was regularly constitut-
ed, they have, by unanimous vote, passed the following resolutions: 

1) The registered office of the company is in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
The general meeting authorizes the Board of Directors to fix at any time a new registered office within the munici-

pality of Luxembourg.

2) The number of directors is fixed at three and that of the auditors at one.

3) Are appointed as directors:
- Mr Egon Bentz, businessman, residing in Luxembourg, Chairman of the Board of Directors;
- Mr Hermann-Josef Dupré, lawyer, residing in Luxembourg;
- Mr Götz Schöbel, Betriebswirt, residing in Luxembourg.

4) Is appointed as statutory auditor:
- LUXEMBOURG CONSULTING GROUP, having its registered office in L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph

II.

5) The mandates of the directors and the auditor shall expire immediately after the annual general meeting of 2006.

6) Pursuant to article 60 of the law of 10th August 1915 on commercial companies and pursuant to article 6 of the

present statutes, the general assembly authorizes the board of directors to delegate part of all of its powers to one or
more members of the board of directors.

The undersigned notary who understands and speaks German, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in German, followed by a English translation; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the German and the English text, the German text will be prevailing.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the docu-

ment.

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.

Gezeichnet: E. Bentz, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 27 décembre 2000, vol. 416, fol. 38, case 1. – Reçu 224.951 francs.

<i>Le Receveur (signé): A. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung, dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks Veröffentlichung erteilt. 

(01705/228/265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

ARBI, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R. C. Luxembourg B 53.136. 

<i>Notification du gérant

Il résulte de la Décision du Conseil d’Administration de la société ARBI, S.à r.l., du 31 août 2000, que les Administra-

teurs, à l’unanimité des voix, ont pris la résolution suivante:

Modification de l’adresse de la société à :
46A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
Cette modification prendra effet en date du 1

er

 septembre 2000.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations. 

Enregistré à Luxembourg, le 8 janvier 2001, vol. 548, fol. 6, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(01755/683/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 janvier 2001.

Mersch, den 8. Januar 2001. 

E. Schroeder.

<i>Pour ARBI, S.à r.l.
MANACOR (LUXEMBOURG) S.A.
Gérant
<i>Signatures

27115

NARCANDO HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 73.515. 

Messieurs les Actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 août 2001 à 14.00 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.

(03676/000/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

EXA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 29.248. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>7 août 2001 à 12.30 heures au siège social avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes. 
2. Approbation du bilan et compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Elections statutaires.
5. Divers.

Comme la première assemblée générale ordinaire, convoquée pour le 16 juillet 2001 avec le même ordre du jour,

n’a pu délibérer valablement sur les points figurants à l’ordre du jour, cette deuxième assemblée prendra les décisions
à la majorité des actions présentes ou représentées.

Le Conseil d’Administration

(03677/000/18) 

<i>Signature

CASTOR ET POLLUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 25.770. 

Le Conseil d’Administration de la Société sous rubrique a l’honneur de convoquer Messieurs les Actionnaires à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

modificative des statuts qui aura lieu le <i>31 juillet 2001 à 10.00 heures, au siège social de la Société, avec l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de modifier la devise de capital de la société pour la libeller, non plus en LUF, mais en euro (EUR), et de

remplacer toute référence aux devises composant l’euro par une référence à l’euro.

2. Divers.

Les actionnaires sont informés que, en conformité avec la loi du 10 décembre 1998, relative à la conversion par les

sociétés commerciales de leur capital en euro, aucun quorum n’est requis pour la tenue de cette assemblée. Les déci-
sions seront prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés et votant.

Les actionnaires détenteurs d’actions au porteur qui désirent participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire, sont

priés d’effectuer le dépôt de leurs titres deux jours francs au moins avant la date de l’Assemblée, au siège social de la
Société.

Les actionnaires nominatifs qui désirent prendre part à l’Assemblée Générale Extraordinaire, sont priés de faire con-

naître à la société, deux jours francs au moins avant l’Assemblée, leur intention d’y participer. Ils y seront admis sur
justification de leur identité.

Tout actionnaire a par ailleurs la possibilité de voter par procuration. A cet effet, des formulaires de procuration sont

disponibles sur simple demande au siège social de la Société.
(03713/755/25) 

<i>Le Conseil d’Administration.

27116

PRONTOFUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

R. C. Luxembourg B 51.690. 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés par le présent avis qu’avec effet au 24 août 2001, le Conseil

d’administration a décidé de procéder aux changements suivants dans le prospectus d’émission daté de décembre 2000:

<i>Commissions de gestion et de performance

- Compartiments ProntoFund-Global One, ProntoFund-Global Two, ProntoFund-Global Three
Le taux de la commission de gestion appliqué sur les actifs nets relevant des actions de catégorie I (destinée exclusi-

vement aux institutionnels) des compartiments ProntoFund-Global One, ProntoFund-Global Two et ProntoFund-Glo-
bal Three est diminué et passe de 0,40 % à 0,30 %. 

De plus, le gestionnaire des compartiments ProntoFund-Global One et ProntoFund-Global Three aura droit à une

commission de performance payable dans le mois qui suit la clôture d’exercice et calculée de la manière suivante:

«le taux de la commission de performance, appliquée sur les actifs moyens (avant charges) de ces deux comparti-

ments, sera égal à 25 % de la différence positive entre la valeur nette d’inventaire par action au terme de l’exercice écou-
lé et la valeur nette d’inventaire par action au terme de l’exercice précédent (et pour l’exercice 2001 à la VNI du 24
août 2001) et le taux Eurolibor 12 mois (360), augmenté de 1 % en valeur absolue et fixé deux jours ouvrables avant le
dernier jour ouvrable de l’exercice précédent, tous deux exprimés en pourcentage (et pour l’exercice 2001 à la VNI du
24 août 2001)».

Compartiment ProntoFund-Bond One
Le taux de la commission de gestion appliqué sur les actifs nets relevant des actions de catégorie I (destinée exclusi-

vement aux institutionnels) du compartiment ProntoFund-Bond One est augmenté et passe de 0,13 % à 0,17 % jusqu’à
100 mio EUR, de 0,11 % à 0,15 % de 100 à 200 mio EUR et de 0,09 % à 0,13 % au-delà de 200 mio EUR.

Suite à cette augmentation, la commission de performance due par ce compartiment au gestionnaire a été supprimée.
Pendant un délai d’un mois à partir de la publication de la présente, à savoir du 24 juillet 2001 au 24 août 2001, les

actionnaires des compartiments susmentionnés auront la possibilité de demander le rachat sans frais de leurs actions.

<i>Actions

- Fractionnement d’actions
A partir du 6 août 2001 et conformément à ses statuts, la SICAV pourra émettre des fractions d’actions (millièmes)

qui pourront non seulement être de forme nominative, mais également au porteur. D’autre part, en cas d’émission d’ac-
tions au porteur fractionnées, une confirmation de souscription sera émise et en cas de demande de livraison d’actions
au porteur, seuls des certificats représentatifs d’actions entières pourront être émis, la fraction d’action étant automa-
tiquement présentée au remboursement et le solde remboursé à l’actionnaire.

Luxembourg, le 24 juillet 2001.

(03714/755/35) 

<i>Le Conseil d’administration.

LUX INTERNATIONAL FINANCE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 42.714. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 août 2001 à 15.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

II (03524/795/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

GOLF FINANCIAL INVESTMENT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R. C. Luxembourg B 45.574. 

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à 

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>2 août 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire 
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 mars 2001
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire

27117

4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août

1915 sur les sociétés commerciales

5. Divers

II (03525/795/16) 

<i>Le Conseil d’Administration.

JUMI S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 11.774. 

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> août 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 mai 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au 31

mai 2001.

4. Divers.

II (03540/005/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

TALANTA HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 44.844. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 août 2001 à 11.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31 décembre 1999 et au 31

décembre 2000 et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes y relatifs.

2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 1997, au 31 décembre 1998, au 31

décembre 1999 et au 31 décembre 2000.

3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre en vertu de l’article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
6. Autorisation au Conseil d’Administration dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998, de procéder aux formalités

de conversion du capital social (et du capital autorisé) en Euro, d’augmenter le capital social (et le capital autorisé),
d’adapter ou de supprimer la désignation de valeur nominale des actions et d’adapter les statuts en conséquence.

7. Divers.

II (03550/534/21) 

<i>Le Conseil d’Administration.

FIVER S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.

R. C. Luxembourg B 39.018. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra extraordinairement le vendredi <i>3 août 2001 à 10.00 heures au siège social avec pour

<i>Ordre du jour:

– Rapports de gestion du Conseil d’Administration,
– Rapports du commissaire aux comptes,
– Approbation des comptes annuels au 31 décembre 1999 et au 31 décembre 2000 et affectation des résultats,
– Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
– Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes,
– Poursuite de l’activité de la société,
– Autorisation à conférer au Conseil d’Administration pour entreprendre les démarches en vue de la conversion du

capital de la société de BEF en EUR dans le cadre de la loi du 10 décembre 1998.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq

jours francs avant l’Assemblée au siège social.
II (03637/755/20) 

<i>Le Conseil d’Administration.

27118

SOCAPAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.138. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 août 2001 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II (03551/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

ROCAGEST S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 52.251. 

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à 

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra à l’adresse du siège social, le <i>2 août 2001 à 10.00 heures, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

II  (03552/534/15) 

<i>Le Conseil d’Administration.

CHAMELLE S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 3, place Dargent.

R. C. Luxembourg B 65.069. 

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> août 2001 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2000.
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire.
4. Divers.

II (03574/696/14) 

<i>Le Conseil d’Administration.

IMMO-ROYAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 30.187. 

Les actionnaires sont convoqués à

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

de IMMO-ROYAL (la «Société») qui se tiendra le <i>2 août 2001 à 11.00 heures, dans les bureaux de la BANQUE GENE-
RALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, pour voter sur l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décider la mise en liquidation de la Société.
2. Nommer comme liquidateurs les membres du Conseil d’Administration de la Société actuellement en fonction et

déterminer leurs pouvoirs et rémunérations. 

Le quorum requis pour cette assemblée est de 50 % des actions en émission et la première résolution devra réunir

les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. L’adoption de la seconde résolution ne re-
quiert la réunion que de la majorité simple des actions représentées à l’assemblée.

27119

Si le quorum de 50 % des actions émises n’est pas atteint lors de cette assemblée, une seconde assemblée avec le

même ordre du jour sera convoquée. Aucun quorum n’est requis pour cette assemblée reconvoquée et les résolutions
devront réunir le même nombre de voix des actionnaires présents ou représentés que lors de la première assemblée.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration. Des procurations seront disponibles sur demande

au siège social de la Société et doivent être retournées dûment complétées audit siège. Pour être valables, les procura-
tions doivent être reçues par courrier au plus tard le 27 juillet 2001.

Afin de pouvoir prendre part au vote, les détenteurs d’actions au porteur doivent déposer leurs certificats auprès de

la BANQUE GENERALE DU LUXMBOURG S.A. ou de la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A. cinq jours au moins avant
la date de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Les certificats d’actions resteront bloqués jusqu’après la tenue de l’As-
semblée Générale Extraordinaire.

Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter votre intermédiaire financier habituel, la BANQUE GENE-

RALE DU LUXEMBOURG S.A. ou la BANQUE DE LUXEMBOURG S.A.
II (03636/584/29) 

<i>Pour le Conseil d’Administration.

BENIGA HOLDING S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 78.691. 

Le Gérant Commandité a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>1

<i>er

<i> août 2001 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapport de la Gérance, du Conseil de Surveillance et du Réviseur d’Entreprises.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 30 juin 2001, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner à la Gérance, au Conseil de Surveillance et au Réviseur d’Entreprises pour l’exercice de leur

mandat au 30 juin 2001.

4. Nomination de PricewaterhouseCoopers, S.à r.l. comme Réviseur d’Entreprises.
5. Divers.

II (03635/005/16) 

<i>Le Gérant Commandité.

RICHEMONT S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R. C. Luxembourg B 16.576. 

Les actionnaires et les porteurs de titres bénéficiaires (participation certificates) de RICHEMONT S.A. (la «Société»)

sont informés par la présente qu’une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

se tiendra le <i>2 août 2001 au siège social de la Société à 11.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. De diviser chaque titre bénéficiaire existant en cent (100) titres bénéficiaires, la division devenant effective à la date

de la division des actions correspondantes de la COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG (une Aktiengesell-
schaft constituée sous les lois Suisses avec siège social à Zoug) et modification conséquente du paragraphe 5.4 de
l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
«La Société a émis cinq cent soixante-quatorze million deux cent mille (574.200.000) titres bénéficiaires qui ne font
pas partie du capital de la Société et qui bénéficient des droits tels que décrits à l’article 7 ci-dessous, tous titres
bénéficiaires ont été attribués aux détenteurs et aux souscripteurs des actions de toutes classes de COMPAGNIE
FINANCIERE RICHEMONT AG (une Aktiengesellschaft constituée sous les lois Suisses avec siège social à Zoug,
dans les proportions suivantes: un (1) titre bénéficiaire pour chaque action «A» de COMPAGNIE FINANCIERE
RICHEMONT AG et un (1) titre bénéficiaire pour dix (10) actions «B» de COMPAGNIE FINANCIERE RICHE-
MONT AG. Chaque titre bénéficiaire de la Société porte le même nombre distinctif que l’action ou les actions
correspondantes de COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG.»

2. De modifier l’article 8.2 des statuts de la Société par l’ajout du paragraphe suivant qui sera numéroté 8.2.1:

«En cas d’une division ou d’une consolidation des actions de COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG le(s)
titre(s) bénéficiaire(s) détenu(s) par les détenteurs de ces actions seront automatiquement et sans autre démarche
de la part de la Société divisé(s) ou consolidé(s), selon le cas, de la même manière que le(s) action(s) correspon-
dante(s) de COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG, étant entendu qu’une telle subdivision ou consolida-
tion ne résultera pas en une réduction des droits des détenteurs concernés par cet événement. Chaque fois,
qu’une telle subdivision ou consolidation aura lieu, le conseil d’administration prendra note du changement de l’ar-
ticle 5 de ces statuts et qui en résulte fera constater ce changement par acte notarié.»

27120

<i>Vote

Le quorum requis pour l’assemblée est de 50% des actions existantes et de 50% des titres bénéficiaires existants.

L’approbation de la résolution nécessite le vote favorable des deux tiers des actions et des deux tiers des titres béné-
ficiaires représentés à l’assemblée.

Au cas où le quorum n’est pas atteint, une deuxième assemblée sera convoquée pour le 6 septembre 2001 à 11.30

heures afin de considérer le même ordre du jour. Aucun quorum n’est requis pour l’assemblée re-convoquée et les
résolutions seront prises par une majorité des deux tiers des actions et des deux tiers des titres bénéficiaires représen-
tés à cette assemblée re-convoquée.

Les cartes d’admission à l’assemblée générale extraordinaire ainsi que les formulaires de procuration seront remis

aux détenteurs de titres bénéficiaires au porteur lors du dépôt de leurs certificats correspondant à leurs actions de la
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG et les titres bénéficiaires de la Société auprès des agences des banques
suivantes jusqu’au 26 juillet 2001:

UBS AG  /  DARIER, HENTSCH &amp; CIE
BANK VONTOBEL AG  /  PICTET &amp; CIE
BANK VON ERNST &amp; CIE AG
Les certificats déposées seront bloquées jusqu’à la clôture de l’assemblée ou, au cas où l’assemblée est révoquée,

jusqu’à la clôture de l’assemblée re-convoquée. Aucune carte d’admission ne pourra être délivrée le jour même de l’as-
semblée. Les actionnaires et les porteurs de titres bénéficiaires peuvent voter en personne ou par procuration. Les for-
mulaires de procuration sont fournis au dos des cartes d’admission. Au cas où une deuxième assemblée est nécessaire
en raison de l’absence de quorum à la première assemblée, les détenteurs des titres bénéficiaires sont requis de bloquer
leurs certificats de titres avec les banques énumérées ci-avant jusqu’à la clôture de l’assemblée devant se tenir le 6 sep-
tembre 2001.
II (03638/000/56) 

<i>Pour et au nom du Conseil d’Administration.

GENEIMMO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.

R. C. Luxembourg B 31.874. 

Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

de notre société qui se tiendra au siège social en date du <i>31 juillet 2001 à 15.30 heures avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation du Rapport du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes concernant les années fi-

nancières se terminant aux 31 décembre 1999 et 2000;

2. Approbation des bilans concernant les années mentionnées ci-dessus et affectation des résultats;
3. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
4. Question de la dissolution de la société conformément à l’application de l’article 100 de la loi du 10 août 1915 telle

que modifiée.

5. Modification de la devise du capital social en Euro.

II (03642/000/17) 

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg


Document Outline

Sommaire

Casa Style, S.à r.l.

Accenture Minority III Norway 1 S.C.A.

Accenture Minority III Norway 2 S.C.A.

Lloyds TSB International Liquidity

Lloyds TSB International Liquidity

Theis Luxembourg, S.à r.l.

Midwest Holding S.A.

Monblan Holding S.A.

Arbi, S.à r.l.

Narcando Holding

Exa Holding

Castor et Pollux

Prontofund, Sicav

Lux International Finance S.A.

Golf Financial Investment S.A.

Jumi S.A.

Talanta Holding

Fiver S.A.

Socapar S.A.

Rovagest S.A.

Chamelle S.A.

Immo-Royal

Beniga Holding S.C.A.

Richemont S.A.

Geneimmo S.A.