This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
17617
MEMORIAL
MEMORIAL
Amtsblatt
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L
D E S
S O C I E T E S
E T
A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 368
18 mai 2001
S O M M A I R E
A & A Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
17618
Lairnisia Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
17655
A & A Holdings S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . .
17620
Lairnisia Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . .
17655
Cimex S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17637
Language Enterprises, S.à r.l., Luxembourg . . . . .
17656
Cimex S.A., Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17638
Laurus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
17656
Escalade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17638
Laurus Luxembourg, S.à r.l., Luxembourg . . . . . .
17659
Escalade S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17639
Leap International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
17660
Exmar Lux S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . .
17638
Leap International, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . .
17660
(La) Fiduciaire Magellan Luxembourg S.A., Luxem-
LeDaLux, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
17623
bourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17655
Lellinv Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . .
17659
Fiem Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17631
Lentz Lucien et Cie, S.à r.l., Pétange . . . . . . . . . . .
17660
Fiem Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17633
Leonberg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
17661
FMC Finance II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
17640
Leonberg Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . .
17661
FMC Finance II, S.à r.l., Luxembourg. . . . . . . . . . . .
17648
Link Distribution S.A., Kehlen. . . . . . . . . . . . . . . . .
17661
Ibercapital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17633
Lodi Holding S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . .
17662
Ibercapital S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17635
Lodi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17662
Investlife Luxembourg S.A., Luxembourg . . . . . . . .
17639
Lodi Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . .
17662
IPN S.A., Luxembourg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17640
M. M. Advisors, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . . .
17664
Isatis S.A.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17652
M. M. Warburg & Co Holding S.A., Luxembourg .
17664
Isidore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17652
M. M. Warburg & Co Holding S.A., Luxembourg .
17664
Isidore Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
17653
M. M. Warburg & Co Holding S.A., Luxembourg .
17664
J. P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund, Sicav,
Mapenti Holding S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . .
17662
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17654
Mater S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17663
Jarny, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17652
Mater S.A., Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17663
JMP Conseil, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . .
17653
Melobesia S.A. Holding, Luxembourg . . . . . . . . . .
17663
JMP Conseil, S.à r.l., Fentange . . . . . . . . . . . . . . . . .
17654
Metropolitan Trading Corporation, Luxembourg.
17663
Kegefin Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
17620
Metropolitan Trading Corporation, Luxembourg.
17663
Kegefin Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
17622
Minico Holding Luxembourg S.A., Luxembourg . .
17664
Kids & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17654
N.H.C. Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
17627
Kids & Co S.A., Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17654
N.H.C. Holding S.A., Luxemburg . . . . . . . . . . . . . .
17629
La Ciociara, S.à r.l., Walferdange . . . . . . . . . . . . . . .
17655
Richemont Luxury Group S.A., Luxembourg . . . .
17629
Lairnisia Gestion, S.à r.l., Luxembourg . . . . . . . . . .
17655
17618
A & A HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.433.
—
In the year two thousand, on the sixth of November.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
Was held an extraordinary general meeting of the Company established in Luxembourg under the denomination of
A & A HOLDINGS S.A., R. C. B Number 61.433, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on Octo-
ber 21st, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, No. 70 of February 3rd,1998.
The meeting begins at five-thirty p.m., Mr Roger Nlend, lawyer, residing in Howald, being in the chair.
The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr Raymond Thill, maître en droit, residing in Luxembourg.
The meeting elects as scrutineer Mr Marc Prospert, maître en droit, residing in Bertrange.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the members of the Bureau that the twelve thousand
five hundred (12,500) shares with a par value of one hundred (100.-) Luxembourg francs each, representing the entire
capital of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs are duly represented at this meet-
ing which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on its agenda, hereinafter reproduced,
without prior notice, all the shareholders having agreed to meet after examination of the agenda.
The attendance list, signed by the shareholders all present or represented at the meeting, shall remain attached to
the present deed together with the proxies and shall be filed at the same time with the registration authorities.
II. The agenda of the meeting is worded as follows:
1.- Increase of the Company’s share capital by an amount of LUF 5,000,000.-, so as to raise it from its present amount
of LUF 1,250,000.- to LUF 6,250,000.- by the creation and issue of 50,000 new shares with a par value of LUF 100,- each.
Subscription and payment in cash of the new shares.
2.- Subsequent amendment of Article 3 of the Company’s Articles of Incorporation to give it henceforth the following
wording:
«Art. 3. The corporate capital is set at six million two hundred and fifty thousand (6,250,000.-) Luxembourg francs,
divided into sixty-two thousand five hundred (62,500) shares with a par value of one hundred (100.-) Luxembourg francs
each.»
3.- Miscellaneous.
After approval of the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted, the meeting
passed, after deliberation, the following resolutions by unanimous vote:
<i> First resolutioni>
The Company’s share capital is increased by an amount of five million (5,000,000.-) Luxembourg francs so as to raise
it from its present amount of one million two hundred and fifty thousand (1,250,000.-) Luxembourg francs to six million
two hundred and fifty thousand (6,250,000.-) Luxembourg francs by the creation and issue of fifty thousand (50,000)
new shares with a par value of one hundred (100.-) Luxembourg francs each.
These new shares have been entirely subscribed as follows:
- for twenty-five thousand five hundred (25,500) shares by ELMEC SPORT S.A., a company established and having
its registered office at 96 Vouliagmenis Avenue, Glyfada, 16674 Athens Greece,
- for nineteen thousand five hundred (19,500) shares by ARDEN INVESTMENTS LIMITED, a company established
and having its registered office at Level 4 North, Town Mills, St. Peter Port, Guernsey, Channel Islands, and
- for five thousand (5,000) shares by CONNECTION S.A., a company established and having its registered office at
Kafisioa, Street Kifisou-Evrota 22,
all three here represented by Mr Roger Nlend, prenamed,
by virtue of three proxies given in Athens, Luxembourg and Kafisia, on November 3, 2000.
Such proxies after signature ne varietur by the mandatory and the undersigned notary, shall remain attached to the
present deed to be filed at the same time.
The reality of the subscriptions has been proved to the undersigned notary by relevant papers.
The new shares have been fully paid up in cash, so that the amount of five million (5,000,000.-) Luxembourg francs
is henceforth at the free disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly bears
witness of it.
<i> Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution Article 3 of the Company’s Articles of Incorporation is amended and
shall henceforth read as follows:
«Art. 3. The corporate capital is set at six million two hundred and fifty thousand (6,250,000.-) Luxembourg francs,
divided into sixty-two thousand five hundred (62,500) shares with a par value of one hundred (100.-) Luxembourg francs
each.»
Nothing else being on the agenda, and nobody wishing to address the meeting, the meeting was closed at six p.m.
In faith of which We, the undersigned notary, set our hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of the document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version and that in case of divergences between
the English and the French texts, the English version will prevail.
17619
The document having been read and translated into the language of the persons appearing, said persons appearing
signed with Us, the notary, the present original deed.
Traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le six novembre.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomination
de A & A HOLDINGS S.A., R. C. B Numéro 61.433, ayant son siège social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire, le 21 octobre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, N
°
70 du
3 février 1998.
La séance est ouverte à dix-sept heures trente sous la présidence de Monsieur Roger Nlend, juriste, demeurant à
Howald,
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxem-
bourg.
L’assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les douze mille cinq cents
(12.500) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) francs luxembourgeois chacune représentant l’intégralité du ca-
pital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000.-) francs luxembourgeois, sont dûment représentées à la
présente assemblée qui, en conséquence, est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires ayant accepté de se réunir sans convo-
cations préalables.
Ladite liste de présence, portant la signature des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au pré-
sent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistre-
ment.
II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1.- Augmentation du capital social à concurrence de LUF 5.000.000,-, pour le porter de son montant actuel de LUF
1.250.000,- à LUF 6.250.000,-, par la création et l’émission de 50.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de LUF
100,- chacune.
<i> Souscription et libération en espèces des nouvelles actionsi>
2. Modification subséquente de l’article 3 des statuts de la Société, pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à six millions deux cent cinquante mille (6.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé
en soixante-deux mille cinq cents (62.500) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) francs luxembourgeois chacu-
ne.»
3. Divers.
L’assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s’être reconnue régulièrement cons-
tituée, a abordé les points précités de l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les réso-
lutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le capital social de la Société est augmenté à concurrence de cinq millions (5.000.000,-) de francs luxembourgeois,
pour le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille (1.250.00,-) francs luxembourgeois à six
millions deux cent cinquante mille (6.250.000,-) francs luxembourgeois par la création et l’émission de cinquante mille
(50.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent (100,-) francs luxembourgeois chacune.
Ces nouvelles actions ont été entièrement souscrites comme suit:
- pour vingt-cinq mille cinq cents (25.500) actions par ELMEC SPORT S.A., une société établie et ayant son siège
social au 96 Vouliagmenis Avenue, Glyfada, 16674 Athènes Grèce,
- dix-neuf mille cinq cents (19.500) actions par ARDEN INVESTMENTS LIMITED, une société établie et ayant son
siège social à Level 4 North, Town Mills, St. Peter Port, Guernesey, Iles Anglo-Normandes, et
- cinq mille (5.000) actions par CONNECTION S.A., une société établie et ayant son siège social à Kafisioa, Street
Kifisou -Evrota 22,
toutes les trois ici représentées par Monsieur Roger Nlend, préqualifié,
en vertu de trois procurations données à Athènes, Luxembourg et Kafisia, le 3 novembre 2000.
Lesquelles procurations, après signature ne varietur par la mandataire et le notaire instrumentaire, demeureront an-
nexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
La réalité des souscriptions a été prouvée au notaire instrumentant par des justificatifs.
Les nouvelles actions ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que le montant de cinq millions
(5.000.000,-) de francs luxembourgeois se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il a été prouvé
au notaire instrumentant, qui le constate expressément.
<i> Deuxième résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l’article 3 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur sui-
vante:
«Art. 3. Le capital social est fixé à six millions deux cent cinquante mille (6.250.000,-) francs luxembourgeois, divisé
en soixante-deux mille cinq cents (62.500) actions d’une valeur nominale de cent (100,-) francs luxembourgeois chacu-
ne.»
17620
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à dix-huit heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes com-
parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; à la requête des mêmes personnes et en cas
de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, la présente
minute.
Signé: R. Nlend, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 126S, fol. 87, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65685A/230/143) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
A & A HOLDINGS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 19, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 61.433.
—
Statuts coordonnés suivant l’acte n
°
1350 du 6 novembre 2000, déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65686A/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
KEGEFIN HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II.
—
Im Jahre zweitausend, am sechzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitz in Hesperange.
Sind erschienen:
1. Herr Gérard Matheis, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,
vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïence-
rie, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 27. September 2000, und
2. Herr Georg Kerschhackl, Geschäftsführer, wohnhaft in 39, avenue Princesse Grace, 98000 Monte Carlo, aufgrund
einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, 16. Oktober 2000.
Diese Vollmachten werden nach Unterzeichnung durch den Notar und den Bevollmächtigten mit dieser Urkunde ein-
registriert.
Der Bevollmächtigte ersucht den Notar im Namen der Komparenten nachstehenden, durch alle Parteien vereinbar-
ten Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden :
Titel I - Name, Sitz, Zweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung KEGEFIN HOLDING S.A. wird hiermit eine Holdinggesellschaft in Form einer Akti-
engesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsange-
hörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden,
welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Kapitalgesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufneh-
men und den Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.
Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.
Ausserdem kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte
erwerben, verwerten und veräussern.
Generell wird die Gesellschaft nur solche Geschäfte tätigen, die das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesell-
schaften gestattet.
Luxembourg, le 20 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
Luxembourg, le 22 novembre 2000.
A. Schwachtgen.
17621
Titel II - Kapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) aufgeteilt in
1.250 (tausendzweihundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (tausend Euro).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Kapitel III - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jederzeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsnitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft er-
fordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestegehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen
im Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwär-
tige Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungs-
rates.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die
Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezi-
elle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung oder Vollmachterteilung durch den Verwaltungsrat im Rah-
men des Artikels 10 dieser Satzung.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren Verwal-
tungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.
Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung oder einem oder mehreren Direktoren über-
tragen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigten erteilen; diesel-
ben brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagte beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-
schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratmitglied vertreten wird.
Titel IV - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt ausserdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 15. Septem-
ber um 10.00 Uhr.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-
schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenom-
men und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder eingesetzt werden bis
zu ihrer vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegebenen Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII - Auflösung, Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein
oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre,
welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre
Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
17622
<i>Zeichnungi>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, das genannte Kapital wie folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden zu 100% (hundert Prozent) in bar eingezahlt; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort
uneingeschränkt über einen Betrag von EUR 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) wie dies dem
Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr läuft vom Tag der Unterzeichnung dieser Urkunde bis zum 31. Dezember 2001.
Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kosteni>
1.250.000,- EUR=50.424.875,- LUF.
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 600.000,- LUF.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen. Sie fassten, nachdem sie die ord-
nungsgemässe Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 und diejenige der Kommissare auf 1 festgelegt.
2. Folgende Personen werden in den Verwaltungsrat berufen :
a) Herr Gérard Matheis, vorgenannt,
b) Herr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la
Faïencerie, und
c) Herr Cornelius Martin Bechtel, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la
Faïencerie.
3. Zum Kommissar wird ernannt :
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, INTERAUDIT mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la Faïence-
rie.
4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars wird am Ende der jährlichen Generalversamm-
lung des Jahres 2006 enden.
5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II.
6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft an die Herren
Gérard Matheis und André Wilwert, vorgenannt, zu übertragen.
Woraufhin diese notarielle Urkunde an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten vorgelesen worden war, wurde sie von dem Bevollmächtigten und dem
Notar unterzeichnet.
Gezeichnet : P. Marx, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 126S, fol. 52, case 2. – Reçu 504.249 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausschrift zum zwecke der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
erteilt.
(65661A/220/155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
KEGEFIN HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II.
—
Den Herren André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, und Gérant Matheis, conseil économique, beide beruflich
wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, wurde die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft mit
Einzelzeichnungsbefugnis übertragen und Herr André Wilwert, vorgenannt, wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates ernannt.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 126S, fol. 52, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65662A/220/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Herr Gérard Matheis, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Aktie
Herr Georg Kerschhackl, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.249 Aktien
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250 Aktien
Hesperingen, den 15. November 2000.
G. Lecuit.
Luxemburg, den 16. Oktober 2000.
Für gleichlautende Mitteilung
<i>Für KEGEFIN HOLDING S.A.
i>Unterschrift
17623
LeDaLux, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
—
STATUTES
In the year two thousand, on the thirtieth of October.
Before Maître Joseph Elvinger, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
DOTCOMPLEMENT LIMITED, residing at La Motte Chambers, St Hélier, Jersey, JE1 1BJ Channel Islands,
hereby represented by Mr Patrick Van Hees, jurist, residing in Messancy, Belgium, by virtue of a proxy given under
private seal.
The aforesaid proxy, being initialled ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed to be filed at the saure time with the registration authorities.
Thereafter, the predesignated appearing party, acting as founder, has requested the undersigned notary to draw up
the Articles of Incorporation of a «société à responsabilité limitée» (limited liability partnership), which it has established
as follows:
Articles of Incorporation
Art. 1. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée», limited liability partnership company, governed
by the present articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10th, 1915 on
commercial companies, of September 18th, 1933 on «sociétés à responsabilité limitée», as amended, and more partic-
ularly the law of December 28th, 1992 about unipersonal companies.
At any moment, the partner may join with one or more joint partners and, in the saure way, the following partners
may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company.
Art. 2. The Company is incorporated under the name of LeDaLux, S.à r.l.
Art. 3. The Company’s purpose is to take participations, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, fi-
nancial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation, contri-
bution, underwriting, firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, to manage and develop them; to grant to enterprises in which the Company has an interest, any assistance,
loans, advances or guarantees, finally to perform any operation which is directly or indirectly related to its purpose,
however without taking advantage of the Act of July 31st, 1929 on Holding Companies.
The company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly to all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The regis-
tered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the partners.
Art. 5. The Company is constituted for an unlimited period.
Art. 6. The Company’s capital is set at EUR 18,200 (eighteen thousand and two hundred euros), represented by 182
(one hundred eighty-two) shares of EUR 100 (one hundred euros) each.
Art. 7. The shares are freely transferable among the partners.
No transfer of shares to a non-partner may take place without the agreement of the other partners and without
having been first offered to them.
Otherwise, it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.
Art. 8. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insol-
vency of any partner.
Art. 9. The creditors, representatives, rightful owners or heirs of any partner are neither allowed, in any circum-
stances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the ad-
ministration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions
of the meetings.
Art. 10. The Company is managed by one or more managers (who can be partners or non-partners), appointed by
the partners with or without limitation of their period of office.
The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of partners holding a majority of
votes.
Each manager shall have individually and on his single signature the full power to bind the Company for all acts within
the bounds laid down by its purpose and by the law.
The powers and remuneration of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the
first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 11. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regu-
larly taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.
Art. 12. The sole partner exercises the powers devolved to the meeting of partners by the dispositions of Section
XII relating to sociétés à responsabilité limitée of the law of August 10th, 1915.
As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole partner.
17624
In case of more partners, the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the partners meet-
ing.
Resolutions are validly adopted when taken by partners representing more than half of the capital.
However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a super-majority vote
of partners representing at least three quarters of the capital. If this super-majority is not attained at a first meeting, the
partners shall be convened at a second meeting having the same agenda, with at least thirty days notice, which will be
held within two months from the first meeting.
At this second meeting, decisions will be taken by a single majority vote of partners, regardless of the amount of cap-
ital being represented at such second meeting.
Art. 13. The Company’s financial year runs from the first of January to the thirty-first of December.
Art. 14. Each year, as of the 31st of December, the management will draw up the balance sheet which will contain
a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex con-
taining a summary of all its commitments and the debts of the managers toward the company.
At the same time the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meet-
ing of partners together with the balance sheet.
Art. 15. Each partner may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.
Art. 16. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but
must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.
The excess is distributed among the partners. However, the partners may decide, at the majority vote determined
by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an ex-
traordinary reserve.
Art. 17. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by the managers or a partner
upon agreement which are vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of debts.
When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the partners pro-
portionally to the shares they hold.
Art. 18. For all matters not provided for in the present articles of incorporation, the partners refer to the existing
laws.
<i>Transitory Measurei>
Exceptionally, the first financial year shall begin today and end on December 31, 2000.
<i>Payment - Contributionsi>
Nowor Limited, sole founder prenamed, declares and acknowledges that each subscribed share has been fully paid
up in cash, so that from now on the Company has at its free and entire disposal the contributions referred to above.
Proof thereof has been given to the undersigned notary who expressly acknowledges it.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about sixty thousand Luxembourg Francs.
<i>Extraordinary General Meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-
scribed capital and exercising the powers of the meeting, passed the following resolutions:
1) Is appointed as managers for an undetermined duration
Mr Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, residing at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Mr Wayne Tallowin, Director, c/o ABACUS FINANCIAL SERVICES LTD, P.O. Box 626, National Westminster-
House, Le Truchot, St Peter Port, Guernsey GY1 4PW.
2) The Company shall have its registered office at L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the founder, the
present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person and in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
In faith of which We, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg City, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the proxy holder, said person signed with Us, the Notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trente octobre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
DOTCOMPLEMENT LIMITED, La Motte Chambers, St Helier, Jersey, Je1 1BJ Channel Islands
17625
ici représentée par Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée;
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte pour être formalisée avec lui.
Ensuite le comparant prédésigné, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné de dresser acte des
statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il a arrêté comme suit:
Art. 1
er
. II est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les présents statuts et
les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et du 18 septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée, telles que modifiées, et plus particulièrement la loi du
28 décembre 1992 sur les sociétés unipersonnelles, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La Société prend la dénomination de LeDaLux, S.à r.l.
Art. 3. L’objet de la Société est de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-
prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d’acquérir tous titres et
droits par voie de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute
autre manière et notamment d’acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d’octroyer aux en-
treprises dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes
opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, toutefois sans vouloir
bénéficier de la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés holding.
La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les secteurs prédécrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 18,200,- (dix-huit mille deux cents euros) divisé en 182 (cent quatre-vingt-
deux) parts sociales de EUR 100,- (cent euros) chacune.
Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Une cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu’avec l’agrément des autres
associés et après leur avoir été offerte en priorité.
Pour le reste il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune d’elle.
Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture d’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Art. 9. Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce
soit, requérir l’apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.
Art. 10. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, choisis par les associés avec ou sans
limitation de la durée de leur mandat.
Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans justification, par une résolution des associés titulaires
à la majorité des votes.
Chaque gérant aura individuellement et sous sa seule signature les pleins pouvoirs pour engager la Société pour tous
actes, dans les limites fixées par son objet social ou la loi.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement
des premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.
Art. 11. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n’est responsable que de l’exécution de son mandat.
Art. 12. L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale des associés par les dispositions de la
section XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.
Il s’ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d’associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises en assemblée
générales.
Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu’elles soient prises par les associés représentant plus
de la moitié du capital social.
Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu’à une majorité qua-
lifiée des associés représentant les trois quarts du capital social. Si ce quorum n’est pas atteint lors de la première as-
semblée, les associés seront convoqués avec le même ordre du jour et moyennant un préavis de trente jours à une
seconde asemblée qui se tiendra endéans les deux mois de la première.
17626
Lors de cette seconde assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votants quelle que soit
la portion du capital représenté.
Art. 13. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.
Art. 14. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l’inventaire des avoirs
de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements,
ainsi que les dettes des gérants et associés envers la société.
Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l’assemblée ensemble avec
le bilan.
Art. 15. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire, du bilan et du compte
de profits et pertes.
Art. 16. L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements
et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d’être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais
devront être repris jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.
Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par
la loi, décider qu’après déduction de la réserve légale, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réservé
spéciale.
Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par les gérants
ou un associé désigné et qui auront les pouvoirs les plus larges pour réaliser les actifs et régler le passif de la Société.
La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts sociales qu’ils
détiennent.
Art. 18. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
<i>Disposition transitoirei>
Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2000.
<i>Libération - Apportsi>
NOWOR LIMITED, seul fondateur prédésigné, déclare et reconnaît que chacune des parts sociales souscrites a été
intégralement libérée en espèces, de sorte que les apports susmentionnés sont dès à présent à l’entière et libre dispo-
sition de la Société.
Preuve en a été apportée au notaire instrumentant qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ soixante mille francs luxembourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,
exerçant les pouvoirs de l’assemblée, a pris les résolutions suivantes:
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
Monsieur Gérard Becquer, réviseur d’entreprises, demeurant à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
M. Wayne Tallowin, Director, c/o ABACUS FINANCIAL SERVICES LTD, P.O. Box 626, National WestminsterHou-
se, Le Truchot, St PeterPort, Guernsey GY1 4PW.
2) Le siège social de la Société est établi à L-1471 Luxembourg, 400, route d’Esch.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate par le présent qu’à la requête du fondateur les présents
statuts sont rédigés en anglais, suivis d’une version française; à la requête de la même personne et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: P. Van Hees, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 7 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 64, case 9. – Reçu 7.342 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65663A/211/249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
J. Elvinger.
17627
N.H.C. HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, am sechzehnten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Gérard Lecuit, Notar im Amtswohnsitz in Hesperange.
Sind erschienen:
1. Herr Gérard Matheis, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie,
vertreten durch Herrn Paul Marx, docteur en droit, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïence-
rie, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 27. September 2000, und
2. Herr Cornelius Martin Bechtel, conseil économique, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la
Faïencerie, vertreten durch Herrn Paul Marx, vorgenannt, aufgrund einer Vollmacht, ausgestellt in Luxemburg, am 27.
September 2000.
Diese Vollmachten werden nach Unterzeichnung durch den Notar und den Bevollmächtigten mit dieser Urkunde ein-
registriert werden.
Der Bevollmächtigte ersucht den Notar im Namen der Komparenten nachstehenden, durch alle Parteien vereinbar-
ten Gesellschaftsvertrag wie folgt zu beurkunden:
Titel I - Name - Sitz - Zweck - Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung N.H.C. HOLDING S.A. wird hiermit eine Holdinggesellschaft in Form einer Aktien-
gesellschaft gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg. Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden ande-
ren Ort innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollten aussergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche ge-
eignet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem
Sitz und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederher-
stellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsange-
hörigkeit nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden,
welches unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.
Art. 3. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung, die Verwertung und die Veräusserung von Beteili-
gungen in irgendwelcher Form an anderen in- und ausländischen Kapitalgesellschaften. Sie kann auch Anleihen aufneh-
men und den Gesellschaften, an denen sie direkt beteiligt ist, jede Art von Unterstützung, Darlehen, Vorschuss oder
Sicherheit gewähren.
Desweiteren kann die Gesellschaft alle sonstigen Arten von Wertpapieren erwerben, sei es durch Zeichnung, Kauf,
Tausch oder sonstwie, und dieselben durch Verkauf, Tausch oder sonstwie veräussern.
Ausserdem kann die Gesellschaft Patente und Lizenzen, sowie davon abgeleitete oder dieselben ergänzende Rechte
erwerben, verwerten und veräussern.
Generell wird die Gesellschaft nur solche Geschäfte tätigen, die das Gesetz vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesell-
schaften gestattet.
Titel II - Kapital - Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) aufgeteilt in
1.250 (tausendzweihundertfünfzig) Aktien mit einem Nennwert von je EUR 1.000,- (tausend Euro).
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der Ak-
tionäre.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Titel III - Verwaltung
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Rat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, welche nicht Aktionäre zu
sein brauchen und welche für eine Amtszeit von höchstens sechs Jahren durch die Generalversammlung der Aktionäre
bestellt werden. Die Generalversammlung darf sie jederzeit abberufen.
Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.
Art. 7. Der Verwaltungsrat wird unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden ernennen.
Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft er-
fordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im
Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsra-
tes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.
17628
Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die
Einzelunterschrift des delegierten Verwaltungsratsmitgliedes rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezi-
elle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im Falle der Befugnisübertragung oder Vollmachterteilung
durch den Verwaltungsrat im Rahmen des Artikels 10 dieser Satzung.
Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren
Verwaltungsratsmitgliedem, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.
Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertra-
gen und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben
brauchen nicht Aktionäre zu sein.
Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesell-
schaft vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck
bestimmte Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.
Titel IV - Aufsicht
Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung
der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt ausserdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amts-
zeit, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Titel V - Generalversammlung
Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet statt an dem in der Einberufung angegebenen Ort, am 15. Septem-
ber um 9.00 Uhr.
Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Titel VI - Geschäftsjahr - Gewinnverteilung
Art. 14. Das Geschäftsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres.
Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Ab-
schreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenom-
men und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend
vorgeschrieben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder eingesetzt werden bis
zu ihrer vollständigen Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund
auch immer in Anspruch genommen worden ist.
Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.
Titel VII - Auflösung - Liquidation
Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein
oder mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre,
welche ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.
Titel VIII - Allgemeine Bestimmungen
Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, sowie die Bestim-
mungen des Gesetzes vom 31. Juli 1929 über die Holdinggesellschaften, einschliesslich der Änderungsgesetze, finden ihre
Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.
<i>Zeichnungi>
Nach erfolgter Festlegung der Satzung erklären die Komparenten, das gennante Kapital wie folgt zu zeichnen:
Sämtliche Aktien wurden zu 100 % (hundert Prozent) in bar eingezahlt ; demgemäss verfügt die Gesellschaft ab sofort
uneingeschränkt über einen Betrag von EUR 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Euro) wie dies dem
Notar nachgewiesen wurde.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr läuft vom Tag der Unterzeichnung dieser Urkunde bis zum 31.Dezember 2001.
Die erste jährliche Generalversammlung findet im Jahr 2002 statt.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr 600.000,- LUF.
Herr Gérard Matheis , vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 Aktien
Herr Comelius Martin BECHTEL, vorgenannt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
625 Aktien
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.250 Aktien
17629
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Alsdann traten die eingangs erwähnten Parteien, die das gesamte Aktienkapital vertreten, zu einer ausserordentlichen
Generalversammlung zusammen, zu der sie sich als rechtens einberufen bekennen. Sie fassten, nachdem sie die ord-
nungsgemässe Zusammensetzung dieser Generalversammlung festgestellt hatten, einstimmig folgende Beschlüsse
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 3 und diejenige der Kommissare auf 1 festgelegt.
2. Folgende Personen werden in den Verwaltungsrat berufen:
a) Herr Gérard Matheis, vorgenannt,
b) Herr André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, beruflich wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la
Faïencerie, und
c) Herr Cornelius Martin Bechtel, vorgenannt.
3. Zum Kommissar wird ernannt:
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, INTERAUDIT mit Sitz in L-1511 Luxemburg, 119, avenue de la Faïencerie.
4. Die Amtszeit der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars wird am Ende der jährlichen Generalversamm-
lung des Jahres 2006 enden.
5. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II.
6. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die tägliche Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft an die Herren
Gérard Matheis und André Wilwert, vorgenannt, zu übertragen.
Woraufhin diese notarielle Urkunde an dem zu Beginn erwähnten Tag erstellt wurde.
Nachdem die Urkunde dem Bevollmächtigten vorgelesen worden war, wurde sie von dem Bevollmächtigten und dem
Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: P. Marx, G. Lecuit
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 126S, fol. 52, case 4. – Reçu 504.249 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift zwecks der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(65668A/220/156) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
N.H.C. HOLDING S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2340 Luxemburg, 23, rue Philippe II.
—
Den Herren André Wilwert, diplômé ICHEC Bruxelles, und Gérard Matheis, conseil économique, beide beruflich
wohnhaft in L-1511 Luxemburg, 121, avenue de la Faïencerie, wurde die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft mit
Einzelzeichnungsbefugnis übertragen und Herr André Wilwert, vorgenannt, wurde zum Vorsitzenden des Verwaltungs-
rates ernannt.
Luxemburg, den 16. Oktober 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 2000, vol. 126S, fol 52, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Auf Anfrage der Gesellschaft zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
(65669A/220/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
RICHEMONT LUXURY GROUP S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 62.422.
—
In the year two thousand, on the ninth of November.
Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg,
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of RICHEMONT LUXURY GROUP S.A. (the «Corpo-
ration»), a société anonyme, having its registered office in Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, (R.C. Luxem-
bourg B 62.422), incorporated pursuant to a deed of Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg, on July 28,
1993 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), number 400 of September 2,
1993. The Articles of Incorporation have been amended several times and for the last time by deed of Maître Jacques
Delvaux, notary, residing in Luxembourg, dated 23rd May 2000, published in the Mémorial number 730 of October 5,
2000.
The meeting was opened at 11.30 a.m., presided by Mr Christian Scheer, licencié en droit, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Léon Gloden, maître en droit, residing in Luxembourg
The meeting elected as scrutineer Mr Bertrand Reimmel, maître en droit, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record:
Hesperingen, den 15. November 2000.
G. Lecuit.
für gleichlautende Mitteilung
<i>für N.H.C. HOLDING S.A.
i>Unterschrift
Hesperingen, den 15. November 2000.
G. Lecuit.
17630
I. That the agenda of the meeting is as follows:
A. Conversion of the capital of the Corporation into Euro with effect from 1st October, 2000 at the Euro/Swiss Franc
exchange rate prevailing as at the close of business on 29th September, 2000 so that the amount of five billion Swiss
Francs (CHF 5,000,000,000.-), representing the capital is converted into three billion two hundred and eighty-two mil-
lion one hundred and thirty-two thousand and seventy-two euro (EUR 3,282,132,072.-) and the restatement of the cap-
ital at three billion euro (EUR 3,000,000,000.-), the balance of the existing capital consisting in two hundred and eighty-
two million one hundred and thirty-two thousand and seventy-two euro (EUR 282,132,072.-) being allocated to the
paid-in surplus.
B. Consequent amendment of paragraph 1 of article 5 of the articles of incorporation.
II. The shareholders represented, the proxies of the represented parties and the number of their shares are shown
on an attendance list; this attendance list, signed by the proxies, the Board of the meeting and the undersigned notary,
will remain annexed to the present deed.
III. The whole corporate capital is represented at the present meeting.
IV. It appears from the above that the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on the agen-
da.
After deliberation, the meeting unanimously resolved as follows:
<i>First resolutioni>
It is resolved to convert the capital of the Corporation into euro with effect from 1st October, 2000 at the Euro/
Swiss Franc exchange rate prevailing as at the close of business on 29th September, 2000 so that the amount of five
billion Swiss Francs (CHF 5,000,000,000.-) representing the capital is converted into three billion two hundred and
eighty-two million one hundred and thirty-two thousand and seventy-two euro (EUR 3,282,132,072.-) and to restate
the capital at three billion euro (EUR 3,000,000,000.-), the balance of the existing capital consisting in two hundred and
eighty two million one hundred and thirty-two thousand and seventy-two euro (EUR 282,132,072.-) being allocated to
the paid-in surplus.
<i>Second resolutioni>
As a result of the preceding resolutions, the meeting resolved to amend the first paragraph of Article 5 of the articles
of incorporation of the Corporation so as to read as follows:
«The subscribed capital of the Corporation is set at three billion euro (EUR 3,000,000,000.-) divided into four hun-
dred eighty-eight million and four hundred thousand (488,400,000) shares with no par value.»
There being nothing further on the agenda, the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Corporation as
a result of its conversion of capital are estimated at thirty-five thousand Luxembourg francs.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of di-
vergences between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading these minutes, the members of the bureau signed
together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille, le neuf novembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de RICHEMONT LUXURY GROUP S.A. (la «So-
ciété»), une société anonyme ayant son siège à Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri, (R.C. Luxembourg B
62.422), constituée par acte de Maître Frank Baden, notaire, résidant à Luxembourg, le 28 juillet 1993, publié au Mémo-
rial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 400 du 2 septembre 1993.
Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte de Maître Jacques Delvaux, notaire,
résidant à Luxembourg le 23 mai 2000, publié au Mémorial C, numéro 730 du 5 octobre 2000.
L’assemblée a commencé à 11.30 heures, présidée par Monsieur Christian Scheer, maître en droit, demeurant à
Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Monsieur Léon Gloden, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée a choisi comme scrutateur Monsieur Bertrand Reimmel, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et a demandé au notaire instrumentant d’ac-
ter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est comme suit:
A. Conversion du capital social de la Société en euro avec effet au 1
er
octobre 2000, au taux de conversion euro/
franc suisse prévalant à la clôture du marché le 29 septembre 2000, de telle sorte que le montant de cinq milliards de
francs suisses (CHF 5.000.000.000,-) représentant le capital social est converti en trois milliards deux cent quatre-vingt-
deux millions cent trente-deux mille et soixante-douze euros (EUR 3.282.132.072,-) et la refixation du capital social à
trois milliards d’euros (EUR 3.000.000.000,-), la différence de deux cent quatre-vingt-deux millions cent trente-deux mil-
le et soixante-douze euros (EUR 282.132.072,-) avec le capital existant étant affectée à la réserve prime d’émission.
B. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts.
17631
II. Les actionnaires représentés, les procurations des parties représentées et le nombre d’actions sont montrés sur
une liste de présence; la liste de présence, signée par les porteurs de procuration, le bureau de l’assemblée et le notaire
instrumentant restera annexée au présent acte.
III. L’intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée.
IV. Il apparaît de ce qui précède que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer
sur l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée a unanimement pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Il est décidé de convertir le capital social de la Société en euro avec effet au 1
er
octobre 2000, au taux de conversion
euro / franc suisse prévalant à la clôture du marché le 29 septembre 2000, de telle sorte que le montant de cinq milliards
de francs suisses (CHF 5.000.000,-) représentant le capital est converti en trois milliards deux cent quatre-vingt-deux
millions cent trente-deux mille et soixante-douze euros (EUR 3.282.132.072,-) et de refixer le capital à trois milliards
d’euros (EUR 3.000.000.000,-), Ia différence de deux cent quatre-vingt-deux millions cent trente-deux mille et soixante-
douze euros (EUR 282.132.072,-) avec le capital social existant étant affectée à la réserve prime d’émission.
<i>Deuxième résolutioni>
A la suite de la résolution qui précède, l’assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l’article 5 des statuts
pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital souscrit de la Société est fixé à trois milliards d’euros (EUR 3.000.000.000,-) divisé en quatre cent quatre-
vingt-huit millions quatre cent mille (488.400.000) actions sans valeur nominale.
Rien n’étant plus à l’ordre du jour, l’assemblée a été ensuite clôturée.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société à la suite de la conver-
sion en euro du capital s’élèvent à approximativement trente-cinq mille francs luxembourgeois.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants, le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Scheer, L. Gloden, B. Reimmel, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 13 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 71, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65669/211/53) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 novembre 2000.
FIEM HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. FIEM S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.346.
—
L’an deux mille, le dix octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme FIEM S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, constituée sous la dénomination PORTINCO S.A. suivant acte notarié, en date du 10 mars 1983, publié au Mé-
morial C, Recueil Spécial numéro 106 du 20 avril 1983, dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier
lieu suivant acte notarié, en date du 17 décembre 1996, publié au Mémorial C, Recueil numéro 130 du 18 mars 1997.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Tim van Dijk, administrateur de sociétés, demeurant à
Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire Madame Karine Vautrin, juriste, demeurant à F-Thionville.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Christelle Ferry, juriste, demeurant à Luxembourg. Le bureau ainsi
constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de la dénomination de la société en FIEM HOLDING S.A. et modification afférente de l’article 1
er
des
statuts.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs suisses en Euro.
3. Augmentation du capital social d’un montant maximum de soixante-huit mille trois cent quarante-sept virgule qua-
tre-vingt-dix-huit Euros (un maximum de 68.347,98 EUR) sans émission d’actions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette
augmentation, le capital social aura un montant maximum de un million quatre cent cinquante mille Euros (1.450.000,-
EUR), représenté par trente-neuf mille quatre cent quarante (39.440) actions sans désignation de valeur nominale.
Luxembourg, le 16 novembre 2000.
J. Elvinger.
17632
4. Souscription de cette augmentation de capital et paiement en espèces par les actionnaires.
5. Modification afférente de l’article 5 des statuts.
6. Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la société en FIEM HOLDING S.A. et décide en conséquence de
modifier l’article 1
er
des statuts comme suit:
«Art. 1
er
. Il est formé une société anonyme sous la dénomination de FIEM HOLDING S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir la monnaie d’expression du capital social de francs suisses (CHF) en Euro (EUR) avec
effet au 29 septembre 2000 au cours de change de 1,52585 CHF pour 1,- EUR applicable au 29 septembre 2000 et, sur
base du cours préindiqué.
La preuve du cours existant entre le franc suisse et l’Euro au 29 septembre 2000 a été apportée au notaire instru-
mentant suivant certificat bancaire.
L’assemblée décide de changer la monnaie d’expression de tous les comptes de la société de francs suisses (CHF) en
Euro (EUR).
Après cette conversion, le capital social est fixé à un million quatre cent onze mille neuf cent quarante virgule quatre-
vingt-neuf Euros (1.411.940,89 EUR), représenté par trente-neuf mille quatre cent quarante (39.440) actions sans dési-
gnation de valeur nominale.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social de cinquante-neuf virgule onze Euros (59,11 EUR) sans émission d’ac-
tions nouvelles, c’est ainsi qu’après cette augmentation, le capital social aura un montant de un million quatre cent douze
mille Euros (1.412.000,- EUR), représenté par trente-neuf mille quatre cent quarante (39.440) actions sans désignation
de valeur nominale.
<i> Quatrième résolutioni>
L’augmentation de capital a été intégralement libérée en espèces par les actionnaires actuels de la société au prorata
de leurs participations dans le capital de sorte que le montant de cinquante-neuf virgule onze Euros (59,11 EUR) est à
la disposition de la société; preuve de ces paiements a été donnée au notaire instrumentant.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article 5 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital social de la société est fixé à un million quatre cent douze mille Euros (1.412.000,- EUR), repré-
senté par trente-neuf mille quatre cent quarante (39.440) actions sans désignation de valeur nominale.»
<i>Fraisi>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de cinquante-neuf virgule onze Euros (59,11 EUR) est évalué à deux
mille trois cent quatre-vingt-quatre francs luxembourgeois (2.384,- LUF).
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes à environ vingt-cinq mille francs luxembour-
geois (25.000,- LUF).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: T. van Dijk, K. Vautrin, C. Ferry, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 43, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65797/220/89) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
17633
FIEM HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. FIEM S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.346.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65798/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
IBERCAPITAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.370.
—
In the year two thousand, on the eleventh day of October at 11.30. am.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of IBERCAPITAL S.A, a société anonyme, having its reg-
istered office in Luxembourg, incorporated by a notarial deed on the 28th of November, 1990, published in the Mémo-
rial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, of 1991 page 7500, the articles of which have been amended several
times and for the last time pursuant to a notarial deed on the 25th of February 1992, published in the Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, of 1992 page 15924.
The company was set into liquidation by a deed of the undersigned notary of December 2, 1999, published in the
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 123 of February 5, 2000.
The meeting was opened by Mr Hans de Graaf, managing director, residing in Mamer, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Ruth Brand, employée privée, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Juliette Lorang, administrateur de sociétés, residing in Neuhäusgen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. That the present extraordinary general meeting has been convened by registered letters to the holders of shares
(all in registered form) on the 22nd of September 2000.
II. The agenda of the meeting is the following:
1. Report of the liquidator.
2. Appointment of an auditor («commissaire»).
3. New appointment for a second general meeting, which will approve the audit report, give discharge to the liquida-
tor and close the liquidation.
III. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
IV. As appears from the said attendance list, 15,688 shares out of 16,279 shares in circulation are present or repre-
sented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
V. As a consequence, more than half of the capital being present or represented, the present meeting is regularly
constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting listens to the report of the liquidator, i.e., MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., on the
management and the use of the social goods.
<i> Second resolutioni>
The general meeting appoints as auditor for the liquidation (commissaire à la liquidation), in conformity with article
151 of the law of August 10, 1915 governing commercial companies: Mrs Juliette Lorang, prenamed.
<i>Third resolutioni>
The general meeting decides that a second general meeting will be held immediately after the present meeting with
the following agenda:
1. Approval of the audit report.
2. Discharge to the liquidator for the performance of his mandate.
3. Closing of the liquidation.
4. Fixing of the place where the company’s documents and vouchers are to be kept during the five years following
the closing of the liquidation.
5. Sundries.
There being no further business, the meeting is terminated at 12.00 a.m.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
17634
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille le onze octobre à 11.30 heures.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IBERCAPITAL S.A., avec siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 28 novembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, de 1991 page 7500 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant
acte notarié du 25 février 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et associations, de 1992 page 15924.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 décembre 1999, publié
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 123 du 5 février 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hans de Graaf, administrateur de sociétés, demeurant à Ma-
mer,
qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Juliette Lorang, administrateur de sociétés, demeurant à Neuhäusgen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées aux propriétaires
d’actions (toutes sous forme nominative) en date du 22 septembre 2000.
II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du liquidateur
2) Nomination du commissaire
3) Fixation d’une seconde assemblée, qui entendra le rapport du commissaire, donnera décharge au liquidateur et
prononcera la clôture de la liquidation.
III. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
IV. - Qu’il ressort de la dite liste de présence que 15.688 actions sur les 16.279 actions en circulation sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale.
V. - Qu’en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement cons-
tituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée entend le rapport du liquidateur, savoir, MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A., sur la gestion et
l’emploi des valeurs sociales.
<i>Deuxième résolutioni>
Après avoir délibéré, l’assemblée nomme en qualité de commissaire à la liquidation conformément à l’article 151 de
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales: Madame Juliette Lorang, prénommée.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide encore qu’une seconde assemblée se tiendra à la suite des présentes et aura pour ordre du jour:
1) rapport du commissaire.
2) décharge au liquidateur.
3) clôture de la liquidation.
4) Fixation de l’endroit où les documents et livres de la société seront conservés durant les cinq années qui suivront
la liquidation.
5) Divers.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.00 heures.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. de Graaf, R. Brand, J. Lorang, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 42, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65823/220/124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
17635
IBERCAPITAL S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.370.
—
DISSOLUTION
In the year two thousand, on the eleventh day of October at 12.00. a.m.
Before the undersigned Maître Gérard Lecuit, notary public residing in Hesperange.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of IBERCAPITAL S.A., a société anonyme, having its reg-
istered office in Luxembourg, incorporated by a notarial deed on the 28th of November, 1990, published in the Mémo-
rial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, of 1991 page 7500, the articles of which have been amended several
times and for the last time pursuant to a notarial deed on the 25th of February 1992, published in the Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et associations, of 1992 page 15924.
The company was set into liquidation by a deed of the undersigned notary of December 2, 1999, published in the
Mémorial, Recueil des sociétés et Associations, number 123 of February 5, 2000.
The meeting was opened by Mr Hans de Graaf, managing director, residing in Mamer, being in the chair,
who appointed as secretary Mrs Ruth Brand, employée privée, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Juliette Lorang, administrateur de sociétés, residing in Neuhäusgen.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. That the present extraordinary general meeting has been convened by registered letters to the holders of shares
(all in registered form) on the 22nd of September 2000.
II. The agenda of the meeting is the following:
1. Approval of the audit report.
2. Discharge to the liquidator for the performance of his mandate.
3. Closing of the liquidation.
4. Fixing of the place where the company’s documents and vouchers are to be kept during the five years following
the closing of the liquidation.
5. Sundries.
III. The extraordinary general meeting of shareholders, at its meeting held on the 11th of October 2000 has nomi-
nated Mrs Juliette Lorang, prenamed, after having heard the liquidator’s report, as «commissaire à la liquidation»
and has fixed at this day, hour and location the present meeting.
IV. The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxy holders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.
The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
V. As appears from the said attendance list, 15,308 shares out of 16,279 shares in circulation are present or repre-
sented at the present general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.
VI. As a consequence, more than half of the capital being present or represented, the present meeting is regularly
constituted and may validly deliberate on the items of the agenda.
After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting hears the audit report of Mrs Juliette Lorang, previously named, on the verification of the doc-
uments of the liquidation and the work of the liquidator.
This report proposes to adopt the accounts of the liquidation and to grant discharge to the liquidator.
<i>Second resolutioni>
Adopting the conclusion of the audit report, the general meeting approves the accounts of the liquidation and grants
full and complete discharge, without any reserve nor restriction, to the liquidator, MeesPIERSON TRUST (LUXEM-
BOURG) S.A. The general meeting grants the same discharge to the «commissaire à la liquidation», previously named.
<i>Third resolutioni>
The general meeting declares the liquidation as accomplished and the company IBERCAPITAL S.A. to have ceased to
exist.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides that the company’s documents and vouchers are to be kept during the five years follow-
ing the closing of the liquidation at 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg.
There being no further business, the meeting is terminated at 12.30. p.m.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is
worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will be binding.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
17636
Suit la version française:
L’an deux mille, le onze octobre à 12.00 heures.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme IBERCAPITAL S.A., avec siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte notarié du 28 novembre 1990, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, de 1991 page 7500 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant
acte notarié du 25 février 1992, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et associations, de 1992, page 15924.
La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 5 décembre 1999, publié
au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 123 du 5 février 2000.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hans de Graaf, administrateur de sociétés, demeurant à Ma-
mer,
qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Juliette Lorang, administrateur de sociétés, demeurant à Neuhäusgen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par lettres recommandées aux propriétaires
d’actions (toutes sous forme nominative) en date du 22 septembre 2000.
II. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Rapport du commissaire.
2) Décharge au liquidateur.
3) Clôture de la liquidation.
4) Fixation de l’endroit où les livres et documents de la société seront gardés durant les cinq années qui suivront la
clôture de la liquidation.
5. Divers.
III. - Que l’assemblée générale extraordinaire tenue par-devant le notaire instrumentant, en date de ce jour, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a nommé en sa qualité de commissaire à la liquidation:
Madame Juliette Lorang, prénommée, et a fixé à ces jour, heure et lieu la présente assemblée.
IV. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée «ne
varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bu-
reau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de
l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
V. - Qu’il ressort de ladite liste de présence que 15.308 actions sur les 16.279 actions en circulation sont présentes
ou représentées à la présente assemblée générale.
VI. - Qu’en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement cons-
tituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée entend le rapport de Madame Juliette Lorang sur l’examen des documents de la liquidation et sur la ges-
tion du liquidateur.
Ce rapport conclut à l’adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
<i> Deuxième résolutioni>
Adoptant les conclusions de ce rapport, l’assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine
et entière, sans réserve ni restriction, au liquidateur MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A. de sa gestion de li-
quidateur de la société.
L’assemblée donne également décharge au commissaire pour l’exécution de son mandat.
<i> Troisième résolutioni>
L’assemblée prononce la clôture de liquidation et constate que la société IBERCAPITAL S.A. a définitivement cessé
d’exister.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à
partir d’aujourd’hui à L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 12.30 heures.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l’a requis
de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d’une version française, et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
17637
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: H. de Graaf, R. Brand, J. Lorang, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 42, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65824/220/139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
CIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3514 Dudelange, 83, route de Kayl.
R. C. Luxembourg B 64.090.
—
L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant, Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CIMEX S.A., avec siège social à Mamer,
constituée par acte du notaire instrumentant, en date du 6 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil numéro 501 du 7
juillet 1998.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Liliane Hofferlin, employée privée, demeurant à Howald,
qui désigne comme secrétaire Madame Myriam Schmit, employée privée, demeurant à Kehlen.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alexandre Jelobetski, manager, demeurant à Mamer.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1) Transfert du siège social de la société de Mamer à L-3514 Dudelange, 83, route de Kayl.
2) Modification afférente de l’article 2 des statuts.
3) Acceptation de la démission de Mademoiselle Céline Humbert de son mandat d’administrateur et décharge.
4) Nomination d’un nouvel administrateur.
5) Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et décharge.
6) Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes.
7) Divers.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstrac-
tion des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et décla-
rant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer le siège social à L-3514 Dudelange, 83, route de Kayl, de sorte que le pre-
mier alinéa de l’article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2, 1
er
alinéa. Le siège de la société est établi à Dudelange.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide d’accepter la démission de Mademoiselle Céline Humbert de son mandat d’administrateur et de
la société Capital PARTNERS, S.à r.l., de son mandat de commissaire aux comptes et leur accorde pleine et entière
décharge en ce qui concerne l’exercice de leurs fonctions jusqu’à ce jour.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer un nouvel administrateur, qui continuera le mandat de l’administrateur démissionnai-
re, à savoir:
Monsieur Raphaël Ioppo, administrateur de société, demeurant à Luxembourg.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide de nommer un nouveau commissaire aux comptes, qui continuera le mandat du commissaire dé-
missionnaire, à savoir:
INTERAUDIT, S.à r.l., ayant son siège social à Luxembourg.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
17638
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: L. Hofferlin, M. Schmit, A. Jelobetski, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 126S, fol. 45, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65733/200/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
CIMEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3514 Dudelange, 83, route de Kayl.
R. C. Luxembourg B 64.090.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65734/200/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
EXMAR LUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 9, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 35.901.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 33, case 6, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65795/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
ESCALADE S.A., Société Anonyme,
(anc. ESCALADE HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.020.
—
L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ESCALADE HOLDING S.A., avec siège
social à Luxembourg, constituée suivant acte notarié en date du 13 février 1996, publié au Mémorial, Recueil des Socié-
tés et Associations, de 1996 page 11750.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hans de Graaf, managing director, demeurant à Mamer,
qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Juliette Lorang, administrateur de sociétés, demeurant à Neuhäusgen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Changement de la dénomination sociale de ESCALADE HOLDING S.A. en ESCALADE S.A.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale ESCALADE HOLDING S.A. en ESCALADE S.A., de sorte que
l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination ESCALADE S.A.»
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
EXMAR LUX S.A.
17639
Suit la version anglaise:
«Art. 1. A corporation exists in the form of a société anonyme, under the name of ESCALADE S.A.»
<i> Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes est évalué à environ 20.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. de Graaf, R. Brand, J. Lorang, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 42, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65793/220/50) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
ESCALADE S.A., Société Anonyme,
(anc. ESCALADE HOLDING S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 54.020.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65794/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 47.240.
Société constituée par acte devant M
e
André Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 avril 1994,
publié au Mémorial C, Recueil N° 186 du 11 mai 1994.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 8 novembre 2000 à 11.00 heures au siège sociali>
Mode de convocation:
- Tous les actionnaires étant présents ou représentés, il a été fait abstraction des convocations d’usage.
Présences:
- Voir liste annexe
Bureau:
- Président: Gérard Binet;
- Scrutateur: Paul Henrion;
- Secrétaire: Antoine Lecomte.
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de réviseur des comptes d’INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A.
<i>Résolutionsi>
1. L’Assemblée a pris acte de la démission du cabinet DEBELUX AUDIT S.A. (MAZARS ET GUERARD) comme ré-
viseur des comptes d’INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A.
2. L’Assemblée approuve la nomination d’ARTHUR ANDERSEN dont le siège social est situé 6, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg comme nouveau réviseur des comptes d’INVESTLIFE LUXEMBOURG S.A.
Ce mandat prend effet à compter du 8 novembre 2000.
Toutes ces résolutions ont été adoptées à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12.00 heures
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65839/009/37) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
Statuts modifiés par acte devant M
e
André Schwachtgen, en date du 14 juin 1995, publié au Mémorial C, Recueil
N° 440 du 8 septembre 1995.
Statuts modifiés par acte N° 1401 devant M
e
André Schwachtgen, en date du 10 décembre 1999.
Signatures
<i>Scrutateur / Secrétaire / Présidenti>
17640
IPN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R. C. Luxembourg B 31.518.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 33, case 2, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65840/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
FMC FINANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. NEPHROCARE EUROPE S.A., Société Anonyme).
Registered office: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 62.086.
—
In the year two thousand, on the seventh November.
Before Us, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy of Lux-
embourg).
Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the company NEPHROCARE EUROPE S.A., with
registered office in L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon Premier, duly registered with the register of com-
merce and companies Luxembourg under section B number 62.086, incorporated by a deed of the undersigned notary
on December 2, 1997, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 174 of March 24,
1998.
The extraordinary general meeting of shareholders is opened by Maître Rina Breininger, lawyer, residing in Luxem-
bourg, acting as chairman.
The Chairman appointed as secretary of the meeting Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting appointed as scrutiniser Maître Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the committee of the meeting draws up the attendance list, which, after having been
signed ne varietur by any shareholder present and any representative in proxy, as well as by the members of the com-
mittee and the notary, will remain attached to the present minutes together with any proxy for the purpose of regis-
tration.
The chairman declared and requested the notary to declare that:
According to the attendance list, all shareholders representing the entire share capital of two hundred and fifty thou-
sand French francs (FRF 250,000.-) are duly present or validly represented at the meeting. The meeting can thus validly
deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening.
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Change of the currency of the issued share capital from French francs to Euro, the share capital resulting of such
change amounting to thirty eight thousand one hundred and twelve point two hundred and fifty-four Euros (Euros
38,112,254.-)
2. Increase of the issued share capital as results from the foregoing by an amount of three hundred and eighty seven
point seven hundred and forty six Euros (Euros 387,746.-) to raise it from its amount of thirty-eight thousand one hun-
dred and twelve point two hundred and fifty-four Euros (Euros 38,112,254.-) to thirty-eight thousand five hundred Euros
(Euros 38,500.-), represented by one thousand five hundred and forty (1,540) shares with a par value of twenty-five
Euros (Euros 25.-) each, without issuing new shares, by taking out of the reserves of a total amount of three hundred
and eighty-seven point seven hundred and forty-six Euros (Euros 387,746.-)
3. Transfer of the registered office of the Company to L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
4. Change of the object of the Company as follows:
«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.
It may lend or borrow with or without security, provided that any moneys so borrowed may only be used for the
purposes of the corporation, or companies which are subsidiaries of or sister companies to the corporation; in general,
it may undertake any operations directly connected with these objects.
The Company may participate in the establishment and development of any industrial, commercial or financial enter-
prise in Luxembourg and abroad.
Generally, it may render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise. Also, the Company may
borrow in any form and in connection therewith issue bonds, debentures and otherwise evidences of indebtedness.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.»
5. Change of the legal form of the Company to convert it from a «Société Anonyme» to a «Société à Responsabilité
Limitée».
6. Change of the name of the Company to FMC FINANCE II, S.à r.l.
7. Adaptation of the articles of association to the new legal form of the Company.
Luxembourg, le 22 novembre 2000.
B. Risack.
17641
8. Termination of the mandates of the Directors and the statutory auditor.
9. Full and complete discharge to the Directors and to the statutory auditor.
10. Fixing of the number of managers and appointment of the managers.
11. Any other business.»
Then, the meeting of shareholders, after having considered itself as duly composed and convened, and given its ap-
proval to the explanations of the chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to change the currency of the share capital from French francs to Euro, the share capital re-
sulting of such change amounting to thirty eight thousand one hundred and twelve point two hundred and fifty-four Eu-
ros (Euros 38,112,254.-).
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company as results from the foregoing by an amount
of three hundred and eighty seven point seven hundred and forty-six Euros (Euros 387,746.-) to raise it from its amount
of thirty-eight thousand one hundred and twelve point two hundred and fifty-four Euros (Euros 38,112,254.-) to thirty
eight thousand five hundred Euros (Euros 38,500.-), represented by one thousand five hundred and forty (1,540) shares
with a par value of twenty-five Euros (Euros 25.-) each, without issuing new shares, by taking out of the reserves of a
total amount of three hundred and eighty-seven point seven hundred and forty-six Euros (Euros 387,746.-) such as has
been justified to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolved to transfer the registered office of the Company to L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert
Stumper.
<i>Fourth resolutioni>
The Company resolved to change the object of the Company and to subsequently amend article 2 of the articles of
incorporation so as to reflect the change of the object to read as follows:
«The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg companies and
foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, ex-
change or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, adminis-
tration, development and management of its portfolio.
It may lend or borrow with or without security, provided that any moneys so borrowed may only be used for the
purposes of the corporation, or companies which are subsidiaries of or sister companies to the corporation; in general,
it may undertake any operations directly connected with these objects.
The Company may participate in the establishment and development of any industrial, commercial or financial enter-
prise in Luxembourg and abroad.
Generally, it may render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise.
Also, the Company may borrow in any form and in connection therewith issue bonds, debentures and otherwise
evidences of indebtedness.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.»
<i>Fifth resolutioni>
The meeting resolved to change the legal form of the Company without interruption of its legal personality and to
adopt the form of a Société à Responsabilité Limitée.
The share capital and the reserves stay unchanged as well as all the assets and liabilities, the redemptions, the de-
creases and increases of value, and the Société à Responsabilité Limitée will continue the book entries and the account-
ancy held by the Société Anonyme.
Each of the shares of the Company has been fully paid in before the transformation of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The meeting resolved to change the name of the Company from NEPHROCARE EUROPE S.A. to FMC FINANCE
II, S.à r.l.
<i>Seventh resolutioni>
The meeting resolved to adapt the articles of incorporation to the new legal form as well as to the aforementioned
changes and to fix the articles of incorporation of the Société à Responsabilité Limitée as follows:
Title I - Name - Duration - Registered office - Purpose
Art. 1. There is hereby established between the subscriber and all those who may become members in the future,
a Company with limited liability (société à responsabilité limitée), under the name of FMC FINANCE II, S.à r.l.
Art. 2. The Company is established for an unlimited period.
Art. 3. The registered office of the corporation is established in Luxembourg City.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of its members. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of
the board of managers.
Art. 4. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg compa-
nies and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by
17642
sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership,
administration, development and management of its portfolio.
It may lend or borrow with or without security, provided that any moneys so borrowed may only be used for the
purposes of the corporation, or companies which are subsidiaries of or sister companies to the Company; in general, it
may undertake any operations directly connected with these objects.
The Company may participate in the establishment and development of any industrial, commercial or financial enter-
prise in Luxembourg and abroad.
Generally, it may render every assistance, whether by way of loans, guarantees or otherwise.
Also, the Company may borrow in any form and in connection therewith issue bonds, debentures and otherwise
evidences of indebtedness.
In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful
in the accomplishment and development of its purposes.
Title II - Capital - Units
Art. 5. The subscribed capital is set at thirty eight thousand five hundred Euros (Euros 38,500.-), represented by one
thousand five hundred and forty (1,540) corporate units with a par value of twenty five Euros (Euros 25.-) each.
All the units have been subscribed by FRESENIUS MEDICAL CARE AG, a company incorporated under German law,
with registered office in D-61346 Bad Homburg, Else-Kröner-Str. 1 and have been entirely paid in.
Art. 6. Any regularly constituted meeting of members of the Company shall represent the entire body of members
of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the
Company.
Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of members duly convened will be passed by a simple
majority of those present and voting.
The capital and other provisions of these articles of incorporation may, at any time, be changed by the sole member
or by a majority of members representing at least three quarters (3/4) of the capital. The members may change the
nationality of the Company by an unanimous decision.
If all of the members are present or represented at a meeting of members, and if they state that they have been in-
formed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 7. Each unit is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.
The Company will recognize only one holder per unit; in case a unit is held by more than one person, the Company
has the right to suspend the exercise of all rights attached to that unit until one person has been appointed as the sole
owner in relation to the Company.
Each unit gives right to one fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to its relationship
with the number of units in existence.
Art. 8. If the Company has only one member, this sole member exercises all the powers of the general meeting.
The decisions of the sole member which are taken in the scope of the first paragraph are recorded in minutes or
drawn up in writing.
Also, contracts entered into between the sole member and the Company represented by him are recorded on min-
utes or drawn up in writing. Nevertheless, this latter provision is not applicable to current operations entered into un-
der normal conditions.
Art. 9. If the Company has at least two members, the corporate units are freely transferable between the members.
The unit transfer inter vivos to non-members is subject to the consent given in a general meeting of members rep-
resenting at least three quarters (3/4) of the Company’s capital.
In the case of the death of a member the unit transfer to non-members is subject to the consent of owners of units
representing no less than three quarters (3 /4) of the rights held by the surviving members. In this case, however, the
approval is not required if the units are transferred either to heirs entitled to a compulsory portion or to the surviving
spouse.
Art. 10. Death, loss of legal capacity, bankruptcy or insolvency of the sole member or of one of the members will
not bring the Company to an end.
Art. 11. For no reason and in no case, the creditors, legal successors or heirs are allowed to seal assets or docu-
ments of the Company.
Title III - Administration
Art. 12. The Company shall be managed by a board of managers composed of two managers at least who need not
be members of the Company.
The managers are appointed and removed by the general meeting of members, which determines their powers, com-
pensation and duration of their mandates. Their mandate may not exceed a period of six years and they shall hold office
until their successors are appointed.
Art. 13. The board of managers may choose from among its members a chairman. It may also choose a secretary,
who needs not be a manager, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
and of the members.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice
of meeting.
17643
Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in
advance of the hour set for such a meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the notice of the meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by
cable, telegram, telex or telefax of each manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at
times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable, telegram, telex
or telefax another manager as his proxy.
Votes may also be cast in writing or by cable, telegram, telex or telefax.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or repre-
sented at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of votes of the managers present
or represented at such meeting.
Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions voted at the man-
agers’ meetings.
Art. 14. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by
the chairman, by the secretary or by two managers.
Art. 15. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and dispo-
sition on behalf of the Company in its interests.
All powers not expressly reserved by law to the general meeting of members fall within the competence of the board
of managers.
The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and
the representation of the Company for such management and affairs, with prior consent of the general meeting of mem-
bers, to any manager or managers of the board or to any committee (the members of which need not be managers)
deliberating under such terms and with such powers as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees, and fix their
emoluments.
Art. 16. The Company will be bound by the joint signature of two managers or the single signature of any person
or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.
Art. 17. In the execution of their mandate, the managers are not held personally responsible for the obligations of
the Company. As agents of the Company, they are responsible for the correct performance of their duties.
Art. 18. The accounting year of the Company shall begin on January first of each year and shall terminate on De-
cember 31st, with the exception of the first accounting year, which shall begin on the date of the formation of the Com-
pany and shall terminate on December 31st of the year two thousand and one.
Art. 19. The annual accounts are drawn up by the board of managers as at the end of each fiscal year and will be at
the disposal of the members at the registered office of the Company.
Out of the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be placed into the legal reserve account. This
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10 %) of the capital of the Company.
The general meeting of members, upon recommendation of the board of managers, will determine how the annual
net profits will be disposed of.
Interim dividends may be distributed under the following conditions:
1. Interim accounts are drafted on a quarter or semi-annual basis,
2. These accounts show a profit including profits carried forward,
3. The decision to pay interim dividends is taken by the board of managers if there is enough cash. Otherwise, the
decision has to be taken by an extraordinary general meeting of the members.
Title IV - Winding-up - Liquidation
Art. 20. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
(who may be physical persons or legal entities) appointed by the meeting of members effecting such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
Art. 21. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law
of August 10, 1915 on commercial companies and amendments thereto.
<i>Eighth resolutioni>
Pursuant to the conversion of the Company into a Société à Responsabilité Limitée, the mandates of the three direc-
tors and of the statutory auditor of the Company are terminated.
The aforementioned sole member, representing the entire subscribed capital, gives full and complete discharge to the
directors and to the statutory auditor for their mandates.
<i>Ninth resolutioni>
The sole member resolves to fix the number of managers at three (3).
The following persons are appointed managers:
a) Dr Werner Brandt, Diplom-Kaufmann residing in D-61350 Bad Homburg, Heinrich von Kleist Strasse, 49A;
b) Dr Andrea Stopper, Doktor der Betriebswirtschaft, residing in CH-6900 Lugano, via privata Maraini Sommaruga,
26;
c) Mrs Gabriele Dux, Diplom-Kauffrau, residing in L-7390 Blaschette, 11, rue de Wormeldange.
17644
The term of office of the managers shall end at the annual general meeting of members to be held in two thousand
and two.
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The transformation of the Company from a S.A. to a S.à r.l. is exempt from capital duty under the terms of Article
4.a) of the law dated December 29, 1971, which provides for capital duty exemption. The expenses, costs, fees and
outgoings borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at approximately eighty thousand
Luxembourg francs (LUF 80,000.-).
With no outstanding points on the agenda the Chairman brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their name, sur-
name, civil status and residence, they signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausend, am siebten November.
Vor dem Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in Luxemburg-Bonneweg (Grossherzogtum Lu-
xemburg).
Versammelte sich eine ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Gesellschaft NEPHROCARE EU-
ROPE S.A., mit eingetragenem Sitz in L-2210 Luxemburg, 54, boulevard Napoléon Premier, gegründet infolge Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 2. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Register der Ge-
sellschaften (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) unter der Nummer 174 am 24. März 1998.
Die ausserordentliche Hauptversammlung der Aktionäre wird von Frau Rechtsanwältin Rina Breininger, wohnhaft in
Luxemburg, handelnd als Vorsitzende, eröffnet.
Die Vorsitzende bestellt zur Sekretärin der Versammlung Frau Rechtsanwältin Patricia Thill, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestellt Frau Rechtsanwältin Carole Lacroix zur Stimmenzählerin.
Der somit bestellte Versammlungsvorstand setzt die Anwesenheitsliste auf, welche, nach ne varietur-Zeichnung
durch jeden anwesenden Aktionär und jeden bevollmächtigten Vertreter sowie durch den Versammlungsvorstand und
den Notar, zum Zwecke der Registrierung und zusammen mit allen Vollmachten an vorliegender Urkunde anliegend
verbleibt.
Die Vorsitzende erklärte und bat den Notar folgendes aufzunehmen:
In Übereinstimmung mit der Anwesenheitsliste sind alle Aktionäre, die das gesamte Grundkapital der Gesellschaft
von zweihundertfünfzigtausend Französischen Franken (FRF 250.000,-) darstellen, anwesend oder ordnungsgemäss in
der Versammlung vertreten. Die Versammlung kann somit wirksam beraten und über alle in der Tagesordnung erwähn-
ten Punkte entscheiden, ohne dass es einer vorherigen Einberufung bedurfte.
Die Versammlung hat folgende Tagesordnung:
<i> Tagesordnung:i>
1. Umwandlung der Währung des Grundkapitals von Französischen Franken in Euro, wobei das aus dieser Umwand-
lung resultierende Grundkapital achtunddreissigtausendeinhundertundzwölf Komma zweihundertundvierundfünfzig
Euro (38.112,254 Euro) beträgt.
2. Erhöhung des Grundkapitals, so wie es sich aus dem Vorhergehenden ergibt, um einen Betrag von dreihundert-
undsiebenundachzig Komma siebenhundertundsechsundvierzig Euro (Euro 387,746) von einem Betrag von
achtunddreissigtausendeinhundertundzwölf Komma zweihundertundvierundfünfzig Euro (Euro 38.112,254) auf achtund-
dreissigtausendfünfhundert Euro (Euro 38.500,-) eingeteilt in eintausendfünfhundertundvierzig (1.540) Aktien mit einem
jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (Euro 25,-) ohne Ausgabe neuer Aktien, durch Einlage eines Gesamtbe-
trages von dreihundertundsiebenundachzig Komma siebenhundertundsechsundvierzig Euro (Euro 387,746), welcher aus
den Reserven entnommen wird.
3. Verlagerung des Sitzes der Gesellschaft nach L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper.
4. Änderung des Gesellschaftszweckes wie folgt:
«Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter welcher Form auch immer, an in- und ausländischen Gesellschaften,
sowie der Erwerb, sei es durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie, und die Veräußerung, sei es durch Verkauf, Tausch oder
sonstwie, von Aktien, Pfandbriefen, Anleihen, Schuldverschreibungen und Wertpapieren aller sonstigen Arten, sowie
der Besitz, die Verwaltung, Entwicklung und Kontrolle dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann Geld verleihen oder leihen, mit oder ohne Sicherheiten, unter der Bedingung, dass sämtliche
auf diese Weise geliehenen Gelder ausschließlich für die Zwecke der Gesellschaft genutzt werden oder für die Zwecke
von Tochter- oder Schwestergesellschaften der Gesellschaft; generell kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, wel-
che zum vorgenannten Zweck in direkter Beziehung stehen.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung sämtlicher in- und ausländischer gewerblicher, kaufmän-
nischer und finanzieller Gesellschaften beteiligen.
Generell kann die Gesellschaft jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien oder sonst-
wie.
Die Gesellschaft kann ebenfalls Geld leihen und in diesem Zusammenhang Pfandbriefe, Anleihen und andere Formen
von Schuldverschreibungen ausgeben.
17645
Generell kann die Gesellschaft alle Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, um
den vorgenannten Zweck zu erfüllen oder zu fördern.»
5. Änderung der gesetzlichen Form der Gesellschaft von einer «Société Anonyme» in eine «Société à Responsabilité
Limitée».
6. Änderung des Namens der Gesellschaft in FMC FINANCE II, S.à r.l.
7. Anpassung der Satzung der Gesellschaft an die neue gesetzliche Form der Gesellschaft.
8. Beendigung der Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Rechnungsprüfers.
9. Vollständige und umfassende Entlastungserteilung an die Verwaltungsratsmitglieder und den Rechnungsprüfer.
10. Bestimmung der Anzahl der Geschäftsführer und Bestellung der Geschäftsführer.
11. Verschiedenes.
Anschliessend beriet die Aktionärsversammlung und fasste, nachdem sie sich für ordnungsgemäss zusammengesetzt
und einberufen befunden hat und die Ausführungen des Vorsitzenden genehmigt hat, einstimmig die folgenden Beschlüs-
se:
<i> Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, die Währung des Grundkapitals von Französischen Franken in Euro umzuwandeln, wo-
bei das hieraus resultierende Grundkapital achtunddreissigtausendeinhundertundzwölf Komma zweihundertundvie-
rundfünfzig Euro (Euro 38.112,254) beträgt.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, das Grundkapital der Gesellschaft, wie es sich aus dem Vorhergehenden ergibt, um einen
Betrag von dreihundertundsiebenundachzig Komma siebenhundertundsechsundvierzig Euro (Euro 387,746) von derzeit
achtunddreissigtausendeinhundertundzwölf Komma zweihundertundvierundfünfzig Euro (Euro 38.112,254) auf achtund-
dreissigtausendfünfhundert Euro (Euro 38.500,-) eingeteilt in eintausendfünfhundertundvierzig (1.540) Aktien zum je-
weiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (Euro 25,-), ohne Ausgabe neuer Aktien, durch Einlage eines
Gesamtbetrages von dreihundertundsiebenundachzig Komma siebenhundertsechsundvierzig Euro (Euro 387,746) wel-
cher aus den Reserven entnommen wird, zu erhöhen, so wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, den Sitz der Gesellschaft nach L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper zu verlegen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu ändern und Artikel 2 der Satzung dement-
sprechend wie folgt anzupassen:
«Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter welcher Form auch immer, an in- und ausländischen Gesellschaften,
sowie der Erwerb, sei es durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie, und die Veräußerung, sei es durch Verkauf, Tausch oder
sonstwie, von Aktien, Pfandbriefen, Anleihen, Schuldverschreibungen und Wertpapieren aller sonstigen Arten, sowie
der Besitz, die Verwaltung, Entwicklung und Kontrolle dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann Geld verleihen oder leihen, mit oder ohne Sicherheiten, unter der Bedingung, dass sämtliche
auf diese Weise geliehenen Gelder ausschließlich für die Zwecke der Gesellschaft genutzt werden oder für die Zwecke
von Tochter- oder Schwestergesellschaften der Gesellschaft; generell kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, wel-
che zum vorgenannten Zweck in direkter Beziehung stehen.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung sämtlicher in- und ausländischer gewerblicher, kaufmän-
nischer und finanzieller Gesellschaften beteiligen.
Generell kann die Gesellschaft jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien oder sonst-
wie.
Die Gesellschaft kann ebenfalls Geld leihen und in diesem Zusammenhang Pfandbriefe, Anleihen und andere Formen
von Schuldverschreibungen ausgeben.
Generell kann die Gesellschaft alle Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, um
den vorgenannten Zweck zu erfüllen oder zu fördern.»
<i> Fünfter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, die gesetzliche Form der Gesellschaft ohne Unterbrechung ihrer Rechtspersönlichkeit
zu ändern, und die Form einer Société à Responsabilité Limitée zu übernehmen.
Das Grundkapital und die Rücklagen bleiben unverändert sowie auch alle Vermögenswerte und Verpflichtungen, Til-
gungsleistungen, Wertminderungen und Wertzuwächse, die Société à Responsabilité Limitée wird die Buchführung und
das Rechnungswesen der Société Anonyme fortführen.
Alle Aktien der Gesellschaft wurden vor Umwandlung der Gesellschaft voll einbezahlt.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Versammlung beschloss die Änderung des Namens der Gesellschaft von NEPHROCARE EUROPE S.A. in FMC
FINANCE II, S.à r.l.
<i> Siebter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, die Satzung an die neue juristische Form sowie an die vorgehenden Änderungen anzu-
passen und die Satzung der Gesellschaft mit Beschränkter Haftung wie folgt festzulegen:
17646
Titel I - Bezeichnung - Dauer - Sitz - Zweck
Art. 1. Hiermit wird zwischen dem Zeichner und all den Personen, welche in Zukunft Gesellschafter werden, eine
Gesellschaft mit Beschränkter Haftung (Société à Responsabilité Limitée), unter der Bezeichnung FMC FINANCE II, S.à
r.l., gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Dauer gegründet.
Art. 3. Der Gesellschaftssitz ist Luxemburg-Stadt. Er kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesell-
schafter an jeden anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden. Filialen oder andere Niederlassungen
können, entweder in Luxemburg oder im Ausland, durch Beschluss des Verwaltungsrats eröffnet werden.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung, unter welcher Form auch immer, an in- und ausländischen Gesell-
schaften, sowie der Erwerb, sei es durch Kauf, Zeichnung oder sonstwie, und die Veräußerung, sei es durch Verkauf,
Tausch oder sonstwie, von Aktien, Pfandbriefen, Anleihen, Schuldverschreibungen und Wertpapieren aller sonstigen Ar-
ten, sowie der Besitz, die Verwaltung, Entwicklung und Kontrolle dieser Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann Geld verleihen oder leihen, mit oder ohne Sicherheiten, unter der Bedingung, dass sämtliche
auf diese Weise geliehenen Gelder ausschließlich für die Zwecke der Gesellschaft genutzt werden oder für die Zwecke
von Tochter- oder Schwestergesellschaften der Gesellschaft; generell kann die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, wel-
che zum vorgenannten Zweck in direkter Beziehung stehen.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung sämtlicher in- und ausländischer gewerblicher, kaufmän-
nischer und finanzieller Gesellschaften beteiligen.
Generell kann die Gesellschaft jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien oder sonst-
wie.
Die Gesellschaft kann ebenfalls Geld leihen und in diesem Zusammenhang Pfandbriefe, Anleihen und andere Formen
von Schuldverschreibungen ausgeben.
Generell kann die Gesellschaft alle Überwachungs- und Aufsichtsmaßnahmen ergreifen und alle Geschäfte tätigen, um
den vorgenannten Zweck zu erfüllen oder zu fördern.
Titel II - Gesellschaftskapital - Gesellschaftsanteile
Art. 5. Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf achtunddreissigtausendfünfhundert Euro (Euro 38.500,-) festge-
legt, eingeteilt in eintausendfünfhundertundvierzig (1.540) Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (Eu-
ro 25,-).
Sämtliche Geschäftsanteile wurden von FRESENIUS MEDICAL CARE AG gezeichnet, einer Gesellschaft deutschen
Rechts, mit Gesellschaftssitz in D-61346 Bad Homburg, Else-Kröner-Str. 1 und voll eingezahlt.
Art. 6. Jede ordnungsmässige Hauptversammlung der Gesellschafter wird die Gesamtheit der Mitglieder der Gesell-
schaft vertreten. Sie wird die ausgedehntesten Befugnisse haben, alle Handlungen bezüglich der Geschäfte der Gesell-
schaft anzuordnen, zu vollstrecken oder zu ratifizieren.
Sofern das Gesetz nichts Gegenteiliges vorsieht, werden die Beschlüsse der ordnungsgemäß einberufenen Hauptver-
sammlung der Gesellschafter mit einfacher Mehrheit der anwesenden und abstimmenden Gesellschafter angenommen.
Das Gesellschaftskapital und die sonstigen Satzungsbestimmungen können jederzeit durch den alleinigen Gesellschaf-
ter oder durch die Mehrheit der Gesellschafter, welche mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten,
abgeändert werden. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft durch einen einstimmigen Beschluss
ändern.
Falls alle Gesellschafter an der Hauptversammlung der Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und falls sie er-
klären, daß sie über die Tagesordnung informiert wurden, kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung oder
Bekanntmachung abgehalten werden.
Art. 7. Jeder Gesellschaftsanteil gibt Anrecht auf eine Stimme in den ordentlichen und außerordentlichen General-
versammlungen.
Die Gesellschaft wird nur einen einzigen Eigentümer pro Anteil anerkennen; falls ein Anteil im Besitz von mehr als
einer Person ist, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung aller Rechte des betreffenden Anteils aufzuheben, bis dass
eine Person als alleiniger Eigentümer in den Beziehungen mit der Gesellschaft benannt wurde.
Jeder Gesellschaftsanteil gibt ein anteilmäßiges Recht am Gesellschaftsvermögen und -gewinn, im direkten Verhältnis
zur Gesamtzahl der bestehenden Anteile.
Art. 8. Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter begreift, so hat dieser alleinige Gesellschafter alle der Haupt-
versammlung zuerkannten Befugnisse.
Die Beschlüsse des alleinigen Gesellschafters, die im Bereich des ersten Absatzes gefasst werden, werden in ein Pro-
tokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt.
Ebenfalls werden die Verträge welche zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der von ihm vertretenen Gesell-
schaft eingegangen werden, in ein Protokollbuch eingetragen oder schriftlich niedergelegt. Nichtsdestoweniger ist diese
letzte Vorschrift für laufende Geschäfte, die unter normalen Bedingungen abgeschlossen wurden, nicht anwendbar.
Art. 9. Falls die Gesellschaft wenigstens zwei Gesellschafter zählt, sind die Gesellschaftsanteile zwischen den Gesell-
schaftern frei übertragbar.
Die Abtretung von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter unterliegt der Zustimmung der
Hauptversammlung der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Bei Todesfall von einem Gesellschafter, ist die Übertragung von Anteilen an Nichtgesellschafter der Zustimmung der
Anteilsbesitzer, welche mindestens drei Viertel (3/4) der den Überlebenden gehörende Rechte vertreten, unterlegen.
17647
In diesem Fall, jedoch, bedarf es keiner Zustimmung, falls die Gesellschaftsanteile an pflichtteilsberechtigte Erben oder
an den überlebenden Ehepartner übertragen werden.
Art. 10. Das Ableben, der Verlust der Geschäftsfähigkeit, der Konkurs oder die Zahlungsunfähigkeit des alleinigen
Gesellschafters oder eines der Gesellschafter werden in keiner Weise die Beendigung der Gesellschaft bewirken.
Art. 11. Aus keinem Grund und in keinem Fall sind die Gläubiger, Rechtsnachfolger oder Erben eines Gesellschafters
befugt, die Güter und Dokumente der Gesellschaft versiegeln zu lassen.
Titel III - Geschäftsführung
Art. 12. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens zwei Geschäftsführern verwaltet, die
nicht Gesellschafter sein müssen.
Die Geschäftsführer werden von der Hauptversammlung der Gesellschafter, die über ihre Befugnisse, Bezüge und
Amtszeit entscheidet, ernannt und abberufen. Ihr Mandat darf den Zeitraum von sechs Jahren nicht überschreiten, und
sie werden, solange ihre Nachfolger nicht bestimmt sind, im Amt bleiben.
Art. 13. Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen. Er kann ebenfalls einen Sekretär wäh-
len, der nicht Geschäftsführer sein muß, und der dafür verantwortlich sein wird, die Protokolle der Verwaltungsratssit-
zungen und der Hauptversammlungen der Gesellschafter zu führen.
Der Verwaltungsrat wird auf Einberufung durch den Vorsitzenden, oder zwei Geschäftsführer, an dem in der Einbe-
rufung festgesetzten Ort zusammenkommen.
Schriftlicher Bescheid von jeder Sitzung des Verwaltungsrats wird jedem Geschäftsführer wenigstens vierundzwanzig
Stunden vor der vorgesehenen Stunde für die Sitzung gegeben werden, außer im Falle von Dringlichkeit, in welchem Fall
die Natur von solchen Umständen in der Einberufung erläutert werden muss. Es kann auf diese Einberufung durch Ein-
verständnis per Schreiben oder per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax von jedem Geschäftsführer verzichtet wer-
den. Eine spezielle Einberufung wird nicht notwendig sein für eine Verwaltungsratssitzung, welche zu einer Stunde und
an einem Ort, die in einem vorausgehenden Arbeitsplan des Verwaltungsrats festgehalten wurden, stattfinden soll.
Jeder Geschäftsführer kann an jeder Verwaltungsratssitzung durch eine schriftliche, oder per Kabel, Telegramm, Te-
lex oder Telefax gegebene Vollmacht an einen anderen Geschäftsführer handlungsfähig werden.
Stimmen können ebenfalls schriftlich, per Kabel, Telegramm, Telex oder Telefax abgegeben werden.
Der Verwaltungsrat kann nur ordnungsgemäß beraten und handeln, wenn wenigstens die Mehrzahl der Geschäftsfüh-
rer an der Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit Stim-
menmehrheit der an einer solchen Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder gefasst.
Schriftliche Beschlüsse, welche von allen Geschäftsführern gutgeheißen und unterschrieben wurden, haben die gleiche
Wirkung wie Beschlüsse, die in einer Verwaltungsratssitzung getroffen werden.
Art. 14. Die Protokolle der Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder, im Falle seiner Abwesenheit,
vom pro tempore Vorsitzenden, welcher den Vorsitz einer solchen Verwaltungsratssitzung übernahm, unterschrieben.
Abschriften oder Auszüge solcher Protokolle welche vor Gericht oder anderswo vorgezeigt werden könnten, wer-
den von dem Vorsitzenden, dem Sekretär oder von zwei Geschäftsführern unterschrieben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, jegliche Verwaltungs- und Verfügungshandlungen
im Namen der Gesellschaft und in deren Interesse vorzunehmen. Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das
Gesetz der Hauptversammlung der Gesellschafter vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit des Verwaltungsrats.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse betreffend die tägliche Geschäftsführung und Angelegenheiten der Gesell-
schaft sowie die Vertretung der Gesellschaft betreffend solche Geschäftsführung und Angelegenheiten, mit dem voraus-
gehenden Einverständnis der Hauptversammlung der Gesellschafter, an einen oder mehrere Geschäftsführer des
Verwaltungsrats oder an ein Komitee (dessen Mitglieder nicht Geschäftsführer sein müssen), welche unter den Bedin-
gungen und Befugnissen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, beraten, übertragen. Er kann außerdem jegliche Be-
fugnisse und Sondervollmachten an jede Person, welche nicht Geschäftsführer sein muss, übertragen, Beamte und
Angestellte einstellen oder absetzen und ihre Bezüge festsetzen.
Art. 16. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, oder durch die Ein-
zelunterschrift der Person oder Personen welcher(n) solche Vertretungsmacht vom Verwaltungsrat übertragen werden
wird, verpflichtet.
Art. 17. Die Geschäftsführer gehen in der Ausübung ihres Mandats keinerlei persönlichen Verpflichtungen hinsicht-
lich der von der Gesellschaft eingegangenen Verbindlichkeiten ein. Als Bevollmächtigte der Gesellschaft haften sie ledig-
lich für die korrekte Ausführung ihrer Pflichten.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird am ersten Januar eines jeden Jahres beginnen und am einunddrei-
ßigsten Dezember enden, mit der Ausnahme vom ersten Geschäftsjahr, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft
beginnen und am 31. Dezember zweitausendundeins enden wird.
Art. 19. Der Jahresabschluss wird von den Geschäftsführern am Ende eines jeden Geschäftsjahres aufgestellt und
den Gesellschaftern am Sitz der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden.
Von dem Nettogewinn der Gesellschaft werden fünf Prozent (5 %) für die Bildung der gesetzlichen Rücklage verwen-
det werden. Dieser Abzug wird nicht mehr zwingend sein, sobald die Rücklage zehn Prozent (10 %) des Gesellschafts-
kapitals erreicht hat. Auf Empfehlung des Verwaltungsrats, wird die Hauptversammlung der Gesellschafter darüber
entscheiden, wie über den Nettogewinn verfügt werden wird.
Vorschüsse auf Dividenden können unter folgenden Bedingungen ausgezahlt werden:
1. Trimestrielle oder semestrielle Aufstellungen der Aktiven und Passiven werden erstellt,
17648
2. Diese Aufstellungen zeigen einen Gewinn bezüglich des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr,
3. Der Beschluß, Vorschüsse auf Dividenden auszuschütten, wird vom Verwaltungsrat getroffen, wenn ausreichende
Bargeldmittel zur Verfügung stehen. Andernfalls muß der Beschluß von einer außerordentlichen Hauptversammlung der
Gesellschafter getroffen werden.
Titel IV - Abwicklung - Auflösung
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft, wird die Abwicklung durch einen oder mehrere Liquidator(en) (wel-
che natürliche Personen oder Körperschaften sein können) erfolgen, die durch die Hauptversammlung ernannt werden,
welche über diese Auflösung entschieden hat und ihre Befugnisse und Vergütungen festlegen wird.
Art. 21. Alle Punkte, die nicht in der vorliegenden Satzung vorgesehen sind, werden gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und dessen Abänderungen festgelegt.
<i>Achter Beschlussi>
Nach Umwandlung der Gesellschaft in eine Gesellschaft mit Beschränkter Haftung , Société à Responsabilité Limitée,
ist das Mandat der drei Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers beendet.
Der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesellschaftskapital vertritt, gewährt den Verwaltungsrats-
mitgliedern und dem Wirtschaftsprüfer volle und uneingeschränkte Entlastung für ihr Mandat.
<i>Neunter Beschlussi>
Der alleinige Gesellschafter beschliesst, die Zahl der Geschäftsführer auf drei (3) festzusetzen.
Die folgenden Personen werden als Geschäftsführer ernannt:
a) Dr Werner Brandt, Diplom-Kaufmann, wohnhaft in D-61350 Bad Homburg, Heinrich von Kleist Strasse, 49A;
b) Dr Andrea Stopper, Doktor der Betriebswirtschaft, wohnhaft in CH-6900 Lugano, via privata Maraini Sommaruga,
26;
c) Fr. Gabriele Dux, Diplom-Kauffrau, wohnhaft in L-7390 Blaschette, 11, rue de Wormeldange.
Das Ende der Amtszeit der Geschäftsführer wird mit der Hauptversammlung der Gesellschafter welche zweitausend-
undzwei (2002) abzuhalten ist, eintreten.
<i>Kosteni>
Die Umwandlung der Gesellschaft von einer Société Anonyme in eine Société à Responsabilité Limitée ist von der
Kapitalsteuer befreit, gemäss Artikel 4.a) des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, welcher eine Befreiung von der Kapi-
talsteuer vorsieht.
Der Betrag der Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben zu Lasten der Gesellschaft infolge der vorliegenden Ur-
kunde wird auf ungefähr achtzigtausend Luxemburgische Franken (LUF 80.000,-) geschätzt.
Da die Tagesordnung erledigt ist, beendet die Vorsitzende die Versammlung.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende Urkunde
auf Antrag der oben erschienenen Parteien in Englisch, gefolgt von einer deutschen Version, verfasst ist. Auf Antrag der-
selben erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text ist
der englischen Version Vorrang zu geben.
Worüber die vorliegende Urkunde an dem zu Beginn dieser Urkunde genannten Datum in Luxemburg aufgenommen
wurde.
Nachdem die Urkunde vor den erschienenen Personen verlesen wurde, welche dem Notar alle mit Namen, Vorna-
men, Familienstand und Wohnadresse bekannt sind, unterzeichneten diese zusammen mit dem Notar die vorliegende
Urkunde.
Gezeichnet: R. Breininger, P. Thill, C. Lacroix, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 126S, fol. 84, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreiem Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(65802/222/566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
FMC FINANCE II, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper.
R. C. Luxembourg B 62.086.
—
In the year two thousand, on the ninth November.
Before Us, Maître Léon Thomas called Tom Metzler, notary residing in Luxembourg-Bonnevoie (Grand Duchy of
Luxembourg).
Was held an extraordinary general meeting of the members of the company FMC FINANCE II, S.à r.l, with registered
office in L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stumper, duly registered with the Register of Commerce and companies
Luxembourg under section B number 62.086, incorporated by a deed of the undersigned notary, on December 2, 1997,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 174 of March 24, 1998.
The extraordinary general meeting of members is opened by Maître Rina Breininger, lawyer, residing in Luxembourg,
acting as chairman.
The Chairman appointed as secretary of the meeting Maître Patricia Thill, lawyer, residing in Luxembourg.
Luxemburg-Bonneweg, den 17. November 2000.
T. Metzler.
17649
The meeting appointed as scrutineer Maître Carole Lacroix, lawyer, residing in Luxembourg.
Having thus been constituted, the committee of the meeting draws up the attendance list, which, after having been
signed ne varietur by any member present and any representative in proxy, as well as by the members of the committee
and the notary, will remain attached to the present minutes together with any proxy for the purpose of registration.
The chairman declared and requested the notary to declare that:
According to the attendance list, the sole member, representing the full amount of the corporate capital of thirty-
eight thousand five hundred Euro (Euro 38,500.-) was present or validly represented at the meeting. The meeting can
thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having been a prior convening.
The agenda of the meeting is the following:
<i>«Agenda:i>
1. Increase of the corporate capital by an amount of three million five hundred and sixteen thousand and five hundred
Euro (Euro 3,516,500.-) to raise it from its present amount of thirty-eight thousand five hundred Euro (Euro 38,500.-),
represented by one thousand five hundred and forty (1,540) corporate units with a par value of twenty-five Euro (Euro
25.-) each, to the amount of three million five hundred and fifty-five thousand Euro (Euro 3,555,000.-), represented by
one hundred and forty-two thousand and two hundred (142,200) corporate units with a par value of twenty-five Euro
(Euro 25.-) by the issuing of one hundred and forty thousand six hundred and sixty (140,660) corporate units with a par
value of twenty-five Euro (Euro 25.-) each having the same rights and obligations as the existing corporate units.
2. Subscription and payment of the one hundred and forty thousand six hundred and sixty (140.660) additional cor-
porate units by FRESENIUS MEDICAL CARE AG, a company incorporated under German law, with registered office in
D-61346 Bad Homburg, Else-Kröner-Str. 1, by the transfer to the Company and conversion into corporate capital of a
certain, liquid and due for payment debt of the Company in favour of FRESENIUS MEDICAL CARE AG, aforementioned,
for an amount of three million five hundred and sixteen thousand and five hundred and eight point nineteen Euro (Euro
3,516,508.19).
3. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the articles of incorporation so as to reflect the foregoing
to read as follows:
«The subscribed capital is set at three million five hundred and fifty-five thousand Euro (Euro 3,555,000.-)- represent-
ed by one hundred and forty-two thousand and two hundred (142,200) corporate units with a par value of twenty-five
Euro (Euro 25.-) each.»
4. Any other business.»
Then, the meeting of members, after having considered itself as duly composed and convened, and given its approval
to the explanations of the chairman, deliberated and passed, via unanimous vote, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company by an amount of three million five hundred
and sixteen thousand and five hundred Euro (Euro 3,516,500.-) to raise it from its present amount of thirty-eight thou-
sand five hundred Euro (Euro 38,500.-), represented by one thousand five hundred and forty (1,540) corporate units
with a par value of twenty five Euro (Euro 25.-) each, to the amount of three million five hundred and fifty-five thousand
Euro (Euro 3,555,000.-), represented by one hundred and forty-two thousand and two hundred (142,200) corporate
units with a par value of twenty-five Euro (Euro 25.-) by the issuing of one hundred and forty thousand and six hundred
and sixty (140,660) corporate units with a par value of twenty-five Euro (Euro 25.-) each having the same rights and
obligations as the existing corporate units.
<i>Second resolutioni>
The meeting resolved to issue one hundred and forty thousand and six hundred and sixty (140,660) corporate units,
with a par value of twenty-five Euro (Euro 25.-) each, having the same rights and obligations as the existing corporate
units.
<i>Subscription and paymenti>
There now appeared M
e
Rina Breininger, prenamed, acting in her capacity as duly appointed attorney in fact of FRE-
SENIUS MEDICAL CARE AG, a company incorporated under German law, with registered office in D-61346 Bad Hom-
burg, Else-Kröner-Str. 1,
by virtue of a power of attorney granted by the board of directors of FRESENIUS MEDICAL CARE AG on November
7, 2000 which power will remain attached to the present deed.
It results from a waiver agreement dated November 8, 2000, duly signed by FRESENIUS MEDICAL CARE AG and
the Company that FRESENIUS MEDICAL CARE AG has waived its debt towards the Company for an amount of three
million five hundred and sixteen thousand and five hundred and eight point nineteen Euro (Euro 3,516,508.19) in con-
sideration of the issuing and allotment by the Company of one hundred and forty thousand and six hundred and sixty
(140,660) new corporate units, with a par value of twenty-five Euro (Euro 25.-) each, having the same rights and obliga-
tions as the existing units.
This waiver will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authorities.
According to a valuation report of FRESENIUS MEDICAL CARE AG, prenamed, dated November 7, 2000, the board
of managers of the Company valued the waived Loans at the amount of three million five hundred and sixteen thousand
and five hundred and eight point nineteen Euro (Euro 3,516,508.19).
As a consequence the appearing person declares subscribing in the name and on the account of FRESENIUS MEDI-
CAL CARE AG, aforementioned, one hundred and forty thousand and six hundred and sixty (140,660) newly issued
corporate units and to fully pay up said units by the transfer to the Company and conversion into corporate capital of
a certain, liquid and due for payment debt of the Company in favour of FRESENIUS MEDICAL CARE AG, aforemen-
17650
tioned, in a total amount of three million five hundred and sixteen thousand and five hundred and eight point nineteen
Euro (Euro 3,516,508.19).
Thereupon the meeting resolved to accept the said subscription and payment and to allot one hundred and forty
thousand and six hundred and sixty (140,660) additional corporate units to the said subscriber FRESENIUS MEDICAL
CARE AG.
<i>Third resolutioni>
The meeting resolves to amend article 5, first paragraph of the Articles of Incorporation so as to reflect the said in-
crease in capital.
Consequently, article 5, first paragraph of the articles of incorporation should now read as follows:
«The subscribed capital is set at three million five hundred and fifty five thousand Euro (Euro 3,555,000.-), represent-
ed by one hundred and forty-two thousand and two hundred (142,200) corporate units with a par value of twenty-five
Euro (Euro 25.-) each.»
<i>Declarations, costs, evaluationi>
The expenses, costs, fees and outgoings borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at
approximately one million five hundred fifty thousand Luxembourg francs (LUF 1,550,000.-).
With no outstanding points on the agenda the Chairman brought the meeting to a close.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a German version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausend, am neunten November, vor dem Notar Léon Thomas genannt Tom Metzler, mit Amtssitz in
Luxemburg-Bonneweg (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelte sich eine ausserordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschafter der FMC FINANCE II, S.à
r.l., mit eingetragenem Sitz in L-2557 Luxemburg, 7A, rue Robert Stumper, eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register von Luxemburg unter Sektion B Nummer 62.086, gegründet infolge Urkunde aufgenommen durch den unter-
zeichneten Notar am 2. Dezember 1997, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer
174 vom 24. März 1998.
Die ausserordentliche Gesellschafterversammlung wird von Frau Rechtsanwältin Rina Breininger, wohnhaft in Lu-
xemburg, handelnd als Vorsitzende, eröffnet.
Die Vorsitzende bestellte zur Sekretärin der Versammlung Frau Rechtsanwältin Patricia Thill, wohnhaft in Luxem-
burg.
Die Versammlung bestellte Frau Rechtsanwältin Carole Lacroix, wohnhaft in Luxemburg, zur Stimmenzählerin.
Der somit bestellte Versammlungsvorstand setzt die Anwesenheitsliste auf, welche, nach ne varietur-Zeichnung
durch jeden anwesenden Gesellschafter und jeden bevollmächtigten Vertreter sowie durch den Versammlungsvorstand
und den Notar, zum Zwecke der Registrierung und zusammen mit allen Vollmachten an vorliegender Urkunde anliegend
verbleibt.
Die Vorsitzende erklärte und bat den Notar folgendes aufzunehmen:
In Übereinstimmung mit der Anwesenheitsliste ist der alleinige Gesellschafter, der das gesamte Stammkapital von
achtunddreissigtausendfünfhundert Euro (Euro 38.500,-) darstellt, ordnungsgemäss anwesend oder wirksam in der Ver-
sammlung vertreten. Die Versammlung kann somit wirksam beraten und entscheidet über alle in der Tagesordnung er-
wähnten Punkte, ohne dass es einer vorherigen Einberufung bedurfte.
Die Versammlung hat folgende Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Erhöhung des Stammkapitals um einen Betrag von drei Millionen fünfhundertsechzehntausendfünfhundert Euro
(Euro 3.516.500,-) von seinem gegenwärtigen Betrag von achtunddreissigtausendfünfhundert Euro (Euro 38.500,-), ein-
geteilt in eintausendfünfhundertvierzig (1.540) Geschäftsanteile mit einem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig
Euro (Euro 25,-) auf einen Betrag von drei Millionen fünfhundertfünfundfünfzigtausend Euro (Euro 3.555.000,-) eingeteilt
in einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (142.200) Geschäftsanteile mit einem jeweiligen Nennwert von fünf-
undzwanzig Euro (Euro 25,-) durch Ausgabe von einhundertvierzigtausendsechshundertsechzig (140.660) Geschäftsan-
teilen mit einem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (Euro 25,-), welche mit denselben Rechten und pflichten
wie die bereits bestehenden Geschäftsanteile versehen sind.
2. Zeichnung und Einzahlung der einhundertvierzigtausendsechshundertsechzig (140.660) zusätzlichen Geschäftsan-
teile durch die FRESENIUS MEDICAL CARE AG, einer unter deutschem Recht gegründeten Gesellschaft, mit Sitz in
D-61346 Bad Homburg, Else-Kröner-Str. 1, durch die Übertragung einer bestimmten, liquiden und fälligen Schuld der
Gesellschaft gegenüber der vorgenannten FRESENIUS MEDICAL CARE AG in Höhe von drei Millionen fünfhundert-
sechzehntausendfünfhundertacht Komma neunzehn Euro (Euro 3.516.508,19) auf die Gesellschaft und deren Umwand-
lung in Stammkapital.
3. Änderung von Artikel 5, Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages infolge des Vorgesagten wie folgt:
«Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf drei Millionen fünfhundertfünfundfünfzigtausend Euro (Euro 3.555.000,-)
festgelegt, eingeteilt in einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (142.200) Anteile mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig Euro (Euro 25,-).»
4. Verschiedenes.
17651
Anschliessend beriet die Gesellschafterversammlung und fasste, nachdem sie sich für ordnungsgemäss zusammenge-
setzt und einberufen befunden hat und die Ausführungen der Vorsitzenden genehmigt hat, einstimmig die folgenden Be-
schlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, das Stammkapital der Gesellschaft um einen Betrag von drei Millionen fünfhundertsech-
zehntausendfünfhundert Euro (Euro 3.516.500,-) von seinem gegenwärtigen Betrag von achtunddreissigtausendfünfhun-
dert Euro (Euro 38.500,-), eingeteilt in eintausendfünfhundertvierzig (1.540) Geschäftsanteile mit einem jeweiligen
Nennwert von fünfundzwanzig Euro (Euro 25,-) auf einen Betrag von drei Millionen fünfhundertfünfundfünfzigtausend
Euro (Euro 3.555.000,-), eingeteilt in einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (142.200) Geschäftsanteile mit ei-
nem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (Euro 25,-) zu erhöhen, durch Ausgabe von einhundertvierzigtau-
sendsechshundertsechzig (140.660) Geschäftsanteilen mit einem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (Euro
25,-), welche mit denselben Rechten und Pflichten wie die bereits bestehenden Geschäftsanteile versehen sind.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, einhundertvierzigtausendsechshundertsechzig (140.660) Geschäftsanteile mit einem je-
weiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (Euro 25,-) auszugeben, welche mit denselben Rechten und Pflichten wie
die bereits bestehenden Geschäftsanteile versehen sind.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Aus einer Verzichtserklärung vom 8. November 2000, unterzeichnet von der FRESENIUS MEDICAL CARE AG und
der Gesellschaft, folgt, da die FRESENIUS MEDICAL CARE AG auf ihre Forderung in Höhe von drei Millionen
fünfhundertsechzehntausendfünfhundertacht Komma neunzehn Euro (Euro 3.516.508,19) gegen die Gesellschaft ver-
zichtet hat, als Gegenleistung für die Ausgabe und Zuteilung von einhundertvierzigtausendsechshundertsechzig
(140.660) neuen Geschäftsanteilen mit einem jeweiligen Nennwert von fünfundzwanzig Euro (Euro 25,-) durch die Ge-
sellschaft, welche mit denselben Rechten und Pflichten wie die bereits bestehenden Geschäftsanteile versehen sind.
Diese Verzichtserklärung verbleibt anliegend an vorliegender Urkunde und wird mit dieser den Registrierungsbehör-
den zugeleitet.
In Übereinstimmung mit einem Bewertungsbericht der vorgenannten FRESENIUS MEDICAL CARE AG vom 7. No-
vember 2000, hat die Geschäftsführung der Gesellschaft den Wert der verzichteten Forderungen mit drei Millionen
fünfhundertsechzehntausendfünfhundertacht Komma neunzehn Euro (Euro 3.516.508,19) bewertet.
Demzufolge erklärt die Erschienene im Namen und für Rechnung der vorgenannten FRESENIUS MEDICAL CARE
AG, einhundertvierzigtausendsechshundertsechzig (140.660) neu ausgegebene Geschäftsanteile zu zeichnen und die be-
sagten Geschäftsanteile voll einzuzahlen, durch die Übertragung einer bestimmten, liquiden und fälligen Schuld der Ge-
sellschaft gegenüber der vorgenannten FRESENIUS MEDICAL CARE AG in Höhe von drei Millionen
fünfhundertsechzehntausendfünfhundertacht Komma neunzehn Euro (Euro 3.516.508,19) auf die Gesellschaft und deren
Umwandlung in Stammkapital.
Darüber hinaus beschloss die Versammlung der besagten Zeichnung und Einzahlung zuzustimmen und
einhundertvierzigtausendsechshundertsechzig (140.660) zusätzliche Geschäftsanteile an die besagte zeichnende FRESE-
NIUS MEDICAL CARE AG zuzuteilen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Versammlung beschloss, Artikel 5, Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages im Sinne der besagten Kapitalerhöhung
anzupassen.
Demnach bekommt Artikel 5, Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages den folgenden Wortlaut:
«Das gezeichnete Gesellschaftskapital ist auf drei Millionen fünfhundertfünfundfünfzigtausend Euro (Euro 3.555.000,-)
festgelegt, eingeteilt in einhundertzweiundvierzigtausendzweihundert (142.200) Anteile mit einem Nennwert von je
fünfundzwanzig Euro (Euro 25,-).»
<i> Erklärungen, Kosten, Bewertungeni>
Der Betrag der Kosten, Gebühren, Honorare und Ausgaben zu Lasten der Gesellschaft infolge der vorliegenden Ur-
kunde wird auf ungefähr eine Million fünfhundertfünfzigtausend Luxemburgische Franken (LUF 1.550.000.-) geschätzt.
Da die Tagesordnung erledigt ist, beendet die Vorsitzende die versammlung.
Der unterzeichnete Notar, welcher Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, da die vorliegende Urkunde auf
Antrag der oben erschienenen Parteien in Englisch, gefolgt von einer deutschen Version, verfasst ist. Auf Antrag dersel-
ben erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dein englischen Text ist der
englischen Version Vorrang zu geben.
Worüber die vorliegende Urkunde an dem zu Beginn dieser Urkunde genannten Datum in Luxemburg aufgenommen
wurde.
Nachdem die Urkunde vor den erschienenen Personen verlesen wurde, unterzeichneten letztere diese zusammen
mit dem Notar.
Gezeichnet: R. Breininger, P. Thill, C. Lacroix, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 10 novembre 2000, vol. 126S, fol. 85, case 5. – Reçu 1.418.553 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Für gleichlautende Abschrift auf stempelfreiem Papier dem Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, zwecks
Veröffentlichung erteilt.
(65801/222/218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Luxemburg-Bonneweg, den 17. November 2000.
T. Metzler.
17652
ISATIS S.A.H., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 45.454.
—
La soussignée FIDUCIAIRE INTERNATIONALE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT «F.I.G.E.D.» dénonce le
siège social de la société ISATIS S.A.H. en ses bureaux, 3B, boulevard du Prince Henri à Luxembourg.
Avis est donné par ailleurs que les membres du Conseil d’Administration ainsi que le commissaire de la société dé-
missionnent à dater de ce jour en l’occurrence:
Messieurs Guy Glesener, Jacques Tordoor, Yves Wallers du poste d’administrateur et de la société FIDUPARTNERS
A.G.du poste de commissaire.
Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65841/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
JARNY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R. C. Luxembourg B 65.647.
—
Le propriétaire et le locataire de l’immeuble situé à L-7233 Bereldange, 40, cité Grand-Duc Jean déclarent que
JARNY, S.à r.l. n’est plus autorisée à fixer son siège social à cette adresse, et ceci à partir du 6 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 33, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65844/607/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
ISIDORE HOLDING S.A., Société Anonyme,
(anc. ISIDORE S.A.).
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.405.
—
L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ISIDORE S.A., avec siège social à Luxem-
bourg, constituée suivant acte notarié en date du 20 septembre 1995, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et asso-
ciations de 1995, page 29431 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant
acte notarié, en date du 13 janvier 1999, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations de 1999, page 14850.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hans de Graaf, managing director, demeurant à Mamer,
qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Juliette Lorang, administrateur de sociétés, demeurant à Neuhäusgen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Changement de la dénomination sociale de ISIDORE S.A. en ISIDORE HOLDING S.A.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale ISIDORE S.A. en ISIDORE HOLDING S.A., de sorte que l’ar-
ticle 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination ISIDORE HOLDING S.A.»
Pour copie conforme
F.I.G.E.D.
Signature / Signature
<i>Chef de Service principal / Administrateuri>
Signature.
17653
<i> Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ 20.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. de Graaf, R. Brand, J. Lorang, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 42, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65842/220/49) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
ISIDORE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 52.405.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65843/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
JMP CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Fentange.
R. C. Luxembourg B 70.629.
—
L’an deux mille, le douze octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
A comparu:
Madame Doris Prouteau-Roschlaub, administrateur de sociétés, demeurant au 15, Op der Sterz, Résidence «An
Echels», L-5823 Fentange.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:
- Qu’elle est la seule et unique associée actuelle de la société à responsabilité limitée JMP CONSEIL, S.à r.l, avec siège
social à Fentange, constituée suivant acte du notaire instrumentant, en date du 21 juin 1999, publié au Mémorial, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 715 du 25 septembre 1999, dont les statuts ont été modifiés suivant acte
du notaire instrumentant, en date du 28 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil numéro 16 du 6 janvier 2000;
- Qu’aux termes de deux cessions de parts sous seing privé, intervenues en date du 30 mars 2000, respectivement
en date du 1
er
septembre 2000, lesquelles resteront, après avoir été signées ne varietur par la comparante et le notaire
instrumentant, annexées aux présentes pour être formalisées avec elles, il a été cédé:
- par Monsieur Jean-Marc Prouteau, administrateur, demeurant au 15, Op der Sterz, Résidence «An Echels», L-5823
Fentange, 124 parts sociales à Mademoiselle Stéphanie Prouteau, enseignante, demeurant à Résidence de l’Ile, 14, rue
du Dr Collé, F-91440 Bures-sur-Yvette, au prix global de mille cinq cents Euros (1.500,- EUR) quittancés; et
- par Mademoiselle Stéphanie Prouteau, prénommée, 124 parts sociales à Madame Doris Prouteau-Roschlaub, pré-
nommée, au prix global de mille cinq cents Euros (1.500,- EUR) quittancés.
- Que la cessionnaire est propriétaire des parts cédées et qu’elle aura droit aux bénéfices y afférents à partir de ladite
cession.
<i> Résolution de l’associée uniquei>
Ensuite, l’associée unique a déclaré prendre les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associée unique accepte les cessions de parts ci-avant documentées.
<i>Deuxième résolutioni>
Suite aux cessions de parts ci-avant documentées, l’associée unique décide de modifier l’article 6 des statuts, pour lui
donner désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cents Euros (12.400,- EUR), représenté par cent-vingt-quatre
(124) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (100) chacune, toutes souscrites et détenues par Madame Do-
ris Prouteau-Roschlaub, administrateur, demeurant 15, Op der Sterz, Résidence «An Echels», L-5823 Fentange.»
Suit la version anglaise:
«Art. 6. The corporate capital is fixed at twelve thousand four hundred Euros (12,400.- EUR), represented by one
hundred and twenty-four (124) shares, with a par value of one hundred Euros (100.- EUR) each, all held by Mrs Doris
Prouteau-Roschlaub, director, residing in 15, Op der Sterz, Résidence «An Echels», L-5823 Fentange.»
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
17654
<i> Troisième résolutioni>
L’associée unique accepte la démission de Monsieur Jean-Marc Prouteau de son mandat de gérant de la société et lui
accorde pleine et entière décharge en ce qui concerne l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce jour.
<i>Quatrième résolutioni>
Est nommée nouvelle gérante de la société pour une durée indéterminée:
Madame Doris Prouteau-Roschlaub, prénommée.
Madame Doris Prouteau-Roschlaub, prénommée, en sa qualité de gérant unique, déclare accepter lesdites cessions
de parts au nom et pour le compte de la société et dispenser les cédants de les faire notifier à la société, le tout con-
formément à l’article 1690 du Code civil.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: D. Prouteau-Roschlaub, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 19 octobre 2000, vol. 126S, fol. 45, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65845/220/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
JMP CONSEIL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: Fentange.
R. C. Luxembourg B 70.629.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65846/220/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
J. P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R. C. Luxembourg B 65.038.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65848/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
KIDS & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 46.038.
Acte constitutif publié à la page n° 4161 du Mémorial C n°87 du 7 janvier.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65850/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
KIDS & CO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1512 Luxembourg, 7, rue Federspiel.
R. C. Luxembourg B 46.038.
Acte constitutif publié à la page n° 4161 du Mémorial C n° 87 du 7 janvier.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65849/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
Luxembourg, le 15 novembre 2000.
Luxembourg, le 15 novembre 2000.
17655
LA CIOCIARA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7220 Walferdange, 15, rue de Diekirch.
R. C. Luxembourg B 62.669.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 546, fol. 33, case 1, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65851/607/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LA FIDUCIAIRE MAGELLAN LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
R. C. Luxembourg B 65.290.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 14 novembre 2000i>
Le siège social est transféré de L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet, à L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Enregistré à Luxembourg, le 16 novembre 2000, vol. 546, fol. 18, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65852/000/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LAIRNISIA GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.348.
—
Le bilan rectifié au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 12, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Ce bilan rectifié annule le bilan au 31 décembre 1997 déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
le 12 octobre 1998, enregistré: vol.512, fol. 32, case 5 le 25 septembre 1998, publié au Mémorial C n
°
890 du 9 décem-
bre 1998.
(65853/531/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LAIRNISIA GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.348.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65854/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LAIRNISIA GESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 59.348.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65855/531/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
i>J.M. Thys
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
Signature.
17656
LANGUAGE ENTERPRISES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1210 Luxembourg, 23, rue Barblé.
—
L’an deux mille, le sept novembre.
Par-devant Maître Marc Cravatte, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
1) Madame Marcelle Herman, institutrice, demeurant à B-6700 Arlon, 66, rue de l’Hydrion,
2) Monsieur Wolfgang Schnitzer, professeur de langues, demeurant à D-54456 Tawern, Kapellstrasse 30,
seuls associés de la société à responsabilité limitée avec siège social à L-6791 Grevenmacher, 28, rue de Thionville,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 18 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, page 1862 de l’année 1997,
lesquels comparants, représentant l’intégralité du capital social de la susdite société, se sont réunis en assemblée gé-
nérale extraordinaire et ont pris à l’unanimité et sur ordre du jour conforme les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de transférer le siège social de la société de son adresse actuelle à Luxembourg, et de modifier
en conséquence l’article 2 des statuts de la société, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg; il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de
Luxembourg par simple décision des associés.»
<i> Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de fixer l’adresse de la société à L-1210 Luxembourg, 23, rue Nicolas-Ernest Barblé.
Rien d’autre n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée a été clôturée.
<i> Fraisi>
Les frais des présentes sont à la charge de la société.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état
et demeure, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: M. Herman, W. Schnitzer, M. Cravatte.
Enregistré à Diekirch, le 8 novembre 2000, vol. 604, fol. 43, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): M. Siebenaler.
Pour copie conforme, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65856/205/36) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Registered office: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.302.
—
In the year two thousand, on the thirty-first day of October.
Before Us, Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary public, residing in Luxembourg-Bonnevoie, Grand
Duchy of Luxembourg.
There appeared:
LAURUS NV, a corporation incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office in NL-5223
Al’ s-Hertogenbosch, Parallelweg 64,
duly represented by Maître Charles Ossola, lawyer, residing in Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe, by virtue of a proxy
given under private seal on October 30, 2000.
The said proxy, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The presaid LAURUS NV is the sole member of LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., société à responsabilité limitée,
which has its registered office in L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, incorporated by a deed of the presaid notary
public, on June 2000, published in the official Register Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no. 743, dated
October 10, 2000.
Such appearing party, represented as hereabove stated, in its capacity as sole member of LAURUS LUXEMBOURG,
S.à r.l., has requested the notary to state its following resolutions:
<i>First resolutioni>
The capital of the company shall be increased by an amount of forty-five million seven hundred and seventy thousand
Euros (EUR 45,770,000.-) so as to raise it from its present amount of fifteen thousand Euros (EUR 15,000.-), divided
into one hundred and fifty (150) corporate units with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) to an amount of
forty-five million seven hundred and eighty-five thousand Euros (EUR 45,785,000.-), divided into four hundred fifty-seven
thousand eight hundred and fifty (457,850) corporate units with a par value of one hundred Euros (EUR 100.-) per unit.
Ettelbruck, le 10 novembre 2000.
M. Cravatte.
17657
<i> Second resolutioni>
Four hundred fifty-seven thousand seven hundred (457,700) new corporate units with a par value of one hundred
Euros (EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units shall be issued.
The new corporate units shall be issued with an aggregate premium of one hundred eighty-three million and eighty
thousand Euros (EUR 183,080,000.-).
<i>Subscription and paymenti>
DE BOER UNIGRO BEHEER BV, a corporation incorporated under the laws of The Netherlands, having its regis-
tered office in NL-5223 Al’ s-Hertogenbosch, Parallelweg 64,
duly represented by Maître Charles Ossola, presaid, by virtue of a proxy given under private seal on October 30,
2000,
declared to subscribe in its name and on behalf of itself for four hundred fifty-seven thousand seven hundred
(457,700) additional corporate units and to make payment in full for such new corporate units by a contribution in kind,
by the transfer to the Company of all its assets and liabilities as set up in the balance sheet as at October 12, 2000.
The appearing parties stated a report has been drawn up by KPMG AUDIT LUXEMBOURG S.C, auditor, having its
registered office in Luxembourg, on October 30, 2000, where the contributed assets and liabilities of DE BOER UNI-
GRO BEHEER BV are described and valued.
The appearing parties produced that report, the conclusion of which is as follows:
«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the con-
tribution which corresponds at least to the number and nominal value of the units and the premium to be issued as
consideration.
Luxembourg, October 30, 2000.
That report will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the registration authori-
ties.
It results from an asset transfer agreement dated October 31, 2000, duly signed by DE BOER UNIGRO BEHEER BV
and LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., that all the assets and liabilities of DE BOER UNIGRO BEHEER BV have been
transferred to the Company.
A certified copy of that agreement will remain attached to the present deed and will be filed together with it with the
registration authorities.
<i> Third resolutioni>
The sole partner of LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., LAURUS NV, representing the entire share capital, declared
approving DE BOER UNIGRO BEHEER BV as new partner in LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l.
<i>Fourth resolutioni>
Further to the aforesaid resolutions, article 5 of the articles of incorporation has to be amended.
Consequently, article 5 of the articles of association is replaced by the following text:
«The subscribed capital is set at forty-five million seven hundred and eighty-five thousand Euros (EUR 45,785,000.-),
represented by four hundred fifty-seven thousand eight hundred and fifty (457,850) corporate units with a par value of
one hundred Euros (EUR 100.-) each.
The units have been fully subscribed as follows:
All the units have been fully paid in by the subscribers, as was certified to the notary executing this deed.»
<i> Expensesi>
Insofar as the contribution in kind results in the Company holding all the assets and liabilities of the company DE
BOER UNIGRO BEHEER BV, having its registered office and its place of management in the European Community, such
contribution qualifies under the terms of Article 4-1 of the law dated December 29, 1971, which provides for capital
duty exemption.
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the company as a result of the present stated
increase of capital, are estimated at three hundred thousand Luxembourg francs (LUF 300,000.-).
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the above appearing par-
ties, the present deed is worded in English, followed by a French translation; at the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English text shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the person appearing, the latter signed together with the notary the present deed.
KPMG AUDIT
<i>Réviseurs d’Entreprises
i>T. Feld »
LAURUS NV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
DE BOER UNIGRO BEHEER BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457,700
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457,850
17658
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trente et un octobre.
Par-devant Nous, Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Du-
ché de Luxembourg.
Ont comparu:
LAURUS NV, une société constituée sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à NL-5223 Al’s-Hertogenbosch,
Parallelweg 64,
dûment représentée par Maître Charles Ossola, avocat, demeurant à Luxembourg, 6, rue Sainte Zithe, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé le 30 octobre 2000.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La prénommée LAURUS NV est l’associée unique de LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limi-
tée, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal, constituée par un acte du notaire soussigné, le
14 juin 2000, publié au journal officiel Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n
°
743, daté du 10 octobre 2000.
Cette comparante, représentée comme ci-avant décrit, en sa qualité d’associée unique de LAURUS LUXEMBOURG,
S.à r.l., a requis le notaire de documenter ses résolutions suivantes:
<i> Première résolutioni>
Le capital de la société sera augmenté à concurrence d’un montant de quarante-cinq millions sept cent soixante-dix
mille Euros (EUR 45.770.000,-), pour le porter de son montant actuel de quinze mille Euros (EUR 15.000,-), représenté
par cent cinquante (150) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune, au montant de qua-
rante-cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille Euros (EUR 45.785.000,-), représenté par quatre cent cinquante-
sept mille huit cent cinquante (457,850) parts sociales d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
Quatre cent cinquante-sept mille sept cents (457.700) parts sociales additionnelles d’une valeur nominale de cent
Euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, seront émises.
Les parts sociales additionnelles seront émises avec une prime d’émission globale de cent quatre-vingt-trois millions
quatre-vingt mille Euros (EUR 183.080.000,-).
<i>Souscription et libérationi>
La société DE BOER UNIGRO BEHEER BV, société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à
NL-5223 Al’s-Hertogenbosch, Parallelweg 64,
dûment représentée par Maître Charles Ossola, préqualifié, en vertu d’une procuration sous-seing privé, donnée le
30 octobre 2000,
a déclaré souscrire en son nom et pour son compte quatre cent cinquante-sept mille sept cents (457.700) parts so-
ciales nouvelles et faire libérer entièrement ces parts sociales nouvelles par un apport en nature, par le transfert à la
société de tout son actif et passif comme décrit dans le bilan au 12 octobre 2000.
Les comparantes ont exposé qu’un rapport a été établi par KPMG AUDIT S.C., réviseur d’entreprises, ayant son siège
social à Luxembourg, le 30 octobre 2000, dans lequel l’actif et le passif de DE BOER UNIGRO BEHEER BV apportés
sont décrits et évalués.
Les comparantes ont produit ce rapport, dont les conclusions sont décrites ci-dessous:
«Based on the verification carried out as described above, we have no observation to make on the value of the con-
tribution which corresponds at least to the number and nominal value of the units and the premium to be issued as
consideration.
Luxembourg, October 30, 2000.»
Ce rapport restera annexé au présent acte et sera soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Il résulte d’une convention de transfert d’actifs et de passifs datée du 31 octobre 2000, dûment signée par DE BOER
UNIGRO BEHEER BV et LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., que l’intégralité des actifs et passifs de DE BOER UNIGRO
BEHEER BV a été transférée à LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Une copie certifiée conforme de cette convention restera annexée à la présente et sera soumise avec elle aux for-
malités de l’enregistrement.
<i>Troisième résolutioni>
L’associée unique de la société LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., LAURUS NV, représentant la totalité du capital
social, déclare approuver DE BOER UNIGRO BEHEER BV comme nouvelle associée de la société LAURUS LUXEM-
BOURG, S.à r.l.
<i>Quatrième résolutioni>
Suite aux résolutions précédentes, l’article 5 des statuts doit être modifié.
En conséquence, l’article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant:
«Le capital souscrit est fixé à quarante-cinq millions sept cent quatre-vingt-cinq mille Euros (EUR 45.785.000,-), re-
présenté par quatre cent cinquante-sept mille huit cent cinquante (457.850) parts sociales d’une valeur nominale de cent
Euros (EUR 100,-).
KPMG AUDIT
<i> Réviseurs d’Entreprises
i> T. Feld»
17659
Les parts sociales ont été intégralement souscrites par:
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par les souscripteurs, ce dont il a été justifié au notaire.»
<i>Fraisi>
Dans la mesure où l’apport en nature a pour résultat que LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., détient l’intégralité des
actifs et passifs de la société DE BOER UNIGRO BEHEER BV, et où DE BOER UNIGRO BEHEER BV a son siège social
et son établissement principal dans l’Union Européenne, un tel apport entre dans le champ d’application de l’article 4-1
de la loi du 29 décembre 1971, qui prévoit l’exemption du droit d’apport.
Le montant des frais, coûts, rémunération et charges, incombant à la société en raison de la présente augmentation
de capital est estimé approximativement à la somme de trois cent mille francs luxembourgeois (LUF 300.000,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate que sur la demande des comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande des mêmes comparantes et en cas de diver-
gences entre les textes français et anglais, ce dernier fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite à la personne comparante, ladite personne comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. Ossola, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 3 novembre 2000, vol. 6CS, fol. 61, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations.
(65857/222/185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LAURUS LUXEMBOURG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 76.302.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65858/222/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LELLINV HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich.
R. C. Luxembourg B 58.621.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 9 novembre 2000 que:
- Monsieur Claudio Leo-Personnettaz et Monsieur Aldo Garzotto ont démissionné des fonctions d’administrateur;
- Maître Victor Elvinger, avocat, demeurant à Luxembourg et Maître Edouard de Fierlant Dormer, avocat, demeurant
à Luxembourg ont été nommés aux fonctions d’administrateur pour un terme expirant lors de l’assemblée générale or-
dinaire de 2002;
- La société CORAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED, ayant son siège social aux Iles Vierges Britanniques, a
été élue aux fonctions de commissaire aux comptes pour un terme expirant lors de l’assemblée générale ordinaire de
2002, en remplacement de l’ancien;
- Le siège social de la société a été transféré du 4, rue Tony Neuman à L-2241 Luxembourg au 31, rue d’Eich à L-1461
Luxembourg avec effet immédiat.
Luxembourg, le 17 novembre 2000
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 32, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65861/304/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LAURUS NV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
DE BOER UNIGRO BEHEER BV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457.700
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
457.850
Luxembourg-Bonnevoie, le 17 novembre 2000.
T. Metzler.
Luxembourg-Bonnevoie, le 17 novembre 2000.
T. Metzler.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
17660
LEAP INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 61.456.
—
L’an deux mille, le huit novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Madame Michèle Arnoe, employée privée, demeurant au 17, chemin des Présidanes, F-78290 Roissy sur Seine,
ici représentée par Monsieur Joseph Treis, expert-comptable, demeurant à Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé, laquelle procuration restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant déclare être le seul associé de la société à responsabilité limitée unipersonnelle LEAP INTERNA-
TIONAL, S.à r.l., avec siège social à Dalheim, constituée sous la dénomination de SYNAPSE, S.à r.l., suivant acte reçu
par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 septembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, en date du 4 février 1998, numéro 73.
Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglins-
ter, en date du 31 mars 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 29 juin 1998, nu-
méro 472.
L’associé a prié le notaire instrumentaire d’acter la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’associé décide de transférer le siège social de L-5681 Dalheim, Luissgaass 13, à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de
la Faïencerie.
Le premier alinéa de l’article cinq des statuts aura désormais la teneur suivante:
Art. 5. Premier alinéa. Le siège social est établi à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom, état et demeu-
re, le comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: J. Treis, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 13 novembre 2000, vol. 415, fol. 85, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65859/228/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LEAP INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 61.456.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65860/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LENTZ LUCIEN ET CIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Pétange.
R. C. Luxembourg B 15.934.
—
<i>Acte de cessioni>
La soussignée GOOD FOOD HOLDING S.A. déclare céder, contre paiement de la somme de LUF 25.500.000,- dont
il est, par la présente, donné quittance à INTERNATIONAL KAPITAL HOLDING S.A. qui accepte, 799 parts sociales
de LUF 10.000,- chacune de la Société LUCIEN LENTZ ET CIE, S.à r.l.
Les cédant et cessionnaire soussignés déclarent à cet effet donner pouvoir à UNIVERSALIA (FIDUCIAIRE) S.A. de
signer tous actes et registres, remettre tous titres et espèces et généralement faire tout ce qui est nécessaire pour l’ac-
complissement des formalités de transfert requises par la loi et les statuts.
Fait à Luxembourg, le 30 juin 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65862/643/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Mersch, le 20 novembre 2000.
E. Schroeder.
Mersch, le 20 novembre 2000.
E. Schroeder.
GOOD FOOD HOLDING S.A. / INTERNATIONAL KAPITAL HOLDING S.A.
<i>Le Cédant / Le Cessionnaire
i>Signatures / Signatures
<i>Administrateur - Administrateur / Administrateur - Administrateuri>
17661
LEONBERG HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.579.
—
L’an deux mille, le onze octobre.
Par-devant Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Hesperange.
S’est réunie:
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LEONBERG S.A., avec siège social à
Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch en date du 18 avril 1984,
publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, de 1984 page 7063.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hans de Graaf, managing director, demeurant à Mamer,
qui désigne comme secrétaire Madame Ruth Brand, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée choisit comme scrutateur Madame Juliette Lorang, administrateur de sociétés, demeurant à Neuhäusgen.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. - Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
Changement de la dénomination sociale de LEONBERG S.A. en LEONBERG HOLDING S.A.
II. - Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée ne
varietur par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées
ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant.
III. - Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibé-
rer valablement telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d’admi-
nistration à proposer les points figurant à l’ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution unique:i>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale LEONBERG S.A. en LEONBERG HOLDING S.A., de sorte
que l’article 1
er
des statuts aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe une société anonyme holding sous la dénomination LEONBERG HOLDING S.A.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
en raison des présentes, est évalué à environ 20.000,- LUF.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: H. de Graaf, R. Brand, J. Lorang, G. Lecuit.
Enregistré à Luxembourg, le 18 octobre 2000, vol. 126S, fol. 43, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65863/220/47) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LEONBERG HOLDING S.A., SociétéAnonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.579.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65864/220/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LINK DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R. C. Luxembourg B 28.671.
Acte constitutif publié à la page n
°
13253 du Mémorial C n
°
281 du 20 octobre 1988.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 10, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
Hesperange, le 15 novembre 2000.
G. Lecuit.
17662
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65865/581/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LODI HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.196.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65866/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LODI HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.196.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65867/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
LODI HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.196.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 juillet 2000 à Luxembourgi>
L’Assemblée décide d’accepter la démission de Monsieur Edmond Ries de son poste d’Administrateur et de Monsieur
Marc Lamesch de son poste de Commissaire et leur accorde pleine et entière décharge pour l’exécution de leur mandat.
L’Assemblée décide de nommer en remplacement au poste d’Administrateur Monsieur Jacques Tordoor, Employé
Privé, 3B, boulevard du Prince Henri, Luxembourg et au poste de Commissaire la société FIDUPARTNER A.G., 124,
route d’Arlon à Luxembourg.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Statutaire à tenir en 2002.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 34, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65868/531/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
MAPENTI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 54.107.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 24, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 novembre 2000.
(65871/576/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Signatures.
Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Signature.
Luxembourg, le 21 novembre 2000.
Signature.
Pour copie conforme
Signature / Signature
<i>Administrateur / Administrateuri>
<i>Pour le Conseil d’Administration
i>Signature
17663
MATER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 41.364.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, vol. 546, fol. 33, case 1, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65873/607/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
MATER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4660 Differdange, 11, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 41.364.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 546, fol. 33, case 1, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65872/607/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
MELOBESIA S.A. HOLDING, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration tenu par voie de circulaire daté au 14 novembre 2000 que Mon-
sieur Angelo Umberto Dufour a été nommé administrateur-délégué, avec tous les pouvoirs pour engager la Société par
sa signature individuelle dans toutes affaires de gestion ordinaire et encore celles qui sont relatives à l’exécution des
décisions de l’assemblée générale et du conseil d’administration.
Luxembourg, le 14 novembre 2000.
Enregistré à Luxembourg, le 21 novembre 2000, vol. 546, fol. 32, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveuri> (signé): J. Muller.
(65876/535/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
METROPOLITAN TRADING CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 32.006.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65877/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
METROPOLITAN TRADING CORPORATION, Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 32.006.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 28, case 9, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65878/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Signature.
Signature.
Pour extrait conforme
<i>Par mandat
i>N. Schaeffer
METROPOLITAN TRADING CORPORATION
Société Anonyme
METROPOLITAN TRADING CORPORATION
Société Anonyme
17664
MINICO HOLDING LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 60.246.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 17 novembre 2000, vol. 546, fol. 21, case 12, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65879/531/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
M. M. ADVISORS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2014 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.
R. C. Luxembourg B 60.601.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, vol. 546, fol. 33, case 1, a été déposé au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65880/607/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
M. M. WARBURG & CO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 17.881.
—
Le bilan au 30 juin 1994, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 28, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65881/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
M. M. WARBURG & CO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 17.881.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 28, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65883/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
M. M. WARBURG & CO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 17.881.
—
Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 20 novembre 2000, vol. 546, fol. 28, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(65882/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 novembre 2000.
Luxembourg, le 17 novembre 2000.
Signature.
Signature.
M.M. WARBURG & CO HOLDING
Société Anonyme
M.M. WARBURG & CO HOLDING
Société Anonyme
M.M. WARBURG & CO HOLDING
Société Anonyme
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, société à responsabilité limitée, 6, rue François Hogenberg, L-1735 Luxembourg
Sommaire
A & A Holdings S.A.
A & A Holdings S.A.
Kegefin Holding S.A.
Kegefin Holding S.A.
LeDaLux, S.à r.l.
N.H.C. Holding S.A.
N.H.C. Holding S.A.
Richemont Luxury Group S.A.
Fiem Holding S.A.
Fiem Holding S.A.
Ibercapital S.A.
Ibercapital S.A.
Cimex S.A.
Cimex S.A.
Exmar Lux S.A.
Escalade S.A.
Escalade S.A.
Investlife Luxembourg S.A.
IPN S.A.
FMC Finance II, S.à r.l.
FMC Finance II, S.à r.l.
Isatis S.A.H.
Jarny, S.à r.l.
Isidore Holding S.A.
Isidore Holding S.A.
JMP Conseil, S.à r.l.
JMP Conseil, S.à r.l.
J. P. Morgan Multi-Manager Strategies Fund
Kids & Co S.A.
Kids & Co S.A.
La Ciociara, S.à r.l.
La Fiduciaire Magellan Luxembourg S.A.
Lairnisia Gestion, S.à r.l.
Lairnisia Gestion, S.à r.l.
Lairnisia Gestion, S.à r.l.
Language Enterprises, S.à r.l.
Laurus Luxembourg, S.à r.l.
Laurus Luxembourg, S.à r.l.
Lellinv Holding S.A.
Leap International, S.à r.l.
Leap International, S.à r.l.
Lentz Lucien et Cie, S.à r.l.
Leonberg Holding S.A.
Leonberg Holding S.A.
Link Distribution S.A.
Lodi Holding
Lodi Holding
Lodi Holding
Mapenti Holding S.A.
Mater S.A.
Mater S.A.
Melobesia S.A. Holding
Metropolitan Trading Corporation
Metropolitan Trading Corporation
Minico Holding Luxembourg S.A.
M. M. Advisors, S.à r.l.
M. M. Warburg & Co Holding S.A.
M. M. Warburg & Co Holding S.A.
M. M. Warburg & Co Holding S.A.