This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
25345
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 529
24 juillet 2000
S O M M A I R E
ACM International Technology Fund, Sicav, Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
25389
Arens-Scheer S.A., Diekirch……………………………………………
25379
BLN, GmbH, Troisvierges ………………………………
25370
,
25371
BTK-Lux A.G., Weiswampach ………………………………………
25362
Camping Neumühle/Ermsdorf, S.à r.l., Neumühle/
Ermsdorf ………………………………………………………………………………
25367
Communauté d’Exploitation Agricole Trierweiler-
Weber S.C. …………………………………………………………………………
25366
Creutz & Partners, Global Asset Management S.A.,
Weiswampach ……………………………………………………………………
25367
Diabois S.A., Wiltz ………………………………………………………………
25372
Dinvest S.A., Luxembourg ………………………………………………
25355
Dinvest Two S.A., Luxembourg ……………………………………
25356
Dragon de Chine, S.à r.l., Hosingen ……………………………
25377
Dr. H.Bimbes A.G., Weiswampach ……………………………
25367
Engineering, Construction and Promotion, S.à r.l.,
Ettelbruck ……………………………………………………………………………
25379
Etablissement Massen S.A., Wemperhardt ……………
25365
Ets. Claude Kremer, S.à r.l., Vianden …………………………
25379
Eurolux Partners S.A., Bollendorf-Pont ……
25375
,
25378
Fel S.A., Weiswampach ……………………………………………………
25361
Fiduciaire Interrégionale S.A., Rippweiler ………………
25361
Haff, S.à r.l., Doennange……………………………………………………
25371
Immobilière de Sorozée S.A., Derenbach ………………
25365
Intereureka S.A., Luxembourg………………………………………
25389
Kegworth S.A., Luxembourg …………………………………………
25391
Lakimar, G.m.b.H., Weiswampach ……………………………
25361
LAMESCH EXPLOITATION S.A., Jean Lamesch
Exploitation, Bettembourg…………………………………………
25388
LG
2
Engineering S.A., Weiswampach ………………………
25366
Loca-Nord S.A., Heinerscheid ………………………………………
25366
Lombard Odier Invest, Sicav, Luxembourg
25358
,
25361
Luxemburger Agrarhandel, G.m.b.H., Diekirch……
25367
Lux-Gastronomie, S.à r.l., Diekirch ……………………………
25379
Luximco AG, Weiswampach …………………………………………
25375
Menuiserie Reckinger, S.à r.l., Pommmerloch ………
25366
MLB(S) (Lux) International Portfolios, Sicav, Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
25391
MLB(S) Specialty Portfolio, Sicav, Luxembourg …
25390
Morgules S.A., Bollendorf-Pont ……………………………………
25378
Murray Universal, Sicav, Luxembourg ………………………
25390
Musirent-Lux, S.à r.l., Asselborn …………………………………
25367
Nouvelle Terrest S.A., Remich………………………………………
25379
Office City S.A., Luxembourg ………………………………………
25380
Olex S.A., Luxembourg ……………………………………………………
25380
Olky International Holding S.A., Livange …………………
25380
Osdi S.A., Luxembourg ……………………………………………………
25381
Pfaffebruch, S.à r.l., Mamer ……………………………………………
25380
Participations Financières Européennes S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
25381
Partogest S.A., Luxembourg …………………………………………
25381
P.B.I., Procédés et Brevets Industriels S.A., Luxbg
25384
Perlmar S.A.H., Luxembourg…………………………………………
25382
Pharma/wHealth Management Company, S.à r.l.,
Luxembourg ………………………………………………………………………
25382
Pigali S.A., Luxembourg ……………………………………………………
25381
Pininfarina International S.A., Luxembourg……………
25382
Pito Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
25383
Plutos S.A.H., Luxembourg ……………………………………………
25383
P.O.P.Y. Holding S.A., Luxembourg …………………………
25383
Prime Multibond, Sicav, Luxembourg ………………………
25384
Promolux S.A., Differdange ……………………………………………
25385
(La) Pyramide, S.à r.l., Marnach ……………………………………
25362
Quintech Engineering S.A., Luxembourg…………………
25385
Reachim S.A., Luxembourg ……………………………
25383
,
25384
Reckinger Philippe, S.à r.l., Perlé …………………………………
25370
Recordati S.A., Chemical and Pharamceutical
Company, Luxembourg…………………………………………………
25385
Redelcover S.A., Luxembourg ………………………………………
25386
Red S.A.H., Luxembourg …………………………………………………
25386
Reisdorff Invest S.A., Weiswampach …………………………
25365
Renelux S.A., Luxembourg………………………………………………
25385
Rial, S.à r.l., Huldange ………………………………………………………
25365
RMS Europe, Risk Management Services S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………
25386
,
25387
Robling’s Malerwerkstatt, S.à r.l., Mertert ………………
25387
Safimmo S.A., Luxembourg ……………………………………………
25388
Sahiti S.A., Bollendorf-Pont ……………………………………………
25378
Schreinerei Arnold Becker, S.à r.l., Echternach ……
25365
Softbank Global Selection Fund, Fonds Commun
de Placement………………………………………………………………………
25346
Standard Chartered Investment Fund, Sicav, Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………
25388
Supermarché Massen S.A., Wemperhardt………………
25365
Transnational Financial Investments S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………
25387
,
25388
Transporte Hammes S.A., Weiswampach ………………
25366
Vibora S.A., Luxembourg…………………………………………………
25392
Vinaluc S.A.H., Luxembourg …………………………………………
25391
Wood & Forest, S.à r.l., Troisvierges …………………………
25364
Zondor S.A., Luxembourg ………………………………………………
25392
Zurich Invest (Lux) Sicav, Luxembourg ……………………
25392
SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND,
Fonds Commun de Placement à Compartiments Multiples.
—
MANAGEMENT REGULATIONS
1) The Fund
SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND (hereafter referred to as the «Fund»), organised under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg as a mutual investment umbrella fund (fonds commun de placement à compartiments
multiples), is an unincorporated coproprietorship of the securities and other assets (hereinafter referred to as
«securities») of the Fund, managed in the interest of its co-owners (hereafter referred to as the «unitholders») by
SOFTBANK FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (hereafter referred to as the «Management Company»), a
company incorporated under the laws of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. The assets of the
Fund, which are held in custody by CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ LUXEMBOURG (hereafter referred to as the
«Custodian»), are segregated from those of the Management Company. By the acquisition of units of the Fund, any
unitholder fully accepts these management regulations which determine the contractual relationship between the
unitholders, the Management Company and the Custodian.
The Fund will be an umbrella fund composed of different sub-funds (as defined hereafter) to be created pursuant to
Article 4).
2) The Management Company
The Fund is managed on behalf of the unitholders by the Management Company which shall have its registered office
in Luxembourg.
The Management Company is invested with the broadest powers to administer and manage the Fund, subject to the
restrictions set forth in Article 6 hereafter, on behalf of the unitholders, including but not limited to, the purchase, sale,
subscription, exchange and receipt of securities and the exercise of all the rights attached directly or indirectly to the
assets of the Fund.
The Board of Directors of the Management Company (hereinafter the «Board of Directors») shall determine the
investment policy of the Fund within the restrictions set forth in Article 6 hereafter.
The Board of Directors may appoint a general manager or managers and/or administrative agents to implement the
investment policy and administer and manage the assets of the Fund.
The Management Company may obtain investment information, management advice and other services, remuneration
for which will be at the Fund’s or the sub-funds’ charge to the extent provided herein.
The Management Company and its appointed investment manager(s), investment adviser(s), agent member(s) and
distributor(s) are entitled to fees payable periodically which may not exceed an annual rate of 1.5% of the average net
asset values of the assets of the Fund during the relevant period.
3) The Custodian
The Management Company shall appoint and terminate the appointment of the Custodian. CREDIT AGRICOLE
INDOSUEZ LUXEMBOURG, a corporation organised under the laws of Luxembourg with its registered office in
Luxembourg, has been appointed Custodian.
The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon 3
months’ prior written notice delivered by the one to the other. In the event of termination of the appointment of the
Custodian, the Management Company will use its best endeavours to appoint a new custodian who assumes the respon-
sibilities and functions of the Custodian under these Management Regulations. Pending the appointment of a new
custodian, the Custodian shall take all necessary steps to ensure good preservation of the interests of the unitholders.
After termination as aforesaid, the appointment of the Custodian shall continue thereafter for such period as may be
necessary to the transfer of all assets of the Fund to the new custodian.
The Custodian shall assume its functions and responsibilities in accordance with the law of 30th March, 1988 on
collective investment undertakings.
All cash and securities constituting the assets of the Fund shall be held by the Custodian on behalf of the unitholders
of the Fund. The Custodian may entrust banks and financial institutions with the custody of such assets. It will have the
normal duties of a bank with respect to the Fund’s deposits of cash and securities. The Custodian may only dispose of
the assets of the Fund and make payments to third parties on behalf of the Fund on receipt of instructions from the
Management Company or its appointed agents.
Upon receipt of instructions from the Management Company or its appointed agents, the Custodian will perform all
acts of disposal with respect to the assets of the Fund.
The Custodian is entitled to a fee out of and based on the net assets of the Fund as determined from time to time by
agreement between the Management Company and the Custodian.
4) The Sub-Funds
The Management Company may, from time to time, with the consent of the Custodian, create sub-funds (collectively
«Sub-Funds» and individually «Sub-Fund»), which have different investment objectives and policies. The units issued by
the Management Company in relation to each Sub-Fund shall constitute units of a class separate from the other unit
classes created in relation to other Sub-Funds.
A separate portfolio of investments and assets will be maintained for each Sub-Fund. The different portfolios will be
separately invested in accordance with an investment policy fixed for each Sub-Fund.
25346
Upon creation of a Sub-Fund, these Management Regulations shall be completed by an appendix containing the name
and investment policy of the Sub-Fund concerned as well as any other possible specificities of the Sub-Fund.
Any Sub-Fund may be dissolved upon decision of the Management Company with the consent of the Custodian as
more fully described in Article 20 hereafter.
5) Investment objective and policy of the Sub-Funds
The investment objective and policy of each Sub-Fund will be set forth in an appendix, for each Sub-Fund, attached to
these Management Regulations.
6) Investment restrictions
While managing the assets of the Sub-Funds, the Management Company, or its appointed agents, shall, unless
otherwise provided in an appendix to these Management Regulations, comply with the following restrictions:
1) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, invest in securities of any one issuer, if the value of
the holdings of a Sub-Fund in the securities of such issuer exceeds 10 % of the Sub-Fund’s total net assets, except that
the limit of 10% shall be 35% in respect of securities issued or guaranteed by governmental issuers, and except further
that such restriction shall not apply to securities issued or guaranteed by Member States of the Organisation for
Economic Cooperation and Development («OECD») or their local authorities or public international bodies with EU,
regional or world-wide scope.
2) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, invest in securities of any single issuer if, as a result
of such investment, the Fund owns more than 10% of any class of the outstanding equity shares, or more than 10% of
the outstanding voting securities, or more than 10% of the debt securities, of such issuer. The Management Company
may not purchase securities of any company or other body if, upon such purchase, the Fund, together with other
investment funds which may be managed by the Management Company, would own more than 15% of any class of the
equity shares of such company or body.
3) The Management Company may not invest in voting shares of companies allowing it to exercise a significant
influence in the management of the issuer.
4) The Management Company may invest up to 10% of the net assets of a Sub-Fund in shares or units of other
collective investment funds of the open-ended type. The acquisition of shares or units in a collective investment fund
managed by the same Management Company or by any other company with which the Management Company is linked
by common management or control or by substantial direct or indirect holding shall be permitted only in the case of
investment in a collective investment fund which specialises in the investment in a specific geographical area or economic
sector. In such event the Management Company may not charge any fee or cost on account of transactions in
connection with such shares or units.
5) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, purchase real estate. Mortgage backed securities and
collateralised mortgage obligations are not considered real estate for purposes of this restriction.
6) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, enter into transactions involving commodities,
commodity contracts or securities representing merchandise or rights to merchandise and for the purposes hereof
commodities includes precious metals and certificates representing them, except that it may purchase and sell securities
that are secured by commodities and securities of companies which invest or deal in commodities and that this
restriction shall not prevent a Sub-Fund from entering into financial futures and forward contracts (and options thereon)
on financial instruments, stock indices and foreign currencies, to the extent permitted by applicable laws and regulations
and the Management Regulations.
7) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, purchase any securities on margin, (except that the
Management Company may obtain such short-term credit as may be necessary for the clearance of purchases and sales
of portfolio securities) or make short sales of securities or maintain a short position, except that it may make initial and
maintenance margin deposits in respect of futures and forward contracts (and options thereon).
8) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, borrow other than borrowings which in the
aggregate do not exceed 10% of the total net assets of the Sub-Fund, which borrowings may, however, only be made on
a temporary basis.
9) The Management Company may not mortgage, pledge, hypothecate or in any manner transfer as security for indeb-
tedness, any securities owned or held on behalf of a Sub-Fund, except as may be necessary in connection with borro-
wings mentioned in 8) above and provided that the purchase or sale of securities on a when-issued or delayed-delivery
basis, and collateral arrangements with respect to the writing of options or the purchase or sale of forward or future
contracts are not deemed the pledge of the assets.
10) The Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, invest more than 15% of the net assets of the Sub-
Fund in securities which are not traded on an official stock exchange or another regulated market, operating regularly
and being recognised and open to the public, and for the purpose of this restriction, the so called «U.S. OTC Fixed
Income Market» shall be considered as a regulated market. A Sub-Fund will not invest more than 15% of its net assets
in shares of stock privately placed, Japanese mortgage securities (known as «teito shoken» in Japan) or unlisted shares
of stock which cannot be readily realised.
11) The Management Company may not use the assets of a Sub-Fund to underwrite or sub-underwrite any securities.
12) The Management Company may, on behalf of a Sub-Fund, employ techniques and instruments relating to trans-
ferable securities under the conditions and within the limits laid down by law, regulation or administrative practice
provided that such techniques or instruments are used for the purpose of efficient portfolio management.
25347
With respect to options:
a) the Management Company may not, on behalf of a Sub-Fund, invest in put or call options on securities unless:
i) such options are quoted on a stock exchange or dealt in on a regulated market; and
ii) the acquisition price of such options does not exceed, in terms of premiums, 15% of the total net assets of the Sub-
Fund;
b) the Management Company may sell, on behalf of a Sub-Fund, call options on securities provided that:
i) such securities are already held or the Sub-Fund holds equivalent call options or other instruments capable of
ensuring adequate coverage of the commitments resulting from such contracts, such as warrants; or
ii) the aggregate of the exercise prices of uncovered call options does not exceed 25% of the Sub-Fund’s net assets
and the Sub-Fund must at any time be in the position to ensure the coverage of the position taken as a result of the
writing of such options.
c) the Management Company may not write put options on securities unless the Sub-Fund holds sufficient liquid assets
to cover the aggregate of the exercise prices of such options written.
13) The Management Company may not deal, on behalf of a Sub-Fund, in financial futures, except that:
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of the value of its portfolio securities the Management
Company, on behalf of the Sub-Fund, may have outstanding commitments in respect of financial futures sales contracts
not exceeding the corresponding risk of fluctuation of the value of the corresponding portion of the Sub-Fund’s
portfolio;
b) for the purpose of efficient portfolio management, the Management Company, on behalf of the Sub-Fund, may
enter into financial futures purchase contracts, provided that sufficient cash, short-dated debt securities or instruments
(other than the liquid assets which might have to be held by the Sub-Fund pursuant to restriction 12 c) above), or
securities to be disposed of at a predetermined value exist to match the underlying exposure of any such futures
positions.
14) The Management Company may not deal, on behalf of a Sub-Fund, in index options except that:
a) for the purpose of hedging the risk of the fluctuation of its portfolio securities, the Management Company, on
behalf of the Sub-Fund, may sell call options on stock indexes or acquire put options on stock indexes. In such event the
value of the underlying securities included in the relevant stock index option shall not exceed, together with outstanding
commitments in financial futures contracts entered into for the same purpose, the aggregate value of the portion of the
securities portfolio to be hedged; and
b) for the purpose of the efficient management of its securities portfolio, the Management Company, on behalf of the
Sub-Fund, may acquire call options on stock indexes, provided the value of the underlying securities included in the
relevant stock index options is covered by cash, short-dated debt securities and instruments (other than the liquid assets
which might have to be held by the Sub-Fund pursuant to restrictions 12c) and 13 b)) or securities to be disposed of at
predetermined prices;
provided, however, that the aggregate acquisition cost (in terms of premiums paid) of options on securities and index
options purchased by the Management Company, on behalf of the Sub-Fund, shall not exceed 15% of the net assets of
the Sub-Fund at the time of purchase of such options.
15) The Management Company may, on behalf of a Sub-Fund, lend the Sub-Fund’s portfolio securities to specialised
banks, credit institutions and other financial institutions of high standing, or through recognised clearing institutions such
as Cedel or Euroclear. The lending of securities will be made for periods not exceeding 30 days. Loans will be secured
continuously by collateral consisting of cash and/or of securities issued or guaranteed by member states of the OECD
or by their local authorities which at the conclusion of the lending agreement, must be at least equal to the value of the
global valuation of the securities lent. The collateral must be blocked in favour of the Sub-Fund until termination of the
lending contract. Lending transactions may not be carried out on more than 50% of the aggregate market value of the
securities of the portfolio, provided, however, that this limit is not applicable where the Sub-Fund has the right to
terminate the lending contract at any time and obtain restitution of the securities lent. Any transaction expenses in
connection with such loans may be charged to the Sub-Fund.
The Management Company, on behalf of a Sub-Fund, may engage in repurchase agreements and reverse repurchase
agreements, with high quality financial institutions specialised in this type of transactions. During the duration of a
repurchase agreement, the Management Company may not, on behalf of the Sub-Fund, sell the securities which are
subject to the agreement before the repurchase by the counterparty or the expiration of the repurchase period.
Further, the Sub-Fund must ensure that it is all times capable to meet its obligation to purchase or repurchase such
securities upon request of their holders.
The Management Company may, on behalf of a Sub-Fund, enter into the transactions referred to under 13) and 14)
above only if these transactions concern contracts which are traded on a regulated market operating regularly, being
recognised and open to the public. With respect to options referred to under 12) and 14) above and in connection with
options on interest rates as set forth below, the Management Company, on behalf of a Sub-Fund, may enter into OTC
option transactions with first class financial institutions specialised in this type of transactions if such transactions are
more advantageous to the Sub-Fund or if quoted options having the required features are not available.
If the above percentages are exceeded for reasons beyond the control of the Management Company or as a result of
the exercise of subscription rights, the Management Company must adopt as a priority objective for its sales transac-
tions the remedying of that situation, taking due account of the interests of the Sub-Fund’s unitholders.
The Management Company may, on behalf of a Sub-Fund, sell interest rate futures contracts for the purpose of
hedging against interest rate fluctuations. It may also for the same purpose write call options or purchase put options on
interest rates or enter into interest rate swaps by private agreement with highly-rated financial institutions specialised in
25348
these types of operations. In principle, the aggregate of the commitments of each Sub-Fund relating to futures contracts,
options and swap transactions on interest rates may not exceed the aggregate estimated market value of the assets to
be hedged and held by the Sub-Fund in the currency corresponding to those contracts.
The Management Company may, for the purpose of hedging currency risks for units of a Sub-Fund as described in the
investment policy, enter into forward currency contracts or write call options and purchase put options on currencies,
provided, however, that these transactions may only concern contracts which are traded on a regulated market
operating regularly, being recognized and open to the public except that the Management Company may also enter into
forward sales of currencies or exchange currencies on the basis of private agreements with highly-rated financial insti-
tutions specialised in these type of transactions. The transactions may neither exceed the value of the assets of that Sub-
Fund denominated in that currency nor exceed the period during which such assets are held.
The Management Company shall, on behalf of a Sub-Fund, not sell, purchase or loan securities except the units of the
Sub-Fund, or receive loans, to or from (a) the Management Company, (b) its affiliated companies, (c) any director of the
Management Company or its affiliated companies or (d) any major shareholder thereof (meaning a shareholder who
holds, on his own account whether in his own or other name (as well as a nominee’s name), 10% or more of the total
issued outstanding units of such a company) acting as principal or for their own account unless the transaction is made
within the restrictions set forth in the Management Regulations, and, either (i) at a price determined by current publicly
available quotations, or (ii) at competitive prices or interest rates prevailing from time to time, on internationally
recognised securities markets or internationally recognised money markets.
The Management Company may not grant loans to or act as guarantor for third parties. This provision shall not
prevent the Management Company from lending a Sub-Fund’s portfolio securities in accordance with restriction 15)
above.
The Management Company may from time to time impose further investment restrictions which shall be set out in
the relevant Appendix to this Prospectus as shall be compatible with or in the interest of the unitholders and in order
to comply with the laws and regulations of the countries where the units of the Sub-Fund are placed.
7) Issue of Units
Units of a Sub-Fund shall be issued by the Management Company subject to payment therefor to the Custodian within
five Luxembourg bank business days counting from and including the applicable Valuation Date.
The Management Company may accept contributions in kind at its discretion if the assets to be contributed are in
compliance with the investment policy of the relevant Sub-Fund and if the contribution is in compliance with the
investment restrictions set forth above. The assets to be contributed in kind will be valued in a report of the auditor of
the Fund.
Units of a Sub-Fund shall be issued in registered form only.
All units of each Sub-Fund have equal rights and privileges. Each unit of each Sub-Fund is, upon issue, entitled to parti-
cipate equally with all other units of such Sub-Fund in any distribution upon declaration of dividends in respect of such
Sub-Fund and upon liquidation of such Sub-Fund.
Confirmations of holding and certificates (if issued) shall be delivered by the Management Company, provided that
payment therefor shall have been received by the Custodian.
The Management Company shall comply, with respect to the issuing of units of a Sub-Fund with the laws and regula-
tions of the countries where these units are offered. The Management Company may, at any time, at its discretion,
temporarily discontinue, cease definitely or limit the issue of units. The Management Company may also prohibit certain
persons or corporate bodies from acquiring units, if such a measure is necessary for the protection of the unitholders
as a whole and the Fund.
The sale of the Fund’s units will not be promoted to the public in the European Union or any part thereof.
Furthermore, the Management Company may:
(a) reject at its discretion any application for units when the Management Company deems it necessary for the
protection of the Fund;
(b) repurchase at any time the units held by unitholders who are excluded from purchasing or holding units.
The Management Company may split or consolidate the units.
8) Issue price
The terms of the initial offering will be determined by the Management Company.
If the Board of Directors of the Management Company resolves that additional units will be issued after the initial
offering period, the issue price per unit will be based on the net asset value per unit of the relevant Sub-Fund as deter-
mined in accordance with the provisions of Article 10 hereof on the applicable Valuation Date. Any applicable sales
charge of up to 3% of the applicable net asset per unit shall be set forth in the Prospectus of the Fund.
The Valuation Date is defined in the relevant appendix to these Management Regulations.
Payment of the issue price shall be made in the currency specified in the appendix relating to the respective Sub-Fund,
within maximum five Luxembourg bank business days counting from and including the applicable Valuation Date.
The Management Company may fix from time to time minimum subscription amounts.
9) Unit certificates and confirmations
Any person or corporate body shall be eligible to participate in the Fund by subscribing for units, subject, however,
to the provisions contained in Article 7 of these Management Regulations. The Management Company may deliver
confirmations or certificates (if issued) in registered form. Each certificate shall carry the signatures of the Management
Company and the Custodian, both of which may be in facsimile. In the absence of a request for certificates, investors will
be deemed to have requested that no certificate be issued in respect of their units and a confirmation will be delivered
instead.
25349
10) Determination of Net Asset Value
The net asset value of units of each Sub-Fund in the Fund shall be expressed in the respective reference currency of
the relevant Sub-Fund as a per unit figure.
The Net Asset Value of units of each Sub-Fund will be determined by the Management Company on each Valuation
Date by dividing the value of the assets of the relevant Sub-Fund less the liabilities (including any provisions considered
by the Management Company to be necessary or prudent) attributable to such Sub-Fund by the total number of units of
the relevant Sub-Fund outstanding to the extent possible, investment income, interest payable, fees and other liabilities
(including management fees) will be accrued daily.
For the purpose of determining the assets and liabilities of each Sub-Fund there shall be established a mass of assets
for each Sub-Fund in the following manner:
(a) the proceeds from the issue of units of each Sub-Fund shall be applied in the books of the Fund to the mass of
assets established for that Sub-Fund and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall
be applied to such mass subject to the provisions of this article;
(b) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Fund to
the same mass as the assets from which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution
in value shall be applied to the relevant mass;
(c) where the Fund incurs a liability which relates to any asset of a particular mass, such liability shall be allocated to
the relevant mass;
(d) in the case where any asset or liability of the Fund cannot be considered as being attributable to a particular mass,
such asset or liability shall be allocated to all the mass pro rata to the total Net Asset Values of the relevant Sub-Funds;
(e) upon the record date for determination of the person entitled to any dividend declared on any Sub-Fund, the Net
Asset Value of units of such Sub-Fund shall be reduced by the amount of such dividends.
The assets of a Sub-Fund shall be deemed to include:
(a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(b) all bills and demand notes and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
(c) all bonds, time notes, shares, stock, debenture stocks, subscription rights, warrants, options, futures contracts and
other investments and securities owned or contracted for the Sub-Fund;
(d) all stock, stock dividends, cash dividends and cash distributions receivable by the Sub-Fund (provided that the
Management Company may make, on behalf of the Sub-Fund, adjustments with regard to fluctuations in the market value
of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar practices);
(e) all interest accrued on any interest-bearing securities owned by the Sub-Fund except to the extent that the same
is included or reflected in the principal amount of such security;
(f) all forward currency contracts or other hedging instruments;
(g) the preliminary expenses of the Sub-Fund insofar as the same have not been written off; and
(h) all other assets of every kind and nature, including prepaid expenses.
The liabilities of the Sub-Fund shall be deemed to include:
(a) all loans, bills and accounts payable;
(b) all accrued or payable administrative expenses (including management company fees, custodian fees and
withholding and other taxes);
(c) all known liabilities, whether billed or unbilled, including all matured contractual obligations for payments of money
or property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Management Company on behalf of the Sub-
Fund where the Valuation Date falls on the record date for determination of the person entitled thereto or is sub-
sequent thereto;
(d) an appropriate provision for future taxes based on the total assets and income to the Valuation Date and other
reserves, as determined from time to time by the Management Company; and
(e) all other liabilities of the Sub-Fund of whatsoever kind and nature except liabilities represented by units in the Sub-
Fund. In determining the amount of such liabilities, the Management Company may calculate administrative and other
expenses of a regular or recurring nature on an estimated figure for yearly or other periods in advance, and may accrue
the same in equal proportions over any such period.
Interest on securities and liquid assets as well as on fees and expenses shall be accrued in a manner that the applicable
Net Asset Value on any Valuation Date takes into account a calculated amount of interest due to or by the Sub-Fund
until the payment date applicable for units issued or repurchased on the relevant Valuation Date.
The total net assets of the Fund are composed of the aggregate net assets of each individual Sub-Fund.
The assets of the Sub-Funds will be valued as follows:
(a) Securities that are officially quoted on a stock exchange are valued at their last known price on such stock
exchange on the relevant Valuation Date; if there is no such last known price on such Valuation Date, they are valued at
their probable realisation value on the relevant Valuation Date, determined prudently and in good faith;
(b) If a security is quoted on several stock exchanges, the last known price at the stock exchange which constitutes
the main market for such securities, will be determining;
(c) Securities that are not quoted on a stock exchange but dealt in on a regulated market or on another organised
market are also valued at their last known price on the relevant Valuation Date;
(d) Securities whose prices are not fair market prices, as well as all other assets, are valued at their probable reali-
sation value, on the relevant Valuation Date determined prudently and in good faith;
(e) Equity investments in unquoted private companies are valued (i) in principle, at cost (ii) if the Management
Company considers that such valuation at cost is different from fair market price, at their market value on the relevant
Valuation Date, determined prudently and in good faith;
(f) Cash is valued at its face value plus accrued interest;
25350
(g) Assets which are not denominated in the reference currency of a Sub-Fund are translated into such reference
currency at the rate of exchange prevailing in Luxembourg at that time on the relevant Valuation Date.
In the event that extraordinary circumstances render such valuations impracticable or inadequate, the Management
Company, is authorised, prudently and in good faith, to follow other rules in order to achieve a fair valuation of the
assets of the Fund.
11) Suspension of determination of Net Asset Value
The Management Company may temporarily suspend the determination of the net asset value of units of a Sub-Fund
and in consequence the issue and the repurchase of units in a Sub-Fund in any of the following events:
- when one or more stock exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the
assets of the Sub-Fund, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which a substantial portion
of the assets of the Sub-Fund are denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if dealings therein are
restricted or suspended;
- when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsibility
and the control of the Management Company, disposal of the assets of the Sub-Fund is not reasonably or normally
practicable without being seriously detrimental to the interests of the unitholders;
- in the case of a breakdown in the normal means of communication used for the valuation of any investment of the
Sub-Fund or if, for any reason, the value of any asset of the Sub-Fund may not be determined as rapidly and accurately
as required;
- if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of
the Sub-Fund are rendered impracticable or if purchases and sales of the Sub-Fund’s assets cannot be effected at normal
rates of exchange.
12) Repurchase
The Management Company may close the Fund for redemptions. The closed period (if any) applicable to any Sub-
Fund will be disclosed in the relevant appendix to these Management Regulations.
Outside of any period during which a Sub-Fund would be closed for redemptions, unitholders may request
repurchase of their units on any Valuation Date.
Repurchase will be based on the net asset value per unit of the relevant Sub-Fund determined on the applicable
Valuation Date as determined in accordance with the terms of Article 10 above. Such repurchase request must be
accompanied by the relevant unit certificates (if issued). Any applicable repurchase charge of up to 2% of the applicable
net asset value per share shall be set forth in the Prospectus of the Fund.
The Management Company shall ensure that an appropriate level of liquidity is maintained in the Sub-Fund’s assets,
so that under normal circumstances, repurchase of the units of each Sub-Fund may be made promptly upon request by
unitholders.
Payment of the repurchase price will be made within maximum five Luxembourg bank business days counting from
and including the applicable Valuation Date subject to receipt of the unit certificates (if issued).
The Custodian must make payment only if no statutory provisions, such as exchange control regulations or other
circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the transfer of the payment of the repurchase price to the
country where repurchase was applied for.
If total requests for repurchase/conversion on any Valuation Date are received in respect of a number of units of any
Sub-Fund which exceed 10% of the total number of units of that Sub-Fund outstanding on such Valuation Date, the
Management Company is entitled to defer all repurchase/conversion requests pro rata, so that the 10% level is not
exceeded. Any repurchase/conversion requests in respect of the relevant Valuation Date so reduced will be effected in
priority to subsequent repurchase/conversion requests received on the next Valuation Date, subject always to the 10%
limit.
13) Conversions
The provisions regarding conversion shall only be applicable at the time where several Sub-Funds exist and where
there are no limitations on issues and repurchases of units.
Unitholders wishing to convert from units of one Sub-Fund to units of other Sub-Funds and vice versa will be entitled
to do so on any day which is a Valuation Date for the Sub-Funds concerned by tendering the unit certificates (if issued)
to the Management Company, accompanied with an irrevocable written conversion request. Such request should specify
the number of units to be converted. The number of units issued upon conversion will be based upon the respective Net
Asset Value of the two Sub-Funds on the applicable Valuation Date and shall be calculated as follows:
N1 = NAV2 (1-X) x N2
NAV1
N1:
The number of units to be issued upon conversion.
A unit fraction shall not be issued. Any residual amount resulting from a unit fraction will be forfeited to the
benefit of the Sub-Fund to which units are to be converted.
N2:
The number of units requested for conversion.
NAV1: Net Asset Value as of the applicable Valuation Date of units to be issued upon conversion
NAV2: Net Asset Value as of the applicable Valuation Date of units requested for conversion which is converted into
the reference currency of units to be issued upon conversion at the applicable exchange rate on the appli-
cable Valuation Date.
X:
Any conversion charge applicable will be set forth in the relevant Appendix to these Management Regula-
tions.
25351
14) Charges of the Fund
The Fund, or each Sub-Fund where appropriate, will bear, inter alia, the following charges:
- all taxes which may be due on the assets and the income of the Fund;
- usual banking fees due on transactions involving securities held in the portfolio of the Fund;
- the remuneration of the Management Company and the appointed investment manager(s) and investment adviser(s);
- the remuneration and reasonable disbursements and out-of-pocket expenses of the distributor(s) and the agent
member in Japan;
- the remuneration and reasonable disbursements and out-of-pocket expenses of the Custodian (acting as custodian
and administration agent);
- legal expenses incurred by the Management Company or the Custodian while acting in the interests of the
unitholders;
- the cost of preparing and printing certificates (if any) and unit confirmations; the cost of preparing and/or filing and
printing of these Management Regulations and all other documents concerning the Fund, including registration state-
ments and prospectuses and explanatory memoranda with all authorities (including local securities dealers’ associations)
having jurisdiction over the Fund or the offering of units of the Fund; the cost of preparing and printing in such languages
as are necessary for the benefit of the unitholders, including the beneficial holders of the units and distributing to
unitholders and intermediaries annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be required
under the applicable laws or regulations of the above-cited authorities; the cost of preparing and distributing public
notices to the unitholders; lawyers’ and auditor’s fees; and all similar administrative charges except all advertising
expenses and other expenses directly incurred in offering or distributing the units.
- all other costs resulting from the administration of the Fund in compliance with the requirements of applicable law
and regulations.
All recurring charges will be charged first against income, then against capital gains and then against assets. Other
charges may be amortised over a period not exceeding five years.
15) Accounting Year, Audit
The accounts of the Fund are closed each year on 30th June and for the first time on 30th June, 2001.
The accounts of the Management Company will be audited by auditors appointed by the Management Company.
The Management Company shall also appoint an authorised auditor who shall, with respect to the assets of the Fund,
carry out the duties prescribed by the law of 30th March, 1988 regarding collective investment undertakings.
16) Distributions
The distribution policies for the different Sub-Funds are disclosed in the relevant Appendices to these Management
Regulations.
No distribution may be made as a result of which the total net assets of the Fund would fall below the equivalent of
50 million Luxembourg francs.
Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and will revert to the relevant Sub-Fund.
17) Co-management
In order to reduce operational and administrative charges while allowing a wider diversification of the investments,
the Management Company may decide that part or all of the assets of any Sub-Fund will be co-managed with assets
belonging to other Sub-Funds within the present structure and/or other collective Luxembourg investment schemes. In
the following paragraphs, the words «co-managed entities» shall refer to any Sub-Fund and all entities with and between
which there would exist any given co-management arrangement and the words «co-managed assets» shall refer to the
entire assets of these co-managed entities and co-managed pursuant to the same co-management arrangement.
Under the co-management arrangement, the Management Company or its appointed investment manager will be
entitled to take, on a consolidated basis for the relevant co-managed entities, investment, disinvestment and portfolio
readjustment decisions which will influence the composition of the Sub-Fund’s portfolio. Each co-managed entity shall
hold a portion of the co-managed Assets corresponding to the proportion of its net assets to the total value of the co-
managed Assets. This proportional holding shall be applicable to each and every line of investment held or acquired
under co-management. In case of investment and/or disinvestment decisions these proportions shall not be affected and
additional investments shall be allotted to the co-managed entities pursuant to the same proportion and assets sold shall
be levied proportionately on the co-managed Assets held by each co-managed entity.
In case of new subscriptions in one of the co-managed entities, the subscription proceeds shall be allotted to the co-
managed entities pursuant to the modified proportions resulting from the net asset increase of the co-managed entity
which has benefited from the subscriptions and all lines of investment shall be modified by a transfer of assets from one
co-managed entity to the other in order to be adjusted to the modified proportions. In a similar manner, in case of
redemptions in one of the co-managed entities, the cash required may be levied on the cash held by the co-managed
entities pursuant to the modified proportions resulting from the net asset reduction of the co-managed entity which has
suffered from the redemptions and, in such case, all lines of investment shall be adjusted to the modified proportions.
Unitholders should be aware that, in the absence of any specific action by the Management Company or its appointed
agents, the co-management arrangement may cause the composition of assets of a Sub-Fund to be influenced by events
attributable to other co-managed entities such as subscriptions and redemptions. Thus, all other things being equal,
subscriptions received in one entity with which any Sub-Fund is co-managed will lead to an increase of this Sub-Fund’s
reserve of cash. Conversely, redemptions made in one entity with which any Sub-Fund is co-managed will lead to a
reduction of the Sub-Fund’s reserve of cash. Subscriptions and redemptions may, however, be kept in the specific
account opened for each co-managed entity outside the co-management arrangement and through which subscriptions
25352
and redemptions must pass. The possibility to allocate substantial subscriptions and redemptions to these specific
accounts together with the possibility for the Management Company or its appointed agents to decide at any time to
terminate a Sub-Fund’s participation in the co-management arrangement permit the Sub-Fund to avoid the readjust-
ments of its portfolio if these readjustments are likely to affect the interest of the Fund and of its Unitholders.
If a modification of the composition of the Sub-Fund’s portfolio resulting from redemptions or payments of charges
and expenses peculiar to another co-managed entity (i.e. not attributable to the Sub-Fund) is likely to result in a breach
of the investment restrictions applicable to the Sub-Fund, the relevant assets shall be excluded from the co-management
arrangement before the implementation of the modification in order for it not to be affected by the ensuing adjustments.
Co-managed Assets of any Sub-Fund shall only be co-managed with assets intended to be invested pursuant to
investment objectives identical to those applicable to the co-managed Assets of such Sub-Fund in order to assure that
investment decisions are fully compatible with the investment policy of the Sub-Fund. Co-managed Assets of any Sub-
Fund shall only be co-managed with assets for which the Custodian is also acting as depository in order to assure that
the Custodian is able, with respect to the Fund, to fully carry out its functions and responsibilities pursuant to the Law
of March 30, 1988 relating to undertakings of collective investment. The Custodian shall at all times keep the Fund’s
assets segregated from the assets of other co-managed entities, and shall therefore be able at all time to identify the
assets of the Fund. Since co-managed entities may have investment policies which are not strictly identical to the
investment policy of one of the Sub-Funds, it is possible that as a result the common policy implemented may be more
restrictive than that of the Sub-Fund.
The Management Company may decide at any time and without notice to terminate the co-management arran-
gement.
18) Amendment of the Management Regulations
The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these Management Regulations in whole or
in part at any time.
Amendments will become effective on their date of publication in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
of Luxembourg if not otherwise specified.
19) Publications
The audited annual report and the unaudited semi-annual report of the Fund are made available to the unitholders at
the registered offices of the Management Company and the Custodian.
Any amendments to these Management Regulations will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations of Luxembourg.
The amendments and any notices to unitholders may also be published, as the Management Company may decide, in
newspapers of countries where the units of the Fund are offered and sold.
20) Duration of the Fund and of the Sub-Funds, Liquidation
The Fund is established for an unlimited period. The Fund may be dissolved at any time by agreement between the
Management Company and the Custodian. The Fund may further be dissolved in the cases provided for by Luxembourg
law. If net assets of a Sub-Fund become less than JPY 500 million (or its equivalent) or the total net assets of the Fund
become less than JPY 500 million (or its equivalent), the Management Company will, upon consultation with the distri-
butor(s) in Japan, consider the liquidation of a Sub-Fund or the Fund.
By agreement between the Management Company and the Custodian, (i) a Sub-Fund may be liquidated at any time
and unitholders of such Sub-Fund will be allocated the net sales proceeds of the assets of the Sub-Fund or (ii) a Sub-Fund
may be liquidated at any time and units of another Sub-Fund may be allocated to the unitholders of the Sub-Fund to be
liquidated against contribution in kind of the assets of such Sub-Fund (to be valued by a report of the auditor of the Fund)
to the other Sub-Fund. A liquidation and contribution as contemplated in (ii) can only be made if such liquidation is
justified by the size of the liquidated Sub-Fund, by a change of the economic or political situation affecting the Sub-Fund
or is made for any other reason to assure the best interest of the unitholders concerned.
In case of a liquidation as described in (i) above, the effective date of the liquidation will be notified to unitholders by
mail.
In case of liquidation and contribution of a Sub-Fund as described in (ii) above, all unitholders of the Sub-Fund
concerned will receive one month’s prior notice of such liquidation by mail during which they may repurchase their units
free of charge.
Until the effective date of the liquidation of a Sub-Fund, unitholders may continue to repurchase or convert (if appli-
cable) their units at the applicable net asset value reflecting provisions made to cover expenses resulting from the liqui-
dation of such Sub-Fund.
Any unclaimed liquidation proceeds will be transferred to the Caisse des Consignations in Luxembourg for the benefit
of the person(s) entitled thereto 6 months after the closure of the liquidation.
Any notice of dissolution of the Fund will be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of
Luxembourg, and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a Luxem-
bourg newspaper, to be determined jointly by the Management Company and the Custodian.
The Management Company will realise the assets of the Fund in the best interests of the unitholders and the
Custodian, upon instructions given by the Management Company, will distribute the net proceeds of the liquidation,
after deducting all liquidation expenses, among the unitholders in proportion of the units held.
The liquidation of the Fund and/or a Sub-Fund may not be requested by unitholders or by their heirs or beneficiaries.
25353
21) Statute of limitation
The claims of the unitholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date
of the event which gave rise to such claims.
22) Applicable Law, Jurisdiction and governing language
Disputes arising between the unitholders, the Management Company and the Custodian shall be settled according to
Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided, however, that the
Management Company and the Custodian may subject themselves and the Fund to the jurisdiction of courts of the
countries, in which the units of the Fund are offered and sold, with respect to claims by investors resident in such
countries and, with respect to matters relating to subscriptions and repurchases by unitholders resident in such
countries to the laws of such countries. English shall be the governing language for these Management Regulations.
These Management Regulations were initially executed in Luxembourg, on 6th June, 2000 and amended to their
present form on 16th June, 2000. These Management Regulations come into effect on 26th June, 2000.
SOFTBANK FUND MANAGEMENT
CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
COMPANY S.A.
LUXEMBOURG
Signature
Signatures
APPENDIX I
TO THE MANAGEMENT REGULATIONS OF
SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND
Relating to the sub-fund
SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND - SOFTBANK BOND & PRIVATE EQUITY FUND
1. Name of the sub-fund
SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND - SOFTBANK BOND & PRIVATE EQUITY FUND (in this Appendix «the
Sub-Fund»).
2. Reference Currency
Japanese Yen.
3. Valuation Date
Each bank business day in Luxembourg and Tokyo.
4. Investment Objective and Policy
This Sub-Fund aims to achieve best investment yields in Yen terms while benefiting from long-term capital appre-
ciation on its equity investments.
The Sub-Fund’s assets are primarily invested in publicly traded securities of which the majority will be fixed and
floating rate debt securities. Up to 15% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in unlisted private equity shares
(«private equity portion»).
5. Investment Restrictions
For investments qualifying under the private equity portion as defined above, the Management Company may not, on
behalf of the Sub-Fund, invest in securities of any single issuer if, as a result of such investment, the Sub-Fund owns more
than 30% of the outstanding equity shares of such issuer. In connection with these investments, the Management
Company may not purchase securities of any issuer if, upon such purchase, the Fund together with other investment
funds managed by the Management Company would own more than 30% of the equity shares of such issuer. In the
context of these investments, the Management Company may be in a position to exercise significant influence over such
issuer but it is not the intended policy of the Management Company to exercise corporate governance.
6. Distribution Policy
Until the end of the accounting year to end on 30th June, 2002, the Management Company does not intend to declare
distributions in respect of the Sub-Fund. Thereafter, distributions shall be declared and paid out of net investment
income and realized net capital gains.
7. Repurchase
The Management Company has resolved that unitholders may not request repurchase of their units until (and
excluding) 1st July, 2002, provided that the Management Company may in its absolute discretion accept repurchase
requests from unitholders (or their heir(s)): (A) when (1) a unitholder dies; (2) a substantial portion of a unitholder’s
assets are lost due to natural disaster or an act of God; (3) a unitholder is adjudicated bankrupt; (4) a unitholder cannot
maintain his or her livelihood due to illness; or (5) the Management Company judges that an event similar to the (1) to
(4) above has taken place (such as fire, accident, loss of job, to the extent that the Management Company determines)
and (B) a unitholder, via the Distributor in Japan, submits to the Management Company reasonable evidence verifying
that any of the conditions (1) through (5) above is satisfied.
8. Duration of the Sub-Fund
The Sub-Fund is established for an undetermined period.
Enregistré à Luxembourg, le 21 juin 2000, vol. 538, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(33095/260/596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 juin 2000.
25354
DINVEST S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
In the year two thousand, on the fourteenth of June.
Before Us, Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DINVEST S.A. (the «Corporation») with its registered
office in Luxembourg, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Tom Metzler, notary
residing in Luxembourg-Bonnevoie, on 15th July 1986, published in the Mémorial C on 7th August, 1986.
The meeting was presided by Miss Léone Brachmond, private employee, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mr Bastien Collette, private employee, residing in Arlon (B).
The meeting elected as scrutineer Mr André Schmit, private employee, residing in Schieren.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned
Notary to state:
I. That the agenda of this meeting is the following:
1. to amend article six of the Articles of Incorporation of the Corporation in order to allow the issuance of fractions
of shares by replacing the last sentence by the following:
«If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, the person entitled to such fraction shall
not be entitled to vote but shall, to the extent the Corporation shall determine as to the calculation of fractions, be
entitled to dividends on a pro rata basis.»
2. to amend paragraph C (d) of article twenty-three of the articles of incorporation of the Corporation so as to read
as follows:
«d) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset attributable to a particular pool or class of
shares or to any action taken in connection with an asset attributable to a particular pool or class of shares, such liability
shall be allocated to the relevant pool and/or class of shares»;
3. to amend article twenty-four of the articles of incorporation of the Corporation so as to read as follows:
«Art. 24. Whenever the Corporation shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares
shall be offered and sold, shall be the Net Asset Value as herein above defined for the relevant class of shares plus any
adjustment or charge which reverts to the Corporation and such sales charge as the sale documents may provide. The
price per share will be rounded upwards or downwards as the board of directors may resolve. The price so determined
shall be payable not later than five business days after the date on which the application was accepted.»
II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this
attendance list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary, as well as the proxies,
will remain annexed to the present deed.
III. All shareholders have been given notice of the meeting by means of registered letters sent to their address
appearing in the register of shareholders on 2nd June 2000.
IV. Out of the 141,233 shares in issue on 2nd June 2000, 133,918 shares (being more than 50% of the shares in issue)
are represented at the present meeting. The present meeting is thereby regularly constituted and may validly deliberate
on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Resolutioni>
The meeting resolved to amend article six, paragraph C (d) of article twenty-three and article twenty-four of the
articles of incorporation of the Corporation as provided in the agenda.
There being nothing further on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.
All costs and fees due as a result of the foregoing shall be charged to the Corporation.
The undersigned Notary who understands and speaks English states that, at the request of the parties hereto, these
minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading of these minutes, the members of the bureau
signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède.
L’an deux mille, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de DINVEST S.A. (la «Société»), ayant son siège
social à Luxembourg, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg; constituée suivant acte reçu par le notaire Tom Metzler,
résidant à Luxembourg-Bonnevoie, en date du 15 juillet 1986, publié au Mémorial C le 7 août 1986.
L’Assemblée est présidée par Mademoiselle Léone Brachmond, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Bastien Collette, employé privé, demeurant à Arlon.
L’Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur André Schmit, employé privé, demeurant à Schieren.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de l’article six des statuts de la Société afin de permettre l’émission de fractions d’actions en
remplaçant la dernière phrase par ce qui suit:
«Si le paiement effectué par un souscripteur aboutit à l’émission de fractions d’actions, cette fraction ne conférera pas
de droit de vote, mais donnera droit, dans les conditions à déterminer par la Société, à des dividendes proportionnels.»
2. Modification du paragraphe C (d) de l’article vingt-trois des statuts de la Société comme suit:
25355
«d) lorsque la Société supporte un engagement qui est en rapport avec un avoir d’une masse déterminée ou une
catégorie d’actions ou en relation avec une opération effectuée en rapport avec un avoir attribuable à une masse déter-
minée ou une classe d’actions déterminée, cet engagement sera attribué à la masse et/ou la classe d’actions en question»;
3. Modification de l’article vingt-quatre des statuts de la Société comme suit:
«Art. 24. Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action auquel pareilles actions seront
offertes et émises sera égal à la valeur d’actif net de la catégorie d’actions concernée, telle que définie dans les présents
statuts, augmenté d’un prélèvement ou ajustement en faveur de la Société et de telles commissions de vente qui seront
prévues dans les documents relatifs à la vente. Le prix par action sera arrondi vers le haut ou le bas de la manière décidée
par le conseil d’administration. Le prix ainsi déterminé sera payable au plus tard sept jours ouvrables après le jour où la
souscription a été acceptée.»
II. Les actionnaires représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent
sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires repré-
sentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
III. Tous les actionnaires ont été informés de la tenue de la présente assemblée au moyen de lettres recommandées
qui ont été adressées à leur adresse indiquée dans le registre des actionnaires le 2 juin 2000.
IV. Sur les 141.233 actions émises le 2 juin 2000 par la société, 133.918 actions, (étant plus que la moitié) sont repré-
sentées à la présente assemblée. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
L’assemblée décide de modifier l’article six, paragraphe C (d) de l’article vingt-trois et l’article vingt-quatre des statuts
de la Société tel que prévu dans l’ordre du jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à la charge de la Société.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Brachmond, B. Collette, A. Schmit, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 76, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 juin 2000.
J. Elvinger.
(34628/211/116) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
DINVEST TWO, Société Anonyme.
Registered office: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
—
In the year two thousand on the fourteenth day of June.
Before Us, Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of shareholders of DINVEST TWO (the «Corporation»), with its
registered office in Luxembourg, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, incorporated by a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, on 26th November, 1999, published in the Mémorial C on 29th December,
1999.
The meeting was presided by Miss Léone Brachmond, private employee, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mr Bastien Collette, private employee, residing in Arlon (B).
The meeting elected as scrutineer Mr André Schmit, private employee, residing in Schieren.
The bureau of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned
Notary to state:
I. That the agenda of this meeting is the following:
1. to amend article six of the Articles of Incorporation of the Corporation in order to allow the issuance of fractions
of shares by replacing the last sentence by the following:
«If payment made by any subscriber results in the issue of a share fraction, the person entitled to such fraction shall
not be entitled to vote but shall, to the extent the Corporation shall determine as to the calculation of fractions, be
entitled to dividends on a pro rata basis.»
2. to amend paragraph A (2) of article twenty-three of the articles of incorporation of the Corporation so as to read
as follows:
«2) each share or unit in open-ended undertaking for collective investments will be valued at the actual net asset value
for such shares or units as of the relevant Valuation Day, or if no such actual net asset value is available, they shall be
valued at the estimated net asset value as of such Valuation Day, or if no such estimated net asset value is available they
shall be valued at the last available actual or estimated net asset value which is calculated prior to such Valuation Day
25356
whichever is the closer to such Valuation Day, provided that if events have occurred which may have resulted in a
material change in the net asset value of such shares or units since the date on which such actual or estimated net asset
value was calculated, the value of such shares or units may be adjusted in order to reflect, in the reasonable opinion of
the Directors, such change».
3. to amend paragraph C (d) of article twenty-three of the articles of incorporation of the Corporation so as to read
as follows:
«d) where the Corporation incurs a liability which relates to any asset attributable to a particular pool or class of
shares or to any action taken in connection with an asset attributable to a particular pool or class of shares, such liability
shall be allocated to the relevant pool and/or class of shares;»
4. to amend article twenty-four of the articles of incorporation of the Corporation so as to read as follows:
«Art. 24. Whenever the Corporation shall offer shares for subscription, the price per share at which such shares
shall be offered and sold, shall be the Net Asset Value as herein above defined for the relevant class of shares plus any
adjustment or charge which reverts to the Corporation and such sales charge as the sale documents may provide. The
price per share will be rounded upwards or downwards as the board of directors may resolve. The price so determined
shall be payable not later than five business days after the date on which the application was accepted.»
II. That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list; this
attendance list, signed by the Chairman, the Secretary, the Scrutineer and the undersigned notary as well as the proxies
will remain annexed to the present deed.
III. All shareholders have been given notice of the meeting by means of registered letters sent to their address
appearing in the register of shareholders on 2nd June, 2000.
IV. Out of the 138,235 shares in issue on 2nd June, 2000, 134,310 shares (being more than 50% of the shares in issue)
are represented at the present meeting. The present meeting is thereby regularly constituted and may validly deliberate
on the agenda.
After deliberation, the meeting unanimously took the following resolution:
<i>Resolutioni>
The meeting resolved to amend article six, paragraph A (2) and paragraph C (d) of article twenty-three and article
twenty-four of the articles of incorporation of the Corporation as provided in the agenda.
There being nothing further on the agenda, the Chairman adjourned the meeting.
All costs and fees due as a result of the foregoing shall be charged to the Corporation.
The undersigned Notary who understands and speaks English states that, at the request of the parties hereto, these
minutes are drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall be prevailing.
Done in Luxembourg on the day aforementioned. And after reading of these minutes, the members of the bureau
signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le quatorze juin.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire demeurant à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de DINVEST TWO (la «Société»), ayant son siège
social à Luxembourg, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg; constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph Elvinger,
résidant à Luxembourg, en date du 26 novembre 1999, publié au Mémorial C le 29 décembre 1999.
L’Assemblée est présidée par Mademoiselle Léone Brachmond, employée privée, demeurant à Luxembourg.
La Présidente désigne comme secrétaire Bastien Collette, employé privé, demeurant à Arlon.
L’Assemblée élit aux fonctions de scrutateur Monsieur André Schmit, employé privé, demeurant à Schieren.
Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le Notaire d’acter que:
I. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. modification de l’article six des statuts de la société afin de permettre l’émission de fractions d’actions en
remplaçant la dernière phrase par ce qui suit:
«Si le paiement effectué par un souscripteur aboutit à l’émission de fractions d’actions, cette fraction ne conférera pas
de droit de vote, mais donnera droit, dans les conditions à déterminer par la Société, à des dividendes proportionnels.»
2. modification du paragraphe A (2) de l’article vingt-trois des statuts de la société comme suit:
«2) chaque action ou part d’un organisme de placement collectif du type ouvert sera évaluée à la valeur d’actif net
définitive déterminée comme au jour d’évaluation ou si une telle valeur d’actif net définitive n’est pas disponible, ces
actions ou parts seront évaluées à la valeur nette estimée comme au jour d’évaluation, ou si une telle valeur nette
estimée n’est pas disponible, ces actions ou parts seront évaluées à la dernière valeur d’actif net disponible déterminée
avant ce jour d’évaluation et laquelle est la plus proche de ce jour d’évaluation, étant entendu que si des événements
sont survenus qui ont résulté en une modification substantielle de la valeur d’actif net de ces actions ou de ces parts
après la date à laquelle la valeur d’actif net définitive ou estimée a été calculée, la valeur de ces actions ou parts peut être
ajustée afin de réfléter cette modification selon l’avis raisonnable des administrateurs;»
3. modification du paragraphe C (d) de l’article vingt-trois des statuts de la Société comme suit:
«d) lorsque la Société supporte un engagement qui est en rapport avec un avoir d’une masse déterminée ou une
catégorie d’actions ou en relation avec une opération effectuée en rapport avec un avoir attribuable à une masse déter-
minée ou une classe d’actions déterminée, cet engagement sera attribué à la masse et/ou la classe d’actions en question.»
4. modifier l’article vingt-quatre des statuts de la société comme suit:
25357
«Art. 24. Lorsque la Société offre des actions en souscription, le prix par action auquel pareilles actions seront
offertes et émises sera égal à la valeur d’actif net de la catégorie d’actions concernée, telle que définie dans les présents
statuts, augmenté d’un prélèvement ou ajustement en faveur de la Société et de telles commissions de vente qui seront
prévues dans les documents de vente. Le prix par action sera arrondi vers le haut ou le bas de la manière décidée par le
conseil d’administration. Le prix ainsi déterminé sera payable au plus tard sept jours ouvrables après le jour ou la
souscription a été acceptée.»
II. Les actionnaires représentés, les procurations des actionnaires representés et le nombre d’actions qu’ils détiennent
sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence, signée par les mandataires des actionnaires repré-
sentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
III. Tous les actionnaires ont été informés de la tenue de la présente assemblée au moyen de lettres recommandées
qui ont été adressées à leur adresse indiquée dans le registre des actionnaires le 2 juin 2000.
IV. Sur les 138.235 actions émises le 2 juin 2000 par la société, 134.310 actions (étant plus que la moitié) sont repré-
sentées à la présente assemblée. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur l’ordre du jour.
Après délibération, l’assemblée prend à l’unanimité la résolution suivante:
<i>Résolutioni>
Il est décidé de modifier l’article six, le paragraphe A (2) et le paragraphe C (d) de l’article vingt-trois et l’article vingt-
quatre des statuts de la Société tel que prévu dans l’ordre du jour.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Tous les frais et honoraires dus en vertu des présentes sont à la charge de la Société.
Le Notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, reconnaît par les présentes qu’à la requête des comparants le
présent procès-verbal est rédigé en anglais, suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Dont procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,
état et demeure, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: L. Brachmond, E. Colette, A. Schmit, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 16 juin 2000, vol. 124S, fol. 76, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 juin 2000.
J. Elvinger.
(34629/211/126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 juillet 2000.
LOMBARD ODIER INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 25.301.
—
In the year two thousand on the thirtieth day of June.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Mersch.
Was held an extraordinary general meeting of shareholders of LOMBARD ODIER INVEST, a société d’investissement
à capital variable, having its registered office in Luxembourg, 39 allée Scheffer, incorporated under the denomination of
MEDITERRANEAN FUND by a deed of notary Joseph Kerschen, notary residing in Luxembourg-Eich, on 5th January
1987, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 21st January 1987. The Articles of Incorpo-
ration were amended on 13th May 1988, 11th May 1989, 15th February 1994 and 3rd November 1997 as published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 28th July 1988, 5th October 1989, 24th March 1994 and 15th
November 1997.
The meeting was opened at 11.30 a.m. and was presided by Mrs Anne Felten, juriste, residing in Luxembourg.
The Chairman appointed as secretary Mrs Valérie Letellier, employée privée, residing in Esch-sur-Alzette.
The meeting elected as scrutineer Mrs Sylvie Dobson, juriste, residing in Sierck-les-Bains (France).
The bureau having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state:
I. That the Agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
A) To amend Article 21, paragraph 6, first sentence of the Articles of Incorporation as follows:
«In case of redemption requests on any Valuation Date for more than 10 per cent of the number of shares relating
to an Emerging Markets Fund or to a Sub-Fund having a substantial part of its assets invested in small caps companies,
the Company may elect to sell assets of that Fund representing, as nearly as practicable, the same proportion of the
Fund’s assets as the shares for which redemption applications have been received compared to the total of shares then
in issue.»
To add a new paragraph after paragraph 6:
«In case of redemption requests on any Valuation Date for more than 10 per cent of the number of shares relating
to any Sub-Funds which are not Emerging Markets Funds and do not invest a substantial part in small caps companies,
the Company shall not be bound to redeem on any Valuation Day or in any period of seven consecutive Valuation Days
more than 10 per cent of the number of Shares of any Sub-Fund in issue on such Valuation Day or at the commencement
25358
of such period. Redemption may accordingly be deferred for not more than seven Valuation Days after the date of
receipt of the redemption request (but always subject to the foregoing limits). In case of deferral of redemptions, the
relevant Shares shall be redeemed at the net asset value per share on the Valuation Day on which the request is
executed.»
B) To amend Article 23, paragraph D, (d) of the Articles of Incorporation by deleting the second paragraph regarding
the principle of contagion.
C) To amend Article 28 by adding a new paragraph after paragraph 1 of the Articles of Incorporation with the
following text:
«In case the residual value of the Shares held by an investor falls below USD 5,000.- (or such other amount as the
board of directors may from time to time determine and disclose in the prospectus) following a redemption or a
conversion request, the Company may redeem or convert the remaining holding of the investor.»
III. That the present meeting has been convened by convening notices published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations C and in the Luxemburger Wort on 13 June 2000 and on 21 June 2000 sent to the registered
shareholders on 5 June 2000.
III. That the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and the number of their shares are
shown on an attendance list which, signed by the proxies of the shareholders represented, the members of the bureau
of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with
the registration authorities.
IV. That the attendance list shows that out of 347,028,381 shares representing the total share capital of the Company
299,558,657.373 shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.
V. That the present meeting is regularly convened and constituted and may validly decide on its agenda, the quorum
of shareholders present or represented imposed by law and by the articles of incorporation being reached.
After this has been set forth by the Chairman and acknowledged by the members of the bureau, the meeting
proceeded to its Agenda.
The meeting having considered the Agenda, the following resolutions have been adopted unanimously:
<i>Resolutionsi>
The general meeting of shareholders
1. resolved to amend Article 21, paragraph 6, first sentence of the Articles of Incorporation as follows:
«In case of redemption requests on any Valuation Date for more than 10 per cent of the number of shares relating
to an Emerging Markets Fund or to a Sub-Fund having a substantial part of its assets invested in small caps companies,
the Company may elect to sell assets of that Fund representing, as nearly as practicable, the same proportion of the
Fund’s assets as the shares for which redemption applications have been received compared to the total of shares then
in issue.»
To add a new paragraph after paragraph 6:
«In case of redemption requests on any Valuation Date for more than 10 per cent of the number of shares relating
to any Sub-Funds which are not Emerging Markets Funds and do not invest a substantial part in small caps companies,
the Company shall not be bound to redeem on any Valuation Day or in any period of seven consecutive Valuation Days
more than 10 per cent of the number of Shares of any Sub-Fund in issue on such Valuation Day or at the commencement
of such period. Redemption may accordingly be deferred for not more than seven Valuation Days after the date of
receipt of the redemption request (but always subject to the foregoing limits). In case of deferral of redemptions, the
relevant Shares shall be redeemed at the net asset value per share on the Valuation Day on which the request is
executed.»
2. resolved to amend Article 23, paragraph D, (d) of the Articles of Incorporation by deleting the second paragraph
regarding the principle of contagion.
3. resolved to amend Article 28 by adding a new paragraph after paragraph 1 of the Articles of Incorporation with the
following text:
«In case the residual value of the Shares held by an investor falls below USD 5,000.- (or such other amount as the
board of directors may from time to time determine and disclose in the prospectus) following a redemption or a
conversion request, the Company may redeem or convert the remaining holding of the investor.»
Nothing else being on the Agenda, the meeting was then adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states hereby that upon request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. Upon request of the same appearing
persons and in case of divergencies between the English version and the French text, the English will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the date named on the beginning.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their names,
surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille, le trente juin.
Pardevant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de LOMBARD ODIER INVEST, une société d’inve-
stissement à capital variable ayant son siège social 39, allée Scheffer, à Luxembourg, constituée sous la dénomination de
MEDITERRANEAN FUND par acte du notaire Joseph Kerschen, notaire de résidence à Luxembourg-Eich, le 5 janvier
25359
1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 21 janvier 1987. Les statuts de la société ont été
modifiés le 13 mai 1988, le 11 mai 1989, le 15 février 1994 et le 3 novembre 1997, selon ce qui est publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations du 28 juillet 1988, du 5 octobre 1989, du 24 mars 1994 et du 15 novembre 1997.
La scéance est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Madame Anne Felten, juriste, demeurant à Luxembourg.
Le Président désigne comme secrétaire Madame Valérie Letellier, employée privée, demeurant à Esch-sur-Alzette.
L’assemblée élit aux fonctions de scrutateur Madame Sylvie Dobson, juriste, demeurant à Sierck-les-Bains (France).
Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et prie le notaire d’acter:
I. Que l’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
A. Modification de la première phase de l’article 21 alinéa 6 des statuts:
«En cas de demandes de rachat lors d’un Jour d’Evaluation de plus de 10 pour cent du nombre des Actions d’un Fonds
d’un Marché Emergent ou d’un Portefeuille ayant investi une partie substantielle de ses avoirs dans des sociétés
faiblement capitalisées, la Société peut décider de vendre des avoirs de ce Fonds représentant, dans la mesure du
possible, la même proportion d’avoirs du Fonds que les Actions pour lesquelles des demandes de rachats ont été reçues,
comparé au nombre total d’Actions émises.»
Modification de l’article 21 afin d’y ajouter un alinéa, suite à l’alinéa 6:
«En cas de demandes de rachat lors d’un Jour d’Evaluation pour plus de 10 pour cent du nombre des Actions émises
par un Portefeuille qui n’est pas un Fonds investissant en Marchés Emergents et qui n’investit pas une partie substantielle
de ses actifs dans des sociétés faiblement capitalisées (small caps), la Société ne sera pas obligée de racheter lors d’un
Jour d’Evaluation ou lors de toute période de sept Jours d’Evaluation consécutifs plus de 10 pour cent du nombre des
Actions émises de tous Portefeuilles lors d’un tel Jour d’Evaluation ou au début de cette période. Leur rachat peut ainsi
être reporté pour 7 Jours d’Evaluation au maximum à compter de la date de la réception de la demande de rachat (mais
toujours endéans la limite prédécrite). Au cas où les rachats sont reportés, les Actions en question seront rachetées à
un prix basé sur la Valeur Nette d’inventaire par Action à la date à laquelle le rachat est effectué.»
B. Modification de l’article 23, D, (d) des statuts afin d’y supprimer le deuxième alinéa concernant le principe de
contagion d’un Portefeuille à un autre.
C. Modification de l’article 28 des statuts afin d’y ajouter un nouvel alinéa suite à l’alinéa 1
er
:
«Dans l’hypothèse où la valeur nette résiduelle des Actions détenues par un investisseur devient inférieure à USD
5.000,- (ou tout autre montant, tel que décidé par le Conseil d’Administration de temps en temps et publié dans le
prospectus) suite à une demande de rachat ou de conversion, la Société peut procéder au rachat ou à la conversion des
Actions restantes détenues par l’investisseur.»
II. Que la présente assemblée a été convoquée par des avis de convocation publiés dans le Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations C, et le Luxemburger Wort le 13 et le 21 juin 2000 et par lettres envoyées au actionnaires
nominatifs le 5 juin 2000.
III. Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d’actions qu’ils
détiennent seront renseignés sur une liste de présence qui, signée par les mandataires des actionnaires représentés, les
membres du bureau de l’assemblée et le notaire soussigné, demeurera annexée au présent acte de façon à être enregis-
trée avec celui-ci au même moment auprès de l’Administration de l’Enregistrement.
IV. Qu’il résulte de la liste de présence que sur 347.028.381 actions représentant la totalité du capital de la société,
299.558.657,373 actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.
V. Que la présente assemblée a été régulièrement convoquée et régulièrement constituée et peut valablement
délibérer sur son ordre du jour, les conditions de quorum d’actionnaires présents ou représentés imposées par la loi ou
par les statuts étant atteintes.
Après que ceci a été déclaré par le Président et accepté par les membres de l’assemblée, l’assemblée commence avec
son ordre du jour.
L’assemblée ayant considéré l’ordre du jour, le président a alors soumis au vote de l’assemblée les résolutions
suivantes, qui ont été adoptées à l’unanimité:
<i>Resolutionsi>
L’assemblée générale des actionnaires
1. Décide de modifier la première phase de l’article 21 alinéa 6 des statuts:
«En cas de demandes de rachat lors d’un Jour d’Evaluation de plus de 10 pour cent du nombre des Actions d’un Fonds
d’un Marché Emergent ou d’un Portefeuille ayant investi une partie substantielle de ses avoirs dans des sociétés
faiblement capitalisées, la Société peut décider de vendre des avoirs de ce Fonds représentant, dans la mesure du
possible, la même proportion d’avoirs du Fonds que les Actions pour lesquelles des demandes de rachats ont été reçues,
comparé au nombre total d’Actions émises.»
Décide d’y ajouter un nouvel alinéa suite à l’alinéa 6:
«En cas de demandes de rachat lors d’un Jour d’Evaluation pour plus de 10 pour cent du nombre des Actions émises
par un Portefeuille qui n’est pas un Fonds investissant en Marchés Emergents et qui n’investit pas une partie substantielle
de ses actifs dans des sociétés faiblement capitalisées (small caps), la Société ne sera pas obligée de racheter lors d’un
Jour d’Evaluation ou lors de toute période de sept Jours d’Evaluation consécutifs plus de 10 pour cent du nombre des
Actions émises de tous Portefeuilles lors d’un tel Jour d’Evaluation ou au début de cette période. Leur rachat peut ainsi
être reporté pour 7 Jours d’Evaluation au maximum à compter de la date de la réception de la demande de rachat (mais
toujours endéans la limite prédécrite). Au cas où les rachats sont reportés, les Actions en question seront rachetées à
un prix basé sur la Valeur Nette d’inventaire par Action à la date à laquelle le rachat est effectué.»
25360
2. Décide de modifier l’article 23, D, (d) des statuts afin d’y supprimer le deuxième alinéa concernant le principe de
contagion d’un Portefeuille à un autre.
3. Décide de modifier l’article 28 des statuts afin d’y ajouter un nouvel alinéa suite à l’alinéa 1
er
:
«Dans l’hypothèse où la valeur nette résiduelle des Actions détenues par un investisseur devient inférieure à USD
5.000,- (ou tout autre montant, tel que décidé par le Conseil d’Administration de temps en temps et publié dans le
prospectus) suite à une demande de rachat ou de conversion, la Société peut procéder au rachat ou à la conversion des
Actions restantes détenues par l’investisseur.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’assemblée est alors clôturée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête des personnes compa-
rantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: A. Felten, V. Letellier, S. Dobson, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 juillet 2000, vol. 414, fol. 53, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): A. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 juillet 2000.
E. Schroeder.
(35618/228/191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2000.
LOMBARD ODIER INVEST, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 39, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 25.301.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 5 juillet 2000.
E. Schroeder.
(35619/228/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 juillet 2000.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8720 Rippweiler, 5, an der Brem’chen.
R. C. Diekirch B 3.193.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Redange, le 24 mars 2000, vol. 143, fol. 82, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 12 avril 2000.
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
Signature
(91053/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
LAKIMAR, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, rue de Stavelot.
R. C. Diekirch B 2.160.
—
Le bilan au 5 août 1999, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 5, a été déposé au registre de
commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91055/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
FEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
R. C. Diekirch B 2.458.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91056/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
25361
LA PYRAMIDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9764 Marnach, Marburgerstrooss 9.
R. C. Diekirch B 1.395.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marnach, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91057/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
BTK-LUX A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind erschienen:
1) Die Aktien-Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihren allein zeichnungsberechtigten Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn Herbert März,
Kaufmann, in B-4791 Burg-Reuland, Maldingen, 45, wohnend;
2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herrn Herbert März, vorgenannt.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer
Aktiengesellschaft zu beurkunden:
Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung BTK-LUX A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanzbe-
teiligungsgesellschaft (société de participations financières) gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im
Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhn-
liche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorüber-
gehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser
einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen
Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist:
- der Grosshandel und der Einzelhandel mit Tannenreisig, Weihnachtsbäumen, Gartenartikeln, Blumen, Pflanzen und
Zubehör, der Transport dieser Güter;
- das Betreiben eines Schnell-Imbisses (Fast-Food), sowie jede andere Art von Tätigkeit welche mit dem Gesell-
schaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn fördern kann.
Ausserdem die Beteiligungen auf jede Art und Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,
die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlich-
keiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres
Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen
Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und
unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausendfünfzig (31.050,-) Euro, eingeteilt in sechs-
hunderteinundzwanzig (621) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig (50,-) Euro.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
25362
Kapitel III. Verwaltung, Übertragung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche
Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit,
durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den
Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt
wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen
Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre
Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefasster Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern
genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster
Beschluss.
Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.
Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.
Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-
versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung
gefassten Beschlüsse.
Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
Kapitel V. Generalversammlung
Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im
Mémorial und in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem dritten Dienstag des Monats April um sechzehn Uhr
nachmittags im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verschoben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftska-
pitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2000. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die
Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese
Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit
Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten. Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige
Rücklagen zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Kapitel VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welche
unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
25363
Kapitel VIII. Allgemeines
Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, dass das gesamte Kapital wie
folgt gezeichnet wurde:
1. Die Aktien-Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., vorgenannt, sechshundertzwanzig Aktien …………… 620
2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt, eine Aktie……………………………………………
1
Total: sechshunderteinundzwanzig Aktien …………………………………………………………………………………………………………………………… 621
Sämtliche Aktien wurden in bar einbezahlt, so dass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreissigtausend-
fünfzig (31.050,-) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
Zu allen fiskalischen Zwecken hat das Stammkapital einen Gegewert von einer Million zweihundertzweiundfünfzig-
tausendfünfhundertvierundfünfzig (1.252.554,-) Franken.
<i>Feststellungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend Franken
(50.000,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlung i>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf
einen.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
a) Frau Gisela Weyandt, Kauffrau, wohnhaft zu D-54614 Dingdorf, Waldweg, 9
b) Frau Yvonne Weyandt, Kauffrau, wohnhaft zu D-54608 Bleialf, Poststrasse, 5;
c) Herr Peter Weyandt, Kaufmann, wohnhaft zu D-54614 Dingdorf, Waldweg, 9;
3. Die Generalversammlung bestimmt zur Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren:
- Frau Gisela Weyandt, vorgenannt,
4. Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft vertreten wird durch die alleinige Unterschrift des
Vorsitzenden des Verwaltungsrates ohne finanzielle Beschränkung.
5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt;
6. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd in den vorerwähnten Eigenschaften, dem Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Signé: H. März, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 16 mars 2000, vol. 602, fol. 52, case 10. – Reçu 12.526 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Siebenaler.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-
fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Diekirch, den 10. April 2000.
F. Unsen.
(91054/234/174) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
WOOD & FOREST, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9905 Troisvierges, 39, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 4.807.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Troisvierges, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91058/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
25364
REISDORFF INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 124, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.763.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91059/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
SCHREINEREI ARNOLD BECKER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6484 Echternach, 16B, route de Larochette.
R. C. Diekirch B 3.363.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91060/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
SUPERMARCHE MASSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1-3, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.561.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wemperhardt, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91061/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
RIAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange, 54, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.479.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Huldange, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91062/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
ETABLISSEMENT MASSEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 1-3, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 1.560.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 22, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Wemperhardt, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91063/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
IMMOBILIERE DE SOROZEE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9645 Derenbach, Maison 11.
R. C. Diekirch B 4.759.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 11 avril 2000, vol. 265, fol. 54, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(91071/600/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
25365
LG
2
ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 86, route de Clervaux.
R. C. Diekirch B 3.371.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 22, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91064/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
TRANSPORTE HAMMES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 102, auf dem Kiemel.
R. C. Diekirch B 4.771.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 22, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91065/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
LOCA-NORD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9753 Heinerscheid, 2A, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.566.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 22, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Heinerscheid, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91066/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
MENUISERIE RECKINGER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9638 Pommerloch, 16A, Bastnicherstrooss.
R. C. Diekirch B 4.612.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 22, case 6, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pommerloch, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91067/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
COMMUNAUTE D’EXPLOITATION AGRICOLE TRIERWEILER-WEBER, Société civile.
Constituée par acte sous seing privé en date du 26 février 1991.
—
DISSOLUTION
Les associés Nicolas et Guy Trierweiler, cultivateurs, demeurant ensemble à L-8612 Pratz, 4, rue de la Grotte, et
Victor Weber et son épouse Laure Schrantz, cultivateurs, demeurant ensemble à L-8611 Platen, 51, rue Principale, se
sont réunis en date du 25 mars 2000 et ont déclaré qu’ils sont les seuls titulaires des parts sociales de la COMMU-
NAUTE D’EXPLOITATION AGRICOLE TRIERWEILER-WEBER, en sorte que le capital est intégralement réuni.
Les associés ont décidé de dissoudre la société avec effet au 31 mars 2000 et déclarent l’avoir liquidée aux droits des
parties.
Les livres et documents sociaux seront conservés au siège de l’ancienne société à L-8612 Pratz, 4, rue de la Grotte.
Pratz, le 31 mars 2000.
N. Trierweiler
V. Weber
G. Trierweiler
L. Schrantz
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2000, vol. 535, fol. 52, case 1. – Reçu 500,- francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(91073/262/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2000.
25366
MUSIRENT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9940 Asselborn, 34, rue de Wiltz.
R. C. Diekirch B 5.588.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Asselborn, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91068/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
CREUTZ & PARTNERS, GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 144, route de Stavelot.
R. C. Diekirch B 4.547.
—
Le bilan au 30 septembre 1999, enregistré à Clervaux, le 16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 12 avril 2000.
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91069/667/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 13 avril 2000.
LUXEMBURGER AGRARHANDEL, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9237 Diekirch, 3, place Guillaume.
R. C. Diekirch B 2.866.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 14 avril 2000, vol. 265, fol. 59, case 1, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 14 avril 2000.
Signature.
(91079/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
CAMPING NEUMÜHLE/ERMSDORF, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9364 Neumühle/Ermsdorf.
R. C. Diekirch B 1.310.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Diekirch, le 14 avril 2000, vol. 265, fol. 59, case 2, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 14 avril 2000.
Signature.
(91080/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
DR. H.BIMBES A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den fünfzehnten März.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind erschienen:
1) Die Aktien-Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihren allein zeichnungsberechtigten Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn Herbert März,
Kaufmann, in B-4791 Burg-Reuland, Maldingen, 45, wohnend;
2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herrn Herbert März, vorgenannt.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer
Aktiengesellschaft zu beurkunden:
Kapitel I. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung DR. H.BIMBES A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Form einer
Finanzbeteiligungsgesellschaft (société de participations financières) gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.
25367
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im
Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhn-
liche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorüber-
gehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser
einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen
Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und der Export mit Waren aller Art, der Ankauf, der Verkauf und
die wirtschaftliche Verwertung von Immobilien, sowie jede andere Art von Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck
direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn fördern kann.
Ausserdem die Beteiligungen auf jede Art und Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,
die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbindlich-
keiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres
Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen
Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und
unbeweglichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und
Durchführung ihres Zweckes.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend (31.000,-) Euro, eingeteilt in sechshundert-
zwanzig (620) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig (50,-) Euro.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftskapital erhöht oder erniedrigt werden.
Kapitel III. Verwaltung, Übertragung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche
Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit,
durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den
Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt
wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen
Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre
Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefasster Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern
genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster
Beschluss.
Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden Mitgliedern
unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied oder durch
einen Bevollmächtigten.
Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.
Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-
versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung
gefassten Beschlüsse.
Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
25368
Kapitel V. Generalversammlung
Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im
Mémorial und in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem ersten Donnerstag des Monats Mai um fünfzehn Uhr
nachmittags im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verschoben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftska-
pitals vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2000. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die
Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese
Zuführung ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit
Zustimmung des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat
Zwischendividenden ausschütten. Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige
Rücklagen zur Kapitalbildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Kapitel VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welche
unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Kapitel VIII. Allgemeines
Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, dass das gesamte Kapital wie
folgt gezeichnet wurde:
1. Die Aktien-Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., vorgenannt, sechshundertneunzehn Aktien ………… 619
2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt, eine Aktie……………………………………………
1
Total: sechshundertzwanzig Aktien ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 620
Sämtliche Aktien wurden in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreissigtausend
(31.000,-) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
Zu allen fiskalischen Zwecken hat das Stammkapital einen Gegenwert von einer Million zweihundertfünfzigtausend-
fünfhundertsechsunddreissig (1.250.536,-) Franken.
<i>Feststellungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend Franken
(50.000,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlung i>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf
einen.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
a) Herr Herbert März, vorgenannt;
b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r .l., vorgenannt;
c) Frau Rita Savitskaja, Kauffrau, wohnhaft zu B-4751 Burg-Reuland, Maldingen, 45.
25369
3. Die Generalversammlung bestimmt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren:
- Herr Herbert März, vorgenannt,
4. Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft vertreten wird durch die alleinige Unterschrift des
Vorsitzenden des Verwaltungsrates ohne finanzielle Beschränkung.
5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Herr Hermann-Josef Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft zu B-4784 St. Vith, Hinderhausen, 84;
6. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, handelnd in den vorerwähnten Eigenschaften, dem Notar
nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. März, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 16 mars 2000, vol. 602, fol. 52, case 11. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Siebenaler.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen auf stempelfreiem Papier zum Zwecke der Veröffent-
lichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Diekirch, den 12. April 2000.
F. Unsen.
(91072/234/142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2000.
RECKINGER PHILIPPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8824 Perle, 7, rue de la Poste.
R. C. Diekirch B 3.270.
—
<i>Assemblée générale de cession de partsi>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le six novembre.
Se sont réunis:
1. Monsieur Reckinger Philippe, demeurant Impasse Grand Rue, 4 à B-6630 Martelange;
2. Monsieur Dejana Francis, demeurant rue Monseigneur Louis Picard, 11 à B-6747 Saint Leger qui ont exposé ce qui
suit:
Monsieur Reckinger Philippe, préqualifié, associé unique de la société de droit luxembourgeois RECKINGER
PHILIPPE, S.à r.l., société à responsabilité limitée unipersonnelle avec siège à L-8824 Perle, rue de la Poste, 4, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch sous le numéro 3.270, cède et transporte sous toutes les garanties de
fait ou de droit les cent parts qu’il détient dans la société, soit la totalité du capital social à Monsieur Dejana Francis,
préqualifié pour la somme de quarante mille francs luxembourgeois payée par chèque dont quittance sous réserve
d’encaissement.
Le capital social est désormais réparti comme suit:
Dejana Francis …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100 parts/100
Ensuite, le nouvel associé unique, Monsieur Dejana Francis, préqualifié, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La démission de Monsieur Reckinger Philippe de son poste de gérant est acceptée avec décharge.
<i>Deuxième résolutioni>
Est appelé à la fonction de gérant Monsieur Dejana Francis préqualifié.
Fait est passé à Perle, date qu’en tête, en autant d’exemplaires que de parties distinctes.
P. Reckinger
F. Dejana
Enregistré à Luxembourg, le 6 avril 2000, vol. 535, fol. 49, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(91074/000/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 14 avril 2000.
BLN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 1H, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 3.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Diekirch, le 13 avril 2000, vol. 265, fol. 58, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 14 avril 2000.
COFINOR S.A.
Signature
(91075/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
25370
BLN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 1H, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 3.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 13 avril 2000, vol. 265, fol. 58, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 14 avril 2000.
COFINOR S.A.
Signature
(91076/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
BLN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 1H, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 3.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 13 avril 2000, vol. 265, fol. 58, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 14 avril 2000.
COFINOR S.A.
Signature
(91077/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
BLN, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 1H, rue de Drinklange.
R. C. Diekirch B 3.186.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 13 avril 2000, vol. 265, fol. 58, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 14 avril 2000.
COFINOR S.A.
Signature
(91078/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
HAFF, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Doennange.
R. C. Diekirch B 4.266.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associési>
<i>du 14 octobre 1999i>
Du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 14 octobre 1999, enregistré à Clervaux, le
16 mars 2000, vol. 208, fol. 21, case 1, il ressort que:
1. suite aux deux contrats de cession de parts du 31 août 1998,
enregistré à Clervaux, le 1
er
septembre 1998, vol. 206, fol. 64, case 10, et le 9 septembre 1998, vol. 206, fol. 66, case
8, et
suite au contrat de cession de parts du 16 décembre 1998,
enregistré à Clervaux, le 13 octobre 1999, vol. 207, fol. 70, case 6,
Monsieur Edouard Kremer, administrateur de sociétés, demeurant à L-9745 Doennange, Maison 85, est le
propriétaire de l’intégralité des 4 parts sociales de HAFF, S.à r.l.
2. l’assemblée a décidé d’accepter la démission des trois gérants administratifs:
– M. Nico Broers, Maison 79, L-9745 Doennange;
– M. Christian Schank, Maison 79, L-9745 Doennange;
– M. Romain Schank, Maison 79, L-9745 Doennange,
et que l’assemblée leur a donné décharge pour leur mandat passé.
3. l’assemblée a confirmé comme gérant unique de la société:
– M. Edouard Kremer, prénommé, qui engagera dorénavant la société par sa signature individuelle.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Weiswampach, le 12 avril 2000.
<i>Pour HAFF, S.à r.l.i>
FIDUNORD, S.à r.l.
Signature
(91081/667/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 17 avril 2000.
25371
DIABOIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare.
—
STATUTS
L’an deux mille, le trente et un mars.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Ont comparu:
1.- Monsieur Daniel Pirotte, exploitant forestier, demeurant à B-6983 Ortho, 1, Vieux Château (Belgique).
2.- Monsieur Patrick Vermeulen, tailleur de diamant, demeurant à B-2590 Berlaar, 55, Tarstorijstraat (Belgique),
ici représenté par Monsieur Daniel Pirotte, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée,
laquelle, paraphée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être
formalisée avec lui.
Lesquels comparants, agissant ès-dites qualités, ont requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif d’une
société anonyme qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
.- Dénomination, Siège, Objet, Durée
Art. 1
er
. Forme, Dénomination.
1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents
statuts.
1.2. La société adopte la dénomination DIABOIS S.A.
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi Wiltz. Le conseil d’administration est autorisé à changer l’adresse de la société à
l’intérieur de la commune du siège social statutaire.
2.2. La société peut également par décision du conseil d’administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg qu’à l’étranger, des filiales, agences ou succursales.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d’effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant
ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le
conseil d’administration.
Art. 3. Objet.
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commer-
ciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition de tous titres et droits par voie
de participation, d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat, de négociation et de toute autre manière
et notamment l’acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l’octroi aux entreprises auxquelles
elle s’intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement
quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet, sans vouloir bénéficier du régime fiscal particulier
organisé par la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés de participations financières.
3.2. La société a en outre pour objet:
- la prestation de services dans le domaine de l’exploitation forestière;
- la gestion et la mise en valeur d’un patrimoine mobilier et immobilier propre.
3.3. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou
indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l’accomplissement.
Art. 4. Durée.
4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises
pour une modification statutaire.
Titre II.- Capital
Art. 5. Capital social.
Le capital social souscrit est fixé à LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois),
divisé en 1.250 (mille deux cent cinquante) actions d’une valeur nominale de LUF 1.000,- (mille francs luxembourgeois)
chacune, libéré à raison de 25% (vingt-cinq pour cent).
Art. 6. Modification du capital social.
6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l’assemblée générale des
actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
6.2. La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 7. Versements.
Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques
et aux conditions que le conseil d’administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s’impute à parts
égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
Art. 8. Nature des actions.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire.
25372
Art. 9. Cession d’actions.
Il n’existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d’actions de la société.
Titre III.- Administration, Direction, Surveillance
Art. 10. Conseil d’administration.
10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
10.2. Les administrateurs seront nommés par l’assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six
ans. Il sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale.
10.3. En cas de vacance du poste d’un administrateur nommé par l’assemblée générale pour cause de décès, de
démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son rempla-
cement, à la majorité des votes, jusqu’à la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Art. 11. Réunions du conseil d’administration.
11.1. Le conseil d’administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé
par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d’empêchement du président, il sera remplacé par l’adminis-
trateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
11.2. Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.
11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou repré-
sentée. Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.
11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer
par écrit.
11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration sont signés par tous les membres présents aux
séances.
11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil diadministration ou par deux administrateurs.
Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d’administration.
Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l’assemblée générale.
Art. 13. Délégation de pouvoirs.
13.1. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens
le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.
13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblé générale.
13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.
Art. 14. Représentation de la société.
Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux
administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.
Art. 15. Commissaire aux comptes.
15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale.
15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l’assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six
années.
Titre IV.- Assemblée générale
Art. 16. Pouvoirs de l’assemblée générale.
16.1. L’assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des
affaires sociales.
16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Art. 17. Endroit et date de l’assemblée générale ordinaire.
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convo-
cations le deuxième jeudi du mois de juin à 18.00 heures.
Art. 18. Autres assemblées générales.
Le conseil d’administration ou le commissaire peut convoquer d’autres assemblées générales. Elles doivent être
convoquées sur la demande d’actionnaires représentant le cinquième du capital social.
Art. 19. Votes.
Chaque action donne droit à une voix.
Titre V.- Année sociale, Répartition des bénéfices
Art. 20. Année sociale.
20.1. L’année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
20.2. Le conseil d’administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la société, un mois au moins avant l’assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commen-
teront ces documents dans leur rapport.
Art. 21. Répartition de bénéfices.
21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix pour cent du capital social.
21.2. Après dotation à la réserve légale, l’assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des
bénéfices nets.
25373
21.3. Le conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
Titre VI.- Dissolution, Liquidation
Art. 22. Dissolution, Liquidation.
22.1. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que
celles prévues pour la modification des statuts.
22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s’effectuera par les soins d’un ou de plusieurs liquidateurs,
nommés par l’assemblée générale des actionnaires.
Titre VII.- Disposition générale
Art. 23. Disposition générale.
La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n’y a pas été dérogé
par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
A titre transitoire, le premier exercice social débute le jour de la constitution et prendra fin le 31 décembre 2000.
La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2001.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les 1.250 (mille deux
cent cinquante) actions comme suit:
1.- Monsieur Daniel Pirotte, six cent vingt-cinq actions ………………………………………………………………………………………………
625
2.- Monsieur Patrick Vermeulen, six cent vingt-cinq actions ……………………………………………………………………………………… 625
Total: mille deux cent cinquante actions …………………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes les actions ont été libérées à concurrence de 25% (vingt-cinq pour cent) par des versements en numéraire de
sorte que la somme de LUF 312.500,- (trois cent douze mille cinq cents francs luxembourgeois) se trouve dès à présent
à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent a la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à cinquante-cinq mille francs luxem-
bourgeois.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et immédiatement après la constitution de la société, les actionnaires, représentant l’intégralité du capital social et se
considérant dûment convoqués, se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
1.- L’adresse de la société est fixée au L-9540 Wiltz, 5, avenue de la Gare, Grand-Duché de Luxembourg.
2.- Sont appelés aux fonctions d’administrateur pour une durée de six ans, leur mandat expirant lors de l’assemblée
générale annuelle de 2005:
a) Monsieur Daniel Pirotte, exploitant forestier, demeurant à B-6983 Ortho, 1, Vieux Château (Belgique).
b) Monsieur Patrick Vermeulen, tailleur de diamant, demeurant à B-2590 Berlaar, 55, Tarstorijstraat (Belgique).
c) la société anonyme de droit luxembourgeois BUSINESS AGENCY LUXEMBOURG INTERNATIONAL S.A., ayant
son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert, représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Thierry
Hernalsteen, demeurant à L-9186 Stegen, 4, rue Medernacherstross.
3.- Est appelée aux fonctions de commissaire pour la même période:
la société anonyme BUSINESS IS BUSINESS S.A., ayant son siège social à L-9537 Wiltz, 98, rue Charles Lambert.
4.- L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la société
à un ou plusieurs de ses membres.
<i>Réunion du conseil d’administrationi>
Ensuite, les administrateurs préqualifiés, dont deux représentés comme dit, se sont réunis et ont décidé de nommer
Monsieur Daniel Pirotte et Monsieur Patrick Vermeulen, prénommés, comme administrateurs-délégués de la sociétés,
avec pouvoir d’engager la société sous leur signature individuelle.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: D. Pirotte, T. Hernalsteen J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 123S, fol. 64, case 1. – Reçu 12.500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 avril 2000.
J. Elvinger.
(91082/211/200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
25374
EUROLUX PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 4.118.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2000, vol. 265, fol. 60, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 avril 2000.
Signature.
(91091/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
LUXIMCO A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
—
STATUTEN
Im Jahre zweitausend, den zwanzigsten März.
Vor dem unterzeichneten Fernand Unsen, Notar mit dem Amtswohnsitz in Diekirch.
Sind erschienen:
1) Die Aktien-Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihren allein zeichnungsberechtigten Präsidenten des Verwaltungsrates Herrn Herbert März,
Kaufmann, in B-4791 Burg-Reuland, Maldingen, 45, wohnend;
2) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., mit Sitz in Weiswampach, 117, route de Stavelot,
hier vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer Herrn Herbert März, vorgenannt.
Diese Erschienenen, handelnd in ihren vorerwähnten Eigenschaften, ersuchen den Notar wie folgt die Satzungen einer
Aktiengesellschaft zu beurkunden:
Kapitel l. Benennung, Sitz, Gesellschaftszweck, Dauer
Art. 1. Unter der Bezeichnung LUXIMCO A.G. wird hiermit eine Aktiengesellschaft unter der Form einer Finanz-
beteiligungsgesellschaft (société de participations financières) gegründet.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Weiswampach.
Durch Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen, Zweigstellen, Agenturen und Büros sowohl im
Grossherzogtum Luxemburg, als auch im Ausland errichtet werden. Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesell-
schaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhn-
liche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorüber-
gehend und bis zur vollständigen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Diese
einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser
einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgisch bleibt. Die Bekanntmachung von einer derartigen
Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Geschäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Gesellschaft ist gegründet für eine unbestimmte Dauer.
Art. 4. Gegenstand der Gesellschaft ist der Import und der Export mit Waren aller Art, der Ankauf und der Verkauf
und die wirtschaftliche Verwertung von Immobilien, sowie jede andere Art von Tätigkeiten welche mit dem Gesell-
schaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängt oder ihn fördern kann.
Ausserdem die Beteiligungen auf jede Art und Weise an anderen luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften,
die Verwaltung, die Kontrolle und die Verwertung dieser Beteiligungen, der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf
andere Weise, sowie die Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere Weise von Wertpapieren, Verbin-
lichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die Verwaltung und Verwertung ihres
Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen
Gesellschaft beteiligen und ihnen alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien, oder auf andere Art an verbundene
Gesellschaften. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung geben an verbundene Gesellschaften. Sie
kann alle Kontrollen und Aufsichtsmassnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, beweglichen und unbeweg-
lichen, kommerziellen und industriellen Operationen machen, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung und Durch-
führung ihres Zweckes.
Kapitel II. Gesellschaftskapital, Aktien
Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf einunddreissigtausend (31.000,-) Euro, eingeteilt in sechshundert-
zwanzig (620) Aktien mit einem Nennwert von je fünfzig (50,-) Euro.
Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre mit Ausnahme der Aktien, für welche
das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.
An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien ausgestellt werden, nach Wahl der
Aktionäre.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann das Gesellschaftekapital erhöht oder erniedrigt werden.
Kapitel III. Verwaltung, Übertragung
Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern, welche
Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht. Sie werden ernannt für eine sechs Jahre nicht überschreitende Amtszeit,
durch die Generalversammlung der Aktionäre, welche dieselben zu jeder Zeit abberufen kann.
25375
Wird die Stelle eines Mitgliedes des Verwaltungsrates frei, so können die verbleibenden Mitglieder zusammen mit den
Kommissaren das frei gewordene Amt vorläufig besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat bestellt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden der von der Generalversammlung gewählt
wird. Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden übernimmt das vom Verwaltungsrat bestimmte Mitglied dessen
Aufgaben. Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern einberufen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
ein Verwaltungsratsmitglied jeweils nur einen Kollegen vertreten kann. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre
Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegrafisch oder per Telefax abgeben. Fernschreiben, Telegramme und Telefaxe
müssen schriftlich bestätigt werden. Ein schriftlich gefasster Beschluss der von allen Verwaltungsratsmitgliedern
genehmigt und unterschrieben ist, ist genauso rechtswirksam, wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster
Beschluss.
Art. 8. Die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates werden von den in den Sitzungen anwesenden
Mitgliedern unterschrieben. Die Beglaubigung von Abzügen oder Auszügen erfolgt durch ein Verwaltungsratsmitglied
oder durch einen Bevollmächtigten.
Art. 9. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Vollmachten versehen, um alle, mit dem Gesellschaftszweck
zusammenhängenden Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen.
Sämtliche Handlungen, welche nicht durch das Gesetz oder durch gegenwärtige Satzung ausdrücklich der General-
versammlung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.
Art. 10. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern oder Dritten, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen, seine
Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung übertragen. Die Übertragung an ein Mitglied des Verwaltungsrates bedarf der
vorhergehenden Ermächtigung durch die Generalversammlung.
Art. 11. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung
gefassten Beschlüsse.
Art. 12. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte
Kommissare überwacht, die ihre Zahl und ihre Vergütung festlegt. Die Dauer der Amtszeit der Kommissare wird von
der Generalversammlung festgelegt, sie darf jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
Kapitel V. Generalversammlung
Art. 13. Die Generalversammlung vertritt alle Aktionäre. Sie hat die weitestgehenden Vollmachten, um über die
Angelegenheiten der Gesellschaft zu befinden. Die Einberufung der Generalversammlung erfolgt gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes. Sollten die Aktionäre nicht bekannt sein, erfolgt die Einberufung durch Veröffentlichung im
Mémorial und in den geeigneten Tageszeitungen nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 14. Die jährliche Generalversammlung findet statt an jedem ersten Mittwoch des Monats Mai um vierzehn Uhr
nachmittags im Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.
Sollte dieser Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Arbeitstag
verschoben.
Art. 15. Der Verwaltungsrat oder der oder die Kommissare können eine ausserordentliche Generalversammlung
einberufen. Sie muss einberufen werden, falls Aktionäre, die mindestens zwanzig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals
vertreten, einen derartigen Antrag stellen.
Art. 16. Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
Kapitel VI. Geschäftsjahr, Verteilung des Reingewinnes
Art. 17. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreissigsten Dezember
eines jeden Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft
und endet am 31. Dezember 2000. Der Verwaltungsrat erstellt die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der
Verwaltungsrat legt den Kommissaren die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung mit einem Bericht über die
Geschäfte der Gesellschaft spätestens einen Monat vor der Jahresgeneralversammlung vor.
Art. 18. Der Bilanzüberschuss stellt nach Abzug der Unkosten und Abschreibungen den Nettogewinn der Gesell-
schaft dar. Von diesem Reingewinn werden fünf Prozent (5%) dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; diese Zuführung
ist nicht mehr zwingend wenn der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals darstellt. Mit Zustimmung
des Kommissars und unter Beachtung der diesbezüglichen Vorschriften kann der Verwaltungsrat Zwischendividenden
ausschütten. Die Generalversammlung kann beschliessen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapital-
bildung zu benutzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Kapitel VII. Auflösung, Liquidation
Art. 19. Die Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welche
unter den gleichen Bedingungen gefasst werden muss, wie die Satzungsänderungen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidationsverwalter durch-
geführt, die natürliche oder juristische Personen sind und die durch die Generalversammlung unter Festlegung ihrer
Aufgaben und Vergütung ernannt werden.
Kapitel VIII. Allgemeines
Art. 20. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung vorgesehen sind, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie dieses Gesetz umgeändert wurde, hingewiesen.
25376
<i>Zeichnung der Aktieni>
Nachdem die Satzung wie hiervor festgesetzt wurde, haben die Erschienenen erklärt, dass das gesamte Kapital wie
folgt gezeichnet wurde:
1. Die Aktien-Holdinggesellschaft MINT CONSULTING S.A., vorgenannt, sechshundertneunzehn Aktien ……
619
2. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt, eine Aktie………………………………………
1
Total: sechshundertzwanzig Aktien ……………………………………………………………………………………………………………………………………
620
Sämtliche Aktien wurden in bar einbezahlt, sodass der Gesellschaft ab heute die Summe von einunddreissigtausend
(31.000,-) Euro zur Verfügung steht, worüber dem Notar der Nachweis erbracht wurde.
Zu allen fiskalischen Zwecken hat das Stammkapital einen Gegenwert von einer Million zweihundertfünfzigtausend-
fünfhundertsechsunddreissig (1.250.536,-) Franken.
<i>Feststellungi>
Der amtierende Notar erklärt, dass die in Artikel 26 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesell-
schaften vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind, und bescheinigt dies ausdrücklich.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Abgaben, unter irgendwelcher Form, die der Gesellschaft
im Zusammenhang mit der Gründung erwachsen oder ihr auferlegt werden, beträgt ungefähr fünfzigtausend Franken
(50.000,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Erschienenen sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre, zu der sie sich
als ordentlich einberufen betrachten, zusammengefunden und einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird festgelegt auf drei; diejenige der Kommissare wird festgesetzt auf
einen.
2. Zu Verwaltungsratsmitgliedern werden ernannt für die Dauer von 6 Jahren:
a) Herr Herbert März, vorgenannt;
b) Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung U-BÜRO, S.à r.l., vorgenannt;
c) Frau Rita Savitskaja, Kauffrau, wohnhaft zu B-4751 Burg-Reuland, Maldingen, 45.
3. Die Generalversammlung bestimmt zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates für die Dauer von 6 Jahren:
- Herr Herbert März, vorgenannt.
4. Die Generalversammlung bestimmt, dass die Gesellschaft vertreten wird durch die alleinige Unterschrift des
Vorsitzenden des Verwaltungsrates ohne finanzielle Beschränkung.
5. Zum Kommissar wird ernannt für die Dauer von sechs Jahren:
Herr Hermann-Josef Lenz, Bilanzbuchhalter, wohnhaft zu B-4784 St. Vith, Hinderhausen, 84;
6. Der Gesellschaftssitz der Gesellschaft befindet sich in L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Diekirch, in der Amtsstube, Datum wie Eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles vorstehenden an den Komparenten, handelnd in den vorerwähnten Eigenschaften, dem Notar
nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige
Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: H. März, F. Unsen.
Enregistré à Diekirch, le 21 mars 2000, vol. 602, fol. 56, case 2. – Reçu 12.505 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): M. Felten.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Verlangen, auf stempelfreiem Papier, zum Zwecke der Veröf-
fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Diekirch, den 14. April 2000.
F. Unsen.
(91083/234/170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
DRAGON DE CHINE, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-9806 Hosingen, 13, rue Principale.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Fernand Unsen, notaire de résidence à Diekirch, en date du 15 mars 2000,
enregistré à Diekirch, le 16 mars 2000, vol. 602, fol. 53, case 2, que la société à responsabilité limitée unipersonnelle
DRAGON DE CHINE, S.à r.l., avec siège social à L-9806 Hosingen, 13, rue Principale, constituée par acte du notaire
instrumentaire en date du 15 avril 1998, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 463 du 26
juin 1998, a été dissoute avec effet à partir du 15 mars 2000.
Monsieur Jian-Xin Liu, cuisinier, unique associé de la société a pris à sa charge tout le passif de la société et a transféré
tous les actifs à son profit.
Il se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le passif social.
Pour extrait conforme, délivré à la demande de la société, sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 13 avril 2000.
F. Unsen.
(91084/234/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
25377
EUROLUX PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 4.118.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2000, vol. 265, fol. 60, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 avril 2000.
Signature.
(91085/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
EUROLUX PARTNERS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 4.118.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2000, vol. 265, fol. 60, case 5, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 avril 2000.
Signature.
(91086/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
SAHITI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 4.254.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2000, vol. 265, fol. 60, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 avril 2000.
Signature.
(91087/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
SAHITI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 4.254.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2000, vol. 265, fol. 60, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 avril 2000.
Signature.
(91088/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
MORGULES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 4.253.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2000, vol. 265, fol. 60, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 avril 2000.
Signature.
(91089/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
MORGULES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6555 Bollendorf-Pont, 1, route de Diekirch.
R. C. Diekirch B 4.253.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Diekirch, le 18 avril 2000, vol. 265, fol. 60, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Diekirch, le 18 avril 2000.
Signature.
(91090/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
25378
ETS. CLAUDE KREMER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9417 Vianden, 10, Impasse Kalchesbach.
R. C. Diekirch B 1.833.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 12 avril 2000, vol. 265, fol. 56, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(91092/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
ENGINEERING, CONSTRUCTION AND PROMOTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 53, avenue Kennedy.
R. C. Diekirch B 1.533.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 12 avril 2000, vol. 265, fol. 56, case 7, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(91093/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
LUX-GASTRONOMIE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9233 Diekirch, 77, avenue de la Gare.
R. C. Diekirch B 2.153.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 12 avril 2000, vol. 265, fol. 57, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(91094/561/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
ARENS-SCHEER S.A., Société Anonyme,
(anc. PATISSERIE-CONFISERIE NICOLAS).
Siège social: L-9240 Diekirch, 34A, Grand-rue.
R. C. Diekirch B 2.760.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Diekirch, le 12 avril 2000, vol. 265, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUCIAIRE CHARLES ENSCH
Signature
(91095/561/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 18 avril 2000.
NOUVELLE TERREST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5540 Remich, 36, rue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 60.878.
—
<i>Extrait des résolutions prises par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 mars 2000i>
1.) La démission de Madame Viviane Stockreiser, épouse Bauer, employée privée, demeurant à L-5441 Remerschen,
3, Aal Stross, est acceptée. Décharge lui a été donnée pour l’exercice de son mandat.
2.) Est nommé administrateur en remplacement de Madame Viviane Stockreiser, démissionnaire, Monsieur Christian
Hess, comptable, demeurant à L-4996 Schouweiler. Son mandat cessera lors de l’assemblée générale ordinaire statuant
sur les comptes annuels de l’exercice 2003.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Président de l’Assembléei>
<i>Générale Extraordinairei>
Enregistré à Grevenmacher, le 22 mars 2000, vol. 107, fol. 37, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(20730/745/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
25379
OFFICE CITY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1347 Luxembourg, 6, Circuit de la Foire Internationale.
R. C. Luxembourg B 67.279.
—
<i>Extrait de la décision circulaire du Conseil d’Administration du 7 avril 2000i>
Le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité de:
Augmenter le pouvoir de signature isolée de Monsieur Karl Richteritsch, administrateur-délégué de la société, sur le
compte courant de OFFICE CITY auprès de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A. de 50.000,- LUF à un
montant de 100.000,- LUF.
Luxembourg, le 10 avril 2000.
<i>Pour OFFICE CITYi>
Signature
<i>Un Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 65, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20732/250/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
OLEX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 63.469.
—
<i>Extrait du contrat de domiciliationi>
Parties:
Société domiciliée: OLEX, Société Anonyme, établie et ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de
Vianden.
Domiciliataire: Maître Jean Brucher et Maître Marc Seimetz, Avocats à la Cour, demeurant à L-2680 Luxembourg, 10,
rue de Vianden.
Durée: Indéterminée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
M
e
J. Brucher
<i>Agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20733/257/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
OLKY INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-3378 Livange, Centre d’Affaires «Le 2000».
R. C. Luxembourg B 63.975.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 27 mars 2000 que:
1) Messieurs Franck Rouayroux, Guy Antoine et Claude Cacheux sont nommés en qualité d’administrateurs de la
société OLKY INTERNATIONAL HOLDING S.A. en remplacement des sociétés LENDL FINANCE LTD, FILLIGAN
INC et DUSTIN INVEST INC.
2) Monsieur Franck Rouayroux est nommé en qualité d’administrateur-délégué de la société OLKY INTERNA-
TIONAL HOLDING S.A. en remplacement de la société FILLIGAN INC.
Luxembourg, le 27 mars 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 535, fol. 58, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20734/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
PFAFFEBRUCH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8260 Mamer, rue de Dangé St Romain.
R. C. Luxembourg B 37.351.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Capellen, le 23 novembre 1995, vol. 130, fol. 48, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Meyers
<i>Le Géranti>
(20742/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
25380
OSDI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 13.416.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28 mars 2000i>
Le Conseil a nommé M. Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041
Bertrange, en remplacement de Mme Louise Jastrow, administrateur décédé, sous réserve de ratification de sa
nomination par la prochaine assemblée générale. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur
décédé.
Pour copie conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20736/560/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 32.550.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28 mars 2000i>
Le Conseil a nommé M. Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041
Bertrange, en remplacement de Mme Louise Jastrow, administrateur décédé, sous réserve de ratification de sa
nomination par la prochaine assemblée générale. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur
décédé.
Pour copie conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20739/560/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
PARTOGEST, Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 22.090.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28 mars 2000i>
Le Conseil a nommé M. Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041
Bertrange, en remplacement de Mme Louise Jastrow, administrateur décédé, sous réserve de ratification de sa
nomination par la prochaine assemblée générale. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur
décédé.
Pour copie conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20740/560/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
PIGALI, Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 29.316.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration tenue le 28 mars 2000i>
Le Conseil a nommé IMMOLYS S.A., Société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Tony
Neuman, L-2241 Luxembourg, en remplacement de Mme Louise Jastrow, administrateur décédé, sous réserve de ratifi-
cation de sa nomination par la prochaine assemblée générale. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’adminis-
trateur décédé.
Pour copie conforme
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20744/560/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
25381
PERLMAR S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 38.897.
—
Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1998 portant sur la conversion du capital social des sociétés
commerciales en Euros, le Conseil d’Administration du 31 mars 2000 a procédé à la conversion du capital social en
Euros, de sorte que le capital social actuel de LUF 12.500.000,- est converti en EUR 309.866,91.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du 31
mars 2000 a également augmenté le capital social nouvellement exprimé en Euros, pour le porter du montant actuel de
EUR 309.866,91 à un montant de EUR 310.000,-. Cette augmentation du capital d’un montant de EUR 133,09 est réalisée
sans apports nouveaux et sans création de titres par incorporation au capital d’une somme prélevée sur les bénéfices
reportés.
Cette augmentation de capital porte ainsi la valeur nominale des actions à un montant de EUR 24,80.
En vertu des dispositions prévues à l’article premier de la loi du 10 décembre 1998, le Conseil d’Administration du 31
mars 2000 a également procédé à l’augmentation du capital autorisé nouvellement exprimé en Euros, de sorte que le
capital autorisé actuel de LUF 50.000.000,- est converti et porté à un montant de EUR 1.240.000,-.
En conséquence, le capital social de la société, nouvellement exprimé en Euros, est désormais fixé à un montant de
EUR 310.000,-, représenté par 12.500 actions d’une valeur nominale de EUR 24,80 chacune, entièrement libérées.
Luxembourg, le 6 avril 2000.
<i>Pour PERLMAR S.A.i>
CREGELUX
Crédit Général du Luxembourg
Société Anonyme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 67, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20741/029/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
PHARMA/wHEALTH MANAGEMENT COMPANY , S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 31, allée Scheffer.
R. C. Luxembourg B 47.176.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 66, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2000.
Signature.
(20743/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
PININFARINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 15.978.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 72, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
<i>Pour PININFARINA INTERNATIONAL S.Ai>.
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
(20745/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
PININFARINA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 15.978.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 4 avril 2000i>
Monsieur Adrien Schaus est renommé commissaire aux comptes pour une nouvelle période de 1 (un) an soit jusqu’à
l’Assemblée Générale Statutaire de l’an 2001.
Luxembourg, le 4 avril 2000.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PININFARINA INTERNATIONAL S.A.i>
FIDUCIAIRE MANACO S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 72, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20746/545/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
25382
PITO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 66.057.
—
The balance sheet as per December 31st, 1998, registered in Luxembourg, on April 12, 2000, vol. 535, fol. 67, case 1,
has been deposited at the registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
ALLOCATION OF RESULTS
- To be carried forward …………………………………………………………… USD (5,458.83)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, April 10, 2000.
Signature.
(20747/802/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
PLUTOS S.A.H., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 62.025.
—
<i>Extrait du contrat de domiciliationi>
Parties:
Société domiciliée: PLUTOS S.A.H., Société Anonyme Holding, établie et ayant son siège social à L-2680 Luxembourg,
10, rue de Vianden.
Domiciliataire: Maître Jean Brucher et Maître Marc Seimetz, Avocats à la Cour, demeurant à L-2680 Luxembourg, 10,
rue de Vianden.
Durée: Indéterminée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
M
e
J. Brucher
<i>Agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20748/257/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
P.O.P.Y. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 62.745.
—
<i>Assemblée Générale Extraordinaire du 6 avril 2000i>
Les actionnaires de la société P.O.P.Y. HOLDING S.A. se sont réunis en assemblée générale extraordinaire.
Il a été décidé ce qui suit:
1. Démission et décharge aux administrateurs Messieurs Patrick Laverny, Karl Guenard, et Norbert Schmitz.
2. Nomination aux fonctions d’administrateur en leur remplacement Madame Luiselle Moreschi, Mesdemoiselles
Angela Cinarelli et Sandrine Klusa.
3. Démission et décharge au commissaire aux comptes Monsieur François Sinner.
4. Nomination aux fonctions de commissaire aux comptes en son remplacement de QUEEN’S HOLDINGS LLC.
5. Transfert du siège social du 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg au 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
6. Divers.
Luxembourg, le 7 avril 2000.
<i>Pour P.O.P.Y. HOLDING S.A.i>
L.M.C. GROUP S.A.
Société Anonyme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 63, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20749/744/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
REACHIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 27.154.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535,
fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(20754/730/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
25383
REACHIM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 27.154.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 5 avril 2000i>
«5. L’assemblée accepte la démission de M. Suet en tant qu’administrateur et président du conseil avec effet au 28
octobre 1999 et lui donne entière décharge.
L’assemblée remercie M. Suet pour l’intérêt qu’il a manifesté au développement de la société.
L’assemblée accepte la démission de M. Jameson en tant qu’administrateur avec effet au 31 décembre 1999 et lui
donne entière décharge.
L’assemblée remercie M. Jameson pour l’intérêt qu’il a manifesté au développement de la société.
- L’assemblée ratifie la cooptation de:
- Monsieur David avec effet au 28 octobre 1999,
- Monsieur Jacob avec effet au 31 décembre 1999.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
7. L’assemblée renconduit le mandat du réviseur externe, la société ERNST & YOUNG, jusqu’à l’issue de l’assemblée
générale ordinaire d’avril 2001.
8. L’assemblée accepte la démission de MM. David et Jacob en tant qu’administrateurs de la société avec effet à ce
jour.
L’assemblée remercie MM. David et Jacob pour l’intérêt qu’ils ont manifesté au développement de la société.
L’assemblée nomme MM. Naisse et Baudron en tant qu’administrateurs en remplacement de MM. David et Jacob, à
effet immédiat.
Leur mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2004.
Par ailleurs, l’assemblée prend note que la société ELF AQUITAINE, administrateur, sera dorénavant, habituellement
représentée par Monsieur Castaigne.
A cette occasion, l’assemblée remercie Monsieur Degonse qui, auparavant, représentait habituellement la société ELF
AQUITAINE, pour l’intérêt qu’il a porté au développement de la société.»
<i>Pour la sociétéi>
C. Stiennon
<i>Directeur déléguéi>
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20755/730/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
P.B.I., PROCEDES ET BREVETS INDUSTRIELS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 6.128.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 28 mars 2000i>
Le conseil a nommé IMMOLYS S.A., Société Anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Tony
Neuman, L-2241 Luxembourg en remplacement de Madame Louise Jastrow, administrateur décédé, sous réserve de
ratification de sa nomination par la prochaine assemblée générale. Le nouvel administrateur terminera le mandat de
l’administrateur décédé.
Pour copie conforme
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20751/560/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
PRIME MULTIBOND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 40.997.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 8 février 2000, vol. 533, fol. 49, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 avril 2000.
<i>Pour PRIME MULTIBOND, SICAVi>
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société Anonyme
Signature
Signature
(20750/006/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
25384
PROMOLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4536 Differdange, 3, rue Dr. Nic Conzémius.
R. C. Luxembourg B 58.829.
—
<i>Résolutions de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 16 décembre 1999i>
Tous les actions étant représentées, et ont déclaré se considérer comme étant dûment convoquées et avoir eu parfai-
tement connaissance de l’ordre du jour:
1. Acceptation de la démission de M. Jacques Back et décharge à l’administrateur sortant.
2. Nomination d’un administrateur.
Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La démission de Monsieur Jacques Back de sa fonction d’administrateur est acceptée. Décharge est accordée à l’admi-
nistrateur sortant.
<i>Deuxième résolutioni>
Monsieur Christophe Noël, ingénieur, demeurant à Virton (B) est appelé aux fonctions d’administrateur, il continuera
le mandat de l’administrateur démissionnaire.
Differdange, le 16 décembre 1999.
Signature
Signature
Signature
<i>Le présidenti>
<i>Le scrutateuri>
<i>Le secrétairei>
Enregistré à Echternach, le 17 mars 2000, vol. 132, fol. 92, case 2. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J.M. Miny.
(20752/551/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
QUINTECH ENGINEERING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 41, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 53.243.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 31 mars 2000, vol. 535, fol. 28, case 8, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(20753/794/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY, Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54, boulevard Napoléon I
er
.
R. C. Luxembourg B 59.154.
Constituée sous l’empire du droit suisse en date du 7 décembre 1973, la société a transféré son siège social de Suisse
au Luxembourg par acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 12 mai 1997,
acte publié au Mémorial C, numéro 432 du 7 août 1997; les statuts ont été modifiés par acte reçu par le même
notaire en date du 14 décembre 1999, acte publié au Mémorial C, numéro 139 du 11 février 2000.
—
Le bilan au 31 décembre 1999, enregistré à Luxembourg, le 7 avril 2000, vol. 535, fol. 56, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANYi>
KPMG Financial Engineering
Signature
(20756/528/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
RENELUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 5, place de la Gare.
R. C. Luxembourg B 28.579.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535,
fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
(20759/730/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
25385
RED, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de Vianden.
R. C. Luxembourg B 49.655.
—
<i>Extrait du contrat de domiciliationi>
Parties:
Société domiciliée: RED, Société Anonyme Holding, établie et ayant son siège social à L-2680 Luxembourg, 10, rue de
Vianden.
Domiciliataire: Maître Jean Brucher et Maître Marc Seimetz, avocats à la Cour, demeurant à L-2680 Luxembourg, 10,
rue de Vianden.
Durée: indéterminée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 mars 2000.
M
e
J. Brucher
<i>L’agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20757/257/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
REDELCOVER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 36.055.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le mercredi 1i>
<i>eri>
<i>mars 2000i>
L’assemblée prend acte de la démission comme administrateur de Monsieur Gui de Vaucleroy avec effet au 1
er
juillet
1999. L’assemblée donne décharge à Monsieur Gui de Vaucleroy; en outre, l’assemblée décide de ne pas changer le
nombre des administrateurs et de ne pas nommer de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Gui
deVaucleroy à ce jour; une désignatiion ultérieure par l’assemblée ou par voie de cooptation des administrateurs étant
réservée.
L’assemblée reconduit les mandats des administrateurs, Madame Christine Hariga et Messieurs Pierre-Olivier
Beckers, Jean-Claude Coppieters’t Wallant, Michel Duchâteau, pour une durée d’un an, c’est-à-dire jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2001 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social se
terminant le 31 décembre 2000.
L’assemblée nomme DELOITTE & TOUCHE S.A. comme réviseur d’entreprises indépendant. Ce mandat viendra à
expiration à l’issue de l’assemblée générale à tenir en 2001 et qui aura à statuer sur les comptes de l’exercice social se
terminant le 31 décembre 2000.
Pour extrait sincère et conforme
Pour publication et réquisition
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 61, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20758/253/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
RMS EUROPE, RISK MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 32.134.
—
<i>Extrait des résolutions du conseil d’administration tenu par vote circulaire,i>
<i>en date du 1i>
<i>eri>
<i>octobre 1999 conformément à l’article 9 des statutsi>
«Le conseil prend note de la lettre de démission de WBK en tant qu’administrateur de la société, avec effet au 1
er
octobre 1999.
Le conseil remercie WBK pour l’intérêt que cette dernière a porté à la création et au développement de la société,
et ce dès son origine.
Le conseil décide de coopter Monsieur Frederick Gabriel en tant qu’administrateur de la société, en remplacement
de WBK. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.
Monsieur Jean-Pierre Biland est reconduit en tant que président du conseil d’administration jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire d’avril 2000.»
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20760/730/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
25386
RMS EUROPE, RISK MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 32.134.
—
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, enregistrés à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535,
fol. 68, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 13 avril 2000
<i>Pour la sociétéi>
F. Gabriel
(20761/730/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
RMS EUROPE, RISK MANAGEMENT SERVICES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 73, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 32.134.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue à Luxembourg le jeudi 6 avril 2000i>
«3. L’assemblée approuve le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1999, tels qu’ils ont été arrêtés
par le conseil d’administration.
L’assemblée affecte le montant de 594,- LUF en résultat reporté.
...
6. L’assemblée nomme Monsieur Arnaud Bierry, qui accepte, en tant que commissaire aux comptes de la société
jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 2001.
7. L’assemblée ratifie la cooptation de Monsieur Frederick Gabriel en tant qu’administrateur de la société. Son mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2005.
L’assemblée décide de nommer Monsieur André K. Gebauer en tant qu’administrateur de la société. Son mandat
viendra à échéance lors de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2005.
La société RM RISK MANAGEMENT AG et la société GECALUX sont reconduits en tant qu’administrateurs de la
société jusqu’à l’issue de l’assemblée générale statuant sur les comptes de 2005.»
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 avril 2000, vol. 535, fol. 68, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20762/730/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
ROBLING’S MALERWERKSTATT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6686 Mertert, 59E, route deWasserbillig.
R. C. Luxembourg B 33.667.
—
Les comptes annuels établis au 31 décembre 1997, enregistrés à Grevenmacher, le 22 mars 2000, vol. 167, fol. 36,
case 12, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
<i>Pour la société ROBLING’S MALERWERKSTATT, S.à r.l.i>
FIDUCIAIRE SOCOFISC S.A.
Signature
(20763/745/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
TRANSNATIONAL FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de de Vianden.
R. C. Luxembourg B 34.227.
—
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 15 janvier 1999:
- a ratifié la nomination en date du 17 février 1998 de Monsieur Marc Sunnen en tant qu’administrateur de la société
en remplacement de Monsieur Graham J. Wilson qui a démissionné. Monsieur Marc Sunnen a été nommé en tant qu’ad-
ministrateur pour une période de 5 ans, de sorte que son mandat prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle
de 2004;
- a nommé pour une durée de 5 ans Monsieur Gérard Decker, comptable, demeurant à Luxembourg, en tant que
commissaire aux comptes de la société en remplacement de GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A. Le
mandat de Monsieur Decker prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2004.
Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d’Administrationi>
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 36, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller
(20789/257/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
25387
TRANSNATIONAL FINANCIAL INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2680 Luxembourg, 10, rue de de Vianden.
R. C. Luxembourg B 34.227.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 3 avril 2000, vol. 535, fol. 36, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 avril 2000.
(20790/257/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
SAFIMMO, Société Anonyme.
Siège social: L-2241 Luxembourg, 4, rue Tony Neuman.
R. C. Luxembourg B 31.456.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration tenue le 28 mars 2000i>
Le conseil a nommé M. Marc Alain Jastrow, administrateur de sociétés, demeurant 208, rue des Romains, L-8041
Bertrange en remplacement de Mme Louise Jastrow, administrateur décédé, sous réserve de ratification de sa
nomination par la prochaine assemblée générale. Le nouvel administrateur terminera le mandat de l’administrateur
décédé.
Pour copie conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 10 avril 2000, vol. 535, fol. 58, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20764/560/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 60.686.
—
La société STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, SICAV, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg,
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 60.686 requiert Monsieur le préposé
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de procéder aux inscriptions des modifications suivantes:
d’effacer:
M. Alan Harden, administrateur qui a démissionné du conseil d’administration avec effet au 1
er
janvier
2000;
M. Joseph Edward Silva, administrateur qui a démissionné du conseil d’administration avec effet au 1
er
janvier 2000.
Le conseil d’administration se compose à présent comme suit:
Administrateurs:
M. William Gilson, administrateur, Luxembourg;
M. Toby Trotter, administrateur, STANDARD CHARTERED BANK (Singapore Branch);
M. Tak Kin Chan, administrateur, STANDARD CHARTERED BANK (Singapore Branch).
<i>Pour la sociétéi>
<i>STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, SICAVi>
G. Meis
<i>Head of compliance and legali>
Enregistré à Luxembourg, le 11 avril 2000, vol. 535, fol. 63, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(20779/000/24) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 avril 2000.
LAMESCH EXPLOITATION S.A.,
JEAN LAMESCH EXPLOITATION, Société Anonyme.
Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Wolser Nord.
R. C. Luxembourg B 23.555.
—
Les actionnaires sont invités à assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra le <i>16 août 2000 i>à 15.00 heures à Luxembourg, 32, boulevard Joseph II, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:
25388
<i>Ordre du jour:i>
1. Augmentation du capital social d’un montant de deux cent soixante-six millions cinq cent soixante-quatorze mille
six cent cinquante (266.574.650,-) francs, pour le porter de son montant actuel de vingt-deux millions
(22.000.000,-) de francs, à deux cent quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-quatorze mille six cent cinquante
(286.574.650,-) francs, par incorporation au capital d’un montant de deux cent soixante-six millions cinq cent
soixante-quatorze mille six cent cinquante (266.574.650,-) francs à prélever sur la prime de fusion à concurrence
de quatre-vingts millions dix mille cent dix (80.010.110,-) francs, et sur les réserves libres à concurrence de cent
quatre-vingt-six millions cinq cent soixante-quatre mille cinq cent quarante (186.564.540,-) francs le nombre
d’actions restant inchangé à mille six cents (1.600) et la valeur nominale des actions étant abrogée.
2. Conversion de la monnaie d’expression du capital social de francs luxembourgeois en Euro, pour fixer le capital
social à sept millions cent quatre mille (7.104.000,-) Euro, représenté par mille six cents (1.600) actions sans désig-
nation de valeur nominale.
3. Modification afférente de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Le capital souscrit est fixé à sept millions cent quatre mille (7.104.000,-) Euro, représenté par mille six
cents (1.600) actions sans désignation de valeur nominale.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l’Assemblée Générale des
actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.»
Les propriétaires de titres au porteur devront en effectuer le dépôt au siège social de la société.
I (03439/226/31)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 21.278.
—
Notice is hereby given that an
EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
will be held at the registered office of ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND («the Corporation») on
Wednesday, <i>August 9, 2000 i>at 11.00 a.m. in order to resolve about the following proposed amendments to the Articles
of Incorporation of the Corporation:
<i>Agenda:i>
Amendments to the Articles of Incorporation, including:
(i) an amendment to the first paragraph of article III section 2 of the Articles of Incorporation so as to read as follows:
«Shares may be issued in unlimited number at such time, under such conditions, and for such consideration not
less than the equivalent of the net asset value per share thereof, as may be determined from time to time by the
Board of Directors, consistent with the terms of these Articles of Incorporation without the necessity for any
action by the shareholders and without the existence in the current shareholders at the time of a preferential
right to subscribe for the shares to be issued.»
(ii) an amendment to the second sentence of the second paragraph of article III section 12 of the Articles of Incor-
poration so as to read as follows:
«The repurchase price shall be equal to the equivalent of the net asset value as determined in accordance with
the provisions of Section 13 of this Article III.» and
(iii) an amendment to the section 13 of article III in order to add at the end of this section the following paragraph:
«For the purpose of calculating the issue and repurchase price, such net asset value may be converted into such
currencies as the sales documents of the Corporation shall provide.»
Shareholders are advised that a quorum of fifty per cent of the shares outstanding of the Corporation is required and
the resolution must be carried by a majority of two thirds of the shares represented at the meeting. If the quorum is not
reached, the meeting will be reconvened to be held on Thursday, September 14, 2000.
In order to be valid for this meeting, proxy forms should reach the offices of the Corporation at the close of business
on the day prior to the general meeting.
I (03462/801/33)
<i>By order of the Board of Directors.i>
INTEREUREKA, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 61.004.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
reportée des actionnaires qui se tiendra le <i>9 août 2000 i>à 11.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer sur
l’ordre du jour suivant:
25389
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes
4. Nominations statutaires
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l’article 100 de la loi du 10 août
1915
6. Divers
I (03467/788/19)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
MURRAY UNIVERSAL , SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 8.621.
—
The
ANNUAL GENERAL MEETING
of shareholders of MURRAY UNIVERSAL, SICAV wil be held at its registered office in Luxembourg, 50, avenue J. F.
Kennedy on <i>11 August 2000 i>at 3.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. To hear the Management Report of the Directors and the Report of the Auditor.
2. To approve the Statement of Net Assets and the Statement of Changes in Net Assets for the year ended 31 March
2000 and to consider declaration for the various sub-funds.
3. To discharge the Directors with respect to the performance of their duties during the year ended 31 March 2000.
4. To elect the Directors to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
5. To elect the Auditor to serve until the next Annual General Meeting of shareholders.
6. Any other business.
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken at the majority of the shares present or represented at the meeting.
In order to take part at the statutory meeting of 11 August 2000, owners of bearer shares in Japan Portfolio will have
to deposit their shares five clear days before the meeting at the registered office of the Company, 50, avenue J. F.
Kennedy, Luxembourg, or with the following banks:
-
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, Luxembourg;
-
CLYDESDALE BANK LIMITED, 30, Lombard Street, London.
Owners of bearer shares in Pacific Portfolio will have to deposit their shares five clear days before the meeting at the
registered office of the Company, 50, avenue J. F. Kennedy, Luxembourg, or with the following bank:
-
BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy, Luxembourg.
I (03468/755/29)
<i>The Board of Directors.i>
MLB(S) SPECIALTY PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 55.104.
—
Shareholders of MLB(S) SPECIALTY PORTFOLIOS are hereby kindly invited to attend a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of Shareholders to be held at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, at 11.30 a.m. on <i>August 25, 2000 i>with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of Article 20, fifth paragraph, of the Articles of Incorporation, in order to allow the conversion of
Shares from one category to another category of the same class or of another class, under the circumstances as
may from time to time be determined by the Board of Directors and as disclosed in the prospectus.
This change is needed to allow a conversion facility to certain participants in the MERRILL LYNCH GLOBAL
FUNDS ADVISOR Program in accordance with the terms and conditions of such program.
2. Amendment of Article 21, last paragraph, of the Articles of Incorporation, in order to delete the reference to the
principle of contagion.
3. Miscellaneous.
The quorum required by law not having been reached at a First Extraordinary General Meeting of Shareholders held
on July 12, 2000, the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders shall validly vote on the points of the
agenda, whatever the portion of the share capital of the Company present or represented at such Meeting. The items
on the agenda shall be passed at a two-thirds majority of the shares present or represented at the Meeting and voting.
Proxies should be sent to DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., at its address above to the
attention of Mr Koster no later than August 23, 2000.
The draft text of restated Articles of Incorporation after amendment is available on request at the Registered Office
of the Company.
I (03492/584/28)
<i>The Board of Directors.i>
25390
MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.440.
—
Shareholders of MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS are hereby convened to attend a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to be held at the offices of DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, at 11.30 a.m. on <i>August 25, 2000 i>with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of Article 20, fifth paragraph, of the Articles of Incorporation, in order to allow the conversion of
Shares from one category to another category of the same class or of another class, under the circumstances as
may from time to time be determined by the Board of Directors and as disclosed in the prospectus.
This change is needed to allow a conversion facility to certain participants in the MERRILL LYNCH GLOBAL
FUNDS ADVISOR PROGRAM in accordance with the terms and conditions of such program.
2. Amendment of Article 21, last paragraph, of the Articles of Incorporation, in order to delete the reference to the
principle of contagion.
3. Amendment of Article 15, sub-section (i), of the Articles of Incorporation, in order to replace the reference to
«European Economic Community» by «European Union».
4. Miscellaneous.
The quorum required by law not having been reached at a First Extraordinary General Meeting of Shareholders held
on July 12, 2000, the Second Extraordinary General Meeting of Shareholders shall validly vote on the points of the
agenda, whatever the portion of the share capital of the Company present or represented at such Meeting. The items
on the agenda shall be passed at a two-thirds majority of the shares present or represented at the Meeting and voting.
Proxies should be sent to DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., at its address above to the
attention of M. Koster no later than August 23, 2000.
The draft text of restated Articles of Incorporation after amendment is available on request at the Registered Office
of the Company.
I (03493/584/30)
<i>The Board of Directors.i>
VINALUC S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 58.023.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 août 2000 i>à 15.00 heures, au siège social, avec l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d’Administration et rapport du Commissaire.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 juin 2000.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire.
4. Réélection des administrateurs et du commissaire.
5. Divers.
Il (03043/660/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
KEGWORTH S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 64.781.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra exceptionnellement le <i>1i>
<i>eri>
<i>août 2000 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
Il (03417/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
25391
VIBORA S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 64.797.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra exceptionnellement le <i>1i>
<i>eri>
<i>août 2000 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
Il (03418/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ZONDOR S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, boulevard Dr. Charles Marx.
R. C. Luxembourg B 64.891.
—
Messieurs les actionnaires sont priés d’assister à
l’ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
des actionnaires qui se tiendra exceptionnellement le <i>1i>
<i>eri>
<i>août 2000 i>à 15.00 heures au siège social à Luxembourg pour
délibérer sur l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et affectation des résultats au 31 décembre 1999.
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.
lI (03419/788/16)
<i>Le Conseil d’Administration.i>
ZURICH INVEST (LUX), Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 47, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 66.913.
—
The Shareholders of ZURICH INVEST (LUX) (the «Fund») are hereby kindly invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Fund, which will take place at the registered office of STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., 47, boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, on <i>31 July 2000 i>at 10.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the reports of the Board of Directors and of the Auditor.
2. Approval of the balance sheet, profit and loss accounts as of 31 March 2000 and the allocation of the net profits.
3. Discharge to be granted to the Directors for the financial year ended 31 March 2000.
4. Action on the election of Gerard Fischer, Paul J. Elmlinger, Markus Hongler, Thomas Van Ditzhuyzen as Directors
and election of the Auditor for the ensuing year.
5. Any other business which may be properly brought before the meeting.
The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required, and that the decisions will be
taken at the majority vote of the shares present or represented at the Meeting. Each share is entitled to one vote. A
shareholder may act at the Meeting by proxy.
Shareholders who will not be able to attend the annual general meeting may be represented by power of proxy, the
form of which is available at the registered office of the Fund. The form should be duly filled in and sent back to the
registered office of the Fund until at the latest the bank business day in Luxembourg preceding the annual general
meeting.
Il (03453/755/25)
<i>On behalf of the Board of Directors.i>
25392
S O M M A I R E
SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND
DINVEST S.A.
DINVEST TWO
LOMBARD ODIER INVEST
LOMBARD ODIER INVEST
FIDUCIAIRE INTERREGIONALE S.A.
LAKIMAR
FEL S.A.
LA PYRAMIDE
BTK-LUX A.G.
WOOD & FOREST
REISDORFF INVEST S.A.
SCHREINEREI ARNOLD BECKER
SUPERMARCHE MASSEN S.A.
RIAL
ETABLISSEMENT MASSEN S.A.
IMMOBILIERE DE SOROZEE S.A.
LG2 ENGINEERING S.A.
TRANSPORTE HAMMES S.A.
LOCA-NORD S.A.
MENUISERIE RECKINGER
COMMUNAUTE D’EXPLOITATION AGRICOLE TRIERWEILER-WEBER
MUSIRENT-LUX
CREUTZ & PARTNERS
LUXEMBURGER AGRARHANDEL
CAMPING NEUMÜHLE/ERMSDORF
DR. H.BIMBES A.G.
RECKINGER PHILIPPE
BLN
BLN
BLN
BLN
HAFF
DIABOIS S.A.
EUROLUX PARTNERS S.A.
LUXIMCO A.G.
DRAGON DE CHINE
EUROLUX PARTNERS S.A.
EUROLUX PARTNERS S.A.
SAHITI S.A.
SAHITI S.A.
MORGULES S.A.
MORGULES S.A.
ETS. CLAUDE KREMER
ENGINEERING
LUX-GASTRONOMIE
ARENS-SCHEER S.A.
NOUVELLE TERREST S.A.
OFFICE CITY S.A.
OLEX S.A.
OLKY INTERNATIONAL HOLDING S.A.
PFAFFEBRUCH
OSDI S.A.
PARTICIPATIONS FINANCIERES EUROPEENNES S.A.
PARTOGEST
PIGALI
PERLMAR S.A.
PHARMA/wHEALTH MANAGEMENT COMPANY
PININFARINA INTERNATIONAL S.A.
PININFARINA INTERNATIONAL S.A.
PITO HOLDING S.A.
PLUTOS S.A.H.
P.O.P.Y. HOLDING S.A.
REACHIM S.A.
REACHIM S.A.
P.B.I.
PRIME MULTIBOND
PROMOLUX S.A.
QUINTECH ENGINEERING S.A.
RECORDATI S.A. CHEMICAL AND PHARMACEUTICAL COMPANY
RENELUX S.A.
RED
REDELCOVER S.A.
RMS EUROPE
RMS EUROPE
RMS EUROPE
ROBLING’S MALERWERKSTATT
TRANSNATIONAL FINANCIAL INVESTMENTS S.A.
TRANSNATIONAL FINANCIAL INVESTMENTS S.A.
SAFIMMO
STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND
LAMESCH EXPLOITATION S.A.
ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND
INTEREUREKA
MURRAY UNIVERSAL
MLB S SPECIALTY PORTFOLIOS
MLB S LUX INTERNATIONAL PORTFOLIOS
VINALUC S.A.
KEGWORTH S.A.
VIBORA S.A.
ZONDOR S.A.
ZURICH INVEST LUX