This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
10129
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 212
17 mars 2000
S O M M A I R E
AOL Europe S.A., Luxembourg………………………
page
10130
(The) Carousel Picture Company S.A., Uebersyren
10172
(La) Civette, S.à r.l., Luxembourg…………………………………
10152
(The) Establishment Trust, Sicav, Luxembourg ……
10172
Labora, S.à r.l., Steinsel………………………………………………………
10130
Landesbank Rheinland-Pfalz International S.A.,
Luxemburg …………………………………………………………………………
10152
Lasheid S.A., Luxembourg ………………………………………………
10153
LIM Investment S.A., Luxembourg………………
10155
,
10157
Linster High Tech S.A., Luxembourg …………………………
10154
Lion Oblilux, Luxembourg ………………………………………………
10155
Lophira S.A., Luxembourg ………………………………………………
10157
Lucarvest S.A., Luxembourg……………………………………………
10157
Lunatik, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
10158
Luxomatique S.A., Luxembourg ……………………………………
10158
Lux Orga, S.à r.l., Itzig ………………………………………………………
10158
Lycoop S.A., Luxembourg…………………………………………………
10160
Magali S.A., Luxembourg …………………………………………………
10163
Magepar S.A., Weiswampach …………………………
10158
,
10160
Mandelo S.A., Luxembourg………………………………………………
10162
Manulife Global Fund, Sicav, Luxembourg ………………
10163
Mariucci Frères, S.à r.l., Bettembourg ………
10160
,
10161
Masco Corporation Europe, S.à r.l., Kopstal
10161
,
10162
Mauna International, S.à r.l., Luxembourg ………………
10163
Mersch & Schmitz, Equipements Techniques du
Bâtiment, S.à r.l., Holzem ……………………………………………
10129
Soceurimmo S.A., Luxembourg ……………………………………
10163
Société Civile Immobilière Hinh, Luxembourg………
10164
Société Méditerranéenne de Conseils S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
10164
Sovalim, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
10164
(La) Sphera S.A., Luxembourg ………………………
10154
,
10155
Tandil S.A., Luxembourg …………………………………………………
10165
Tasku Immobilière S.A., Luxemburg …………………………
10165
Tavy S.A., Luxembourg………………………………………………………
10166
Ter-Prom, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………
10166
Terry S.A., Luxembourg ……………………………………………………
10166
T.G.E. S.A., Luxembourg……………………………………………………
10164
Thamaniah S.A., Luxembourg ………………………………………
10170
Themuse S.A., Luxembourg ……………………………………………
10172
Tobo Holding S.A., Luxembourg …………………………………
10173
Toiture Plus, S.à r.l., Ehlerange ……………………
10170
,
10171
TradeArbed Export (Luxembourg) S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………
10166
,
10170
Transmoselle, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
10173
Turicum Luxembourg S.A., Luxembourg …………………
10172
Turn, Page & Wise S.A., Luxembourg ………………………
10174
Usine Aluminium S.A., Luxembourg …………………………
10173
U.S. International S.A., Luxembourg …………………………
10174
Utopia S.A., Luxembourg …………………………………
10174
,
10176
Vank-Immo, S.à r.l., Luxembourg …………………………………
10176
Van Kasteren Services, S.à r.l., Luxembourg …………
10176
Yard S.A., Luxembourg………………………………………………………
10165
MERSCH & SCHMITZ, EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU BATIMENT, S.à r.l.,
Société à responsabilité limitée.
Siège social: Holzem.
R. C. Luxembourg B 13.549.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MERSCH & SCHMITZ,i>
<i>EQUIPEMENTS TECHNIQUES DU BATIMENT, S.à r.l.i>
J. Reuter
(03940/517/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LABORA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7317 Steinsel, 6, rue Paul Eyschen.
R. C. Luxembourg B 49.202.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. LABORAi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(03903/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
AOL EUROPE S.A., Aktiengesellschaft.
Registered office: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-second of December.
Before Us, Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg.
Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of AOL EUROPE S.A., a société anonyme, having its
registered office at L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden, incorporated pursuant to a deed of the under-
signed notary on the 16 December 1999, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
«Company»).
The meeting was opened at 6.30 p.m. with Mr Guy Harles, attorney-at-law, residing in Luxembourg, in the Chair,
who appointed as secretary Mr Marc Feider, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Pierre Beissel, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Increase of the share capital up to EUR 250,031,000.- (two hundred fifty million and thirty one thousand Euros), by
the issue of 100,000,000 (one hundred million) Ordinary B Shares and 100,000,000 (one hundred million) Preferred
Shares;
2. Reduction of the share capital from EUR 250,031,000.- (two hundred fifty million thirty-one thousand Euros) to
EUR 250,000,000.- (two hundred fifty million Euros) by cancellation of 24,800 (twenty-four thousand eight hundred)
own shares held by the Company;
3. Restatement of the articles of incorporation of the Company, which will be part of the present notarial deed.
II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the
represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, initialled ne varietur by the appearing parties will also remain annexed
to the present deed.
Ill. That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and all the shareholders
present or represented declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting,
no convening notices were necessary.
IV. That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items of the agenda.
Then the general meeting after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to increase the share capital from EUR 31,000.- (thirty-one thousand Euros) to EUR
250,031,000.- (two hundred fifty million thirty-one thousand Euros), by the issue of 100,000,000 (one hundred million)
Ordinary B Shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) and 100,000,000 (one hundred million)
Preferred Shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents).
The new shares are subscribed as follows:
- 100,000,000 (one hundred million) Preferred Shares by AOL LUXEMBOURG, S.à r.l., a company existing under the
laws of Luxembourg, having its registered office at rue Richard Coudenhove-Kalergi, B.P. 780, L-2017 Luxembourg, here
represented by Mr Marc Feider, previously named, by virtue of a proxy hereto attached, at a total issue price of EUR
269,036,000.- (two hundred sixty-nine million thirty-six thousand Euros);
The shares so subscribed are fully paid up, by a contribution in kind consisting of
- 42 (forty-two) shares of AOL FINANCE B.V., a company incorporated and existing under the laws of the Nether-
lands;
- 1 (one) share of CompuServe INTERACTIVE SERVICES SCHWEIZ, GmbH, a company incorporated and existing
under the laws of Switzerland;
- 40 (forty) shares of AMERICA ONLINE HOLDING B.V., a company incorporated and existing under the laws of the
Netherlands;
10130
- 631 (six hundred thirty-one) convertible preference shares of AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l, a company
incorporated and existing under the laws of Luxembourg;
- 135,789 (one hundred thirty-five thousand seven hundred eighty-nine) category A shares of AOL PARTICIPA-
TIONS II, S.à r.l., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg;
- 12,400 (twelve thousand four hundred) shares of the Company, for which the amount of EUR 15,500.- (fifteen
thousand five hundred Euros) is allocated;
- a cash amount of EUR 105,000.- (one hundred five thousand Euros);
- an intercompany advance of EUR 107,500.- (one hundred and seven thousand five hundred Euros) granted to AOL
LUXEMBOURG, S.à r.l. such contribution being all the assets and liabilities of AOL LUXEMBOURG, S.à r.l.
- 59,260,689 (fifty-nine million two hundred sixty thousand six hundred eighty-nine) Ordinary B Shares by CYBER FIN
S.A., a company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1543 Luxembourg, 45, boulevard
Pierre Frieden, here represented by Mr Guy Harles, previously named, by virtue of a proxy attached hereto, at a total
issue price of EUR 129,118,562.- (one hundred twenty-nine million one hundred eighteen thousand five hundred sixty-
two Euros).
The shares so subscribed are fully paid up, by a contribution in kind consisting of
- 1 (one) share of CompuServe INTERACTIVE SERVICES SCHWEIZ, GmbH, a company incorporated and existing
under the laws of Switzerland, for which 4.000.000 (four million) Ordinary B Shares of the Company are allocated,
numbered from 1 (one) to 4,000,000 (four million);
- 400 (four hundred) shares of BERTELSMANN STORE B.V., a company incorporated and existing under the laws of
the Netherlands, for which 5,300,000 (five million three hundred thousand) Ordinary B Shares of the Company are
allocated, numbered from 4,000,001 (four million one) to 9,300,000 (nine million three hundred thousand);
- 631 (six hundred thirty-one) shares of AOL PARTICIPATIONS I, S.à r.l., a company incorporated and existing under
the laws of Luxembourg, for which 6,800,000 (six million eight hundred thousand) Ordinary B Shares of the Company
are allocated, numbered from 9.300.001 (nine million three hundred thousand one) to 16,100,000 (sixteen million one
hundred thousand);
- 40,002 (forty thousand and two) shares of CYBER FIN UK S.A., a company incorporated and existing under the laws
of Luxembourg, for which 14,900,000 (fourteen million nine hundred thousand) Ordinary B Shares of the Company are
allocated, numbered from 16,000,001 (sixteen million and one) to 31,000,000 (thirty-one million);
- 12,400 (twelve thousand and four hundred) shares of the Company, for which the amount of EUR 15,500.- (fifteen
thousand five hundred Euros) is allocated;
- a non interest-bearing unsecured subordinated loan note with a nominal value of USD 89,376,000.- (eighty-nine
million three hundred and seventy-six thousand U.S. dollars) due 30 January 2018 issued by CompuServe INTERACTIVE
SERVICES LIMITED (formerly OAKRAIN LIMITED), a company incorporated and existing under the laws of Ireland, for
which 28,260,689 (twenty-eight million two hundred sixty thousand six hundred eighty-nine) Ordinary B Shares of the
Company are allocated, numbered from 31,000,001 (thirty one million one) to 59,260,689 (fifty-nine million two
hundred sixty thousand six hundred eighty-nine);
- a cash amount of EUR 55,998.- (fifty-five thousand nine hundred ninety-eight Euros);
- a liability due to incorporation expenses in the amount of EUR 1,763.- (one thousand seven hundred sixty-three
Euros).
Such contribution being all the assets and liabilities of CYBER FIN S.A.
- 40,739,311 (forty million seven hundred thirty-nine thousand three hundred and eleven) Ordinary B Shares by NET
FIN S.A., a company existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1543 Luxembourg, 45,
boulevard Pierre Frieden, here represented by Mr Guy Harles, previously named, by virtue of a proxy attached hereto,
at a total price of EUR 63,989,952.- (sixty-three million nine hundred eighty-nine thousand nine hundred fifty-two
Euros).
The shares so subscribed are fully paid up, by a contribution in kind consisting of
- all the shares of BERTELSMANN ONLINE VERWALTUNGS, GmbH (renamed to NET FIN ONLINE VERWAL-
TUNGS, GmbH by resolution dated 25 November 1999), a company existing under the laws of Germany and having its
registered office in Guterslob, Germany, for which 40,739,311 (forty million seven hundred thirty-nine thousand three
hundred eleven) Ordinary B Shares of the Company are allocated, numbered from 59,260,690 (fifty-nine million two
hundred sixty thousand six hundred ninety) to 100,000,000 (one hundred million).
Such contribution is made in accordance with the European Merger directive of 23 July 1990, which allows for the tax
neutral transfer of the shares of German companies by way of a combination of book-values under § 23(4) Umwand-
lungssteuergesetz and § 26(2) Umwandlungssteuergesetz. At the moment of transfer, the book value of the German
shares for taxation purposes amounts to DEM 125,048,705.55 (one hundred twenty-five million forty-eight thousand
seven hundred and five Deutschmarks fifty-five Pfennig). Any modifications of such value due to audits shall be adapted
through the company’s reserves. The so contributed shares of German companies shall exclusively be transferred tax
neutrally within the European Union during the seven (7) years following the date of contribution under § 26(2)
Umwandlungssteuergesetz. Any transfer shall require the prior specific and written consent of the shareholder
BERTELSMANN ONLINE BETEILIGUNGS, GmbH;
- a cash amount of EUR 55,327 (fifty-five thousand three hundred twenty-seven Euros);
- a liability due to incorporation expenses in the amount of EUR 1,763.- (one thousand seven hundred sixty-three
Euros).
Such contribution being all the assets and liabilities of NET FIN S.A. The value of this contribution has been described
by a report of H.R.T. REVISION, S.à r.l., réviseurs d’entreprises in Luxembourg, dated 22th December 1999.
10131
The conclusion of this report is the following:
«Based on the work peiformed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-
bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to 200,000,000 shares of nominal value EUR 1.25
each to be issued, increased by a share premium of EUR 212,144,514.-»
This report will remain annexed to the present deed.
The proof of the documentation of the subscription has been given to the undersigned notary, who expressly
acknowledges it.
The total contribution of EUR 462,144,514.- (four hundred sixty-two million one hundred forty-four thousand five
hundred and fourteen Euros), made as provided for hereabove and so accepted by the meeting, consists of EUR
250,000,000.- (two hundred fifty million Euros) allocated to the capital, a cash distribution of EUR 31,000.- (thirty-one
thousand Euros) and EUR 212,144,514.- (two hundred and twelve million one hundred forty-four thousand five hundred
and fourteen Euros) allocated to the issue premium.
As the contribution in kind consists of all the assets and liabilities of a Company of the European Community, all the
conditions as set forth by Article 4-1 of the Law of December 29, 1971, as amended, are met in order to exempt the
above contribution from the capital contribution duty.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to reduce the share capital from from EUR 250,031,000.- (two hundred fifty million thirty-one
thousand Euros) to EUR 250,000,000.- (two hundred fifty million Euros) by cancellation of 24,800 (twenty-four thousand
eight hundred) own shares with a par value of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) held by the Company.
The product of this capital reduction shall not be distributed and shall be booked into the reserves of the Company.
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to restate the articles of incorporation of the company, in replacement of the existing articles of
incorporation.
Name - Registered office - Duration - Object
Art. 1. Name
There exists a joint stock corporation (société anonyme) under the name of AOL EUROPE S.A. (hereafter «the
Company»).
Art. 2. Registered Office
2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. It may be transferred to any other
place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the General Meeting of Shareholders deliberating in the
manner provided for amendments to the Articles.
The address of the registered office may be transferred within the town limits of the City of Luxembourg by simple
resolution of the Board of Directors.
2.2 blank
2.3 If extraordinary events of political, economic or social nature likely to impair the normal activity at the registered
office or the easy communication between that office and foreign countries shall occur, or shall be imminent, the
registered office may be provisionally transferred abroad until such time as circumstances have completely returned to
normal. Such a transfer will, however, have no effect on the nationality of the Company which shall remain a Luxem-
bourg company. The declaration of the provisional transfer abroad of the registered office will be made and brought to
the attention of third parties by the officer of the Company best placed to do so in the circumstances.
Art. 3. Duration
The Company is formed for an unlimited duration.
Art. 4. Objects
4.1. The object of the Company is to carry out the business of providing online and other interactive and related
services, all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations or the making of investments
in any company or enterprise in any form whatsoever, that will provide online and other interactive and related services,
and the administration, management, control and development of those participations; such activities to include, without
limitation, the assessment, supervision and control of business operations and financial data and information and the
preparation of reports and analysis to the Company’s active shareholders.
4.2 The Company may in addition establish, manage, develop and dispose of a portfolio of securities, patents and
licenses of whatever origin and nature, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities,
patents and licenses, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise, and to grant to companies or for
the benefit of companies in which the Company has a participation and/or Affiliates (as defined below), any assistance,
loan, advance or guarantee. «Affiliate» shall mean a company, legal entity or partnership generally whatsoever (collec-
tively an «Entity») in which (i) the Company directly or indirectly holds the majority of the voting rights, or (ii) an Entity
in which the Company owns shares and has the right to appoint or remove a majority of the administrative, management
or supervisory body of such Entity or (iii) an Entity in which the Company is a shareholder and controls alone, pursuant
to an agreement with other shareholders of the Entity, a majority of the voting rights in the Entity.
4.3 In general, the Company may take any measure and carry out any operation, including, without limitation,
commercial, financial, personal and real estate transactions which it may deem necessary or useful for the accom-
plishment and development of its objects.
4.4 The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds and debentures.
10132
Share Capital - Shares
Art. 5. Shares
5.1 The share capital of the Company is EUR 250,000,000.- (two hundred fifty million Euros), divided into 100,000,000
(one hundred million) ordinary shares of EUR 1.25 (one Euro twenty-five cents) each (the «Ordinary B Shares» or the
«B Shares») and 100,000,000 (one hundred million) convertible preferred shares of EUR 1.25 (one Euro twenty-five
cents) each (the «Preferred Shares» or the «A Shares»).
5.2 (i) The Ordinary B Shares and the Preferred Shares shall constitute separate classes of shares in the Company, but
shall rank pan passu in all respects save, as hereinafter specifically provided. The Preferred Shares shall have liquidation
preference, preferred dividend rights and conversion rights under the terms and conditions described hereafter.
(ii) Unless otherwise provided for in these Articles, (x) any resolution proposed at a General Meeting of Shareholders
of the Company as an ordinary resolution shall require the affirmative vote of a simple majority of the votes cast by the
shareholders of each of the class A Shares and of the class B Shares as separate classes as well as the overall simple
majority of all shareholders of the Company, and (y) any resolution proposed at a General Meeting of Shareholders of
the Company as a special resolution shall require the affirmative vote of shareholders representing a simple majority of
the share capital of each of the class A Shares and of the class B Shares as separate classes of shares as well the affir-
mative vote of shareholders representing two thirds of the entire share capital. In case a quorum is not reached at a
general meeting of the Company in accordance with the terms of Article 18.5 of these Articles, the meeting shall be
reconvened in accordance with the formalities laid down in such Article 18.5.
5.3 The Preferred Shares shall confer upon the holders thereof as a class the right, in priority to the payment of
dividends to the holders of any other shares in the capital of the Company, to receive out of the profits of the Company
available for distribution by way of dividend a fixed cumulative preferential cash dividend (hereinafter called the «Prefe-
rence Dividend»), of 3% (three percent) of USD 117,527,000.- (one hundred seventeen million five hundred twenty
seven thousand U.S. dollars), the latter amount being increased by any unpaid Preference Dividend and reduced by any
return of capital, such Preference Dividend to be payable yearly, subject to the terms of Article 5.7 of these Articles, on
30 September in every year commencing in 2000 and being in respect of the previous corporate year, i.e. the 12 month
period ending on the immediately preceding 30 June. The Preferred Shares shall not be entitled to participate in the
distribution of dividends (if any) paid in excess of the Preference Dividend.
For the purposes of these Articles, the applicable exchange rate between EUR and USD shall be the rate applicable
on the last Luxembourg business day of the corporate year of the Company preceding the corporate year in which an
event necessitating an exchange shall occur.
5.4 The holders of the Preferred Shares shall be entitled to receive notices of and to attend at all general meetings of
the Company and subject to Article 6.9 shall be entitled to one vote for each Preferred Share held by them.
5.5 The holders of the Ordinary Shares shall be entitled to receive notices of and to attend at all general meetings of
the Company and shall be entitled to one vote for each share held by them.
5.6 No dividend, whether in cash or kind, shall be paid or declared, nor shall any other distribution be made on the
Ordinary Shares, nor shall any Ordinary Shares be redeemed or purchased by the Company (except for purchases or
redemptions of Ordinary Shares by the Company pursuant to agreements which are approved by the Board of
Directors of the Company with the approval of the A Directors and which permit the Company to purchase or redeem
such shares upon termination of services to the Company or in exercise of the Company’s right of first refusal upon a
proposed transfer) until any accrued Preference Dividend shall have been declared and paid in full. The provisions of this
Article 5.6 shall, without prejudice to mandatory provisions of the Luxembourg Company Act, not apply to
(i) an acquisition of any Ordinary Shares in exchange for the issue of other Ordinary Shares provided the number of
Ordinary Shares so issued shall not be in excess of the number of Ordinary Shares so acquired, or
(ii) any purchase or redemption by the Company of shares which is unanimously approved by the Directors.
5.7 For so long as the Company’s Net Income (as defined below) for any corporate year exceeds USD 9,000,000.-
(nine million U.S. dollars), the Company shall, to the extent permitted by the Luxembourg Company Act, declare and
pay the Preference Dividend. «Net Income» shall mean consolidated net income after tax, and «Net Loss» shall mean
consolidated net loss after tax, in each case calculated in accordance with US Generally Accepted Accounting Principles
(«US GAAP») provided that where the Luxembourg accounting practice shall be more stringent or restrictive the latter
shall apply.
5.8 In the event of a return of capital on liquidation the assets of the Company available for distribution among the
shareholders shall be applied:
(i) firstly, in repayment to the holders of the Preferred S hares (if any such shares are then outstanding) in the amount
of USD 117,527,000.- (one hundred seventeen million five hundred twenty seven thousand U.S. dollars) together with a
sum equal to any arrears and accruals of the unpaid Preference Dividend thereon to be calculated down to the date of
return of capital and to be payable whether or not such Preference Dividend has been declared or earned, less any
return on capital (the «Preferential Liquidation Right»),
(ii) secondly, after payment in full of the Preferential Liquidation Right, the holders of the Ordinary B Shares shall be
entitled to be paid out of the assets of the Company, if any, an amount equal to the Preferential Liquidation Right («the
Ordinary Catch-Up») and
(iii) the surplus shall be distributed pro rata among the holders of the Preferred Shares and the Ordinary B Shares.
5.9 If upon any liquidation, distribution or winding up the assets of the Company shall be insufficient to make payment
of the Preferential Liquidation Right in full to all holders of the Preferred Shares, then such assets shall be distributed
among the holders of the Preferred Shares, rateably in proportion to the full amounts to which they would otherwise
be respectively entitled. If, following the payment and settlement of the Preferential Liquidation Right, the remaining
10133
assets of the Company shall be insufficient to make payment in full to all holders of the Ordinary Shares of the Ordinary
Catch-Up as set out in Article 5.8 (ii), then such remaining assets shall be distributed among the holders of the Ordinary
B Shares, and thereafter to the holders of the other classes of Ordinary Shares rateably in proportion to the full amounts
to which they would otherwise be respectively entitled.
Art. 6. Conversion
The following provisions shall apply with respect to the conversion of the Preferred Shares into Ordinary A Shares:
6.1. Subject to the provisions of this Article 6, all fully paid Preferred Shares shall automatically be converted, without
any further action by the holders thereof and/or the holders of Ordinary Shares and whether or not any certificates
representing such shares are surrendered to the Company, into fully paid Ordinary A Shares upon the closing of an
investment by any person or entity who, following the first date of issuance of Preferred Shares is not an «Affiliate», as
defined in article 4.2 of the Present Articles, or «Associate» of the Company or any shareholder of the Company (a
«Qualified Third Party») by which (a) such Qualified Third Party purchases Ordinary Shares of the Company or
securities convertible into Ordinary Shares (a «Qualified Third Party Investment») and (b) the gross cash proceeds to
the Company (before any discounts, commissions or fees) from such transaction equals or exceeds the greater of (i)
USD 60,000,000.- (sixty million U.S. dollars) or (ii) 30% (thirty percent) of the fair market value of the Company as
determined in good faith by a majority of the A Directors and a majority of the B Directors.
6.2 The holders of the Preferred Shares shall have the right, exercisable at any time between and including the first
and the last days of the corporate year following the first corporate year m which the Company earns Net Income (as
such term is defined in article 5.7 of the present Articles) of not less than USD 9,000,000.(nine million U.S. dollars) to
convert the Preferred Shares (including for such purposes all accrued but unpaid dividends thereon) into Ordinary A
Shares.
6.3 Upon occurrence of a conversion of Preferred Shares into Ordinary A Shares, all references to Preferred Shares
in these Articles shall be understood to be references to Ordinary A Shares.
Preferred Shares shall be convertible into Ordinary A Shares at a conversion ratio of 1 (one) Ordinary A Share per
Preferred Share. The conversion must be exercised for the entirety of the Preferred Shares and may not be exercised
in part.
6.4 The holders of Ordinary B Shares shall have the right, at any moment, subject to the approval of a majority of
A Directors and a majoritiy of B Directors, to convert the Ordinary B Shares, in whole or in part, into Ordinary C
Shares.
Ordinary B Shares shall be convertible into Ordinary C Shares at a conversion ratio of 1 (one) Ordinary C Share per
Ordinary B Share.
6.5 blank
6.6 Upon conversion of the Preferred Shares or of the Ordinary B Shares, each holder of such shares shall promptly
surrender any certificate or certificates therefor at the registered office of the Company. The Company shall not be
obliged to issue certificates evidencing the Ordinary A Shares or the Ordinary C Shares to be issued upon such
conversion unless the certificates evidencing such Preferred Shares or Ordinary B Shares are either delivered to the
Company as provided above, or the holder notifies the Company that such certificates have been lost, stolen, mutilated
or destroyed and executes an agreement satisfactory to the Company to indemnify the Company against any loss
incurred by it in connection with such certificates. Thereupon, there shall be issued and delivered to such holder
promptly and in its name as shown on such surrendered certificate or certificates, a certificate or certificates for the
number of Ordinary A Shares or Ordinary C Shares into which the Preferred Shares or Ordinary B Shares were conver-
tible on the date on which such automatic conversion occurred.
6.7 If at any time the Ordinary A Shares to be issued upon the conversion of Preferred Shares are changed into the
same or a different number of shares of any class or classes, whether by reclassification of such shares or by means of a
sub-division or consolidation of such shares, or a stock dividend or a rights issue, in any such event, each holder of
Preferred Shares shall have the right thereafter to convert such shares into the kind and amount of stock and other
securities receivable upon such event by holders of the maximum number of Ordinary A Shares into which such
Preferred Shares could have been converted immediately prior to such event, all subject to further adjustment as
provided herein or with respect to such other securities by the terms thereof
6.8 If at any time there is a capital reorganisation other than as provided for elsewhere in this Article 6, then as part
of such capital reorganisation, provision shall be made so that the holders of the Preferred Shares shall thereafter be
entitled to receive upon conversion of the Preferred Shares the number of shares of stock or other securities or
property of the Company to which a holder of a number of Ordinary A Shares deliverable upon conversion would have
been entitled on such capital reorganisation, subject to adjustment in respect of such stock or securities by the terms
thereof In any such case, appropriate adjustment shall be made in the application of the provisions of this Article 6 with
respect to the rights of the holders of Preferred Shares after the capital reorganisation to the extent that the provisions
of this Article 6 (including adjustment of the number of shares to be issued upon conversion of the Preferred Shares)
shall be applicable after that event (and be as nearly equivalent as practicable).
6.9 If the holders of the Preferred Shares do not elect to convert all the Preferred Shares into fully paid Ordinary A
Shares within the time period provided for in Article 6.2, then the usufruct, consisting in the right to vote the Preferred
Shares at any general meeting of the Company will pass upon CYBER FIN S.A., save that the bare owners of the
Preferred Shares shall have the right to vote (and their approval shall be required) for any of the actions referred to in
Article 18.8 (a), (c), (d) and (e).
Except as provided for in this Article 6.9, the bare owners of the Preferred Shares shall exercise all rights and be
entitled to all benefits attached by law and these Articles to the Preferred Shares.
10134
Art. 7. Capital Calls - Redemptions - Lien
7.1 Unpaid amounts, if any, on issued and outstanding shares may be called at any time at the discretion of the Board
of Directors, provided however that calls shall be made on all the shares in the same proportion and at the same time.
Any sum, the payment of which is in arrears, automatically attracts interest in favour of the Company at the rate of 7
per cent per year calculated from the date when payment was due.
7.2 The Company may:
(i) issue any shares of the Company which are to be redeemed or are liable to be redeemed at the option of the
Company or the shareholder on such terms and in such manner as may be determined by the Company in General
Meeting of Shareholders (by special resolution of the Company) on the recommendation of the Directors,
(ii) purchase any of its own shares (including any redeemable shares and without any obligation to purchase on any
pro rata basis as between shareholders or shareholders of the same class) and may cancel any shares so purchased or
hold them as treasury shares, provided however that the Company may not at any time redeem or purchase any of the
Preferred Shares.
7.3 The Company shall have a lien on every share for all moneys (whether immediately payable or not) called or
payable at a fixed time in respect of that share, and the Company shall also have a lien on all shares standing registered
in the name of any person or entity whether he or it be the sole registered holder thereof or one of several joint holders
for all moneys immediately payable by him/it or his/its estate to the Company. The Company’s lien on a share shall
extend to all dividends payable thereon.
Art. 8. Authorized Share Capital
The authorised share capital, including the issued share capital, of the Company is set at EUR 1.000.000.000.- (one
billion Euros). It may be issued and the Board of Directors is authorized to issue it up to the amount of the authorized
share capital, at the discretion of the A Directors and the B Directors, as Ordinary B Shares, Ordinary C Shares, (the
Ordinary B Shares and Ordinary C Shares, and if and when the Preferred Shares have been converted, the Ordinary A
Shares, together being referred to as the «Ordinary Shares»), or Preferred Shares upon a resolution approved by a
majority vote of the A Directors and a majority vote of the B Directors. This authority given to the Board of Directors
shall expire five years after 22nd December 1999, but may be previously revoked or varied by the Company in General
Meeting of Shareholders and may be renewed by the Company in General Meeting of Shareholders for a further period
or periods not exceeding five years each from the date of such renewal. The Company may make any offer or agreement
before the expiry of this authority which would or might require relevant securities to be issued after this authority has
expired and the Directors may issue relevant securities in pursuance of any such offer or agreement.
The pre-emption provisions of the Company Act shall, if the Board of Directors takes a resolution to that effect, not
apply to any issue by the Company of equity securities or debt securities convertible into equity securities made by the
Board of Directors in the context of the authority granted to it by virtue of this Article 8. Resolutions taken by the
Board of Directors and precluding shareholders of the Company from their pre-emption rights or restricting such
rights shall have to be approved by a majority vote of the A Directors and a majority vote of the B Directors. The
authority granted to the Board of Directors shall comprise the issue of options, warrants and restricted stock in the
context of employee stock option plans and other employee equity plans as may be approved by the shareholders from
time to time and of shares in the context of employee stock benefit plans as the latter may be approved by the
shareholders from time to time. The Board of Directors shall be authorised to determine at its discretion the practical
conditions (including but not limited to delegating practical matters in relation to the relevant plans to a committee or
committees operating under its control) under which the options to the employees of the Company and its Affiliates
shall be granted and the shares of the Company shall be issued upon the exercise of the relevant options provided such
determination shall be made in writing and be in compliance with the terms of the employee stock option plan or the
employee equity plan or, as the case may be, the employee stock benefit plan as approved by the shareholders from
time to time.
The Board of Directors is authorised and instructed to determine the conditions attached to any subscription, or it
may from time to time resolve to effect such whole or partial increase upon the conversion of any net profit of the
Company into capital and the attribution of fully-paid shares to shareholders in lieu of dividends.
The Board of Directors is further authorised to issue convertible bonds or assimilated instruments or bonds with
subscription rights or to issue any financial debt instruments convertible into shares under the conditions to be set by
the Board of Directors.
Each time the Board of Directors shall act to render effective the increase of capital, as authorised, Article 5 of these
Articles shall be amended at the initiative of the Board of Directors so as to reflect the result of such action; the Board
of Directors shall in such case take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of obtaining the
recording by way of notarial deed and the publication of such amendment.
Art. 9. Share Register - Certificates
9.1 The shares of the Company shall be and remain in registered form.
9.2 A register of shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any
shareholder. Ownership of shares will be established by inscription in the said register.
9.3 Certificates of these inscriptions will be taken from a counterfoil register and signed by the Chairman of the Board
of Directors and one other Director.
9.4 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is held by more than one person, the
Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed
as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a pledgor and a
pledgee.
10135
The usufruct holder and the bare owner of a share, as they are defined in Article 6.9 of these Articles, shall always be
considered as a single holder. The suspension of the rights attached to that share, as provided for hereabove, shall not
apply in this situation.
Management - Supervision
Art. 10. Appointment and Dismissal of Directors
10.1 The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of a minimum of four and a maximum of eight
members, either shareholders or not, who are appointed by the General Meeting of Shareholders for a renewable term
which may not exceed six years. The holders of at least a majority of the Preferred Shares shall present for appointment
a certain number of candidate Directors who, if and when appointed by the General Meeting of Shareholders, shall be
referred to as A Directors and, likewise, the holders of at least a majority of the Ordinary B Shares shall present for
appointment an equal number of candidate directors who, if and when appointed by the General Meeting of
Shareholders, shall be referred to as B Directors. The Company shall always have an equal number of A and B Directors.
The Directors may be dismissed at any time upon the recommendation of the class of shareholders who presented such
Directors, subject to approval of a General Meeting of Shareholders.
10.2 Retiring members of the Board of Directors are eligible for re-election.
10.3 In the event of a vacancy on the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining
Directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting of
Shareholders. An A Director shall be replaced by a Director chosen from among candidates proposed by the holder(s)
of Preferred Shares at the immediately preceding General Meeting of Shareholders and who were not then elected or,
if all the candidates were elected at such immediately preceding General Meeting or some of the candidates shall not be
prepared to accept a mandate,from a list of candidates proposed by the holder(s) of Preferred Shares and vice-versa a
B Director shall be replaced by a Director chosen from among candidates proposed by the holder(s) of Ordinary B
Shares at the immediately preceding General Meeting of Shareholders and who were not then elected or, if all the candi-
dates were elected at such immediately preceding General Meeting or some of the candidates shall not be prepared to
accept a mandate, from a list of candidates proposed by the holder(s) of Ordinary B Shares.
10.4 The Board of Directors will operate in accordance with its internal rules and regulations (the «Internal Rules and
Regulations») as determined in its first meeting and amended or supplemented from time to time by a resolution of the
Board of Directors taken with the majority of each class of Directors. The Internal Rules and Regulations shall be binding
upon all the organs of the Company.
Art. 11. Meetings of the Board of Directors - Resolutions
11.1 The Board of Directors will elect from among its members a Chairman. It may further choose a Secretary, who
shall not be a Director and who shall be in charge of keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors. The
first Chairman shall be appointed by a General Meeting of Shareholders. The Chairman will preside at all General
Meetings of Shareholders and at meetings of the Board of Directors. Both classes of Directors shall alternatively and on
an annual rotating basis hold the chairmanship. The Chairman shall hold office for a twelve month period as from the day
of his appointment and be succeeded by a Director who shall be elected from a list of candidates presented by a class
of Directors not having presented the candidate for chairmanship the the previous year.
11.2 Meetings of the Board of Directors are convened by the Chairman or by at least one class A Director and at
least one class B Director.
The Directors will be convened separately to each meeting of the Board of Directors. Except in cases of urgency
which will be specified in the convening notice or with the prior consent of all those entitled to attend, at least (two)
calendar days’ written notice of Board meetings shall be given.
The meeting will be duly held without prior notice if all the Directors are present or duly represented.
The meetings are held at the place, the day and the hour specified in the convening notice. Meetings shall be held in
Luxembourg.
The notice may be waived by the consent in writing or by telefax or telegram or telex of each Director. No separate
notice is required for meetings held at times and places specified in a schedule previously adopted by resolution of the
Board of Directors.
Any A Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by telefax or telegram
or telex another A Director as his proxy and, likewise, any B Director may appoint any B Director as his proxy.
An A Director may represent more than one of his fellow A Directors and, vice-versa, any B Director may represent
more than one of his fellow B Directors.
Any director may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The parti-
cipation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed
to be held in Luxembourg.
11.3 Circular resolutions signed by all the Directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter, telefax or telex.
11.4 (a) The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors shall be two A Directors and two
B Directors. If, within one hour from the time set for a meeting of the Directors, such quorum is not present, the
meeting shall be reconvened to the same time and place seven calendar days later. A Director or Directors present,
irrespective of class, at the reconvened meeting shall, save for force majeure, constitute a quorum. The convening notice
to the reconvened meeting shall specify that this is a reconvened meeting and that the meeting may proceed regardless
10136
of a then present quorum. (b) For the purpose of determining whether a quorum of Directors exists for the transaction
of the business of the Directors:
(i) in the case of a resolution agreed by Directors in telephonic communication with one another by means of confe-
rence telephone or other means by which all Directors participating can hear each other speak, all such Directors shall
be counted in quorum and any resolution so agreed shall be as valid and effective as if passed at a meeting of the
Directors duly convened and held;
(ii) in the case of a meeting of the Directors, in addition to the Directors present at the meeting, any Director in
telephonic communication with such meeting shall be counted in the quorum and be entitled to vote.
11.5 No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be
affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company have a personal
interest in, or be a director, associate, officer or employee of such other company, firm or other entity. Any director
who is director or officer or employee of any company, firm or other entity with which the Company shall contract or
otherwise engage in business shall not, merely by reason of such affiliation with such other company, firm or other entity
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
11.6 Except as otherwise provided in Articles 11.7 and 11.8, any resolution of the Directors shall require the approval
of a majority of of the A Directors and a majority of the B Directors present or represented at the meeting.
11.7 The Directors may with the approval of a majority of the B Directors and without the necessity of a separate
approval of the A Directors, declare an interim dividend subject to the following conditions being cumulatively met:
(i) the Company shall not be in default of any provision of these Articles which relate to the rights of the holders of
the Preferred Shares;
(ii) interim dividends shall be declared only to the extent permitted by the Luxembourg Company Act;
(iii) such dividends are payable from distributable cumulative Net Income (and cumulative Net Income shall mean
accumulated Net Income less accumulated Net Loss);
(iv) immediately following the payment of any such dividends, the amount of the Company’s working capital will not
fall below EUR 10,000,000.- (ten million Euros), and
(v) the Company shall not be in default under the terms of any lending agreements, debt securities or obligations.
11.8 Decisions in respect of the following matters shall require the consent of a majority of both the A Directors and
the B Directors and, if such consent cannot be obtained, and subject to Article 6.9, the shareholders shall have to adopt
a resolution with a simple majority of the shareholders of the class A Shares and a simple majority of the shareholders
of the class B Shares as separate classes as well as the overall majority of the shareholders of the Company in respect of
each such decision:
(a) adoption of any business plan for the Company or approval of any modification of any line item or other provision
in any business plan in respect of the Company;
(b) adoption of any strategic plan and business projections for the Company and approval, rescission or amendment
of any strategic decision material to the long term conduct of the business of the Company;
(c) any changes to the Company’s method of conduct of business including, but not limited to, the connection of the
services offered by the Company or its subsidiaries, software used by the Company or the content made available by the
Company, entering into, termination in accordance with its terms or the modification or amendment of any material
agreement with either AMERICA ONLINE, INC. or BERTELSMANN A.G. or their respective Affiliates (as defined in
article 4.2 of these Articles) (or the waiver of any material right or obligation thereunder);
(d) change or adoption of any material accounting principle or practice to be applied by the Company;
(e) authorisation of the lending or borrowing of funds or the making of guarantees or capital expenditures by the
Company of amounts in excess of an aggregate of EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) (or its equivalent in any other
currency) in any year;
(f) commencement of any litigation (without regard to the amount in dispute) or settlement of any litigation to which
the Company is a party (i) involving amounts in excess of EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) (or its equivalent in any
other currency) or (ii) materially adversely affecting the rights of either AMERICA ONLINE, INC. or BERTELSMANN
A.G. or any of their respective Affiliates (as defined in article 4.2 of the present Articles) except that litigation relating
to the collection of amounts due to the Company by third parties may be commenced or settled in the discretion of
management;
(g) entering into any transaction with either AMERICA ONLINE, INC. or BERTELSMANN A.G. or any of their
respective Affiliates (as defined in article 4.2 of the present Articles) except transactions entered into on an inadvertent
basis and involving the payment of amounts, or rendering of services with a value of, less than EUR 50,000.- (fifty
thousand Euros) or its equivalent in any other currency;
(h) approval of the entering into, termination or modification by the Company of (i) any material provision of any
long-term contract involving payments by the Company or rendering of services by the Company with a value in excess
of EUR 50,000.- (fifty thousand Euros) (or its equivalent in any other currency) or (ii) any pension plan;
(i) establishment of, or making of any significant modification to, the investment and cash management policies of the
Company;
j) sale of any asset outside the ordinary course of business;
(k) approval of (i) the entering into by the Company of any line of business not currently conducted by the Company
on the date such new business is contemplated or not expressly contemplated by the present Articles in relation to the
activities of the Company or (ii) the discontinuance of any activity engaged in from time to time by the Company;
(I) approval of the entering into of any partnership, joint venture or consortium with any other legal entity by the
Company, the creation of any subsidiary by the Company or the acquisition or sale of any equity interest or rights in any
other entity by the company;
10137
(m) appointment or dismissal of the chief executive officers (or, with respect to those jurisdictions not having chief
executive officers, their equivalent) of the Affiliates of the Company and their direct subordinates;
(n) any press releases or other public statements containing material non-public information;
(o) entering into agreements with respect to content, service or software outside the ordinaiy course of business;
(p) entering into any agreement with any information provider to the Company; and
(q) approval of matters identical or similar to the items listed under (a) through (I) and (n) through (p) applying to the
Affiliates of the Company and requiring or being submitted to shareholder’s approval; provided that, to the extent that
any action requiring the approval of the Directors is specifically set out on a line item basis in any business plan of the
Company, such action shall be deemed to have been approved.
Art. 12. Minutes of Meetings of the Board of Directors
12.1 The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be inserted in a special register and signed
by the Chairman and by a Director who has not been presented for election by the same class of Directors as the
Chairman. Any proxies will remain attached thereto.
12.2 Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise will be signed
by the Chairman and by a Director who has not been presented for election by the same class of Directors as the
Chairman.
Art. 13. Powers of the Board of Directors - Indemnification
13.1 The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by the Luxembourg Company Act or by the present
Articles to the General Meeting of Shareholders fall within the competence of the Board of Directors.
13.2 The Company shall, to the largest extent permitted by Luxembourg law, indemnify any Director or officer and
his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit
or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a Director or officer of the
Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from
which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such
action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised
by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnifi-
cation shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 14. Delegation of Powers
14.1 The Board of Directors may delegate part of its powers to one or more of its members in accordance with the
Internal Rules and Regulations to be adopted by the Board of Directors from time to time. It may further appoint
proxies for specific transactions and revoke such appointments at any time.
14.2 The Board of Directors shall entrust, in accordance with the Internal Rules and Regulations to be adopted by the
Board of Directors from time to time, the daily management of the Company’s business to an agent who will be called
chief executive officer (the «Chief Executive Officer») and who will at all times be chosen from a list of candidates to be
proposed by the B Directors Notwithstanding this provision, the Company shall not be an affiliate of BERTELSMANN
A.G. The delegation in favour of a member of the Board of Directors is subject to the prior authorisation of the General
Meeting of Shareholders.
The right of the B Directors to suggest a list of candidates from whom the Chief Executive Officer will be chosen shall
continue to be vested in the B Directors even if the Board of Directors should fail to appoint the Chief Executive Officer
the first time the B Directors have submitted its proposal to the Board for decision. The same candidates may be
presented for appointment again.
14.3 The Board of Directors shall further have the possibility to decide to create at its discretion an executive body
(the «Group Executive Management» or «GEM») which determines and co-ordinates the management of the Company
and its major subsidiaries. The GEM shall be chaired by the Chief Executive Officer and operate in accordance with the
Internal Rules and Regulations.
14.4. The Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of an A Director and a B Director in
all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory power has been granted by
the Board of Directors, but only within the limits of such power.
Notwithstanding any delegation of powers, any single contract the principal amount of which exceeds EUR
2,500,000.- (two million five hundred Euros) shall require the approval of the Board of Directors in accordance with the
provisions of Article 11.6 or, as the case may be, Article 11.8 of these Articles.
14.5 The exclusive and effective place of management shall be Luxembourg. All management activities shall be carried
out within Luxembourg.
Art. 15. Statutory Auditor
The audit of the Company’s annual accounts shall be entrusted to one or several statutory auditors, appointed by the
General Meeting of Shareholders which shall fix their number, remuneration, and their term of office, such (renewable)
office not to exceed six years.
They may be re-elected and removed at any time.
General Meetings of Shareholders
Art. 16. Powers of the General Meeting of Shareholders
The General Meeting of Shareholders properly constituted represents the entire body of shareholders. It has the
powers conferred upon it by the Luxembourg Company Act and these Articles.
10138
Art. 17. Annual General Meeting of Shareholders - Other General Meetings
17.1 The annual General Meeting of Shareholders shall be held at the registered office of the Company, or at such
other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting, on the 10th day of
October at 10.00 am.
If such day is not a business day in the City of Luxembourg, the annual General Meeting of Shareholders shall be held
on the next following business day.
17.2 Other General Meetings of Shareholders may be held in Luxembourg at such time as may be specified in the
respective notices of meeting.
Art. 18. Proceedings, Vote
18.1 General Meetings of Shareholders shall meet upon call of the Board of Directors or, if exceptional circumstances
require so, by any two Directors acting jointly.
It shall be necessary to call a General Meeting of Shareholders whenever a group of shareholders representing at least
one fifth of the subscribed capital so requests. In such case, the relevant shareholders must indicate the agenda of the
meeting and the Board of Directors shall have the obligation to convene a General Meeting of Shareholders so that such
meeting is held within a month of the request.
18.2 Shareholders will meet upon call by registered letter on not less than 8 calendar days prior notice.
All notices calling General Meetings of Shareholders must contain the agenda for such meetings.
If all the shareholders are present or represented at the General Meeting and if they state that they have been duly
informed on the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
To the extent permitted by law, circular resolutions of the shareholders shall be validly taken if approved in writing
by all the shareholders. Such approval may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter, telefax or telex.
18.3 Any shareholder may act at any General Meeting by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex
as his proxy another person who need not be a shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a General
Meeting of Shareholders.
18.4 Each share entitles its shareholder to one vote.
18.5 No business shall be transacted at any meeting of the Company unless a quorum of shareholders is present at
the time when the meeting proceeds to business. The shareholders present in person or by proxy and representing fifty
percent of the share capital of the Company shall constitute a quorum provided that one of such shareholders is a
shareholder holding one or more Ordinary B Shares and one is a shareholder holding one or more Preferred Shares. If
a quorum shall not be present within 30 minutes of the time set for meeting, the meeting shall be adjourned and recon-
vened to the 1 Or» calendar day of the initial meeting. If a quorum shall not be present within 30 minutes of the time
set for a meeting having at its agenda amendments to the Articles or assimilated matters, then a second meeting shall be
convened by two convening notices to be published in the Luxembourg Official Gazette and two Luxembourg
newspapers with 15 (fifteen) days interval between each notice and with the second notice being given at least 15
(fifteen) days prior to the adjourned meeting and any shareholder or shareholders present at the adjourned meeting
shall constitute a quorum. The quorum needed at the first meeting shall also apply at the second meeting unless
compulsory provisions of Luxembourg law will require that the second meeting has to proceed regardless of a quorum.
18.6 Before commencing any deliberations, the chairman of the General Meeting, who shall be the Chairman of the
Board of Directors unless he is prevented from attending, shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a
scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer form the Meeting’s board.
A Director shall be entitled to receive notice of and to attend and speak at any General Meeting of or any separate
meeting of the holders of any class of shares in the Company.
The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the Meeting’s board and by any shareholder
who wishes to do so.
However, in case decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or
elsewhere must be signed by the Chairman of the Board of Directors, or, in his absence, by a Director presented for
appointment by the same class of Directors as the Chairman, and a Director who has not been presented for
appointment by the same class of Directors as the Chairman.
18.7 Except as otherwise provided in these Articles or in the Luxembourg Company Act, any resolution of the
General Meeting shall be taken with the majority vote of the votes cast by the shareholders of each of the class A Shares
and of the class B Shares as separate classes and the overall majority of all shareholders. The following decisions shall be
taken under the above majority requirements:
(a) approval of the final annual audited financial statements of the Company;
(b) save as expressly provided in these Articles, payment of dividends or making of distributions to shareholders and
determining the amount and date of any such distribution;
(c) appointment or dismissal of the chief executive officers of the Affiliates of the Company and their direct subordi-
nates;
(d) appointment or dismissal of the auditors of the Company.
18.8 The following actions shall not be taken other than by a resolution of the shareholders representing the majority
of the share capital of each of the class A Shares and the class B Shares as separate classes and representing together
two thirds of the entire share capital of the Company:
(a) amendment of the Articles of Association of the Company;
(b) approval of the participation either by way of transfer or subscription of any third party (other than employees
receiving shares in the context of employee stock option plans) in the capital of the Company;
(c) approval of the merger or amalgamation of the Company;
10139
(d) the liquidation or winding up of the Company and the sale of all or substantially all of the assets of the Company;
(e) without prejudice to the provisions of Article 8, the issue of shares, debentures or loan stock of the Company or
options to acquire shares, debentures or loan stock of the Company or any agreement to any of the foregoing, the
consolidation or sub-division of any shares in the share capital of the Company, the creation of any new class of share
in the share capital of the Company or any other change in the share capital of the Company;
Corporate year - Annual Accounts - Distribution of profits
Art. 19. Corporate Year
The Company’s corporate year runs from July to June of the following year.
Art. 20. Annual Accounts
20.1 Each year, at the end of the corporate year, the Board of Directors will draw up the annual accounts of the
Company in the form required by law.
20.2 At the latest one month prior to the Annual General Meeting, the Board of Directors will submit the Company’s
balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law
to the external auditor who will thereupon draw up his report.
20.3 A fortnight before the Annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the Board’s
report, the auditor(s’) report and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered
office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.
Art. 21. Distribution of Profits
21.1 The credit balance on the profit and loss account, after deduction of the general expenses, social charges, write-
offs and provisions for past and future contingencies as determined by the Board of Directors represents the net profit.
21.2 Every year five per cent of the net profit will be set aside in order to build up the legal reserve. This deduction
ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the issued share capital.
21.3 The remaining balance of the Company’s distributable profits, after payment of the Preference Dividend, shall be
entirely distributed unless otherwise provided by the General Meeting of Shareholders.
21.4 Dividends, when payable, will be distributed at the time and place fixed by the Board of Directors within the
limits of the decision of the General Meeting.
21.5 Interim dividends may be paid by the Board of Directors within the conditions provided for by the Luxembourg
Company Act.
21.6 The General Meeting may decide to assign profits and distributable reserves to the reimbursements of the capital
without reducing the corporate capital.
Dissolution - Liquidation
Art. 22. Dissolution
The Company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting of Shareholders deliberating in the
manner set in Article 18.8 of these Articles.
Art. 23. Liquidation
In the event of the dissolution of the Company, the General Meeting, deliberating in the manner required by Article
18.8 of these Articles, will determine the method of liquidation and nominate one or several liquidators and determine
their powers.
Art. 24. General provisions
All matters not governed by the present Articles shall be determined in accordance with the provisions of the law of
10 August, 1915 on commercial companies, as amended, (the «Luxembourg Company Act»).
<i>Transitional provisionsi>
By variation of the prior decision of the shareholders, the first business year begins at incorporation and ends on the
30 June 2000. The first annual meeting will be held on the 10 October 2000.
There being no further business, the meeting is terminated.
Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergence between the
English and the German texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil
status and residences, the members of the board signed together with the notary the present deed.
Folgt di deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg.
Versammelten sich in außerordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft AOL EUROPE
S.A., mit Sitz in L-1543 Luxemburg, 45, boulevard Pierre Frieden, gegründet gemäß Urkunde vom 16. Dezember 1999
des Notars Frank Baden, mit Amtssitz in Luxemburg, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C (die «Gesellschaft»).
Die Versammlung wurde um achtzehn Uhr dreissig unter dem Vorsitz von Herrn Guy Harles, Rechtsanwalt, wohnhaft
in Luxemburg, eröffnet.
Der Vorsitzende benennt zum Schriftführer Herrn Marc Feider, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler: Herrn Pierre Beissel, Rechtsanwalt, wohnhaft in Luxemburg.
10140
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar
aktenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzustellen:
I. Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Erhöhung des gezeichneten Gesellschaftskapitals auf EUR 250.031.000,- (zweihundertfünfzig Millionen einund-
dreißigtausend Euro), durch die Schaffung und Ausgabe von 100.000.000 (hundert Millionen) B Stammaktien und
100.000.000 (hundert Millionen) Vorzugsaktien;
2. Herabsetzung des gezeichneten Gesellschaftskapitals von EUR 250.031.000,- (zweihundertfünfzig Millionen einund-
dreißigtausend Euro) auf EUR 250.000.000,- (zweihundertfünfzig Millionen Euro) durch Annullierung von 24.800
(vierundzwanzigtausendachthundert) eigenen Aktien, welche von der Gesellschaft gehalten werden;
3. Neuformulierung der bestehenden Satzung der Gesellschaft durch eine neue, welche eine Bestandteil dieser nota-
riellen Urkunde ist.
Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre sowie die Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste einge-
tragen; diese Anwesenheitsliste wird von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre
und dem Versammlungsvorstand unterzeichnet und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt um mit derselben einregi-
striert zu werden.
Die Vollmachten der vertretenen Aktionären werden nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Erschienenen
ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.
II. Sämtliche Aktien der Gesellschaft sind auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten; die anwesenden
oder vertretenen Aktionäre bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg Kenntnis der Tages-
ordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.
III. Die gegenwärtige Generalversammlung die sämtliche Aktien der Gesellschaft vertritt; wurde ordnungsgemäß
einberufen und kann in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten.
Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlußi>
Die Versammlung beschließt das Gesellschaftskapital von EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) auf EUR
250.031.000,- (zweihundertfünfzig Millionen einunddreißigtausend Euro), durch die Schaffung und Ausgabe von
100.000.000 (hundert Millionen) B Stammaktien mit einem Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig cents) und
100.000.000 (hundert Millionen) Vorzugsaktien mit einem Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig cents).
Die Aktien werden wie folgt gezeichnet:
- 100.000.000 (hundert Millionen) Vorzugsaktien von der AOL LUXEMBOURG, S.à r.l., einer Gesellschaft nach
luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-2017 Luxembourg, rue Richard Coudenhove-Kalergi, welche hier vertreten ist
durch Herrn Marc Feider, vorgenannt, aufgrund einer beigefügten Vollmacht, zu einem Gesamtpreis von EUR
269.036.000,- (zweihundertneunundsechzig Millionen sechsunddreißigtausend Euro).
Die so gezeichneten Aktien sind voll eingezahlt, durch Sacheinlage der Gesamtheit der Vermögenswerte und
Schulden der vorgenannten Gesellschaft AOL Luxembourg S.ä r.l., bestehend aus
- 42 (zweiundvierzig) Anteilen an AOL FINANCE B.V., einer Gesellschaft nach niederländischem Recht;
- 1 (einem) Anteil an CompuServe INTERACTIVE SERVICES SCHWEIZ, GmbH, einer Gesellschaft nach Schweizer
Recht;
- 40 (vierzig) Anteilen an AMERICA ONLINE HOLDING B.V., einer Gesellschaft nach niederländischem Recht;
- 631 (sechshunderteinunddreißig) umwandelbaren Vorzugsanteilen an AOL PARTICIPATIONS I, einer Gesellschaft
nach luxemburgischem Recht;
- 135.789 (hunderfünfunddreißigtausendsiebenhundertneununachtzig) Klasse A Anteilen an AOL PARTICIPATIONS
II, einer Gesellschaft nach luxemburgischem Recht;
- 12.400 (zwölftausendvierhundert) Aktien der Gesellschaft, für welche die Summe von EUR 15.500,- (fünfzehntau-
sendfünfhundert Euro) zugeordnet wird;
- der Geldsumme von EUR 105.000,- (hundertfünftausend Euro);
- einem Vorschuß von EUR 107.500,- (hundertsiebentausendfünfhundert Euro) zugunsten von AOL LUXEMBOURG,
S.à r.l.
- 59.260.689 (neunundfünfzig Millionen zweihundertsechzigtausendsechshundertneunundachtzig) B Stammaktien von
der CYBER FIN S.A., einer Gesellschaft nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-1543 Luxembourg, 45, boulevard
Pierre Frieden, welche hier vertreten ist durch Herrn Guy Harles, vorgenannt, aufgrund einer beigefügten Vollmacht, zu
einem Gesamtpreis von EUR 129.118.562,- (hundertneunundzwanzig Millionen hundertachtzehntausendfünfhun-
dertzweiundsechzig Euro).
Die so gezeichneten Aktien sind voll eingezahlt, durch Sacheinlage der Gesamtheit der Vermögenswerte und
Schulden der vorgenannten Gesellschaft CYBER FIN S.A., bestehend aus
- 1 (einem) Anteil an CompuServe INTERACTIVE SERVICES SCHWEIZ, GmbH, eine Gesellschaft nach Schweizer
Recht, für welchen 4.000.000 (vier Millionen) B Stammaktien der Gesellschaft zugeordnet werden, numeriert von 1
(eins) bis 4.000.000 (vier Millionen);
- 400 (vierhundert) Anteilen an BERTELSMANN STORE B.V., eine Gesellschaft nach niederländischem Recht, für
welche 5.300.000 (fünf Millionen dreihunderttausend) B Stammaktien der Gesellschaft zugeordnet werden, numeriert
von 4.000.001 (vier Millionen und eins) bis 9.300.000 (neun Millionen dreihunderttausend);
- 631 (sechshunderteinunddreißig) Anteilen an AOL PARTICIPATION I, S.à r.l., einer Gesellschaft nach luxemburgi-
schem Recht, für welche 6.800.000 (sechs Millionen achthunderttausend) B Stammaktien der Gesellschaft zugeordnet
10141
werden, numeriert von 9.300.001 (neun Millionen dreihunderttausendundeins) bis 16.100.000 (sechzehn Millionen
einhunderttausend);
- 40.002 (vierzigtausendzwei) Aktien der CYBER FIN UK S.A., eine Gesellschaft nach luxemburgischem Recht, für
welche 14.900.000 (vierzehn Millionen neunhunderttausend) B Stammaktien der Gesellschaft zugeordnet werden,
numeriert von 16.100.001 (sechzehn Millionen einhunderttausendundeins) bis 31.000.000, für welche 14.900.000
(vierzehn Millionen neunhunderttausend) B Stammaktien der Gesellschaft zugeordnet werden, numeriert von
16.100.001 (sechzehn Millionen einhunderttausendundeins) bis 31.000.000 (einunddreißig Millionen);
- 12.400 (zwölftausendvierhundert) Aktien der Gesellschaft, für welche die Summe von EUR 15.500,- (fünfzehntau-
sendfünfhundert Euro) zugeordnet wird;
- einer non interest-bearing unsecured subordinated loan note mit einem Nennwert von USD 89.376.000,- (neunund-
achtzig Millionen dreihundertsechsundsiebzig U.S. Dollars) zahlbar den 12. Februar 2018, ausgestellt von CompuServe
INTERACTIVE SERVICES LIMITED (früher OAKRAIN LIMITED), eine Gesellschaft nach irischem Recht, für welche
28.260.689 (achtundzwanzig Millionen zweihundertsechzigtausendsechshundertneunundachtzig) B Stammaktien der
Gesellschaft zugeordnet werden, numeriert von 31.000.001 (einunddreißig Millionen und eins) bis 59.260.689 (neunund-
fünfzig Millionen zweihundertsechzigtausendsechshundertneunundachtzig);
- der Geldsumme von EUR 55.998,- (fünfundfünfzigtausendneunhundertachtundneunzig Euro);
- einer Verpflichtung durch Gründungskosten von EUR 1.763,- (tausendsiebenhundertdreiundsechzig Euro).
- 40.739.311 (vierzig Millionen siebenhundertneununddreißigtausenddreihundert) B Stammaktien von der NET FIN
S.A., einer Gesellschaft nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden,
welche hier vertreten ist durch Herrn Guy Harles, vorgenannt, aufgrund einer beigefügten Vollmacht, zu einem Gesamt-
preis von EUR 63.989.952.- (dreiundsechzig Millionen neunhundertneunundachtzigtausendneunhundertzweiundfünfzig
Euro).
Die so gezeichneten Aktien sind voll eingezahlt, durch Sacheinlage der Gesamtheit der Vermögenswerte und
Schulden der vorgenannten Gesellschaft, bestehend aus
- allen Anteilen der BERTELSMANN ONLINE VERWALTUNGS, GmbH (umbenannt in NET FIN ONLINE VERWAL-
TUNGS, GmbH durch Gesellschafterbeschluß vom 25 November 1999), einer Gesellschaft nach deutschem Recht mit
Sitz in Gütersloh, Deutschland, für welche 40.739.311 (vierzig Millionen siebenhundertneununddreißigtausenddreihun-
dertelf) B Stammaktien der Gesellschaft zugeordnet werden, numeriert von 59.260.690 (neunundfünfzig Millionen
zweihundertsechzigtausendsechshundertneunzig) bis 100.000.000 (hundert Millionen).
Die Übertragung der obengenannten Anteile erfolgt steuerneutral gemäß europäischer Fusionsrichtlinie vom 23. Juli
1990 unter Buchwertverknüpfung nach § 23 Absatz 4 Umwandlungssteuergesetz und § 26 Absatz 2 Umwandlungssteu-
ergesetz. Der zum Zeitpunkt der Übertragung übermittelte steuerliche Buchwert beträgt hundertfünfundzwanzig
Millionen achtundvierzigtausendsiebenhundertfünftausend Deutschmark fünfundfünfzig Pfennig (DEM 125.048.705,55).
Etwaige Änderungen aufgrund nachfolgender Betriebsprüfungen werden über Kapitalrücklage angepaßt. Die so einge-
brachten Anteile dürfen innerhalb der sieben (7) nachfolgenden Jahre ausschließlich im Rahmen von § 26 Absatz 2
Umwandlungssteuergesetz steuerneutral innerhalb der EU übertragen werden. Jegliche Übertragung ist nur mit
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Aktionär BERTELSMANN ONLINE BETEILIGUNGS, GmbH zulässig.
- der Geldsumme von EUR 55.327,- (fünfundfünzigtausenddreihundertsiebenundzwanzig Euro).
- emer Verpflichtung durch Gründungskosten von EUR 1.763,- (tausendsiebenhundertdreiundsechzig Euro).
Der Wert dieser Aktien wird beschrieben in einem Bericht der Treuhandgesellschaft H.R.T. REVISION, S.à r.l.,
Wirtschaftsprüfer in Luxemburg, mit Datum vom 21. Dezember 1999.
Die Schlußfolgerung dieses Berichts lautet:
«Based on the work performed and described above, we have no observation to mention on the value of the contri-
bution in kind which corresponds at least in number and nominal value to 250,000,000 shares of nominal value EUR 1.25
each to be issued, increased by a share premium of EUR 212,144,514.-»
Dieser Bericht ist dieser Urkunde als Anlage beigefügt.
Der Beweis der Unterzeichnung dieser Kapitalerhöhung wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher dies
ausdrücklich bestätigt.
Die Gesamteinlage von EUR 462.144.514,- (vierhundertzweiundsechzig Millionen einhundertvierundvierzigtausend-
fünfhundertvierzehn Euro), welche erfolgt ist wie oben beschrieben und von der Versammlung angenommen worden ist,
besteht aus einer Kapitaleinlage von EUR 250.000.000,- (zweihundertfünfzig Millionen Euro), einer Bargeldzahlung von
EUR 31.000,- (einunddreißigtausend Euro) und einer Ausgabeprämie von EUR 212.144.513,- (zweihundertzwölf
Millionen hundertvierundvierzigtausendfünfhundertdreizehn Euro).
Da die Sacheinlage aus allen Aktiva und Passiva einer Gesellschaft der Europäischen Union besteht, sind gemäß Artikel
4-1 des Gesetzes vom 29. Dezember 1971, einschließlich nachfolgender Änderungen, sämtliche Bedingungen erfüllt, um
die vorgenannte Einlage von der Gesellschaftssteuer zu befreien.
<i>Zweiter Beschlußi>
Die Versammlung beschließt, das Gesellschaftskapital von EUR 250.031.000,- (zweihundertfünfzig Millionen einund-
dreißigtausend Euro) auf EUR 250.000.000,- (zweihundertfünfzig Millionen Euro) durch Annullierung von 24.800
(vierundzwanzigtausendachthundert) eigenen Aktien mit einem Nennwert von EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig
Cents), welche von der Gesellschaft gehalten werden.
Das Produkt dieser Herabsetzung des Kapitals wird nicht ausgeschüttet und wird der Kapitalrücklage der Gesellschaft
zugeordnet.
<i>Dritter Beschlußi>
Die Versammlung beschließt, die bestehende Satzung der Gesellschaft neu zu formulieren:
10142
Gesellschaftsform und Bezeichnung - Sitz - Dauer - Geschäftszweck
Art. 1. Gesellschaftsform und Bezeichnung
Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) unter der Bezeichnung AOL EUROPE S.A. (die «Gesellschaft»).
Art. 2. Sitz
2.1 Der Gesellschaftssitz befindet sich in der Stadt Luxemburg. Er kann durch Beschluß der Generalversammlung der
Aktieninhaber an jeden anderen beliebigen Ort innerhalb des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden, in der Art
und Weise wie es für die Abänderungen der Artikel vorgesehen ist.
Der Gesellschaftssitz kann innerhalb der Grenzen des Großherzogtums Luxemburg durch einen einfachen Beschluß
des Verwaltungsrates verlegt werden.
2.2 blanko
2.3 Im Fall wo außergewöhnliche politische oder kriegerische oder wirtschaftliche oder soziale Ereignisse auftreten
oder unmittelbar bevorstehen würden, welche den gewöhnlichen Geschäftsverlauf der Gesellschaft an ihrem Sitz oder
die Kommunikation mit Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, kann der Sitz zeitweilig und bis zur völligen
Normalisierung der Lage ins Ausland verlegt werden. Eine solche Verlegung wird jedoch keinen Einfluß auf die Staatszu-
gehörigkeit der Gesellschaft, welche eine Luxemburger Gesellschaft bleibt.
Diese zeitweilige Verlegungserklärung des Gesellschaftssitzes ins Ausland wird durch das leitende Organ durchge-
führt, das in diesen Umständen am Besten geeignet ist und zur Kenntnis der Dritten gebracht.
Art. 3. Dauer
Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Art. 4. Zweck der Gesellschaft
4.1 Zweck der Gesellschaft sind der Handel mit On-Line Dienstleistungen und anderen interaktiven und damit
verbundenen Dienstleistungen, alle Aktivitäten die in direkter oder indirekter Weise den Erwerb von Beteiligungen in
Gesellschaften oder Unternehmen jeder Art und Form betreffen, die On-Line Dienstleistungen und andere interaktive
und damit verbundenen Dienstleistungen, die Verwaltung, die Geschäftsführung, die Kontrolle und die Entwicklung
dieser Beteiligungen; diese Aktivitäten beinhalten ohne Einschränkung, die Beurteilung, Überwachung und Kontrolle der
Geschäftsaktivitäten und finanziellen Daten und Informationen und die Vorbereitung von Berichten und Analysen für die
aktiven Gesellschafter.
4.2 Die Gesellschaft kann zusätzlich eine Brieftasche von Wertpapieren, Patenten und Lizenzen schaffen, verwalten,
entwickeln und über diese verfügen, jeder Art und Herkunft, um durch Anlegen, Zeichnung, Übernahmen oder
Optionen Wertpapiere, Patente und Lizenzen zu erlangen, um sie durch Verkauf, Übertragung oder Tausch durch
andere Art und Weise zu realisieren, und um Gesellschaften oder zum Nutzen von Gesellschaften in denen die Gesell-
schaft Beteiligungen hat und/oder die ihre Tochtergesellschaften (so wie hiernach definiert) sind, Unterstützung,
Darlehen, Vorschüsse, und Sicherheiten zu gewährleisten. Tochtergesellschaft heißt alle Gesellschaften, juristischen
Personen oder Handelsgesellschaften (allgemein eine «Körperschaft») in welcher (i) die Gesellschaft direkt oder indirekt
über die Mehrheit der Wahirechte verfügt, oder (ii) Körperschaften in denen die Gesellschaft Aktien oder Anteile
besitzt und das Recht hat die Mehrheit der Verwaltungsgeschäftsführungsorgane oder der Überwachungsorgane zu
ernennen oder abzusetzen oder (iii) Körperschaften in denen die Gesellschaft Aktieninhaber ist und, gemäß eines
Abkommens mit anderen Aktieninhabern der Körperschaft, allein die Kontrolle über eine Mehrheit der Wahlrechte der
Körperschaft ausübt.
4.3 Im allgemeinen kann die Gesellschaft ohne Einschränkung alle notwendigen Maßnahmen ergreifen und Aktivitäten
ausführen, kaufmännische und finanzielle Geschäftsabschlüsse sowohl wie Geschäftsabschlüsse betreffend bewegliche
und unbewegliche Dinge einbegriffen, welche zum Erreichen und zur Entwicklung des Gesellschaftszwecks notwendig
oder nützlich erscheinen.
4.4 Die Gesellschaft kann Kredite jeder Art und Form aufnehmen und Pfandbriefe und Schuldverschreibungen
ausgeben.
Aktienkapital - Aktien
Art. 5. Aktien
5.1 Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt EUR 250.000.000,- (zweihundertfünfzigtausend Millionen Euro), einge-
teilt in 100.000.000 (einhundert Millionen) Stammaktien zu EUR 1,25 (ein Euro fünfundzwanzig Cents) jede (die Stamm-
aktien« oder die «B-Aktien») und 100.000.000 (einhundert Millionen) umwandelbare Vorzugsaktien zu EUR 1,25 (ein
Euro fünfundzwanzig Cents) (die «Vorzugsaktien» oder die «A-Aktien»).
5.2 (i) Die Stammaktien und die Vorzugsaktien stellen getrennte Aktienklassen in der Gesellschaft dar. Jedoch sind
ihre Rechte identisch, außer wenn es hiernach spezifisch anders vorgesehen ist. Die Vorzugsaktien haben, gemäß der
Bestimmungen und der Bedingungen wie sie hiernach beschrieben sind, ein Vorzugsrecht auf Ausschüttung des Liquida-
tionsüberschusses, ein Recht auf Vorzugsdividenden und Umwandlungsrechte.
(ii) Bestimmt diese Satzung nichts Gegenteiliges, so (x) muß jeder gemeine Beschluß, welcher der Generalver-
sammlung der Aktieninhaber vorgelegt wird, mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen jeder einzelnen Aktieninhaber-
klasse wie auch mit einer allgemeinen Mehrheit aller Aktieninhaber der Gesellschaft gefaßt werden, und (y) jeder außer-
ordentliche Beschluß, der der Generalversammlung der Aktieninhaber vorgelegt wird, mit einer einfachen Mehrheit der
Stimmen jeder einzelnen Aktienklasse wie auch mit einer einfachen Mehrheit der Stimmen derjenigen Aktieninhaber die
zwei Drittel des Aktienkapital darstellen. Sollte dieses Quorum bei einer Generalversammlung, gemäß Artikel 18.5 der
Satzung nicht erreicht werden, so wird die Versammlung, gemäß den Formalitäten die im Artikel 18.5 der Satzung vorge-
sehen sind, wieder einberufen.
10143
5.3 Die Vorzugsaktien berechtigen ihre Inhaber, im Vorzug gegenüber der Ausschüttung von Dividenden zugunsten
der Inhaber aller anderen Aktien im Stammkapital der Gesellschaft, aus dem Gewinn der Gesellschaft welcher zur
Ausschüttung bereitsteht, eine festgelegte kumulative Vorzugs-Bardividende (hiernach «Vorzugsdividende»), von 3%
(drei Prozent) von USD 117.527.000,- (einhundertsiebzehn Millionen fünfhundertsiebenundzwanzigtausend), zu
erhalten. Der letzere Betrag wird durch alle nichtausgeschütteten Vorzugsdividenden erhöht und durch alle Kapital-
rückzahlungen gemindert. Diese Vorzugsdividende ist, vorbehaltlich des Artikels 5.7 der Satzung, jährlich am 30.
September, ab dem Jahr 2000 zahlbar, mit Berücksichtigung des vorherigen Geschäftsjahr, d.h. daß der zwölfmonatige
Zeitabschnitt am direkten vorherigen 30. Juni endet, unter der Bedingung, daß das erste Geschäftsjahr am 30. Juni
folgend des Gründungsjahres endet. Die Vorzugsaktien sind nicht berechtigt an der Ausschüttung der Dividenden teilzu-
nehmen, welche die Vorzugsdividenden überschreiten.
Zum Zwecke dieser Satzung, ist der anwendbare Wechselkurs zwischen EUR und USD der des letzten Arbeitstages
in Luxemburg des Geschäftsjahres der Gesellschaft, welches dem Geschäftsjahr vorhergeht, in dem das den Wechsel
auslösende Ereignis auftritt.
5.4 Die Inhaber der Vorzugsaktien sind berechtigt, Einberufungsschreiben zu jeglichen Generalversammlungen der
Gesellschaft zu erhalten und an diesen teilzunehmen und sind, vorbehaltlich des Artikel 6.9, berechtigt eine Stimme für
jede von ihnen gehaltene Vorzugsaktie abzugeben.
5.5 Die Inhaber von Stammaktien sind berechtigt, Einberufüngsschreiben zu jeglichen Generalversammlungen der
Gesellschaft zu erhalten und an diesen teilzunehmen und sind, vorbehaltlich des Artikel 6.9, berechtigt, eine Stimme für
jede von ihnen gehaltene Aktie abzugeben.
5.6 Solange wie die aufgelaufenen Vorzugsdividenden nicht ausgeschüttet oder vollständig ausbezahlt worden sind,
wird keine Dividende, weder in bar noch in Natura, erklärt oder ausgeschüttet, noch wird eine Ausschüttung auf den
Stammaktien gemacht, noch werden Stammaktien von der Gesellschaft zurückgezahlt oder zurückgekauft (außer für
Rückzahlungen oder Rückkäufe von Stammaktien, die von der Gesellschaft, gemäß Abkommen, denen der Verwal-
tungsrat der Gesellschaft zugestimmt hat, mit der Zustimmung der A Verwaltungsratsmitglieder, durchgeführt werden,
und die es der Gesellschaft erlauben solche Aktien, nach Beendigung von Dienstleistungen für die Gesellschaft oder
unter Ausübung des Vorkaufsrechtes der Gesellschaft bei erwogener Abtretung, zu zurückzuzahlen oder zurückzu-
kaufen). Die Bestimmungen des Artikels 5.6 beziehen sich nicht, unbeschadet der zwingenden Bestimmungen des luxem-
burgischen Gesellschaftsgesetz, auf
(i) einen Erwerb von Stammaktien im Umtausch gegen die Ausgabe von anderen Stammaktien, vorausgesetzt, daß die
vorhergesehene Zahl der so herausgegebenen Stammaktien nicht die Zahl der so erworbenen Stammaktien
überschreitet oder auf,
(ii) einen, von der Gesellschaft durchgeführten Aktienerwerb oder -Rückzahlung, dem die Verwaltungsmitglieder
einstimmig zugestimmt haben.
5.7. Solange die Nettoeinkünfte der Gesellschaft (wie hiernach defmiert) jedes Geschäftsjahr USD 9.000.000,- (neun
Millionen US Dollar) überschreiten, schüttet und zahlt die Gesellschaft, insofern durch die Bestimmungen des Luxem-
burger Gesellschaftsrechts erlaubt, die Vozugsdividenden aus. «Nettoeinkommen» bedeutet konsolidiertes Nettoein-
kommen nach Besteuerung, und Nettoverlust bedeutet konsolidierter Nettoverlust nach Besteuerung, welche in jedem
Fall, gemäß den US allgemein angenommenen Buchhaltungsgrundsatzen (US General) Accepted Accounting Principles,
«US GAAP») ausgerechnet werden, vorausgesetzt, daß in dem Fall wo, die in Luxemburg angewendete Buchhaltungs-
praxis strenger oder restriktiver ist, letztere Anwendung findet.
5.8.1 Im Falle eines Kapitalrückschusses bei Liquidation wird die Aktivmasse der Gesellschaft, die zur Verteilung
zwischen den Aktieninhabern verfügbar ist, wie folgt verwendet:
(i) zuerst, zur Rückzahlung an die Inhaber der Vorzugsaktien (falls solche Aktien zu diesem Zeitpunkt ausstehen) des
Betrags von USD 117.527.000,- (hundertsiebzehn Millionen fünfhundertsiebenundzwanzigtausend U.S. Dollars),
zusammen mit einem Betrag gleichwertig zu Zahlungsrückständen und Auflaufen von nicht gezahlten Vorzugsdividenden,
welcher auf den Tag des Kapitalrückzahlung zurückgerechnet wird und ausgezahlt wird, ob die Vorzugsdividende erklärt
oder gezahlt worden ist oder nicht, abzüglich jeglicher Kapitalrückzahlungen (das «Vorzugsrecht bei Liquidation»).
(ii) zweitens, nach der vollständigen Auszahlung des Vorzugsrechts bei Liquidation, sind die Inhaber der B Stamm-
aktien berechtigt, von dem Gesellschaftsvermögen eine dem Vorzugsrechts bei Liquidation gleichgestellten Summe,
wenn vorhanden, ausgezahlt zu bekommen (das «Nachholrecht der Stammaktien»), und
(iii) der Überschuß wird anteilsmaßig zwischen den Inhabern der Vorzugsaktien und den Inhabern der B Stammaktien
verteilt.
5.9. Wenn, bei Liquidation, Verteilung oder Auflösung, die Aktivmasse der Gesellschaft nicht ausreichen würde, um
das Vorzugsrecht bei Liquidation vollständig an alle Inhaber der Vorzugsaktien auszuzahlen, dann wird die Aktivmasse
zwischen den Inhabern der Vorzugsaktien, im Verhältnis zu den Summen, zu denen Sie andernfalls beziehungsweise
berechtigt gewesen wären, verteilt. Sollte, nach der Auszahlung und Befriedigung des Vorzugsrechts bei Liquidation, die
bleibende Aktivmasse der Gesellschaft nicht ausreichend sein um alle Inhaber der Stammaktien der Nachholrecht der
Stammaktien vollständig zu bezahlen, so wie es in Artikel 5.8.(ii) vorgesehen ist, dann wird die bleibende Aktivmasse
zwischen den Inhabern der B Stammaktien, und danach zwischen den Inhabern der anderen Stammaktienklassen im
Verhältnis zu den Summen, zu denen Sie andernfalls beziehungsweise berechtigt gewesen wären, verteilt.
Art. 6. Umwandlung
Die folgenden Bestimmungen betreffen die Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien:
6.1 Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 6, sind voll eingezahlte Vorzugsaktien ohne weitere Maßnahmen
ihrer Inhaber und/oder der Inhaber der Stammaktien und ungeachtet ob Bescheinigungen solcher Aktien der Gesell-
schaft ausgehändigt worden sind, automatisch in voll eingezahlte A Stammaktien umwandelbar, durch Kapitaleinlage von
Personen oder einer Körperschaften, welche nach dem ersten Ausgabetag von Vorzugsaktien keine «Tochtergesell-
10144
schaften», wie in Artikel 4.2 dieser Satzung definiert, oder «Gesellschaftsmitglieder», oder andere Aktieninhaber der
Gesellschaft sind (eine «Qualifizierte Drittpartei»), durch welche (a) eine solche qualifizierte Drittpartei Stamniaktien
der Gesellschaft oder in Stammaktien umwandelbare Wertpapiere erwirbt (eine «Kapitaleinlage einer Qualifizierten
Drittpartei») und (b) die Kasseneinträge der Gesellschaft (vor Nachlässen, Kommissionen, Gebühren) durch solchen
Geschäftsabschluß, welche gleich (i) USD 60.000.000,- (sechzig Millionen US. Dollars) oder (ii) 30 % (dreißig Prozent)
des angemessenen Marktwerts der Gesellschaft welcher in gutem Glauben von der Mehrheit der A Verwaltungsrats-
mitglieder und der Mehrheit der B Verwaltungsratsmitglieder festgelegt wird, oder diese Beträge überschreiten.
6.2 Die Inhaber der Vorzugsaktien haben zu jeder Zeit das Recht, zwischen dem ersten und dem letzten Tag, beide
einbegriffen, des Geschäftsjahres, das dem ersten Geschäftsjahr in dem das Gesellschaftsnettoeinkommen (so wie es in
Artikel 5.7. der Satzung definiert ist) nicht unter USD 9.000.000,- (neun Millionen U.S. Dollars) liegt, folgt, Vorzugsaktien
(zu solchen Zwecken, alle aufgelaufenen doch nicht bezahlten Dividenden einbegriffen) in A Stammaktien umzuwandeln.
6.3 Nach einer Umwandlung von Vorzugsaktien in Stammaktien, werden alle Verweisungen auf Vorzugsaktien Verwei-
sungen auf A Stammaktien.
Vorzugsaktien der Gesellschaft sind in A Stammaktien umwandelbar, mit einem Umwandelratio von 1 (einer) A
Stammaktie per Vorzugsaktie. Das Umwandelrecht wird für alle Vorzugsaktien ausgeübt und kann nicht teilweise
ausgeübt werden.
6.4 Die Inhaber der B Stammesaktien haben jederzeit das Recht, unter der Bedingung daß die Mehrheit der A Verwal-
tungsratsmitglieder und die Mehrheit der B Verwaltungsratsmitglieder dem zustimmt, ihre B Stammaktien ganz oder
teilweise in C Stammaktien umzuwandeln.
B Stammaktien sind in C Stammaktien umwandelbar, mit einem Umwandelratio von 1 (einer) C Stammaktie per B
Stammesaktie. Das Umwandelrecht wird für alle Vorzugsaktien ausgeübt und kann nicht teilweise ausgeübt werden.
6.5 blanko
6.6 Nach Umwandlung der Vorzugsaktien oder der B Stammaktien gibt jeder Inhaber solcher Aktien sofort seine
Bescheinigung oder alle Bescheinigungen am Gesellschaftssitz ab. Die Gesellschaft ist nicht gezwungen, Bescheinigungen
auszugeben, welche die folgende Ausgabe von A Stammaktien oder C Stammaktien nach einer solchen Umwandlung
bestätigt, es sei denn alle Bescheinigungen die Vorzugsaktien oder B Stammaktien darstellen, wurden, wie oben
beschrieben, ausgehändigt, oder wenn die Inhaber der Gesellschaft zur melden, daß die Bescheinigungen verloren,
gestohlen, verstümmelt oder zerstört worden sind, und sie ein für die Gesellschaft zufriedenstellendes Abkommen
ausführt, in dem sie sich bereit erklären, die Gesellschaft für die im Verhältnis mit den Bescheinigungen aufgekommenen
Unkosten Entschädigung zahlen. Daraufhin wird diesem Inhaber sofort, und in seinem Namen, so wie es aus solchen
abgegebenen Bescheinigungen hervorgeht, eine Bescheinigung oder Bescheinigungen ausgegeben und zugestellt, für die
Zahl der Vorzugsaktien oder der B Stammaktien die am Tag der automatischen Umwandlung in A Stammaktien oder der
Umwandlung in C Stammaktien umwandelbar waren.
6.7 Wenn die auszugebenden A Stammaktien, nach der Umwandlung der Vorzugsaktien in eine gleiche oder eine
andere Zahl von Aktien einer anderen Klasse oder Klassen umgeändert werden sollte, ob durch Reklassifizierung oder
durch Unterteilung oder Konsolidierung solcher Aktien, oder eine Aktiendividende oder eine Ausgabe von Rechten, hat
jeder Inhaber von Vorzugsaktien, nachstehend das Recht, solche Aktien in die Art und den Betrag von Aktien und
anderen Wertpapieren umzuwandeln, welche in diesem Fall den Inhabern der größten Zahl von A Stammaktien gleich
vor dem Ereignis zustehen würde, alles vorherstehende vorbehaltlich weiterer Anpassungen wie hierin oder in denen
die Wertpapiere regelnden Bestimmungen vorgesehen.
6.8 Wenn zu einem Zeitpunkt eine Kapitalreorganisation, welche nicht in diesem Artikel 6 vorgesehen ist, stattfindet,
dann wird in dieser Kapitalreorganisation bestimmt, daß die Inhaber von Vorzugsaktien berechtigt sind, nach
Umwandlung der Vorzugsaktien die Zahl von Aktien oder Wertpapieren oder Eigentum der Gesellschaft zu bekommen,
zu welchen ein Inhaber von A Stammaktien welche nach Umwandlung lieferbar sind, berechtigt wäre im Rahmen dieser
Kapitalreorganisation, vorbehaltlich weiterer Anpassungen wie hierin oder in denen die Wertpapiere regelnden Bestim-
mungen vorgesehen. In einem solchen Fall, wird die angemessene Anpassung, unter Anwendung der Bestimmungen
dieses Artikels 6 bezüglich der Rechte der Inhaber von Vorzugsaktien nach Kapitalreorganisation, in dem Masse wo die
Bestimmungen des Artikels 6 (einschließlich die Anpassung der nach Umwandlung der Vorzugsaktien auszugebenden
Aktienzahl) noch nach diesem Ereignis Anwendung fmden (und so gleichwertig als möglich).
6.9 Sollten die Inhaber der Vorzugsaktien es vorziehen, nicht alle Vorzugsaktien in voll einbezahlte A Stammaktien in
der in Artikel 6.2 vorgesehenen Zeitspanne umzuwandeln, dann geht der Nießbrauch (usufruit) der Vorzugsaktien,
bestehend aus dem Stimmrecht bei allen Generalversammlungen der Gesellschaft auf CYBER FIN S.A. über, ausser daß
der bloße Eigentümer (nu-propriétaire) das Stimmrecht behält (und sein Einverständnis nötig ist) für alle Handlungen
welche in Artikel 18.8 (a), (c), (d) und (e) vorgesehen sind. Mit Ausnahme der Bestimmungen dieses Artikels 6.9 können
die bloßen Eigentümer alle Rechte ausüben und sind berechtigt auf alle gesezlichen Vorteile und Vorteile, welche in
dieser Satzung vorgesehen sind.
Art. 7. Kapitalaufforderungen - Rückkauf - Ansprüche
7.1.1 Unbezahlte Beträge, wenn welche, aus ausgegebenen und ausstehenden Aktien können in jedem Moment vom
Verwaltungsrat, nach seinem freien Ermessen, zur Zahlung gefordert werden, jedoch unter der Bedingung daß diese
Zahlungsaufforderungen auf allen Aktien in der gleichen Proportion und im gleichen Zeitpunkt gemacht werden. Jede
Summe, deren Zahlung in Schwebe ist, produziert automatisch zugunsten der Gesellschaft Zinsen zu einem Zinssatz von
7 Prozent pro Jahr, welche von dem Tag zu laufen beginnt, an dem die Zahlung fällig war.
7.2 Die Gesellschaft kann:
(i) Gesellschaftsaktien rückkaufbare oder optionell rückkaufbare Aktien ausgeben, welche auf Option der Gesellschaft
oder der Aktionäre gemäß der Bedingungen und der Art und Weise wie sie von der Gesellschafterversammlung (durch
außerordentlichen Beschluß der Gesellschaft) auf Empfehlung der Verwaltungsratsmitglieder festgelegt worden sind,
10145
(ii) eigene Aktien (einschließlich Rückkaufsaktien und ohne Erwerbspflicht auf proportionneller Basis zwischen Aktien-
inhabern einer gleichen Klasse) erwerben und diese gleich annullieren oder sie als Schatzakten halten; jedoch unter der
Bedingung, daß die Gesellschaft nicht zu jedem Zeitpunkt Vorzugsaktien zurückkauft oder erwirbt.
7.3 Die Gesellschaft hat ein Pfandrecht auf jede Aktie für alle Beträge (ob sofort zahlbar oder nicht), welche zu einem
bestimmten Zeitpunkt gefordert oder zahlbar in Bezug auf diese Aktie sind, und die Gesellschaft hat auch ein Pfandrecht
auf alle Aktien, die auf den Namen einer Person oder Körperschaft registriert sind, ob diese die Alleininhaber sind oder
einer von vielen Inhabern, betreffend die Beträge die direkt durch diesen oder durch seine Vermögensmasse zahlbar
sind. Das Pfandrecht der Gesellschaft schließt alle zahlbaren Dividenden ein.
Art. 8. Genehmigtes Stammkapital
Das bereits genehmigte, einschliesslich das ausgegebene, Stammkapital der Gesellschaft ist auf EUR 1.000.000.000,-
(eine Milliarde Euro) festgelegt. Es kann ausgegeben werden und der Verwaltungsrat kann es nach freiem Ermessen der
A Verwaltungsratsmitglieder und der B Verwaltungsratsmitglieder, bis zum Betrag des genehmigten Stammkapitals,
durch einen von der Mehrheit der A Verwaltungsratsmitglieder und der Mehrheit der B Verwaltungsratsmitglieder
angenommenen Beschluß, als B Stammaktien oder C Stammaktien (zusammen mit den A Stammaktien, nach
Umwandlung der Vorzugsaktien, die «Stammaktien«) oder als Vorzugsaktien durch Beschluß einer Mehrheit der A
Verwaltungsratsmitglieder und der Mehrheit der B Verwaltungsratsmitglieder ausgeben. Diese dem Verwaltungsrat
anvertraute Befugnis läuft fünf Jahre nach dem 22ten Dezember 1999 aus, kann aber auch von der Gesellschafterver-
sammlung vorher entzogen oder abgeändert oder für eine oder mehrere Perioden erneuert werden, welche jedoch von
dieser Erneuerung an keine fünf Jahre überschreiten dürfen. Bevor diese Befugnis abläuft, kann die Gesellschaft Angebote
oder Abkommen machen, welche nach dem Ablaufen dieser Befugnis, betreffende Wertpapierausgaben mit sich bringen
würden und die Verwaltungsratsmitglieder können die betreffenden Wertpapiere in Sicht solcher Angebote oder
Abkommen ausgeben.
Die Bestimmungen betreffend das Vorkaufsrecht, welches im Gesetz über die Handelsgesellschaften vorgesehen ist,
sind, wenn der Verwaltungsrat zu diesem Zweck einen Beschluß fasst, nicht auf die vom Verwaltungsrat vorgenommene
Ausgabe von Kapitalwertpapieren oder Schuldverschreibungen, die in Kapitalwertpapiere umwandelbar sind, anwendbar
im Kontext der Genehmigung dieses Artikel 8. Beschlüsse, die vom Verwaltungsrat gefasst werden und welche die
Aktieninhaber von ihren Vorkaufsrechten ausschließen oder diese verringern, müssen von der Mehrheit A Verwal-
tungsratsmitglieder und der Mehrheit der B Verwaltungsratsmitglieder angenommen werden. Die dem Verwaltungsrat
anvertrauten Befugnisse beinhalten die Ausgabe von Optionen, Anteilsbezugsrechten, und von vorbehaltlichen Aktien im
Rahmen eines Optionsplanes für Angestellte und anderer Aktienpläne für Angestellte, denen die Aktionäre zugestimmt
haben und von Aktien im Rahmen von ernployee stock benefit plans die wie Erstere von Zeit zu Zeit von den Aktionären
angenommen werden. Der Verwaltungsrat ist befugt, nach seinem eigenen Ermessen die praktischen Bedingungen
(einschließlich aber nicht begrenzt auf die Übertragung von Befugnissen betreffend die praktischen Aspekte dieser Pläne
an eine oder mehrere Kommissionen), unter denen die Optionen der Angestellten der Gesellschaft und ihrer Tochter-
gesellschaften bewilligt werden, und unter denen die Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden, nach Ausübung dieser
Optionen, festzusetzen, unter der Bedingung, daß eine solche Festlegung schriftlich erolgt und in Einklang mit den
Optionsplänen für Angestellte oder Aktienpläne für Angestellte, oder gegebenfalls mit dem employee benefit plans ist,
wie es von Zeit zu Zeit von den Aktionären angenommen.
Der Verwaltungsrat ist befugt und beauftragt, die für alle Zeichnungen anwendbaren Bedingungen zu bestimmen, oder
er kann von Zeit zu Zeit sich beschliessen, das Kapital heraufzusetzen durch ganze oder teilweise Umwandlung von
einem Nettogewinn der Gesellschaft in Stammkapital, sowie die Zuordnung von ganz eingzahlten Aktien an die
Aktionäre anstatt von einer Ausschüttung von Dividenden.
Der Verwaltungsrat ist außerdem befugt, gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Bedingungen, umwandelbare
Obligationen oder assimiierte Mittel oder Obligationen mit Zeichnungsrechten oder finanzielle Schuldinstrumente, die
in Aktien umwandelbar sind, auszugeben.
Jedes Mal wenn der Verwaltungsrat, so wie es erlaubt ist, eine Kapitalerhöhung durchführen will, wird Artikel 5 der
Satzung auf Initiative des Verwaltungsrat insofern abgeändert, daß er eine solche Kapitalerhöhung widerspiegelt. Der
Verwaltungsrat muß in diesem Fall eine Person beauftragen oder ihr die Erlaubnis geben, die notwendigen Schritte zu
unternehmen hinsichtlich einer Eintragung durch notarielle Urkunde und Veröffentlichung einer solchen Abänderung.
Art. 9. Aktienregister - Bescheinigungen
9.1. Aktien der Gesellschaft sind und bleiben Namensaktien.
9.2. Am Gesellschaftsitz wird ein Aktienregister geführt, welches jedem Aktionär zur Einsicht offensteht. Das
Eigentum an einer Aktie wird durch die Eintragung in das genannte Register begründet.
9.3. Bescheinigungen dieser Eintragungen werden von einem Abreißregister genommen, und von dem Vorsitzenden
des Verwaltungsrats und einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterschrieben.
9.4. Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie. Im Fall wo eine Aktie von mehr als einer Person gehalten
wird, hat die Gesellschaft das Recht, die Ausübung der diesbezüglichen Rechte auszusetzen, bis eine einzige Person ihr
gegenüber als alleiniger Inhaber bezeichnet ist. Die gleiche Regel wendet sich im Fall eines Interessenstreits zwischen
dem Pfandgeber und dem Pfandnehmer.
Der Nutznießer und der bloße Eigentümer einer Aktie, so wie von Artikel 6.9 der Satzung definiert, werden immer
als einzelner Inhaber angesehen. Die Einstellung der an der Aktie haftenden Rechte, wie es hiervor vorgesehen ist, ist in
diesem Fall nicht anwendbar.
Verwaltung - Beaufsichtigung
Art. 10. Ernennung und Abberufung der Verwaltungsmitglieder
10.1. Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens vier und aus höchstens acht
Mitgliedern besteht, welche Aktionäre der Gesellschaft sind oder nicht, die von der Gesellschafterversamrnlung für eine
10146
erneubare Amtszeit gewählt werden, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf. Die Inhaber von mindestens der
Mehrheit der Vorzugsaktien schlagen zur Ernennung eine gewisse Zahl von Verwaltungsratskandidaten vor, die, wenn
sie von der Gesellschafterversammlung gewählt werden, als A Verwalter fungieren, und desgleichen schlagen die Inhaber
von mindestens der Mehrheit der Stammaktien, zur Ernennung eine gleiche Zahl von Verwaltungsratskandidaten vor,
die, wenn sie von der Gesellschafterversammlung gewählt werden, als B Verwalter fungieren. Die Gesellschaft hat immer
eine gleiche Anzahl von A und B Verwaltern. Die Verwalter können zu jeder Zeit, auf Empfehlung derjenigen Aktionärs-
klasse, die diese Verwalter vertritt, und mit der Zustimmung der Gesellschafterversammlung, ihres Amtes enthoben
werden.
10.2. Zurücktretende Mitglieder des Verwaltungsrats sind wiederwählbar.
10.3 Wird im Verwaltungsrat eine Stelle durch Sterbefall, Zurücktreten oder durch andere Umstände frei, so
versammeln sich die verbleibenden Verwalter und wählen mit Stimmenmehrheit einen Verwalter, welcher diesen Posten
bis zur nächsten Gesellschafterversammlung, besetzt. Ein A Verwalter wird durch einen Verwalter unter den Verwal-
tungsratskandidaten, die in der direkt vorhergehenden Gesellschafterversammlung, von den Inhabern der Vorzugsaktien
vorgeschlagen und nicht gewählt worden war, oder wenn in dieser direkt vorhergehenden Gesellschafterversammlung
alle Kandidaten gewählt worden sind, oder wenn einige der Kandidaten nicht bereit sind ein solches Mandat
anzunehmen, dann aus der Liste der Kandidaten, die von den Inhaber(n) der Vorzugsaktien vorgeschlagen worden ist,
ersetzt, und umgekehrt, wird ein B Verwalter durch einen Verwalter unter den Verwaltungsratskandidaten, die in der
direkt vorhergehenden Gesellschafterversammlung, von den Inhabern der Stammaktien vorgeschlagen und nicht gewählt
worden war, oder wenn in dieser direkt vorhergehenden Gesellschafterversammlung alle Kandidaten gewählt worden
sind, oder wenn einige der Kandidaten nicht bereit sind ein solches Mandat anzunehmen, dann aus der Liste der Kandi-
daten, die von den Inhaber(n) der Stammaktien vorgeschlagen worden ist, ersetzt.
10.4 Der Verwaltungsrat handelt im Einklang mit den internen Vorschriften und Regelungen, (die «Internen
Vorschriften und Regelungen»), so wie sie in seiner ersten Versammlung festgelegt worden sind, und wie sie von später,
durch einen Beschluß des Verwaltungsrates, mit Stimmenmehrheit jeder Verwalterklasse, abgeändert und ergänzt
werden. Die Internen Vorschriften und Regelungen verpflichten alle Gesellschaftsorgane.
Art. 11. Verwaltungsratssitzungen - Beschlüsse
11.1 Der Verwaltungsrat bestimmt innerhalb seiner Mitglieder einen Vorsitzenden des Verwaltungsrats. Späterhin
kann er einen Schriftführer wählen, der kein Mitglied des Verwaltungsrates zu sein braucht, und welcher die Aufgabe hat,
die Sitzungsprotokolle des Verwaltungsrat zu verwalten.
Der erste Vorsitzende des Verwaltungsrats wird von der Gesellschafterversammlung ernannt.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats führt bei allen Gesellschafterversammlungen der Aktieninhaber und Verwal-
tungsratsversammlungen den Vorsitz. Beide Verwalterklassen halten abwechselnd und auf einer turnusmäßigen Basis das
Amt des Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats vertritt sein Amt, vom Tag seiner Ernennung an, während
zwölf Monaten, und wird von einem Verwaltungsratsmitglied, das von der Kandidatenliste der Aktienklasse gewählt
wird, welche keinen Kandidaten für den Vorsitz vorgeschlagen hat, abgelöst.
11.2. Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von wenigstens einem A
Direktor und von wenigstens einem B Direktor einberufen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden einzeln zu jeder Verwaltungsratssitzung eingeladen.
Außer in Notfällen, welche in der Einladung angemerkt werden, oder mit dem vorherigen Einverständnis all derje-
nigen die berechtigt sind beizuwohnen, wird mindestens zwei Kalendertage vor der Sitzung eine schriftliche schriftliche
Ankündigung der Verwaltungsratssitzungen herausgegeben.
Die Verwaltungsratssitzung wird, auch in Abwesenheit einer vorhergehenden Einladung, ordnungsgemäß abgehalten,
wenn alle Verwaltungsratsmitglieder ordnungsgemäß anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind.
Die Verwaltungsratssitzungen fmden an dem Ort, an dem Tag, und an der Uhrzeit statt, die in der Einladung
angegeben ist. Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.
Auf diese Einladung kann mit der Zustimmung jedes einzelnen Verwaltungsratsmitglied, schriftlich, durch Telefax oder
durch Telegramm oder durch Telex, verzichtet werden. Für Verwaltungsratssitzungen, die an Tagen und Orten
abgehalten werden, die in einem Arbeitsplan, der vorher durch Beschluß des Verwaltungsrates angenommen worden ist,
ist eine separate Einladung nicht erforderlich.
Jedes A Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Verwaltungsratssitzung teilnehmen, in dem es schriftlich, durch Telefax
oder durch Telegramm oder durch Telex, ein anderes A Verwaltungsratsmitglied als seinen Bevollmächtigten ernennt,
und desgleichen kann jedes B Verwaltungsratsmitglied ein anderes B Verwaltungsratsmitglied als seinen Bevollmächtigten
ernennen.
Ein A Verwaltungsratsmitglied kann mehr als einen der anderen A Verwaltungsratsmitglieder vertreten, und
umgekehrt, kann ein B Verwaltungsratsmitglied mehr als einen der anderen B Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann an einer Verwaltungsratssitzung, durch Telefon oder Video Konferenzschaltung
oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es allen Personen erlaubt, die an der Sitzung
teilnehmen, sich gegenseitig zu hören. Die Teilnahme an einer Sitzung durch diese Mittel gilt als persönliche Teilnahme
an der Sitzung, und die Sitzung wird als in Luxemburg abgehalten erachtet.
11.3. Rundbeschlüsse, die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet sind, sind genauso gültig und genauso
bindend wie wenn die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Solche Unterschriften können
auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden.
11.4. (a) Zwei A Verwaltungsratsmitglieder und zwei B Verwaltungsratsmitglieder bilden das nötige Quorum flär die
von den Verwaltungsratsmitgliedern getätigten Geschäftsabschlüssen. Wenn dieses Quorum eine Stunde vor der
Verwaltungsratssitzung, nicht vorhanden ist, wird die Verwaltungsratssitzung zur gleichen Uhrzeit und am gleichen Ort
10147
sieben Kalendertage später erneut einberufen. In der erneut einberufenen Verwaltungsratssitzung bilden das anwesende
Verwaltungsratsmitglied oder die anwesenden Verwaltungsratsmitglieder, unabhängig von der Klasse, außer im Fall
höherer Gewalt, ein Quorum. Die erneute Einladung der Verwaltungsratssitzung vermerkt, daß es sich um eine erneut
einberufene Verwaltungsratssitzung handelt, und daß sie, ungeachtet des anwesenden Quorums, abgehalten werden
kann.
(b) Zum Zwecke der Bestimmung ob das nötige Quorum für die von den Verwaltungsratsmitgliedern getätigten
Geschäftsabschlüssen gebildet ist:
(i) im Fall eines Beschlusses, der von Verwaltungsratsmitgliedern, die miteinander in telefonischer Verbindung durch
Konferenzschaltungsmittel oder anderen Mitteln, die den teilnehmenden Verwaltungsratsmitglieder erlauben, sich
gegenseitig sprechen zu hören, stehen, gefasst wird, werden alle diese Verwaltungsratsmitglieder im Quorum gezählt
und jeder Beschluß der so getroffen wird, ist genauso gültig und genauso bindend wie wenn die Verwaltungsratssitzung
ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre;
(ii) im Fall einer Verwaltungsratssitzung, wird jedes Verwaltungsratsmitglied, das sich in telefonischer Verbindung mit
einer solchen Sitzung befindet, zusätzlich zu den bei der Sitzung anwesenden Verwaltungsratsmitgliedern, in dem
Quorum einberechnet und ist berechtigt zu wählen.
11.5. Verträge und sonstige Geschäfte zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft, Firma oder anderen
Körperschaft werden nicht dadurch beeinträchtigt oder deshalb ungültig, daß ein oder mehrere Verwaltungsratsmit-
glieder oder leitende Angestellte der Gesellschaft an dieser anderen Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ein
persönliches Interesse haben oder dort Verwaltungsratsmitglied, Gesellschafter, leitender oder sonstiger Angestellter
sind. Jedes Verwaltungsratsmitglied und jeder leitende Angestellte der Gesellschaft, welcher als Verwaltungsratsmitglied,
leitender Angestellter oder einfacher Angestellter in einer Gesellschaft, Firma oder anderen Körperschaft ist, mit
welcher die Gesellschaft Verträge abschließt oder sonstige Geschäftsbeziehungen eingeht, wird durch diese Verbindung
mit der anderen Gesellschaft oder Unternehmung nicht daran gehindert, im Zusammenhang mit einem solchen Vertrag
oder einer solchen Geschäftsbeziehung zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.
11.6. Vorbehaltlich der Artikeln 11.7 und 11.8, verlangt jeder Beschluß die Zustimmung der Mehrheit der bei der
Verwaltungsratssitzung anwesenden oder vertretenen, A Verwaltungsratsmitgliedern sowie der Mehrheit der bei der
Verwaltungsratssitzung anwesenden oder vertretenen B Verwaltungsratsmitgliedern.
11.7. Die Verwaltungsratsmitglieder können, mit der Zustimmung der Mehrheit der B Verwaltungsratsmitgliedern
und ohne daß eine separate Zustimmung der A Verwaltungsratsmitgliedern nötig wäre, gemäß den folgenden, kumulativ
zu erfüllenden Bedingungen, eine Interimsdividende verkünden:
(i) die Gesellschaft darf nicht mit einer Bestimmung der Satzung betreffend die Rechte der Inhaber der Vorzugsaktien,
in Verzug geraten;
(ii) Interimsdividenden können nur insofern verkündet werden, wie es unter luxemburgischem Gesellschaftsrecht
erlaubt ist; (iii) solche Dividenden sind aus dem verteilbaren kumulativen Nettoeinkommen auszuzahlen, (und kumula-
tives Nettoeinkommen bedeutet angesammeltes Nettoeinkommen weniger angesammelten Nettoverlust);
(iv) sofort nach Auszahlung solcher Dividenden darf der Betrag des Arbeitskapitals der Gesellschaft nicht unter EUR
10.000.000,- (zehn Millionen Euro) fallen;
(v) die Gesellschaft darf nicht in Verzug sein unter den Bedingungen von Dahrlehensabkommen, Schuldgarantien oder
Verpflichtungen.
11.8 Beschlüsse betreffend die folgenden Angelegenheiten fordern die Zustimmung der Mehrheit von sowohl A und
B Verwaltungsratsmitgliedern, und wenn eine solche Zustimmung nicht erreicht wird, und gemäß Artikel 6.9, fassen die
Aktionäre hinsichtlich der folgenden Entscheidungen, einen Beschluß mit der einfachen Mehrheit der A Aktionäre und
der einfachen Mehrheit der B Aktionäre, welche als separate Klassen stimmen, wie auch der gesamten einfachen
Mehrheit der Aktionäre der Gesellschaft bezüglich jedes solchen Entschlusses:
(a) Annahme von Geschäftsplänen für die Gesellschaft, oder Zustimmung einer Umänderung eines Zweigstelle oder
einer anderen Bestimmung eines Geschäftsplans in Bezug auf die Gesellschaft;
(b) Annahme von strategischen Plänen und von Geschäftsplanungen für die Gesellschaft, und Zustimmung, Aufhebung
oder Abänderung einer strategischen Entscheidung welche langfristig wesentlich für den Geschäftsbetrieb ist;
(c) Abänderung der Geschäftsmethoden betreffend die Geschäftsführung, einschließlich, aber nicht darauf begrenzt,
die Dienstverbindungen die von der Gesellschaft oder ihren Tochtergesellschaften angeboten werden, von Computer-
programmen, die von der Gesellschaft benützt werden oder den Inhalt welcher von der Gesellschaft veröffentlicht wird,
der Abschluß, die Beendigung oder die Abänderung eines wesentlichen Vertrags mit AMERICA ONLINE, INC. oder
BERTELSMANN AG. oder ihren betreffenden Tochtergesellschaften (wie in Artikel 4.2 dieser Satzung definiert) (oder
der Verzicht auf ein wesentliches Recht oder Verpflichtung wie im nachstehenden vorgeschrieben);
(d) Abänderung oder Annehmen eines wesentlichen, von der Gesellschaft angewendetem Buchhaltungsgrundsatz
oder einer Buchhaltungspraxis;
(e) Genehmigung der Aufnahme eine Darlehens oder der Gewährung eines Kredits oder die Gewährung von
Bürgschaften oder Anlagekosten durch die Gesellschaft den Gesamtbetrag von EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro) (oder
seine Gleichwertigkeit in einer anderen Währung) innerhalb einen Jahres übersteigen;
(f) Anfang eines Rechtsstreits (ohne Berücksichtigung des Streitwertes) oder Schlichtung eines Rechtsstreits zu der
die Gesellschaft eine Partei ist (i) deren Beträge EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro) (oder seine Gleichwertigkeit in einer
anderen Währung) überschreiten oder (ii) der in wesentlicher Art und Weise die Rechte von AMERICA ONLINE, INC.
oder BERTELSMANN AG. oder einer ihrer betreffenden Tochtergesellschaften (wie in Artikel 4.2 dieser Satzung
definiert) ungünstig beeinflusst, außer daß ein Rechtsstreit in bezug auf Eintreibung von Summen, die der Gesellschaft
von Dritten geschuldet werden, nach freiem Ermessen der Geschäftsführung angefangen oder geschlichtet werden
können;
10148
(g) Abschluß von Transaktionen mit AMERICA ONLINE, INC. oder BERTELSMANN AG. oder einer ihrer betref-
fenden Tochtergesellschaften (wie in Artikel 4.2 dieser Satzung definiert), mit Ausnahme von Geschäftsabschlüssen die
auf einer nachlässigen Grundlage abgeschlossen worden sind und die Zahlungen von Gesamtsummen oder Dienstlei-
stungen von einem Wert von weniger als EUR 50.000,- (fünfzigtausend Euro) (oder seine Gleichwertigkeit in einer
anderen Währung) mit sich tragen;
(h) Zustimmung der Gesellschaft zum Abschluß, zur Beendigung oder Abänderung von (i) einer wesentlichen
Bestimmung eines langfristigen Vertrags, der Zahlungen von Gesamtsummen oder Dienstleistungen von einem Wert
von mehr als EUR 50.000.(fünfzigtausend Euro) (oder seine Gleichwertigkeit in einer anderen Währung) mit sich trägt
oder (ii) eines Rentenplans;
(i) Errichtung oder wesentliche Umänderung der Kapitalanlagen und der Kassenverwaltungspolitik der Gesellschaft;
(j) Verkauf von Aktiva außerhalb des normalen Geschäftsgangs;
(k) Zustimmung der Gesellschaft (i) zur Eröffnung einer Geschäftsaktivität welche noch nicht von der Gesellschaft
ausgeübt wird zu dem Zeitpunkt wo diese Aktivität in Betracht gezogen wird, oder nicht von den Satzungbestimmungen
betreffend die Aktivitäten der Gesellschaft, spezifisch vorgesehen ist, oder (ii) zur Einstellung einer Aktivität der sich die
Gesellschaft von Zeit zu Zeit widmet;
(l) Zustimmung der Gesellschaft zum Abschluß einer Partnerschaft, eines Beteiligungsgeschäfts oder eines Konsor-
tiums mit einer anderen juristischen Körperschaft, zur Errichtung einer Tochtergesellschaft oder zum Erwerb oder dem
Verkauf einer Beteiligung oder eines Rechts in einer anderen juristischen Körperschaft;
(m) Ernennung oder Abberufung des Chief Executive Officer (oder hinsichtlich derjenigen Gerichtsbarkeiten die
keinen Chief Executive Officer besitzen, sein Gleichgestellter) der Tochtergesellschaften und ihren direkt Unterge-
stellten;
(n) Freigabe zu Veröffentlichung oder andere öffentliche Erklärungen, die interne Informationen enthalten;
(o) Abschluß von Verträgen betreffend Inhalt, Dienstleistungen, Computerprogrammen, außerhalb des normalen
Geschäftsgangs;
(p) Abschluß von Verträgen mit einem Informationslieferant der Gesellschaft;
(q) Zustimmung zu identischen oder ähnlichen Angelegenheiten wie die unter (a) bis (l) und (n) bis (p) aufgezählten
Posten, anwendbar auf die Tochtergesellschaften der Gesellschaft und die die Zustimmung der Aktieninhaber erfordern
oder die einer solchen Zustimmung unterliegen;
vorausgesetzt daß, insofern alle Handlungen, die der Zustimmung der Verwaltungsratsmitglieder bedürfen, klar in
einem Geschäftsplan der Gesellschaft ausgelegt sind, als angenommen erachtet werden.
Art. 12. Verwaltungsratsprotokolle
12.1. Über die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden Protokolle geführt, die in ein Spezialregister eingetragen
werden und die von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats und einem Verwaltungsratsmitglied, das nicht von derselben
Verwaltungsratsmitgliederklasse zur Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats vorgestellt worden ist, unterschrieben.
12.2. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in Prozessen oder anderswo vorgelegt werden können, werden
von dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats und einem Verwaltungsratsmitglied, das nicht von derselben Verwaltungs-
ratsmitgliederklasse zur Wahl des Vorsitzenden des Verwaltungsrats vorgestellt worden ist, unterschrieben.
Art. 13. Befugnisse des Verwaltungsrats - Entschädigungen
13.1.1 Der Verwaltungsrat ist im weitesten Sinne befugt, alle Verwaltungsund Verfügungshandlungen vorzunehmen,
welche dem Interesse der Gesellschaft dienen. Sämtliche Befugnisse die nicht ausdrücklich durch das luxemburgische
Gesellschaftsrecht oder durch die Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit
des Verwaltungsrates.
13.2 Die Gesellschaft wird, soweit unter luxemburgischem Recht erlaubt, jedes Mitglied des Verwaltungsrates oder
jeden leitenden Angestellten ebenso wie dessen Erben, Vollstreckungsbevollmächtigte und Verwalter von angemessenen
Auslagen freihalten, welche von ihm im Zusammenhang mit einer Klage, einer Rechtsverfolgungsmaßnahme oder einem
Verfahren entstanden sind, an welchem er aufgrund seiner Stellung als Verwaltungsratsmitglied oder leitender
Angestellter der Gesellschaft oder, auf seinen Antrag hin, auch einer anderen Gesellschaft, an welcher die Gesellschaft
als Aktionär beteiligt ist, oder bei welcher die Gesellschaft Gläubiger ist und von der er keine Entschädigung erhält,
beteiligt ist, außer in Fällen, in welchen er aufgrund solcher Klagen, Rechtsveffolgungsmaßnahmen oder Verfahren wegen
grob fahrlässigem oder fehlerhaftem Verhaltens endgültig verurteilt wird.
Im Falle eines Vergleiches erfolgt eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Angelegenheiten, welche von
dem Vergleich abgedeckt werden, und insofern der Gesellschaft von einem Rechtsberater bestätigt wird, daß die zu
entschädigende Person keine Pflichtverletzung begangen hat. Das vorstehende Recht auf Entschädigung schließt andere
Ansprüche nicht aus.
Art. 14. Übertragung von Befugnissen
14.1. Der Verwaltungsrat kann einen Teil seiner Befugnisse, gemäß der vom Verwaltungsrat beschlossenen internen
Vorschriften und Regelungen, an einen oder mehrere seiner Mitglieder übertragen. Für endgültige Geschäftsabschlüsse
kann der Verwaltungsrat späterhin Bevollmächtigte ernennen und diese zu jeder Zeit von ihrem Amt entheben.
14.2. Der Verwaltungsrat kann die tägliche Geschäftsführung der Gesellschaft, gemäß der vom Verwaltungsrat
beschlossenen internen Vorschriften und Regelungen, einem Verwalter anzuvertrauen, der den Titel chief executive
officer (der «Chief Executive Officer») trägt, und welcher immer von einer von den B Verwaltungsratsmitgliedern vorge-
stellten Liste gewählt wird. Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmung ist die Gesellschaft keine Tochtergesellschaft
von BERTELSMANN AG. Die Übertragung zugunsten eines der Verwaltungsratsmitglieder ist einer vorherigen Erlaubnis
der Gesellschafterversammlung unterworfen.
10149
Das Recht der B Verwaltungsratsmitglieder, eine Liste von Kandidaten vorzustellen, unter welchen der Chief
Executive Officer gewählt wird, wird den B Verwaltungsratsmitgliedern erhalten bleiben, sogar im Falle, daß der Verwal-
tungsrat sich nicht auf die Wahl eines Chief Executive Officer auf der von den B Verwaltungsratsmitglieder vorgestellten
Kandidatenliste einigen kann. Die gleichen Kandidaten können ein zweites mal zur Wahl gestellt werden.
14.3. Der Verwaltungsrat hat späterhin die Möglichkeit, nach seinem freien Ermessen zu entscheiden, eine
ausführende Körperschaft (die «Group Executive Management» oder «GEM») zu gründen, die die Geschäftsführung der
Gesellschaft und ihrer wesentlichsten Tochtergesellschaften festsetzt und koordiniert. Die GEM wird vom Chief
Executive Officer präsidiert und handelt im Einklang mit den internen Vorschriften und Regelungen.
14.4. Dritten gegenüber wird die Gesellschaft in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von einem
A Verwaltungsratsmitglied und einem B Verwaltungsratsmitglied oder durch die gemeinsame oder einzelne Unterschrift
jeglicher Personen, denen der Verwaltungsrat solche Zeichnisbefugnisse überträgt, verpflichtet, aber nur in den Grenzen
dieser Ermächtigungen.
Trotz dieser Befugnisübertragung, ist jeder einzelne Vertrag, dessen Hauptbetrag EUR 2.500.000,- (zwei Millionen
fünfhunderttausend Euro) überschreitet, der Zustimmung des Verwaltungsrats, gemäß der Bestimmungen des Artikels
11.6 oder gegebenenfalls des Artikels 11.8 der Satzung unterlegen.
14.5 Der einzige und tatsächliche Verwaltungsort ist Luxemburg. Alle Verwaltungstatigkeiten werden in Luxemburg
ausgetragen.
Art. 15. Rechnungsprüfer
Die jährliche Prüfung der Buchhaltung der Gesellschaft wird einem oder mehreren Rechnungsprüfern, die von der
Gesellschafterversammlung ernannt werden und deren Anzahl, Entlohnung und Amtszeit (erneuerbar), die nicht sechs
Jahre überschreiten darf, festlegt, anvertraut.
Sie können wiedergewählt werden und zu jeder Zeit von ihrem Amt enthoben werden.
Gesellschafterversammlung
Art. 16. Befugnisse der Gesellschafterversammlung
Die ordnungsgemäß bestellte Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Sie
hat die Befugnisse, die ihr von dem luxemburgischen Gesellschaftsrecht und der Satzung erteilt sind.
Art. 17. Jährliche Gesellschafterversammlung - Andere Gesellschafterversammlung
17.1 Die jährliche Gesellschafterversammlung wird am Gesellschaftssitz abgehalten, oder an jedem anderen Ort, der
sich in derjenigen Gemeinde befindet wo der Gesellschaftssitz eingetragen ist, und der in der Einladung angegeben ist,
am 10. Tag des Monats Oktober, um 10.00 Uhr.
Wenn dieser Tag in Luxemburg kein Arbeitstag ist, wird die jährliche Gesellschafterversammlung am nächstfolgenden
Werktag abgehalten.
17.2 Andere Gesellschafterversammlungen können an solchen Orten und zu solchen Zeiten abgehalten werden, wie
dies in der entsprechenden Einladung angegeben wird.
Art. 18. Verfahrensweise, Wahlen
18.1. Die Gesellschafterversammlung tritt auf Einladung des Verwaltungsrates, und wenn außergewöhnliche
Umstände es verlangen, zweier zusammen handelnder Verwaltungsratsmitglieder, zusammen.
Jedesmal wenn eine Gruppe von Aktionären, die mindestens ein Fünftel des gezeichneten Kapitals darstellen, es
verlangt, wird eine Gesellschafterversammlung einberufen. In einem solchen Fall müssen diese Aktionäre die Tages-
ordnung angeben und der Verwaltungsrat hat die Pflicht eine Gesellschafterversammlung einzuberufen, so daß eine
solche Versammlung innerhalb des Monats nach diesem Ansuchens, zusammentrifft.
18.2 Aktieninhaber treten auf Einladung, welche mindestens acht Tage vor der Gesellschafterversammlung durch
eingeschriebenen Brief versandt wird, zusammen. Jede Einladung enthält die Tagesordung der Gesellschafterver-
sammlung.
Sofern sämtliche Aktieninhaber anwesend oder vertreten sind und sich selbst als ordnungsgemäß eingeladen und über
die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt erachten, kann die Gesellschafterversammlung ohne Einladung stattfinden.
Insofern das Gesetz es erlaubt, können Beschlüsse der Aktionäre im Umlaufverfahren gültig gefäßt werden, indem sie
von allen Aktionären unterzeichnet werden. Solche Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf
mehreren Kopien eines jeden Beschlusses erscheinen, und können per Brief, Telefax oder Telex bestätigt werden.
18.3 Ein Aktionär kann an jeder Gesellschafterversammlung teilnehmen, in dem er sich schriftlich oder durch Telefax,
Kabel, Telegramm oder Telex, durch eine Vollmacht an eine andere Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten
läßt. Der Verwaltungsrat bestimmt alle anderen Bedingungen, die erfüllt sein müssen um an einer Gesellschafterver-
sammlung teilzunehmen.
18.5 Gesellschafterversammlungen können nur handeln, wenn im Moment wo die Versammlung zu den Geschäften
übergehen will, das nötige Quorum der Aktionäre anwesend ist. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre die die
Hälfte des Stammkapital repräsentieren, bilden ein Quorum, unter der Bedingung, daß einer dieser Aktionäre Inhaber
einer oder mehrerer Stammaktien ist und daß einer dieser Aktionäre Inhaber einer oder mehrerer Vorzugsaktien ist.
Wenn dieses Quorum dreißig Minuten vor der Gesellschafterversammlung nicht gebildet ist, wird die Gesellschafter-
versammlung vertagt und zehn Kalendertage nach der ursprünglichen Gesellschafterversammlung erneut einberufen.
Wenn dieses Quorum dreißig Minuten vor der Gesellschafterversammlung nicht vorhanden ist, und wenn diese Gesell-
schafterversammlung in ihrer Tagesordnung Satzungsabänderungen oder ähnliche Angelegenheiten vorsieht, dann wird
eine zweite Versammlung einberufen, indem zwei Einladungen, mit jeweils 15 (fünfzehn) Tagen Abstand sowohl in das
luxemburgische Amtsblatt wie in zwei luxemburgischen Zeitungen veröffentlicht werden, die zweite Einladung späte-
stens 15 (fünfzehn) Tage vor der vorgesehenen Gesellschafterversammlung herausgegeben wird, und der oder die an der
10150
vertagten Gesellschafterversammlung anwesenden Aktionäre ein Quorum bilden. Das an der ursprünglichen Gesell-
schafterversammlung verlangte Quorum gilt auch für die zweite Gesellschafterversammlung, außer wenn obligatorische
Bestimmungen des luxemburgischen Rechts bestimmen, daß die Gesellschafterversammlung ohne das erforderte
Quorum abgehalten werden soll.
18.6 Bevor die Verhandlungen anfangen, ernennt der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, welcher der
Vorsitzende des Verwaltungsrats ist, außer wenn er seiner Anwesenheit entbunden ist, einen Schriftführer, und die
Akionäre ernennen einen Stimmzähler. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, der Schriftführer und der
Stimmzähler bilden das Versammlungskomitee.
Ein Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, zu jeder einzelnen Gesellschafterversammlung der Akionäre jeder Klasse
eine Einladung zu erhalten, ihr beizuwohnen und das Wort zu ergreifen.
Die Protokolle der Gesellschafterversammlung werden von dem Versammlungskomitee und vom jedem Akionär, der
es wünscht, unterzeichnet.
Doch im Fall wo Beschlüsse der Gesellschafterversammlung beglaubigt werden müssen, werden Kopien und Auszüge,
die vor Gericht oder anderswo vorgelegt werden, vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats, oder, in dessen Abwesenheit,
von einem Verwaltungsratsmitglied welches auf der gleichen Liste als der Vorsitzende gewählt wurde, und von einem
Verwaltungsratsmitglied, das nicht von der Verwaltungsratsmitgliedsklasse, dem der Gesellschafterversammlungsvorsit-
zende nicht angehört, für die Wahlen vorgestellt worden ist, unterzeichnet.
18.7 Außer wenn anders von der Satzung oder vom luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorgesehen, wird jeder
Beschluß mit der Zustimmung der Mehrheit der Klasse A Aktien und der Mehrheit der Klasse B Aktien, welche als
separate Klassen stimment, und der allgemeinen Mehrheit aller Aktionäre gefasst:
(a) Zustimmung der jährlichen von den Rechnungsprüfern kontrollierten Schlußerklärungen betreffend die Finanzen
der Gesellschaft;
(b) vorbehaltlich einer gegenteiligen Bestimmung dieser Satzung, das Ausschütten der Dividenden oder der Verteilung
an die Aktionäre, so wie es von der Satzung bestimmt ist, und das Festlegen des Betrages und des Datums einer solchen
Ausschüttung;
(c) Ernennung oder Abberufung der Geschäftsleiter der Tochtergesellschaften und ihrer direkten Untergeordneten;
(d) Ernennung oder Abberufung der Rechnungsprüfer der Gesellschaft.
18.8 Die folgenden Maßnahmen werden nicht anders als durch einen Beschluß der Mehrheit der A Aktionäre und der
Mehrheit der B Aktionäre, welche als separate Klassen stimmen, sowie der Aktionäre welche zwei Drittel des Stamm-
kapitals darstellen, gefaßt:
(a) Abänderung der Satzung der Gesellschaft;
(b) Zustimmung der Beteiligung eines Dritten (anderer als die Angestellten die Aktien im Rahmen von Options-
rechten erhalten) am Stammkapital durch Übertragung oder durch Zeichnung;
(c) Zustimmung zur Vereinigung oder Fusion der Gesellschaft;
(d) Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft und Verkauf von allen oder von praktisch allen Aktiva der Gesell-
schaft;
(e) vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 8, die Ausgabe von Aktien, Schuldverschreibungen, Wertpapier-
darlehen der Gesellschaft oder Optionsrecht auf Aktienkauf, Schuldverschreibungen oder Wertpapierdarlehen oder ein
Abbkommen betreffend das Vorstehende, die Konsolidierung oder Unterteilung von Aktien im Stammkapital, die
Gründung einer neuen Aktienklasse im Stammkapital oder andere Änderungen im Stammkapital;
Geschäftsjahr - Bilanz - Ausschüttungen
Art. 19. Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr beginnt im Juli eines jeden Jahres und endet im Juni des darauffolgenden Jahres.
Art. 20. Bilanz
20.1 Am Ende jedes Geschäftsjahres stellt der Verwaltungsrat, gesetzesgemäß eine Bilanz der Gesellschaft auf.
20.2 Mindestens einen Monat vor der jährlichen Gesellschafterversammlung legt der Verwaltungsrat die Bilanz, die
Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft mit einem Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und
anderen Dokumenten, so wie es vom Gesetz verlangt wird, den Wirtschaftsprüfem vor, die ihrerseits der Gesellschaf-
terversammlung Bericht erstatten.
20.3. Zwei Wochen vor der jährlichen Gesellschafterversammlung, werden die Bilanz, die Gewinn- und Verlust-
rechnung, der Verwaltungsratsbericht und der Bericht des Wirtschaftsprüfers bei dem Gesellschaftsitz abgegeben, wo
sie für jeden Aktieninhaber, während den normalen Arbeitszeiten, zur Einsicht offenstehen.
Art. 21. Ausschüttungen
21.1 Der Guthabensaldo auf der Gewinn- und Verlustrechnung, nach Abrechnung der Kosten, der sozialen Abgaben,
der Verluste und der Rückstellungen für Wertminderung betreffend gegenwärtige und zukünftige Risiken, wie vom
Verwaltungsrat bestimmt, stellt den Nettogewinn dar.
21.2 Es werden jährlich fünf Prozent des Reingewinnes auf die Seite gelegt, um die gesetzlichen Reservefonds zu
bilden. Dieser Vorabzug hört auf, zwingend zu sein, zu dem Zeitpunkt wo der Reservefonds zehn Prozent des Stamm-
kapitals ausmacht.
21.3 Die Differenz der verteilbaren Gewinne der Gesellschaft, nach Ausschüttung der Vorzugsdividenden, wird
vollkommen ausgeschüttet, außer wenn anders von der Gesellschafterversarnmlung bestimmt.
21.4 Dividenden, wenn auszahlbar, werden, in denen von der Gesellschafterversammlung vorgesehenen Grenzen, am
Tag und am Ort ausgeschüttet, der von dem Verwaltungsrat festgelegt worden ist.
21.5 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, Interinisdividenden, in denen vom luxemburgischen Gesellschaftsrecht vorge-
sehenen Grenzen, vorzunehmen.
10151
21.6 Die Gesellschafterversammlung kann entscheiden, die Gewinne und die zur Verteilung kommenden Reserven
der Rückzahlung des Kapitals zuzuteilen, ohne das Stammkapital zu verringern.
Auflösung - Liquidation
Art. 22. Auflösung
Die Gesellschaft kann zu jeder Zeit durch eine Entscheidung der Gesellschafterversammlung, die sich in der Art und
Weise berät, wie im Artikel 18.8 der Satzung festgesetzt ist, aufgelöst werden.
Art. 23. Liquidation
Wird die Gesellschaft aufgelöst, legt die Gesellschafterversammlung, die sich in der Art und Weise berät, wie in
Artikel 18.8 der Satzung festgesetzt, eme Liquidationsmethode fest und ernennt einen oder mehrere Liquidatoren und
setzt ihre Befugnisse fest.
Art. 24. Allgemeine Bestimmungen
Sämtliche Punkte, welche durch diese Satzung nicht geregelt sind, werden im Einklang mit den Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften festgelegt in seiner abgeänderten Fassung («luxemburgisches
Gesetz über Handelsgesellschaften»).
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr fängt bei der Gründung an und endet am 30. Juni 2000.
Die erste Gesellschafterversammlung wird am 10. Oktober 2000 abgehalten.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten
Parteien, diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle
von Abweichungen zwischen dem englischen Text und dem deutschen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,
gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem beurkundenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: G. Harles, M. Feider, P. Beissel, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 87, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung.
Luxemburg, den 17. Januar 2000.
F. Baden.
(03690/200/1461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LA CIVETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.132.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LA CIVETTE, S.à r.l.i>
J. Reuter
(03904/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 10-12, boulevard Roosevelt.
—
<i>Verwaltungsrat:i>
Paul K. Schminke,
président du conseil d’administration,
Vorsitzender des Verwaltungsrates,
membre du directoire,
Mitglied des Vorstandes;
Klaus G. Adam,
vice-président du conseil d’administration,
stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates,
président du directoire,
Präsident des Vorstandes;
Werner Fuchs,
membre du conseil d’administration,
Vorsitzender des Verwaltungsrates,
membre du directoire,
Mitglied des Vorstandes;
Hans-Otto Streuber,
membre du conseil d’administration,
Mitglied des Verwaltungsrates,
président,
Präsident;
10152
Dr Dieter Falke,
membre du conseil d’administration,
Mitglied des Verwaltungsrates,
membre du directoire,
Mitglied des Vorstandes;
Alain Baustert,
administrateur-délégué,
geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied;
Roby Haas,
administrateur-délégué,
geschäftsführendes Verwaltungstatsmitglied.
<i>Directeuri>
Hauck Andreas.
<i>Directeur-adjoint:i>
Jacobi Ralf,
Quary Achim,
Van den Berg Marie-Anne,
Wolff Germain.
<i>Sous-directeur:i>
Schlichter Bernd,
Forstmeyer Frank,
Fusenig Edgar.
<i>Fondé de pouvoir:i>
Back Ursula,
Backes Lisa,
De Paoli Doris,
Felke Johannes,
Gierke Markus,
Grünen Harald,
Habitzky Vincent,
Roadway Adrian,
Roeder Marc,
Spatafora Josef,
Stadler Udo,
Welter Gerhard,
Wenz Achim.
Enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03905/000/60) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LASHEID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 57.257.
—
<i>Extrait des résolutions de l’assemblée générale ordinaire annuelle tenue exceptionnellementi>
<i>le 6 décembre 1999 pour statuter sur l’exercice clos au 31 décembre 1998i>
AFFECTATION DU RESULTAT
L’assemblée générale a décidé, sur proposition du conseil d’administration, de reporter les pertes de l’exercice social
clos au 31 décembre 1998 sur l’exercice en cours.
Luxembourg, le 6 décembre 1999.
Enregistré à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03906/720/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LASHEID S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 57.257.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
<i>Pour LASHEID S.A.i>
(03907/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10153
LINSTER HIGH TECH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 66.637.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
<i>Pour la S.A. LINSTER HIGH TECHi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(03913/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LA SPHERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.390.
—
L’an mit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-sept décembre.
Par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
A comparu:
La société de droit luxembourgeois dénommée SOCIETE EUROPEENNE DE BANQUE, avec siège social à Luxem-
bourg, 19-21, boulevard du Prince Henri, représentée par:
- Monsieur Federico Franzina et,
- Monsieur Carlo Santoiemma, employés privés, demeurant à Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société anonyme de droit luxembourgeois dénommée LA SPHERA
S.A., ayant son siège social à Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date 6 août 1999, en voie de publication au Mémorial C,
et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’un constat d’augmentation de capital reçu par le notaire soussigné
en date du 20 décembre, non encore déposé au registre de commerce,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration de la Société, prise en sa réunion du 24
décembre 1999.
Une copie du procès-verbal de ladite réunion, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte avec lequel elle sera soumise à la formalité du timbre et de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
1) Que le capital social de la société prédésignée s’élève actuellement à six cent mille Euros (EUR 600.000,-), repré-
senté par cent vingt mille (120.000) actions d’une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5,-) chacune.
2) Qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 5 des statuts, la société a un capital autorisé qui est fixé à dix millions
d’Euros (EUR 10.000.000,-), représenté par deux millions (2.000.000) d’actions d’une valeur nominale de cinq Euros
(EUR 5,-) chacune,
et que le même article, autorise le conseil d’administration à augmenter le capital social dans les limites du capital
autorisé.
Les alinéas 5, 6 et 7 du même article 5 des statuts sont libellés comme suit:
Le Conseil d’Administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 6 août 2004 à augmenter en
temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital.
Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises sous forme d’actions avec ou sans prime d’émission
à libérer en espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles
vis-à-vis de la société, ou même par incorporation de bénéfices reportés de réserves disponibles ou de primes
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration. Le conseil d’administration peut déléguer tout
administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne dûment autorisée pour recueillir les souscriptions
et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
le présent article sera à considérer comme automatiquement adapté à la modification intervenue.
3) Que dans sa réunion du 24 décembre 1999, le conseil d’administration a décidé de réaliser une augmentation de
capital jusqu’à concurrence de quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-),
pour porter le capital social de son montant actuel de six cent mille Euros (EUR 600.000) à un million d’Euros
(EUR 1.000.000,-),
par la création de quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles d’une valeur nominale de cinq Euros (EUR 5,-)
chacune,
à libérer intégralement en numéraire et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions anciennes,
et d’accepter la souscription de ces nouvelles actions par l’actionnaire majoritaire, lequel a souscrit à toutes les
quatre-vingt mille (80.000) actions nouvelles, moyennant une contribution en espèces de quatre cent mille Euros
(EUR 400.000,-),
l’actionnaire minoritaire ayant déclaré renoncer à son droit de souscription préférentiel, une copie de cette renon-
ciation restera annexée aux présentes.
4) La réalisation de l’augmentation de capital est constatée par le notaire instrumentant sur le vu des documents de
souscription.
10154
La somme de quatre cent mille Euros (EUR 400.000,-) se trouve être à la disposition de la société ainsi qu’il en a été
justifié au notaire par certificat bancaire.
5) Que suite à la réalisation de cette augmentation, le capital se trouve porté à un million d’Euros (EUR 1.000.000,-),
de sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura dorénavant la teneur suivante:
Le capital social est fixé un million d’Euros (EUR 1.000.000,-), représenté par deux cent mille (200.000) actions d’une
valeur nominale de cinq Euros (EUR 5,-) chacune.
<i>Frais - Evaluationi>
Les frais, dépenses, honoraires ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge,
en raison des présentes sont évalués à LUF 220.000,-.
Pour les besoins de l’enregistrement, l’augmentation de capital social est évalué à LUF 16.135.960,-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation données au comparant, connus du notaire instrumentant par leurs nom, prénom,
état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: F. Franzina, C. Santoiemma, J. Delvaux.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 80, case 7. – Reçu 161.360 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, à la demande de la société prénommée, aux fins de la publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2000.
J. Delvaux.
(03908/208/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LA SPHERA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 71.390.
—
Statuts coordonnés suite à un constat d’augmentation du capital acté sous le numéro 874/99 en date du 27 décembre
1999 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg-Ville, déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(03909/208/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LION OBLILUX.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R. C. Luxembourg B 29.530.
—
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 2 avril 1999, vol. 521, fol. 65, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Signature.
(03914/019/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LIM INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. LIM HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.849.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme LIM HOLDING S.A., ayant
son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, R.C. Luxembourg section B numéro 63.849,
constituée suivant acte reçu le 30 mars 1998, publié au Mémorial C, numéro 460 du 25 juin 1998; dont les statuts n’ont
jamais été modifiés.
L’assemblée est présidée par Monsieur Marc Lamesch, expert-comptable, demeurant à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblee choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l’acte.
II.- Il apparait de la liste de présence que les 1.000 (mille) actions d’une valeur nominale de LUF 1.250,- (mille deux
cent cinquante francs luxembourgeois) chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la
présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points
portés à l’ordre du jour.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
10155
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination sociale en LIM INVESTMENT S.A.
2.- Conversion du capital social minimum de LUF 1.250.000,- en euros pour le fixer à EUR 31.000,- avec suppression
de la valeur nominale des actions.
3.- Augmentation du capital social à concurrence d’un montant de EUR 1.069.000,- (un million soixante-neuf mille
euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 1.100.000,- (un million
cent mille euros) par l’émission de 34.484 (trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale, à libérer par l’apport en nature de l’intégralité des parts sociales d’une société française.
4.- Modification afférente des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière prend à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de changer la dénomination sociale en LIM INVESTMENT S.A.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée décide de convertir capital social minimum de LUF 1.250.000,- (un million deux cent cinquante mille
francs luxembourgeois) en euros pour le fixer à EUR 31.000,- (trente et un mille euros) et de supprimer la désignation
de valeur nominale des 1.000,- (mille) actions représentant le capital.
<i>Troisième résolutioni>
L’assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de EUR 1.069.000,- (un million soixante-neuf mille
euros) pour le porter de son montant actuel de EUR 31.000,- (trente et un mille euros) à EUR 1.100.000,- (un million
cent mille euros) par l’émission de 34.484 (trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatre) actions nouvelles sans
désignation de valeur nominale.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée décide d’admettre Monsieur Frédéric Malinet, administrateur de sociétés, demeurant à F-69100 Villeur-
banne, 3, avenue Antoine Dutrievoz, France, à la souscription des 34.484 (trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-
quatre) actions nouvelles.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Monsieur Frédéric Malinet, apporteur, représenté au présent acte en vertu d’une des procurations susvantées,
déclare et reconnaît que chacune des actions souscrites ont été intégralement libérées par l’apport réalisé en nature de
2.500 (deux mille cinq cents) parts sociales de EUR 400,- (quatre cents euros) chacune, représentant 100% (cent pour
cent) du capital social de la société unipersonnelle à responsabilité limitée de droit français EURL LIM GEOTECHNO-
LOGIE, avec siège social à F-Villeurbanne.
Il résulte de la procuration émise par l’apporteur, que:
- il est le seul plein propriétaire de ces actions et possédant les pouvoirs d’en disposer, celles-ci étant légalement et
conventionnellement librement transmissibles;
- il n’existe aucun droit de préemption ou d’autre droits en vertu desquels une personne pourrait avoir le droit d’en
acquérir une ou plusieurs;
- les transferts de parts sont effectivement réalisés sans réserve aujourd’hui et les conventions de cessions ont été
déjà signées, preuve en ayant été apportée au notaire soussigné;
- toutes autres formalités seront réalisées en France, aux fins d’effectuer la cession et de la rendre effective partout
et vis-à-vis de toutes tierces parties.
<i>Rapport du réviseuri>
Conformément aux articles 32-1 et 26-1 (1) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés, cet apport en nature a fait
l’objet d’un rapport en date du 20 décembre 1999 établi par le Réviseur d’Entreprises indépendant MONTBRUN
REVISION, S.à r.l., représenté par Monsieur Edmond Ries, qui conclut comme suit:
<i>Conclusion:i>
«Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la
valeur globale des apports qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des nouvelles actions à émettre en
contrepartie, c’est-à-dire 34.484 actions sans désignation de valeur nominale, totalisant EUR 1.069.000,-».
L’assemblée accepte la libération des actions nouvelles par l’apport prédécrit ainsi que l’évaluation qui lui en a été
donnée.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de l’augmentation de son capital social, s’élève à environ quatre-vingt-dix mille
francs luxembourgeois.
<i>Provisioni>
Une somme suffisante, égale au moins au montant des frais notariaux mentionné ci-avant est d’ores et déjà à la dispo-
sition du notaire soussigné, l’apport étant réalisé en nature.
<i>Requête en exonération des droits proportionnelsi>
Compte tenu qu’il s’agit de l’augmentation du capital social d’une société luxembourgeoise par l’apport en nature d’au
moins 75% de toutes les parts sociales actuellement émises par une société de capitaux ayant son siège dans l’Union
10156
Européenne, la société requiert sur base de l’article 4.2 de la loi du 29 décembre 1971 l’exonération du droit propor-
tionnel d’apport.
<i>Cinquième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l’assemblée décide de modifier l’article
premier et le premier alinéa de l’article cinq des statuts pour leur donner la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il est régi par les présents statuts une société anonyme luxembourgeoise existant sous la dénomination de
LIM INVESTMENT S.A.»
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à EUR 1.100.000,- (un million cent mille euros), représenté par
35.484 (trente-cinq mille quatre cent quatre-vingt-quatre) actions sans désignation de valeur nominale, disposant
chacune d’une voix aux assemblées générales.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: M. Lamesch, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 27 décembre 1999, vol. 121S, fol. 64, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Kirsch.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 1999.
J. Elvinger.
(03910/211/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LIM INVESTMENT S.A., Société Anonyme,
(anc. LIM HOLDING S.A., Société Anonyme).
Siège social: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 63.849.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Elvinger.
(03911/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LOPHIRA, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R. C. Luxembourg B 46.981.
Société anonyme constituée suivant acte reçu par Maître Georges d’Huart, notaire de résidence à Pétange, en date du
23 décembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 245 du 21 juin
1994. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le même notaire en date du 16 juillet 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 592 du 29 octobre 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 18 janvier 2000, vol. 532, fol. 69, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LOPHIRA S.A.
Signature
(03915/546/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LUCARVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 19.353.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 20
septembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 23 septembre 1999, vol. 843, fol. 97, case 10, que la société anonyme
LUCARVEST S.A., ayant son siège social à L-2953 Luxembourg, 69, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 19.353, constituée suivant acte notarié en date du 29 avril 1982,
publié au Mémorial C, numéro 177 du 26 juillet 1982, au capital social de deux cent cinquante mille francs suisses (CHF
250.000,-), divisé en deux mille cinq cents (2.500) actions de cent francs suisses (CHF 100,-) chacune, entièrement
libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant entre ses mains la totalité
des actions de la société anonyme LUCARVEST S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 17 janvier 2000.
J.J. Wagner.
(03916/239/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10157
LUNATIK, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2651 Luxembourg, 28, rue St. Ulric.
—
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 11 janvier 2000, vol. 532, fol. 44, case 8, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
VIP COMPTA
Signature
(03919/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LUXOMATIQUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 39.930.
—
Les comptes annuels au 30 juin 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
<i>Pour LUXOMATIQUE S.A.i>
(03920/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LUX ORGA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Itzig.
R. C. Luxembourg B 65.015.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour LUX ORGA, S.à r.l.i>
J. Reuter
(03921/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
MAGEPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 117, route de Stavelot.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie:
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MAGEPAR S.A., ayant son siège social à
Strassen, constituée suivant acte notarié en date du 3 juin 1991, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations, numéro 425 du 9 novembre 1991. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné
en date du 10 juin 1993, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 410 du 9 septembre
1993.
L’Assemblée est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur Michel Beckers, administrateur de sociétés,
demeurant à Verviers,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Ghislain Decharneux, pensionné, demeurant à Verviers.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social comme suit:
La société a pour objet l’achat, la vente et la location de véhicules automoteurs, le transport de voyageurs et de
marchandises par route, l’affrètement par fer, eau, route et air.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties. La société a en
outre pour objet la prestation de services de conseil à ces sociétés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.
2. Modification afférente de l’article 2 des statuts.
3. Transfert du siège social et modification subséquente de l’article 1
er
, alinéa 2, des statuts.
10158
4. Fixation du capital autorisé de la société et autorisation à donner au conseil d’administration de limiter ou
supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires. Rapport du conseil prévu à l’article 32-3(5) de la loi sur
les sociétés commerciales.
5. Modification corrélative de l’article 3 des statuts.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Premiere résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social de la société.
En conséquence, l’article 2 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. La société a pour objet l’achat, la vente et la location de véhicules automoteurs, le transport de voyageurs
et de marchandises par route, l’affrètement par fer, eau, route et air.
La société a en outre pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres sociétés
luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute autre manière
des valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou
pouvant les compléter.
La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés tous concours, prêts, avances ou garanties. La société a en
outre pour objet la prestation de services de conseil à ces sociétés.
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de transférer le siège social de la Société de Strassen à L-9991 Weiswampach, 117, route de
Stavelot.
En conséquence, le deuxième alinéa de l’article premier des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:
Art. 1
er
. Deuxième alinéa. Le siège social est établi à Weiswampach.
Le premier alinéa de l’article 8 aura la teneur suivante:
Art. 8. Premier alinéa. L’assemblée générale annuelle se réunit le deuxième vendredi du mois de juin à dix heures
au siège social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de fixer le capital autorisé de la Société à deux cent cinquante millions de francs luxembourgeois
(250.000.000,- LUF) et, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration prévu par l’article 32-3(5) de la loi
sur les sociétés commerciales, renouvelle l’autorisation donnée au conseil de supprimer ou limiter le droit de
souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission d’actions nouvelles à émettre dans le cadre du capital
autorisé.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence de la résolution qui précède, le septième alinéa de l’article 3 des statuts est modifié et aura désormais
la teneur suivante:
Art. 3. Septième alinéa. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de la publi-
cation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 décembre 1999 et peut être renouvelée par une assemblée
générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d’ici là n’auront pas été émises par le Conseil d’Admi-
nistration.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: M. Beckers, N. Weyrich, G. Decharneux, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 janvier 2000.
F. Baden.
(03925/200/99) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10159
MAGEPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weisampach, 117, route de Stavelot.
—
<i>Procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 20 décembre 1999i>
Le 20 décembre 1999, s’est réuni le Conseil d’Administration de la société MAGEPAR S.A., société anonyme avec
siège social à Strassen.
Le Conseil a décidé à l’unanimité de nommer à la fonction de Directeur, auquel il délègue la gestion journalière de la
Société et la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, avec le pouvoir d’engager la Société par sa
signature individuelle, conformément à l’article 5 des statuts:
Monsieur Guillaume Weertz, Directeur Général, demeurant à B-4720 La Calamine, 48, rue Soufflet.
Le mandat du Directeur viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Annuelle de 2001.
Fait à Luxembourg, le 20 décembre 1999.
Signatures.
Enregistré à Luxembourg, le 22 décembre 1999, vol. 121S, fol. 57, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Signature.
(03926/200/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
MAGEPAR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weisampach, 117, route de Stavelot.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
F. Baden.
(03925/200/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LYCOOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.363.
—
<i>Procès-verbal de l’assemblée générale statutaire qui s’est tenue le 9 juin 1999 à 10.00 heures à Luxembourgi>
L’assemblée prend acte de la démission de M. Yvan Juchem de son poste d’administrateur et le remercie pour sa
précieuse collaboration. L’assemblée nomme en remplacement Monsieur Koen Lozie, administrateur de sociétés,
demeurant à Luxembourg, qui terminera son mandat venant à échéance à l’assemblée générale statutaire de 2001.
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03922/009/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
LYCOOP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 43.363.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 6, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2000.
Signature.
(03923/009/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2000.
MARIUCCI FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 22, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.942.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 65, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. MARIUCCI FRERESi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(03931/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10160
MARIUCCI FRERES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3253 Bettembourg, 22, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.942.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 17 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. MARIUCCI FRERESi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(03932/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MASCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Registered office: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 68.105.
—
In the year one thousand nine hundred and ninety-nine, on the twenty-first of December.
Before Maître Joseph Elvinger, notary public residing at Luxembourg.
Is held an Extraordinary General Meeting of the partners of MASCOLUX, S.à r.l., a société à responsabilité limitée,
having its registered office at L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, trade register Luxem-
bourg section B number 68.105, incorporated by deed dated on the 29th of December 1998, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, number 231 of April 2nd, 1999, and whose Articles of Association once have been
amended by deed drawn up on April 19, 1999 and on June 18, 1999.
The meeting is presided by Mrs Myriam Pirotte, employee, residing in Kopstal.
The chairman appoints as secretary Mr Patrick Van Hees, jurist, residing at Messancy, Belgium.
The meeting elects as scrutineer Mr Hubert Janssen, jurist, residing at Torgny-Rouvroy, Belgium.
The chairman requests the notary to act that:
I.- The partners present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered
with the minutes.
II.- As appears from the attendance list, the 400,000 (four hundred thousand) shares of EUR 25.- (twenty-five euros)
each, representing the whole capital of the corporation, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the partners have been beforehand informed.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1.- Change the company name from MASCOLUX, S.à r.l. to MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.
2. - Amendment of article two of the articles of Incorporation in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the partners unanimously decide what follows:
<i>First resolutioni>
The partners decide to change the company name from MASCOLUX, S.à r.l. to MASCO CORPORATION EUROPE,
S.à r.l.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the partners decide to amend the article 2 of the Articles of Incorpo-
ration to read as follows:
«Art. 2. The company’s name is MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present
original deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
persons and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt et un décembre.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée MASCOLUX,
S.à r.l., ayant son siège social à L-8181 Kopstal, 541 route de Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, R.C. Luxembourg
section B numéro 68.105, constituée suivant acte reçu le 29 décembre 1998, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 231 du 2 avril 1999, et dont les statuts ont été modifiés par actes du 19 avril 1999 et du 18 juin
1999.
L’assemblée est présidée par Madame Myriam Pirotte, employée privée, demeurant à Kopstal.
10161
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Patrick Van Hees, juriste, demeurant à Messancy, Belgique.
L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Hubert Janssen, juriste, demeurant à Torgny-Rouvroy, Belgique.
Le président prie le notaire d’acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II.- Il ressort de la liste de présence que les 400.000 (quatre cent mille) parts sociales de EUR 25,- (vingt-cinq euros)
chacune, représentant l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
de sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour, dont les associés ont été
préalablement informés.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1.- Changement de la dénomination de la société de MASCOLUX, S.à r.l. en MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.
2.- Modification afférente de l’article deux des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident le changement de la dénomination de la société de MASCOLUX, S.à r.l. en MASCO CORPO-
RATION EUROPE, S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, les associés décident de modifier l’article 2
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
«Art. 2. La dénomination de la société est MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: M. Pirotte, P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 décembre 1999.
J. Elvinger.
(03933/211/90) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
MASCO CORPORATION EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. MASCOLUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée).
Registered office: L-8181 Kopstal, 54, route de Mersch.
R. C. Luxembourg B 68.105.
—
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Elvinger.
(03934/211/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
MANDELO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 291, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 69.072.
—
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du conseil d’administration du 16 décembre 1999 que suite à la démission de Monsieur Kurt
Kindle, Monsieur Rolf Schmid, directeur, demeurant à FL-9494 Schaan, im Rossfeld 49, a été coopté administrateur. Il
terminera le mandat de son prédécesseur.
Déposé aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 janvier 2000.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 71, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03929/799/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10162
MAGALI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 28.651.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 72, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Signature.
(03924/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
MANULIFE GLOBAL FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 26.141.
—
EXTRACT
The annual general meeting of shareholders held at the registered office on Friday 15 October 1999 adopted the
following decisions:
1. The meeting approved the auditor’s report and the financial statements for the period ended 30 June 1999.
2. The meeting approved to declare the following dividends:
US cents 3.185 per share to shareholders of the CHINA VALUE FUND,
US cents 1.05 per share to shareholders of the INDEX HONG KONG FUND,
US cents 0.425 per share to shareholders of the UK GROWTH FUND,
US cents 0.985 per share to shareholders of the TIGER FUND,
US cents 4.555 per share to shareholders of the RESERVE FUND,
US cents 3.345 per share to shareholders of the INTERNATIONAL INCOME FUND,
on record on 15 October 1999 with an ex-dividend date of 16 October 1999 and a payment date of 22 October 1999.
3. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of the
board of directors with respect to the year ended 30 June 1999.
4. The meeting noted that Mr Joseph B. Mounsey resigned from the board and that the board co-opted Mr Eric Ng
effective as of 1 June 1999.
5. The meeting elected Mr Erig Ng and re-elected Messrs George T. Yoxall, Richard J. Crook, Philip J. Hampden-
Smith, Jonathan C.H. Tate, Vicor S. Apps and Mr Felix P. Chee as directors of the board for a period of one year ending
at the annual general meeting of 2000.
6. The meeting re-elected PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., as auditor of the fund for a period of one year ending at
the annual general meeting of 2000.
7. The meeting noted the details relating to the directors’ fees.
<i>For MANULIFE REGENT GLOBAL FUNDi>
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 532, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(03930/041/33) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
MAUNA INTERNATIONAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R. C. Luxembourg B 57.463.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 21 janvier 2000, vol. 532, fol. 69, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
MeesPIERSON TRUST (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Géranti>
Signature
Signature
(03935/003/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
SOCEURIMMO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 37.116
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
<i>Pour SOCEURIMMO S.A.i>
(04039/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10163
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HINH.
Siège social: L-1530 Luxembourg, 4, rue Anatole France.
—
<i>Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société,i>
<i>tenue au siège à Luxembourg en date du 11 janvier 2000i>
Il résulte de la liste de présence que les associés représentant l’intégralité du capital:
- Monsieur Hihn Nhu Kiet, demeurant à Esch-sur-Alzette, 15, rue des Jardins,
- Monsieur Hinh Nhu Lam, demeurant à Luxembourg, 31, rue Wilson,
- Monsieur Hihn Di Dung, demeurant à Esch-sur-Alzette, 15, rue des Jardins,
sont présents et ont pris la décision suivante:
Il est décidé de transférer le siège social de la S.C.I. HINH, au 4, rue Anatole France, L-1530 Luxembourg.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des voix.
Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2000.
Hinh Nhu Kiet
Hinh Nhu Lam
Hinh Di Dung
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 60, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04040/000/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSEILS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 62.001.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
<i>Pour SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSEILS S.A.i>
(04042/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
SOVALIM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.097.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour SOVALIM, S.à r.l.i>
J. Reuter
(04043/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
T.G.E. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 54, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 55.744.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf quatre-vingt-dix-neuf, le quatorze décembre.
Par-devant Maître Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg.
A comparu:
FLORENTINE INTERNATIONAL LTD, ayant son siège social P.O. Box 3186, Old Scotia Building, Road Town,
Tortola, Iles Vierges Britanniques.
Ci-après qualifiée le «comparant»,
ici représentée par Monsieur Christophe Davezac, demeurant au 10, allée St Hubert L-8138 Bridel,
en vertu d’une procuration donnée le 6 décembre 1999,
laquelle procuration, après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée
aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, tel que représenté, a requis le notaire d’acter ce qui suit:
- La société anonyme T.G.E. S.A. avec siège social au 54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, a été constituée suivant
acte reçu par le notaire Christine Doerner, de résidence à Bettembourg, le 19 juillet 1996, publié au Mémorial, Recueil
des Sociétés et Associations C, N° 532 du 19 octobre 1996.
- Le capital social est fixé à un million cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-), représenté par trente
mille (30.000) actions d’une valeur nominale de cinquante francs luxembourgeois (LUF 50,-) chacune.
- Le comparant est devenu propriétaire de toutes les actions dont il s’agit et a décidé de dissoudre et de liquider la
société
- Par la présente, il prononce la dissolution de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
10164
- Il déclare que toutes les obligations de la société ont été acquittées et qu’il répondra encore personnellement de
tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les frais des présentes. Tous
les actifs de la société sont transférés à l’actionnaire unique.
- Partant, la liquidation de la société est achevée et la société est définitivement dissoute et liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au 54, avenue Pasteur, L-2310
Luxembourg.
Sur ce, le mandataire du comparant a présenté au notaire le registre des actions nominatives avec les transferts
afférents.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, le comparant tel que représenté a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Davezac. C. Doerner.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 20 décembre 1999, vol. 847, fol. 7, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Oehmen.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Bettembourg, le 17 janvier 2000.
C. Doerner.
(04051/209/45) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TANDIL S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 34.945.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Statutairei>
<i>qui s’est tenue le jeudi 11 juin 1998 à 11.00 heures à Luxembourgi>
<i>Résolutioni>
«L’Assemblée Générale ratifie à l’unanimité la nomination par le Conseil d’Administration du 30 septembre 1997 de
M. Eric Berg, au poste d’Administrateur en remplacement de M. Freddy Durinck, dont il terminera le mandat. Son
mandat viendra donc à échéance à l’Assemblée Générale Statutaire de 1999.»
Pour copie conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04046/009/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TASKU IMMOBILIERE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1219 Luxemburg, 23, rue Beaumont.
H. R. Luxemburg B 41.285.
—
Die Bilanz zum 31. Dezember 1998, einregistriert in Luxemburg, am 19. Januar 2000, vol. 532, fol. 72, case 7, wurde
am 20. Januar 2000, beim Handelsregister am Bezirksgericht Luxemburg hinterlegt.
Zur Veröffentlichung im Luxemburger Amtsblatt erteilt.
<i>Für den Verwaltungsrati>
Unterschriften
(04047/535/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
YARD, Société Anonyme.
Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine.
R. C. Luxembourg B 53.969.
—
Le bilan de la société au 31 décembre 1998 ainsi que l’affectation du résultat, enregistrés à Luxembourg, le 18 janvier
2000, vol. 532, fol. 70, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier
2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
(04086/000/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10165
TAVY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.
R. C. Luxembourg B 42.758.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
<i>Pour la S.A. TAVYi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(04048/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TER-PROM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
—
Le bilan de TER-PROM, S.à r.l. au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 59,
case 8, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Luxembourg, le 15 janvier 2000.
P. Neuen.
(04049/000/7) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TERRY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R. C. Luxembourg B 56.551.
—
<i>Réunion du Conseil d’Administrationi>
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le trente novembre.
Se sont réunis les membres du conseil d’administration de la Société Anonyme TERRY S.A. avec siège social au 38,
boulevard Napoléon Ier, L-2210 Luxembourg, à savoir:
- Monsieur Christos Margetis, directeur de sociétés, demeurant à L-1941 Luxembourg, 157, rue de Longwy.
- Monsieur Mark Rummens, directeur de sociétés, demeurant à L-4125 Esch-sur-Alzette, 10, rue des Franciscains.
- La société TURN PAGE & WISE, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
Lesquels, après avoir déclaré se considérer comme dûment convoqués, ont pris à l’unanimité les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
De l’accord de l’assemblée générale des actionnaires, ils désignent Monsieur Christos Margetis, prénommé, adminis-
trateur-délégué, chargé de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui
concerne cette gestion.
<i>Deuxième résolutioni>
En application des statuts, ils décident que la signature individuelle de l’administrateur-délégué engagera la société.
<i>Le Conseil d’Administrationi>
C. Margetis
M. Rummens
TURN PAGE & WISE S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04050/565/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TradeARBED EXPORT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.304.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-trois décembre.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme TradeARBED EXPORT
(LUXEMBOURG), ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg, sous le numéro B 6.304, constituée suivant acte notarié en date du 5 février 1964, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 26 du 4 avril 1964. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 17
décembre 1996, publié au Mémorial, Recueil C, numéro 140 du 22 mars 1997.
L’Assemblée est ouverte à neuf heures sous la présidence de Monsieur Patrick Tanson, ingénieur, demeurant à
Heisdorf,
qui désigne comme secrétaire Madame Nadia Weyrich, employée privée, demeurant à Arlon.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée privée, demeurant à Junglinster.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour:
10166
<i>Ordre du jour:i>
1. Conversion du capital en Euro.
2. Augmentation de capital à concurrence 10.532,38 EUR pour le porter de son montant de 1.239.467,62 EUR à
1.250.000,- EUR par incorporation au capital à due concurrence des réserves libres de la Société.
3. Augmentation de capital à concurrence de 4.500.000,- EUR pour le porter de son montant de 1.250.000.- EUR à
5.750.000,- EUR par l’émission de 28.800 actions sans désignation de valeur nominale.
4. Souscription et libération en espèces des 28.800 nouvelles actions.
5. Refonte complète des statuts.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de convertir le capital social de LUF en Euro. Le capital social est ainsi converti de cinquante
millions de francs (50.000.000,-) en un million deux cent trente-neuf mille quatre cent soixante-sept Euros soixante-deux
cents (1.239.467,62 EUR), représenté par huit mille (8.000) actions sans désignation de valeur nominale.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’augmenter le capital social à concurrence de dix mille cinq cent trente-deux Euros trente-huit
cents (10.532,38 EUR) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent trente-neuf mille quatre cent
soixante-sept Euros soixante-deux cents (1.239.467,62 EUR) à un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,-
EUR) sans émission d’actions nouvelles, par incorporation au capital à due concurrence des réserves libres de la Société.
Il est justifié au notaire soussigné de l’existence de telles réserves libres par les comptes annuels de la société au 31
décembre 1998 et par une situation intermédiaire au 31 octobre 1999 signée par tous les administrateurs.
Ces documents resteront, après avoir été paraphés ne varietur par les comparants et le notaire, annexés aux
présentes.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide en outre d’augmenter le capital social à concurrence de quatre millions cinq cent mille Euros
(4.500.000,- EUR) pour le porter de son montant actuel de un million deux cent cinquante mille Euros (1.250.000,- EUR)
à cinq millions sept cent cinquante mille Euros (5.750.000,- EUR) par la création et l’émission de vingt-huit mille huit
cents (28.800) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale, ayant les mêmes droits et obligations que les
actions existantes.
L’Assemblée admet TradeARBED S.A., société anonyme, ayant son siège social à Luxembourg, à la souscription des
vingt-huit mille huit cents (28.800) actions nouvelles, l’autre actionnaire renonçant à son droit de souscription
préférentiel.
<i>Souscription et libérationi>
De l’accord de tous les actionnaires, les vingt-huit mille huit cents (28.800) actions nouvelles sont souscrites à l’instant
même par TradeARBED S.A., prénommée, ici représentée par Monsieur Patrick Tanson, prénommé,
en vertu d’une procuration sous seing privé.
Les vingt-huit mille huit cents (28.800) actions nouvelles souscrites sont entièrement libérées en espèces, de sorte
que la somme de quatre millions cinq cent mille Euros (4.500.000,- EUR) se trouve à la libre disposition de la Société,
ainsi qu’il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions qui précèdent, le premier alinéa de l’article 6 des statuts est modifié et aura
désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Premier alinéa. Le capital social est fixé à cinq millions sept cent cinquante mille Euros (5.750.000,- EUR);
il est représenté par trente-six mille huit cents (36.800) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement
libérées.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Assemblée décide de procéder à la refonte complète des statuts de la société qui auront désormais la teneur
suivante:
Titre I
er
.- Forme, Dénomination, Objet, Siège, Durée
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme de droit luxembourgeois, régie par les présents statuts ainsi que par la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par ses lois modificatives.
10167
Art. 2. La société a pour dénomination TradeARBED EXPORT (LUXEMBOURG).
Art. 3. La société a pour objet le commerce de matières et de produits de toute nature, en particulier de produits
sidérurgiques, ainsi que toutes activités d’agence, d’intermédiaire ou de conseil. Les opérations prénommées peuvent
être faites pour le propre compte de la société ou pour le compte d’autrui.
La société pourra s’intéresser, par voie de participation, de création de sociétés nouvelles, d’apport, de fusion ou par
toute autre voie à toutes sociétés, entreprises ou opérations dont le but est similaire, connexe ou complémentaire au
sien.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières
ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptibles d’en faciliter la réalisation.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil
d’administration.
Le conseil d’administration pourra établir des sièges administratifs, agences, succursales ou bureaux tant dans le
Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger.
Au cas où des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre
l’activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiraient ou seraient
imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces
circonstances anormales.
Une telle mesure, qui pourra être prise par simple décision du conseil d’administration, n’aura aucun effet sur la natio-
nalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la
société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II.- Capital Social, Actions
Art. 6. Le capital social est fixé à cinq millions sept cent cinquante mille Euros (5.750.000,- EUR); il est représenté
par trente-six mille huit cents (36.800) actions sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
Le capital social pourra être augmenté ou réduit dans les conditions fixées par la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée dans la suite.
Les actions sont nominatives.
Titre III.- Administration
Art. 7. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, associés ou
non, nommés par l’assemblée générale et en tout temps révocables par elle.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six ans au plus; ils sont rééligibles.
Art. 8. Le conseil d’administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. En cas d’empêchement
du président, le vice-président remplira ses fonctions; en cas d’empêchement des deux, les fonctions de président seront
remplies par l’administrateur le plus âgé.
Art. 9. Le conseil d’administration doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.
Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation. Si tous les membres sont d’accord avec cette
procédure, une décision du conseil d’administration peut également être prise par écrit et sans que les membres du
conseil d’administration aient à se réunir.
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié de ses membres est présente ou
représentée. Les administrateurs peuvent donner, même par correspondance (lettre, télégramme, télex ou télécopie),
mandat à un de leurs collègues de les représenter aux délibérations du conseil d’administration et de voter en leur nom
et à leur place, un même membre du conseil ne pouvant représenter plus d’un de ses collègues. Le mandat n’est valable
que pour une seule séance.
Une décision par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une décision
prise à une réunion du conseil d’administration.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés du conseil d’administration. En
cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres qui ont
pris part à la délibération. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés conformes par le président ou
deux administrateurs.
Art. 10. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’adminis-
tration et de disposition qui entrent dans l’objet social. Tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par loi ou
par les statuts à l’assemblée générale rentrent dans ses attributions.
Les actions judiciaires, tant en demandant qu’en défendant, seront suivies au nom de la société par le président ou un
administrateur délégué à ces fins.
La société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou d’un adminis-
trateur et d’un fondé de pouvoir.
Art. 11. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de
la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs-délégués, choisis parmi ses membres
moyennant l’autorisation préalable de l’assemblée générale, et créer en son sein un comité de direction dont il
détermine les attributions.
10168
Il peut, en outre, charger de tout ou partie des missions qui lui incombent un ou plusieurs administrateurs, directeurs
généraux, directeurs ou fondés de pouvoir spéciaux, dont il détermine les fonctions et rémunérations, fixes ou variables,
avec ou sans participation aux bénéfices, la durée des fonctions et toutes autres conditions y afférentes.
Titre IV.- Surveillance
Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale qui fixe leur
nombre et leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans.
A partir du moment où, en vertu des dispositions légales, la Société sera obligée de faire contrôler ses comptes
annuels par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises, le contrôle des comptes annuels et de la concordance du rapport
de gestion avec les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’assemblée
générale. Le ou les réviseurs d’entreprises sont rééligibles.
Ils consignent le résultat de leur contrôle dans le rapport visé à la section XIII de la loi du 10 août 1915 concernant
les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée dans la suite.
Titre V.- Assemblée Générale
Art. 13.
L’assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le
troisième mardi du mois d’avril à onze heures.
Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Art. 14. Le conseil d’administration est en droit de convoquer l’assemblée générale. Il est obligé de la convoquer
de façon qu’elle soit tenue dans un délai d’un mois lorsqu’un ou plusieurs actionnaires représentant le cinquième du
capital social l’en requièrent par une demande écrite, indiquant l’ordre du jour.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l’ordre du jour et sont faites par lettres recommandées
adressées à chacun des actionnaires dix jours avant l’assemblée.
Art. 15. L’ordre du jour est arrêté par le conseil d’administration avec le ou les actionnaires ayant requis la convo-
cation de l’assemblée générale.
Il ne peut être mis en délibération que les propositions portées à l’ordre du jour, à moins que l’assemblée ne décide
à la majorité absolue du capital social de délibérer aussi sur d’autres objets.
Art. 16. A chaque réunion de l’assemblée générale, il est tenu une feuille de présence.
Elle contient les nom et domicile des actionnaires présents ou représentés et le nombre des actions possédées par
chacun d’eux. Cette feuille est signée par tous les actionnaires présents et certifiée par le bureau. Chaque membre de
l’assemblée a autant de voix qu’il possède et représente d’actions, sauf limitation légale.
Art. 17. L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou, en cas d’empêchement de celui-
ci, par le vice-président; en cas d’empêchement des deux, l’assemblée est présidée par un administrateur désigné à cet
effet.
Les fonctions de scrutateur sont remplies par les deux actionnaires présents représentant, par eux-mêmes ou comme
mandataires, le plus grand nombre d’actions. L’assemblée peut décider à l’unanimité de siéger sans scrutateur.
Le bureau nomme un secrétaire choisi ou non parmi les actionnaires.
Art. 18. Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux signés par le président
et le secrétaire de chaque assemblée.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux membres du conseil d’adminis-
tration.
Titre VI.- Exercice Social, Comptes Sociaux, Bénéfices, Répartitions
Art. 19. L’exercice social commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
Au 31 décembre de chaque année, le conseil d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels
conformément à la loi.
L’inventaire et les comptes annuels sont soumis à l’examen du ou des commissaires ou du ou des réviseurs d’entre-
prises.
Art. 20. L’excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux, moins-values, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Ce bénéfice est utilisé comme suit:
1. Cinq pour cent au moins sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement ne sera fait qu’aussi longtemps qu’il sera
légalement obligatoire.
2. Le surplus est à la disposition de l’assemblée générale. L’assemblée générale peut décider de payer un dividende
intérimaire en cours d’exercice.
Titre VII.- Liquidation
Art. 21. En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par les membres du conseil d’administration
alors en exercice, à moins que l’assemblée générale ne décide de nommer un ou plusieurs autres liquidateurs.
Les pouvoirs des liquidateurs et la marche de la liquidation sont réglés par les dispositions de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée dans la suite.
Titre VIII.- Contestations
Art. 22. Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de la société, ou lors de sa liquidation, soit
entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires, les administrateurs et la société, en raison des affaires
sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.
10169
Titre IX.- Dispositions Générales
Art. 23. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux
dispositions de la loi luxembourgeoise du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et de ses lois
modificatives.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital, est évalué à la somme de deux millions de
francs (2.000.000,-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: P. Tanson, N. Weyrich, A. Siebenaler, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 29 décembre 1999, vol. 121S, fol. 87, case 12. – Reçu 1.815.295 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 janvier 2000.
F. Baden.
(04060/200/240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TradeARBED EXPORT (LUXEMBOURG), Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 6.304.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
F. Baden.
(04061/200/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
THAMANIAH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 36.980.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
<i>Pour THAMANIAH S.A.i>
(04052/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TOITURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d’Activité ZARE.
R. C. Luxembourg B 50.517.
—
L’an deux mille, le treize janvier.
Par-devant Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, soussigné,
Ont comparu:
1) Monsieur Carlo Kieffer, couvreur, demeurant à L-3897 Foetz, 3, rue Jean Pierre Bicheler,
2) Madame Josiane Senger, employée de bureau, demeurant à L-3897 Foetz, 3, rue Jean Pierre Bicheler.
Lesquels comparants ont exposé au notaire ce qui suit:
Les comparants Carlo Kieffer et Josiane Senger sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée TOITURE
PLUS, S.à r.l., ayant son siège social à L-4384 Ehlerange, Zone d’activité ZARE, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 50.517, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date
du 13 mars 1995, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 293 du 26 juin 1995,
modifiée en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 12 novembre 1998, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 45 du 26 janvier 1999. Le capital social est fixé à la somme
de un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs, représenté par mille deux cent cinquante parts sociales
d’une valeur de mille francs chacune.
Ces parts ont été souscrites, comme suit:
1) Monsieur Carlo Kieffer, préqualifié, six cent vingt-cinq parts sociales …………………………………………………………………
625
2) Madame Josiane Senger, préqualifiée, six cent vingt cinq parts sociales ………………………………………………………………
625
Total: mille deux cent cinquante parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes ces parts ont été souscrites et entièrement libérées par des versements en espèces.
Lesquels comparants ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
10170
<i>Première résolutioni>
Madame Josiane Senger, préqualifiée, déclare céder et transporter en pleine propriété, cinq cent vingt-cinq parts
sociales, inscrites au nom de Madame Senger dans la société TOITURE PLUS, S.à r.l., prénommée, à Monsieur Carlo
Kieffer, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour le prix de cinq cent vingt-cinq mille francs (525.000,- LUF).
La présente cession est faite moyennant le prix de cinq cent vingt-cinq mille francs (525.000,-), que la cédante
reconnaît avoir reçu du cessionnaire avant la signature des présentes et hors de la présence du notaire instrumentaire,
ce dont elle consent bonne et valable quittance au cessionnaire.
Le cessionnaire Monsieur Carlo Kieffer sera propriétaire des parts cédées à partir des présentes et il aura droit aux
revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
En conformité avec la cession de parts ci-avant faite, les associés Monsieur Carlo Kieffer et Madame Josiane Senger
décident de modifier l’article six des statuts de la société à responsabilité limitée TOITURE PLUS, S.à r.l., pour lui donner
dorénavant la teneur suivante:
«Art. six. Le capital social est fixé à la somme d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxem-
bourgeois, représenté par mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales, d’une valeur de mille (1.000,-) francs luxem-
bourgeois chacune. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales
ordinaires et extraordinaires.
Ces parts sociales sont souscrites comme suit:
1) Monsieur Carlo Kieffer, couvreur, demeurant à L-3897 Foetz, 3, rue Jean-Pierre Bicheler, mille cent
cinquante part sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.150
2) Madame Josiane Senger, employée privée, demeurant à L-3897 Foetz, 3, rue Jean-Pierre Bicheler, cent
parts sociales…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
100
Totale mille deux cent cinquante parts sociales………………………………………………………………………………………………………………
1.250
Toutes ces parts sont intégralement libérées.»
<i>Troisième résolutioni>
Les associés déclarent accepter la démission de Monsieur Armin Mangrig, maître-couvreur, demeurant à D-54998
Aach, Auf dem Triesch 13, comme gérant technique de la société dans la branche travaux de couverture et de ferblan-
terie et ils lui donnent décharge.
Les associés déclarent accepter la démission de Monsieur Carlo Kieffer comme gérant administratif de la société dans
la branche travaux de couverture et de ferblanterie et ils lui donnent décharge.
Les associés déclarent accepter la démission de Monsieur Carlo Kieffer comme gérant unique de la société dans la
branche travaux de ramonage, de fumisterie et nettoyage de toitures.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident de nommer Monsieur Carlo Kieffer gérant unique pour une durée indéterminée et avec effet
immédiat pour toutes les branches de la société.
La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique.
Monsieur Carlo Kieffer, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant unique, déclare accepter la prédite cession de part
pour le compte de la société conformément à l’article 190 de la loi du 18 septembre 1933 concernant les sociétés à
responsabilité limitée respectivement à l’article 1690 du Code civil, et il déclare dispenser le cessionnaire de la faire
signifier à la société par voie d’huissier et n’avoir entre ses mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse
en arrêter l’effet.
<i>Fraisi>
Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des
comparants et de la société.
Dont acte, fait et passé à Grevenmacher, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, tous connus du notaire instrumen-
taire par leurs nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. Kieffer, J. Senger, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 14 janvier 2000, vol. 509, fol. 3, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): G. Schlink.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Grevenmacher, le 18 janvier 2000.
J. Gloden.
(04058/213/83) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TOITURE PLUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zone d’Activité ZARE.
R. C. Luxembourg B 50.517.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J. Gloden.
(04059/213/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10171
THE CAROUSEL PICTURE COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5380 Uebersyren, 45, rue de la Montagne.
R. C. Luxembourg B 50.829.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
<i>Pour THE CAROUSEL PICTURE COMPANY S.A.i>
(04054/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
THE ESTABLISHMENT TRUST, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.
Registered office: Luxembourg, 13, rue Goethe.
R. C. Luxembourg B 21.743.
—
EXTRACT
The Annual General Meeting of shareholders held at the registered office on Thursday, 15 July 1999 adopted the
following decisions:
1. The meeting approved the Chairman’s Report, the Auditor’s Report and the Annual Report and Audited Financial
Statements for the year ended 30 April 1999.
2. The meeting resolved to declare a dividend of 14 US cents payable on or after 23 July 1999 to shareholders of
record on 15 July 1999 with shares being quoted ex-dividend as from 16 July 1999.
3. The meeting proposed that the level of Chairman’s fees and Directors’ fees remain at US$ 10,000 and US$ 7,500
gross per annum respectively.
4. The meeting approved the full and total discharge for the proper performance of their duties to all members of the
Board of Directors with respect to the period ended 30 April 1999.
5. The Chairman noted the co-optation of Mr Raphael Kanza to the Board in the place of Mr Donald P. Lines effective
as of 15 July 1999. The meeting elected Mr Raphael Kanza and re-elected Messrs Marc-Hubert Henry, Hugh Sloane,
Christopher Wilcockson, Richard C Thornton, Henry Thornton and Dr James A C King for a period of one year ending
at the Annual General Meeting of 2000.
6. The meeting re-elected ERNST & YOUNG as Auditor for a period of one year ending at the Annual General
Meeting of 2000.
<i>For THE ESTABLISHMENT TRUSTi>
BANK OF BERMUDA (LUXEMBOURG) S.A.
Signature
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 28 décembre 1999, vol. 532, fol. 8, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04055/041/28) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
THEMUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxemoburg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 26.618.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
<i>Pour THEMUSE S.A.i>
(04056/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TURICUM LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg-Hamm, 11, rue de Bitbourg.
R. C. Luxembourg B 48.729.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire du 16 août 1999 que les résolutions suivantes ont été prises:
1. Sont nommées administrateurs:
ITPS (LUXEMBOURG) S.A., avec siège social au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg;
ITPS (NETHERLAND) B.V., avec siège social au 21, Nieuwe Uitleg, NL-2514 BR ‘S-Gravenhage;
ARD-CHOILLE B.V., avec siège social au 21, Nieuwe Uitleg, NL-2514 BR ‘S-Gravenhage.
2. Est nommée commissaire aux comptes:
DMS & ASSOCIES, S.à r.l., avec siège social à 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
3. Le siège social est transféré au 11, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm.
Signature
<i>Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 59, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): Signature.
(04063/000/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10172
TOBO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Registered office: L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri.
R. C. Luxembourg B 39.033.
—
DISSOLUTION
<i>Extraiti>
It results of a deed received by Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Luxembourg), on the 23rd
December 1999, registered in Esch-sur-Alzette, on the 5th of January 1999, vol. 847, fol. 32, case 5, that the Société
Anonyme TOBO HOLDING S.A., having its registered office at L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri,
registered in the registre de commerce et des sociétés in Luxembourg, section B number 39.033, incorporated by
notarial deed on 18th December 1991, published in the Mémorial C number 247 on 9th June 1991, the capital of which
is fixed at fifteen million Luxembourg Francs (LUF 15,000,000.-), divided into fifteen thousand (15,000) shares of one
thousand Luxembourg Francs (LUF 1,000.-) each, entirely paid up, has been dissolved and liquidated by the concen-
tration of the shares of TOBO HOLDING S.A. prenamed, in one hand, which is the expressly willpower of the sole
shareholder.
Suit la traduction française du texte qui précède:
Il résulte d’un acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg), en date du 23
décembre 1999, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2000, vol. 847, fol. 32, case 5, que la Société Anonyme TOBO
HOLDING S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 11, boulevard du Prince Henri, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 39.033, constituée suivant acte notarié du 18
décembre 1991, publié au Mémorial C numéro 247 du 9 juin 1992, au capital social de quinze millions de francs luxem-
bourgeois (LUF 15.000.000,-), divisé en quinze mille (15.000) actions de mille francs luxembourgeois (LUF 1.000,-)
chacune, entièrement libérées, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant
entre ses mains la totalité des actions de la Société TOBO HOLDING S.A., prédésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 18 janvier 2000.
J.-J. Wagner
<i>Notairei>
(04057/239/31) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TRANSMOSELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2336 Luxembourg, 55, Montée Pilate.
R. C. Luxembourg B 46.081.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 14 janvier 2000, vol. 532, fol. 61, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 janvier 2000.
<i>Pour la S.à r.l. TRANSMOSELLEi>
FIDUCIAIRE CENTRALE DU LUXEMBOURG S.A.
(04062/503/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
USINE ALUMINIUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1233 Luxembourg, 13, rue Bertholet.
R. C. Luxembourg B 51.857.
—
DISSOLUTION
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinairei>
<i>tenue à Luxembourg en date du 23 décembre 1999i>
Il résulte dudit procès-verbal ce qui suit:
1) Adoptant les conclusions du rapport du commissaire-vérificateur, l’assemblée approuve les comptes de liquidation
et donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction à Monsieur Lex Benoy, réviseur d’entreprises,
demeurant à Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la société ainsi qu’au commissaire-vérificateur Monsieur Jean-
Marie Boden, expert comptable et fiscal, demeurant à Luxembourg.
2) Tous les documents et livres comptables de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq
ans à Luxembourg, 13, rue Bertholet.
3) L’assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société Anonyme USINE ALUMINIUM S.A. a
définitivement cessé d’exister.
Luxembourg, le 23 décembre 1999.
<i>Pour la Sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04069/800/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10173
TURN, PAGE & WISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.708.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 2000, vol. 532, fol. 71, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Administrateuri>
(04064/565/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
TURN, PAGE & WISE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 37.708.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 1999i>
Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats ainis que pour la non-tenue de l’assemblée à la date
statutaire.
L’Assemblée renomme pour un terme de six ans M. Marc Rummens comme Administrateur-délégué, Mme
Dominique Cop et M. Sven Bohne comme Administrateurs et H.R.T. REVISION, S.à r.l. comme Commissaire aux
Comptes.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2005.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateur-déléguéi>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 71, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(04065/565/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
U.S. INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 46.527.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1998, enregistrés à Luxembourg, le 13 janvier 2000, vol. 532, fol. 58, case 10,
ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Luxembourg, le 14 janvier 2000.
<i>Pour U.S. INTERNATIONAL S.A.i>
(04068/720/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
UTOPIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.756.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt décembre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.
A comparu:
Monsieur Nico Simon, Administrateur-délégué d’UTOPIA S.A, demeurant à Schuttrange,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d’administration de la société anonyme UTOPIA S.A., avec siège
social à Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy,
en vertu d’un pouvoir lui conféré par décision du conseil d’administration prise lors de sa réunion en date du 13
décembre 1999;
un extrait du procès-verbal de ladite réunion, signé ne varietur par le comparant, agissant ès dites qualités, et le
notaire instrumentant, restera annexé au présent acte avec lequel il sera soumis à la formalité de l’enregistrement,
aux fins d’exécuter les dispositions contenues dans l’article 5 des statuts de la société, y insérées lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 19 octobre 1999.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire d’acter les déclarations suivantes:
I.- La société anonyme UTOPIA S.A., avec siège social à Luxembourg, 45, avenue J.F. Kennedy, immatriculée au
registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 29.756, a été constituée sous forme d’une société
à responsabilité limitée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 29 décembre 1988, publié au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations C, numéro 102 du 17 avril 1989. Elle a été modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné,
le 10 février 1994, publié au Mémorial C, numéro 226 du 9 juin 1994, suivant acte reçu par le notaire soussigné le 26
août 1994, publié au Mémorial C, numéro 516 du 10 décembre 1994, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 20
10174
août 1999, publié au Mémorial C, numéro du 869 du 19 novembre 1999, et suivant acte reçu par le notaire soussigné le
19 octobre 1999, en voie de publication au Mémorial C.
II.- Que le capital social de la société s’élève actuellement à LUF 141.120.000,- (cent quarante et un millions cent vingt
mille francs luxembourgeois), représenté par 705.600 (sept cent cinq mille six cents) actions, chacune sans désignation
de valeur nominale, toutes entièrement libérées.
III.- Conformément à l’article 5 des statuts, le conseil d’administration de la société dont il s’agit a été autorisé à
augmenter le capital social dans la forme suivante:
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de LUF 300.000.000,- (trois cents millions de
francs luxembourgeois) qui sera représenté par 1.500.000 (un million cinq cent mille) actions chacune sans désignation
de valeur nominale.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le Conseil d’administration est autorisé, pendant une période de cinq ans prenant fin le 19 octobre 2004, à
augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé avec émission d’actions
nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d’émission, à libérer en espèces, en
nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la société, ou
même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d’émission, ou par conversion
d’obligations comme dit ci-après.
Le Conseil d’administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Ce capital autorisé peut être utilisé dans le cadre d’un plan d’option d’actions en faveur du personnel de la Société ou
du personnel d’un de ses actionnaires.
Le Conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le Conseil d’administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.»
IV.- Que par résolutions prises le 13 octobre 1999 et le 19 novembre 1999, le conseil d’administration a décidé de
réaliser une première tranche de l’augmentation de capital à concurrence de LUF 37.771.400,- (trente-sept millions sept
cent soixante et onze mille quatre cents francs luxembourgeois) par voie de souscription publique et de porter le capital
de LUF 141.120.000,- (cent quarante et un millions cent vingt mille francs luxembourgeois) à LUF 178.891.400,- (cent
soixante-dix-huit millions huit cent quatre-vingt-onze mille quatre cents francs luxembourgeois), par la création et
l’émission de 188.857 (cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-sept) actions nouvelles chacune sans désignation
de valeur nominale au prix de souscription net de LUF 2.118,- (deux mille cent dix-huit francs luxembourgeois) par
action, représentant le pair comptable de LUF 200,- (deux cents francs luxembourgeois) et une prime d’émission de LUF
1.918,- (mille neuf cent dix-huit francs luxembourgeois).
Les actions nouvelles jouissent des mêmes droits et avantages que les actions existantes à partir du 17 décembre
1999.
V.- Que dans sa réunion du 9 novembre 1999, le conseil d’administration a décidé de réserver dans le cadre de l’offre
un nombre maximum de 2.360 (deux mille trois cent soixante) actions en faveur du personnel et de la direction de la
Société avec un prix d’attribution correspondant au prix d’émission moins une décote de 20% (vingt pour cent), cet
avantage étant uniquement réservé au personnel bénéficiant au moment de la souscription d’un contrat à durée indéter-
minée et ayant au moins un an d’ancienneté, aux membres de la direction, aux administrateurs et aux membres des
comités ainsi qu’aux indépendants bénéficiant d’un contrat de prestation de services permanent.
VI.- Que le conseil d’administration, dans sa réunion du 13 décembre 1999 a constaté la clôture anticipée au 2
décembre 1999 de la période de souscription ainsi que la souscription à toutes les 188.857 (cent quatre-vingt-huit mille
huit cent cinquante-sept) actions nouvelles, les actionnaires actuels de la Société ayant renoncé à leur droit préférentiel
de souscription, sauf la société STRATINVEST S.A.
Sur ces 188.857 (cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-sept) actions nouvelles, 1.694 (mille six cent quatre-
vingt-quatorze) ont été souscrites par le personnel et la direction de la Société, avec un prix d’émission correspondant
à LUF 1.694.- (mille six cent quatre-vingt-quatorze francs luxembourgeois) par action, correspondant au pair comptable
de LUF 200,- (deux cents francs luxembourgeois) et une prime d’émission de LUF 1.494,- (mille quatre cent quatre-
vingt-quatorze francs luxembourgeois); et le solde, soit 187.163 (cent quatre-vingt-sept mille cent soixante-trois) actions
ont été souscrites au prix de souscription de LUF 2.118,- (deux mille cent dix-huit francs luxembourgeois) par action,
correspondant au pair comptable de LUF 200,- (deux cents francs luxembourgeois) et une prime d’émission de LUF
1.918,- (mille neuf cent dix-huit francs luxembourgeois).
Toutes les 188.857 (cent quatre-vingt-huit mille huit cent cinquante-sept) actions nouvelles ainsi souscrites ont été
entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de LUF 399.280.870,- (trois cent quatre-
vingt-dix-neuf millions deux cent quatre-vingt mille huit cent soixante-dix francs luxembourgeois) a été versée sur les
comptes de la société, faisant 37.771.400,- (trente-sept millions sept cent soixante et onze mille quatre cents francs
luxembourgeois) pour l’augmentation de capital social, 2.530.836,- (deux millions cinq cent trente mille huit cent trente-
six francs luxembourgeois) pour la prime d’émission globale des actions souscrites par le personnel et la direction de la
société et LUF 358.978.634,- (trois cent cinquante-huit millions neuf cent soixante-dix-huit mille six cent trente-quatre
francs luxembourgeois) pour la prime d’émission globale des actions souscrites dans le public.
Il a été justifié au notaire instrumentant, qui le constate expressément, de la souscription et de la libération des actions
nouvelles et de la prime d’émission afférente par une attestation bancaire. Les documents justificatifs des renonciations
10175
des anciens actionnaires qui ont renoncé au droit de souscription préférentiel ont également été présentés au notaire
soussigné.
Ces documents, ainsi que des copies des procès-verbaux du conseil d’administration du 13 octobre 1999, du 9
novembre 1999 et du 19 novembre 1999 resteront annexés au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de
l’enregistrement, après avoir été signés ne varietur par le comparant agissant ès dites qualités et le notaire instru-
mentant.
VII.- Que suite à la réalisation de cette première tranche de l’augmentation de capital autorisée, le premier alinéa de
l’article 5 des statuts est modifié en conséquence et a la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à LUF 178.891.400,- (cent soixante-dix-huit millions huit cent
quatre-vingt-onze mille quatre cents francs luxembourgeois), représenté par 894.457 (huit cent quatre-vingt-quatorze
mille quatre cent cinquante-sept) actions chacune sans désignation de valeur nominale, toutes entièrement libérées.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison des présentes est estimé sans nul
préjudice à la somme de LUF 4.200.000,- (quatre millions deux cent mille francs luxembourgeois).
Dont acte, fait et dressé, date qu’en tête des présentes, à Luxembourg.
Et après lecture de tout ce qui précède, donnée en langue de lui connue au comparant, agissant ès dites qualités,
connu du notaire instrumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec Nous,
Notaire.
Signé: N. Simon, T. Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 21 décembre 1999, vol. 4CS, fol. 11, case 5. – Reçu 3.992.809 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 2000.
T. Metzler.
(04070/222/118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
UTOPIA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 45, boulevard J. F. Kennedy.
R. C. Luxembourg B 29.756.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 18 janvier 2000.
T. Metzler.
(04071/222/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
VAN KASTEREN SERVICES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 22.221.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VAN KASTEREN SERVICES, S.à r.l.i>
J. Reuter
(04074/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
VANK-IMMO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 35.046.
—
Le bilan au 31 décembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 19 janvier 2000, vol. 532, fol. 73, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour VANK-IMMO, S.à r.l.i>
J. Reuter
(04075/517/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2000.
10176
S O M M A I R E
MERSCH & SCHMITZ
LABORA
AOL EUROPE S.A.
LA CIVETTE
LANDESBANK RHEINLAND-PFALZ INTERNATIONAL S.A.
LASHEID S.A.
LASHEID S.A.
LINSTER HIGH TECH S.A.
LA SPHERA S.A.
LA SPHERA S.A.
LION OBLILUX.
LIM INVESTMENT S.A.
LIM INVESTMENT S.A.
LOPHIRA
LUCARVEST S.A.
LUNATIK
LUXOMATIQUE S.A.
LUX ORGA
MAGEPAR S.A.
MAGEPAR S.A.
MAGEPAR S.A.
LYCOOP S.A.
LYCOOP S.A.
MARIUCCI FRERES
MARIUCCI FRERES
MASCO CORPORATION EUROPE
MASCO CORPORATION EUROPE
MANDELO S.A.
MAGALI S.A.
MANULIFE GLOBAL FUND
MAUNA INTERNATIONAL
SOCEURIMMO S.A.
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE HINH.
SOCIETE MEDITERRANEENNE DE CONSEILS S.A.
SOVALIM
T.G.E. S.A.
TANDIL S.A.
TASKU IMMOBILIERE S.A.
YARD
TAVY S.A.
TER-PROM
TERRY S.A.
TradeARBED EXPORT LUXEMBOURG
TradeARBED EXPORT LUXEMBOURG
THAMANIAH S.A.
TOITURE PLUS
TOITURE PLUS
THE CAROUSEL PICTURE COMPANY S.A.
THE ESTABLISHMENT TRUST
THEMUSE S.A.
TURICUM LUXEMBOURG S.A.
TOBO HOLDING S.A.
TRANSMOSELLE
USINE ALUMINIUM S.A.
TURN
TURN
U.S. INTERNATIONAL S.A.
UTOPIA S.A.
UTOPIA S.A.
VAN KASTEREN SERVICES
VANK-IMMO