This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
15793
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 330
10 mai 1999
S O M M A I R E
Aries Funding Corporation II, George Town page
15826
Citadel Administration S.A., Luxembourg ………………
15805
Ermitage International Bond Fund, Sicav, Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15794
Euro-Inventeur S.A., Wickrange ……………………………………
15794
Europart, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
15795
Euro Telecom, S.à r.l., Luxembourg ……………………………
15795
Ex Libris (Luxembourg) S.A., Luxembourg ………………
15796
Ex Libris S.A., Luxembourg ………………………………………………
15795
Farma Trading S.A., Luxembourg …………………………………
15796
Felbrigg, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
15797
Felt, S.à r.l., Luxembourg……………………………………………………
15797
Fiduciaire Générale de Luxembourg S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15797
Financial Assets Luxembourg S.A., Luxembourg
15799
Financière Concorde S.A., Luxembourg ……………………
15799
Flour S.A., Luxembourg………………………………………
15797
,
15798
(N.) Folschette, S.à r.l., Kockelscheuer ……
15800
,
15801
Forex Trading Group (Luxembourg) S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15798
Friture de la Moselle, S.à r.l., Remich …………………………
15799
F.T.A. Consulting and Trading, S.à r.l., Luxembourg
15800
Gellet Invest S.A., Luxembourg ………………………………………
15800
General Venture Capital III Holding S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15801
G.F. Consultant, S.à r.l., Luxembourg …………………………
15800
Global Car Consulting S.A., Reckange/Mersch ………
15802
Gooding Consumer Electronics Luxembourg S.A.
15802
Gramano Holding S.A., Luxembourg……………………………
15801
(Le) Grand S.A., Luxembourg …………………………………………
15810
Greenpine S.A., Luxembourg …………………………………………
15803
Greenwood S.A., Luxembourg…………………………………………
15802
Groupe COFILUX (Compagnie Financière Luxem-
bourgeoise) S.A., Luxembourg……………………………………
15804
GS RE, Société de Réassurance du Groupe Gras
Savoye S.A., Luxembourg ……………………………………………
15802
Guapo S.A., Luxembourg……………………………………………………
15804
Gummi-Roller, S.à r.l., Luxembourg ……………
15803
,
15804
Hamel Holding S.A., Luxembourg …………………………………
15804
Healthfinance S.A., Luxembourg ……………………………………
15803
Henneaux Luxembourg S.A., Luxembourg ………………
15805
Human Resources Management S.A., Luxembourg
15804
I.C. Productions, S.à r.l., Luxembourg …………………………
15805
Immobat, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
15806
Immobilière Scheffen, S.à r.l., Frisange ………………………
15805
Immoco, S.à r.l., Rumelange ……………………………………………
15806
International Crédit Mutuel Life S.A., Luxembourg
15805
Internationaal Food Invest S.A., Luxembourg …………
15806
International Telecom, S.à r.l., Luxembourg ……………
15807
Interparco Holding S.A. Luxembourg, Luxembourg
15806
I.T.U., S.à r.l., Luxembourg ………………………………………………
15807
Ixworth, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
15807
J.S.G.B. Holding S.A., Luxembourg ………………………………
15808
Kerverne, S.à r.l., Luxembourg ………………………………………
15808
Kodemac, S.à r.l., Wasserbillig…………………………………………
15807
Kwizda Finanz A.G., Luxemburg ……………………
15809
,
15810
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, Kiel
15808
Leto Holding S.A., Luxembourg ……………………………………
15812
Lotaks S.A. …………………………………………………………………………………
15811
Luxgestion, S.à r.l., Frisange ……………………………………………
15811
Luxsol, S.à r.l., Foetz ……………………………………………………………
15811
Mahifa Investments S.A., Luxembourg ………………………
15812
Malden S.A., Luxembourg …………………………………………………
15811
Ma. Lo S.A., Luxembourg …………………………………………………
15812
Mapom S.A., Luxembourg …………………………………………………
15813
Marowinia Holding S.A., Luxembourg …………………………
15815
Masters Trading Group S.A., Luxemburg …………………
15813
Maxiweb S.A., Luxembourg ………………………………………………
15815
Medafin S.A., Luxembourg…………………………………………………
15816
Medical Services Participations S.A., Luxembourg
15815
Medinger Norbert, S.à r.l., Remich ………………………………
15817
MGM Commerce S.A., Luxembourg ……………………………
15814
M.H.R. Trading Company, S.à r.l., Luxembourg ……
15816
M.M. Warburg-LuxInvest S.A., Luxembourg ……………
15817
Molshi S.A., Luxembourg ……………………………………………………
15817
Montante Holding S.A., Luxembourg …………………………
15819
M.P.H. Participation S.A., Luxembourg ………………………
15818
M.P. Internationale S.A., Luxembourg …………………………
15818
Mulfin S.A., Luxembourg ……………………………………………………
15817
Multi Finance S.A., Strassen ……………………………
15819
,
15820
Multi-House S.A., Esch an der Alzette…………
15820
,
15821
New Enterprises S.A., Luxembourg………………………………
15820
New Style Hairdresser, S.à r.l., Luxembourg……………
15821
Nikko Europe, S.à r.l., Luxembourg………………………………
15823
North Atlantic Fishery Investments S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15824
(Le) Nouveau Chez Nous, S.à r.l., Luxembourg ……
15808
Ocarina S.A., Luxembourg…………………………………………………
15824
Oldie FM S.A., Luxembourg………………………………………………
15824
Omnis Gefibat S.A., Luxembourg …………………………………
15825
Optimed, S.à r.l., Wellenstein …………………………………………
15825
Oti Holding S.A., Luxembourg ………………………………………
15825
Part Hôtel S.A., Luxembourg …………………………………………
15825
Pharminvest S.A., Luxembourg ………………………………………
15826
PK Intertrading, S.à r.l., Alzingen …………………………………
15826
Pneus Mreches, S.à r.l., Windhof ……………………
15821
,
15823
Polygram Holding (Luxembourg) S.A., Luxem-
bourg ………………………………………………………………………………………
15823
Polygram S.A., Luxembourg ……………………………………………
15840
(Le) Run, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………
15809
ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 35.426.
Acte constitutif publié à la page 464 du Mémorial C, n° 10 du 11 janvier 1991.
—
Le bilan au 31 mai 1995, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1999, vol. 519, fol. 89, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(10122/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 35.426.
Acte constitutif publié à la page 464 du Mémorial C, n° 10 du 11 janvier 1991.
—
Le bilan au 31 mai 1996, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1999, vol. 519, fol. 89, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(10123/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 35.426.
Acte constitutif publié à la page 464 du Mémorial C, n° 10 du 11 janvier 1991.
—
Le bilan au 31 mai 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1999, vol. 519, fol. 89, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(10124/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 17, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 35.426.
Acte constitutif publié à la page 464 du Mémorial C, n° 10 du 11 janvier 1991.
—
Le bilan au 31 mai 1998, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1999, vol. 519, fol. 89, case 6, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(10125/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
EURO-INVENTEUR, Société Anonyme, en Liquidation.
Siège social: L-3980 Wickrange, 4-6, rue des Trois Cantons.
R. C. Luxembourg B 45.978.
—
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire i>
<i>tenue en date du 27 janvier 1999 à Wickrangei>
Il résulte de l’assemblée générale ordinaire que:
1. L’assemblée prend acte du rapport du liquidateur sur les actes accomplis pendant la période de liquidation.
2. La FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., 21, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, est nommée en tant
que commissaire à la liquidation.
3. La date de l’assemblée générale extraordinaire qui statuera sur la clôture de la liquidation est fixée au 23 février
1999 à 15.30 heures à Wickrange.
Luxembourg, le 19 février 1999.
Pour extrait conforme et sincère
Signature
<i>Le Mandataire de la Sociétéi>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10132/507/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15794
EUROPART, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1242 Luxembourg, 4, rue André Duchscher.
R. C. Luxembourg B 33.180.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signatures.
(10133/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
EURO TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.421.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 février 1999, vol. 519, fol. 84, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Pour ordre
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
(10134/549/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
EX LIBRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 35.167.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 14 septembre 1998i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Azriel Morag;
- Monsieur Ehud Arad;
- Monsieur Pierre Schneider;
et le mandat du commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1998.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(10135/635/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
EX LIBRIS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 35.167.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg, le 14 septembre 1998i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Azriel Morag;
- Monsieur Ehud Arad;
- Monsieur Pierre Schneider;
et le mandat du commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1998.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(10136/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15795
EX LIBRIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 54.575.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(10137/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
EX LIBRIS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 54.575.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(10138/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FARMA TRADING, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 45.632.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 14 décembre 1998i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Robert Niestle;
- Monsieur José Dominguez;
- Monsieur Sylvain Rigo;
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1998.
Luxembourg, le 1
er
février 1999.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
(10141/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FARMA TRADING, Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 45.632.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 14 décembre 1998i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Robert Niestle;
- Monsieur José Dominguez;
- Monsieur Sylvain Rigo;
ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1998.
Luxembourg, le 1
er
février 1999.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
<i>Agent Domiciliatairei>
(10142/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15796
FELBRIGG, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: LUF 500.000,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.567.
Acte constitutif publié à la page 16629 du Mémorial C, n° 347 du 3 juillet 1997.
—
Le bilan au 5 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 16, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signatures.
(10143/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FELT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 8, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 62.166.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
P. Rochas
<i>Géranti>
(10144/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 60.930.
—
EXTRAIT
Monsieur François Winandy et Madame Mireille Gehlen ont démissionné en date du 31 décembre 1998 de leurs
fonctions d’administrateurs de la société FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A.
Luxembourg, le 11 février 1999.
Pour extrait conforme.
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10146/507/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FLOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
A comparu:
Monsieur John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Contern,
agissant en sa qualité de mandataire de la société FLOUR S.A., avec siège social à Luxembourg,
en vertu d’une délégation de pouvoirs consenti par le conseil d’administration en date du 22 décembre 1998, dont
une copie restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter les déclarations suivantes:
I. FLOUR S.A., ayant son siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en
date du 11 décembre 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 220 du 7 avril 1998.
II. Le capital souscrit de la société est de ITL 100.000.000,- (cent millions de lires italiennes), représenté par 100 (cent)
actions de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune.
Lors de la constitution de la société, le conseil d’administration a été autorisé à augmenter le capital à
ITL 20.000.000.000,- (vingt milliards de lires italiennes) représenté par 20.000 (vingt mille) actions de ITL 1.000.000,- (un
million de lires italiennes) chacune, jouissant des mêmes droits que les actions existantes. En conséquence, il est autorisé
à réaliser cette augmentation de capital, spécialement à émettre les actions nouvelles en une ou plusieurs fois et par
tranches, à fixer l’époque et le lieu de l’émission intégrale ou des émissions partielles éventuelles, à déterminer les condi-
tions de souscription et de libération, à faire appel, le cas échéant, à de nouveaux actionnaires, enfin à arrêter toutes
autres modalités d’exécution se révélant nécessaires ou utiles et même non spécialement prévues en la présente
résolution, à faire constater en la forme requise les souscriptions des actions nouvelles, la libération et les augmentations
effectives du capital et enfin, à mettre les statuts en concordance avec les modifications dérivant de l’augmentation de
capital réalisée et dûment constatée, le tout conformément à la loi modifiée du 15 août 1915, notamment avec la
condition que l’autorisation ci-dessus doit être renouvelée tous les cinq ans.
15797
III. Par résolution prise par le conseil d’administration en date du 22 décembre 1998, le conseil a décidé de procéder
à une première tranche d’augmentation de capital par la souscription de 400 (quatre cents) actions nouvelles d’une
valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes) chacune, entièrement libérées, de sorte que le capital
social se trouve augmenté à concurrence de ITL 400.000.000,- (quatre cents millions de lires italiennes) et passe de ITL
100.000.000,- (cent millions de lires italiennes) à ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes).
Toutes les actions nouvelles ont été libérées intégralement en espèces, la preuve en ayant été rapportée au notaire
instrumentaire.
IV. Suite à cette augmentation de capital, l’article 5, premier alinéa des statuts aura la teneur suivante:
«Art. 5. Premier alinéa. Le capital souscrit est fixé à ITL 500.000.000,- (cinq cents millions de lires italiennes),
représenté par 500 (cinq cents) actions d’une valeur nominale de ITL 1.000.000,- (un million de lires italiennes)
chacune.»
<i>Evaluation du capitali>
Pour les besoins de l’enregistrement, le montant de l’augmentation du capital social est évalué à huit millions trois cent
trente-quatre mille francs luxembourgeois (8.334.000,- LUF).
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite de
cette augmentation de capital s’élève à environ cent trente cinq mille francs luxembourgeois (135.000,- LUF).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état
et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous noataire le présent acte.
Singé: J. Seil, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 janvier 1999, vol. 408, fol. 9, case 2. – Reçu 83.340 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 19 janvier 1999.
E. Schroeder.
(10153/228/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FLOUR S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 février 1999.
E. Schroeder.
(10154/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FOREX TRADING GROUP (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme,
(anc. BENELUX TRADING GROUP S.A. (LUXEMBOURG).)
Succursale: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 60.992.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit février.
Par-devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Monsieur René Jan Willemse, administrateur de sociétés, demeurant à Casa Prat Del Bosc, Pal, La Massana - Princi-
pauté d’Andorra;
agissant pour compte et au nom de la société anonyme de droit panaméen FOREX TRADING GROUP S.A., (ancien-
nement dénommée BENELUX TRADING GROUP S.A.), ayant son siège social à Panama City (République de Panama),
Banco de Boston Building, Etage numéro 8, Via Espana y Calle Elvira Mendez, constituée suivant acte, portant le numéro
notarial 7.249, reçu le 30 juillet 1996 par Maître Alfredo Abraham Sanchez Ortega, notaire de résidence à Panama City
(République de Panama), enregistré au registre public de Panama City le 31 juillet 1996, Volume 348 numéro 6965 et à
la section microfilm (Mercantil) le 1 août 1996, Microjacket 318998 Rôle 50567 Image 12;
en vertu d’une procuration sous seing privé contenue dans une décision du Conseil d’Administration de la société
prénommée, prise en date du 1
er
février 1999, et dont question ci-après.
Lequel comparant, agissant ès dites qualité, a requis le notaire instrumentant de procéder au dépôt au rang de ses
minutes des pièces suivantes:
1) Une décision du conseil d’administration de la société prédésignée en date du 1
er
février 1999, dressée en anglais;
2) Une traduction assermentée en anglais, faite par une traductrice publique autorisée panaméenne, Madame Marlee
Martiz-Lee, du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société BENELUX TRADING GROUP S.A.,
tenue le 25 novembre 1998, authentifié par acte numéro 12.934 du notaire Alfredo Abraham Sanchez Ortega de
résidence à Panama-City (République de Panama) le 26 novembre 1998, contenant entre autres la décision de modifier
la dénomination de la société en FOREX TRADING GROUP S.A.;
15798
3) Un certificat de l’extrait du registre public de Panama City daté du 10 décembre 1998, attestant les modifications
apportées par la prédite assemblée générale extraordinaire, en langue espagnole, suivi d’une traduction assermentée en
anglais.
Lesquels documents, paraphés ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, seront enregistrés avec le
présent acte dont ils font intégralement partie.
Ensuite, le comparant a requis le notaire instrumentant d’acter ses déclarations qui suivent:
I. Que la société FOREX TRADING GROUP S.A., dénommée anciennement BENELUX TRADING GROUP S.A., a
établi au Grand-Duché de Luxembourg une succursale sous la dénomination de BENELUX TRADING GROUP S.A.
(LUXEMBOURG), ayant son siège à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte (5ième étage),
inscrite au registre de commerce de Luxembourg section B numéro 60.992, ceci par un acte signé par-devant Maître
Camille Hellinckx, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 17 septembre 1997, publié au Mémorial C, page
364 de 1998.
II. Que la société BENELUX TRADING GROUP S.A., a modifiée sa dénomination en FOREX TRADING GROUP
S.A., par décision de l’assemblée générale extraordinaire tenue le 25 novembre 1998, authentifiée par acte, portant le
numéro 12.934, du notaire Alfredo Abraham Sanchez Ortega de résidence à Panama-City (République de Panama) le 26
novembre 1998.
III. Que le conseil d’administration de FOREX TRADING GROUP S.A., a décidé en sa réunion du 1
er
février 1999 de
modifier la dénomination de la succursale en FOREX TRADING GROUP (LUXEMBOURG) S.A.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date portée ci-avant et, lecture faite, le comparant a signé avec nous, notaire.
Singé: R. Willemese, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 8 février 1999, vol. 114S, fol. 71, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.
J. Elvinger.
(10157/211/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FINANCIERE CONCORDE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 54.320.
—
Statuts coordonnés en date du 18 février 1999 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le
24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
(10148/208/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FRITURE DE LA MOSELLE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5553 Remich, 2, quai de la Moselle.
R. C. Luxembourg B 43.879.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signatures.
(10158/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
FINANCIAL ASSETS LUXEMBOURG, Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 33.008.
—
DISSOLUTION
Il résulte d’un acte reçu par Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg en date du 25 janvier
1999, enregistré à Luxembourg; le 2 février 1999, volume 114S, fol. 59, case 6, que la société anonyme FINANCIAL
ASSETS LUXEMBOURG ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg, section B sous le numéro 33.008, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 20
décembre 1989, publié au Mémorial, Recueil Spécial C des Sociétés et Associations, numéro 280 du 14 août 1990, et
dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu en date du 28 février 1990, publié au Mémorial C, numéro 331 du 18
septembre 1990;
au capital de quatre millions de francs (Frs 4.000.000,-) représenté par quarante mille (40.000) actions de cent francs
(Frs 100,-) chacune, a été dissoute et liquidée par le fait d’une décision de l’actionnaire unique, réunissant en ses mains
la totalité des actions de la société anonyme FINANCIAL ASSETS LUXEMBOURG, présdésignée.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
M. Thyes-Walch.
(10147/233/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15799
F.T.A. CONSULTING AND TRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1227 Luxembourg, 3, rue Bellevue.
R. C. Luxembourg B 38.420.
Constituée par-devant M
e
Christine Doerner, notaire de résidence à Bettembourg, en date du 4 octobre 1991, acte
publié au Mémorial, C, n° 148 du 16 avril 1992, modifiée par-devant M
e
Edmond Schroeder, notaire de résidence
à Mersch, en date du 9 mars 1995, acte publié au Mémorial C, n° 296 du 28 juin 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 92, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour F.T.A. CONSULTING AND TRADING, S.à r.l.i>
KPMG EXPERTS COMPTABLES
Signature
(10159/537/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GELLET INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 58.049.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg, le 16 juin 1998i>
L’Assemblée renouvelle les mandats d’administrateurs de:
- Monsieur Pierre Letargez;
- Monsieur Yves Geltmeyer;
- Madame Pascale Paindavoine;
L’Assemblée renouvelle le mandat de commissaire aux comptes de la société:
MAZARS & GUERARD (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés prendront fin à l’issue de l’assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de 1998.
Luxembourg, le 24 février 1999.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(10162/636/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
G.F. CONSULTANT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 161, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 61.175.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signatures.
(10166/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
N. FOLSCHETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 16, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.193.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le deux février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée N. FOLSCHETTE,
S.à r.l., ayant son siège social à L-1899 Kockelscheuer, 16, route de Luxembourg, constituée suivant acte, reçu par le
notaire instrumentaire, en date du 19 novembre 1998, non encore publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et
Associations C, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous la section B et le numéro
67.193, au capital social de un million cinq cent mille francs luxembourgeois (LUF 1.500.000,-), représenté par cent
cinquante (150) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune, intégralement libérées.
L’assemblée est composée de:
1.- la société anonyme holding S.C.O.N.A. S.A.H., avec siège social à L-6415 Echternach, 7, rue Bréilekes,
ici représentée par Monsieur Alphonse Weber, administrateur de sociétés, demeurant à Biwer,
en vertu d’une procuration sous seing privé, donnée à
laquelle procuration, paraphée ne varietur, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci:
2.- Madame Nancy Folschette, artisan-commerçante, demeurant à L-5539 Remich, 8, place Nico Klopp.
15800
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de ladite société, se considérer comme dûment convoqués,
avoir connaissance de l’ordre du jour et avoir unanimément pris la résolution suivante:
Les associés décident d’ajouter un deuxième alinéa à l’article dix des statuts avec la teneur suivante:
«Art. 10. (deuxième alinéa). Toute délégation même partielle des pouvoirs attribués à l’organe de gérance, est
soumise à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des associés qui en statue comme en matière de modification
des statuts.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: A. Weber, N. Folschette, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 5 février 1999, vol. 114S, fol. 68, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Luxembourg, le 22 février 1999.
E. Schlesser.
(10155/227/35) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
N. FOLSCHETTE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 16, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 67.193.
—
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 février 1999.
E. Schlesser.
(10156/227/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 38.586.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1995 et au 31 décembre 1996, ainsi que les autres documents et informations
qui s’y rapportent, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Auszug der Ordentlichen Generalversammlung vom 10. Dezember 1998i>
Die Versammlung erteilt dem Rechnungskommissar Entlastung für das von ihm ausgeübte Mandat. Das Mandat des
Rechnungsprüfers wird bis zur Generalversammlung, die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 1997 genehmigt
verlängert.
Die Versammlung erteilt den bei der ausserordentlichen Generalversammlung vom 8. Dezember 1998 zurückgetre-
tenen Verwaltungsratsmitgliedern Entlastung für die von ihnen ausgeübten Mandate. Das Mandat der folgenden Verwal-
tungsratsmitglieder wird bis zur Generalversammlung, die den Jahresabschluss zum 31. Dezember 1997 genehmigt,
verlängert:
- Herr Patrick Rochas;
- Herr Maurice Houssa;
- Frau Céline Stein.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) S.A.
P. Rochas
(10163/636/23) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GRAMANO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 31.826.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 21 juillet 1998i>
Conformément à l’article 100 sur les sociétés, il a été voté la continuation de l’activité de la société malgré une perte
supérieure à la moitié du capital.
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 13, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
GRAMANO HOLDING S.A.
Signature
(10168/005/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15801
GOODING CONSUMER ELECTRONICS LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 46.791.
—
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
janvier 1999, l’agent domiciliataire DELOITTE & TOUCHE S.A., (anciennement FIDUCIAIRE
GENERALE DE LUXEMBOURG, avant l’acte de scission du 23 décembre 1998), a dénoncé le domicile établi en ses
locaux, sis au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, de la Société Anonyme GOODING CONSUMER ELECTRONICS
S.A., de sorte que celle-ci se trouve jusqu’à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.
En outre, à la date susmentionnée, la société DELOITTE & TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l. a donné sa démission
en tant que commissaire aux comptes.
Luxembourg, le 12 février 1999.
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Signature
<i>Le Domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10165/507/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GLOBAL CAR CONSULTING, Société Anonyme,
(anc. GLOBAL CAR CONSULTING, S.à r.l.).
Siège social: L-7597 Reckange/Mersch, 10, Op der Delt.
R. C. Luxembourg B 51.287.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Eich, le 24 février 1999.
<i>Pour la sociétéi>
P. Decker
<i>Le Notairei>
(10167/206/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GREENWOOD S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 49.838.
—
EXTRAIT
Le siège social de la société ne se trouve plus 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg.
Les administrateurs
- Georges Deitz, avocat, demeurant à Luxembourg
- Benoît Schaus, réviseur d’entreprises, demeurant à Vielsalm (Belgique)
- Jean-Pierre Winandy, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette
ont démissionné de leur mandat avec effet immédiat.
Le commissaire aux comptes, Rodolphe Gerbes, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à
Greiveldange, a démissionné de son mandat avec effet immédiat.
Luxembourg, le 1
er
février 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10171/507/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GS RE, SOCIETE DE REASSURANCE DU GROUPE GRAS SAVOYE, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie.
R. C. Luxembourg B 29.131.
—
Après la nomination, par le Conseil d’Administration du 5 mai 1997, de Madame Maryse Delvigne en qualité
d’Administrateur-délégué chargé de la gestion journalière ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne
cette gestion, le Conseil d’Administration tenue le 25 mai 1998 a procédé à la définition des pouvoirs de Madame Maryse
Delvigne. Elle pourra ainsi, en sa qualité d’Administrateur-délégué et de Directeur Agréé, engager la société jusqu’à LUF
600.000,- (six cent mille francs luxembourgeois). Au-delà de cette somme, l’Administrateur-délégué signera conjoin-
tement avec un autre Administrateur ou avec un porteur de procuration désigné par deux Administrateurs.
Enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 19, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10173/000/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15802
GREENPINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.767.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1999, vol. 518, fol. 51, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
C. Blondeau
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(10169/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GREENPINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.767.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 7 janvier 1999i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats en 1997 ainsi que pour la non-tenue de
l’assemblée générale à sa date statutaire.
Les mandats d’Administrateurs de M. Christophe Blondeau, M. Rodney Haigh et de M. Nour-Eddin Nijar ainsi que
celui de Commissaire aux Comptes de HRT REVISION, S.à r.l. viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire à tenir en l’an 2003.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1999, vol. 518, fol. 51, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10170/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
HEALTHFINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R. C. Luxembourg B 40.793.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 17 février 1998, vol. 519, fol. 93, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1998.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Résultat reporté ………………………………………………………………
(33.681.316,-) LUF
- Perte de l’exercice ……………………………………………………………
(18.308.125,-) LUF
- Report à nouveau ……………………………………………………………
(51.989.441,-) LUF
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 1999.
Signature.
(10180/507/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GUMMI-ROLLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 16, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS
Signature
(10175/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GUMMI-ROLLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 16, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS
Signature
(10176/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15803
GUMMI-ROLLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 16, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS
Signature
(10177/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GUMMI-ROLLER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 16, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS
Signature
(10178/601/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GROUPE COFILUX (COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE S.A.), Société Anonyme.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 2, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R. C. Luxembourg B 59.811.
—
Le bilan abrégé au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 13, case 2, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(10172/520/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
GUAPO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2417 Luxembourg, 15, rue de Reims.
R. C. Luxembourg B 55.055.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signatures.
(10174/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
HAMEL HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 38.838.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 13, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
HAMEL HOLDING S.A.
Signature
(10179/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT, Société Anonyme.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 65, avenue de la Gare.
R. C. Luxembourg B 44.628.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 décembre 1998.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
(10185/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15804
HENNEAUX LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 50.446.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 1999.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
(10181/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
CITADEL ADMINISTRATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 21.456.
—
<i>Rapport du commissaire aux comptes à l’assemblée générale extraordinaire du 3 février 1999i>
Rapport sur l’activité pour l’année au 31 décembre 1997 de la société CITADEL ADMINISTRATION S.A.
En vérifiant le bilan et les comptes de pertes et profits, la société a réalisé une année satisfaisante en faisant un bénéfice
de LUF 539.137.
La décision de reporter ce bénéfice au 31 décembre 1997, est supportée et recommandée.
Luxembourg, le 9 octobre 1998.
<i>Pour la sociétéi>
HORSBURGH & CO.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 14, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10184/000/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
I.C. PRODUCTIONS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 50.766.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1999, vol. 518, fol. 51, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
C. Istace
<i>Gérantei>
(10186/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
IMMOBILIERE SCHEFFEN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 6B, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 71.209.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signature.
(10187/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL LIFE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 17, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 53.451.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, ainsi que les autres documents et informations qui s’y rapportent, enregis-
trés à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg, le 24 février 1999.
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale tenue à Luxembourg le 1i>
<i>eri>
<i>avril 1998i>
L’Assemblée nomme aux fonctions d’administrateur:
Jean-Louis Holzmann, Directeur Financier des Assurances du CREDIT MUTUEL, demeurant à Strasbourg, France.
François Blanchard, Directeur, demeurant à Luxembourg.
Alain Schmitter, Directeur Général des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, demeurant à Paris, France.
Ces deux derniers en lieu et place de Madame Muriel Marron et de Monsieur Michel Lucas démissionnaires.
Les mandats des administrateurs ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Annuelle qui
statuera sur les comptes 2003.
Luxembourg, le 16 octobre 1998.
INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL LIFE S.A.
Signature
(10190/636/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15805
INTERNATIONAL FOOD INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R. C. Luxembourg B 40.427.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 17 février 1999i>
- L’Assemblée donne décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat
au 31 décembre 1996, au 31 décembre 1997 et au 31 décembre 1998.
- L’Assemblée accepte la démission de Madame Carine Bittler de ses fonctions d’administrateur. Elle nomme en
remplacement Madame Claude-Emmanuelle Cottier Johansson. Son mandat se terminera lors de l’assemblée générale
ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2003.
- L’Assemblée décide de transférer le siège social de la société du 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg, au 3, rue
Jean Piret à L-2350 Luxembourg.
Pour extrait conforme, Luxembourg, le 17 février 1999.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 99, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10191/595/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
IMMOBAT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 14A, rue des Bains.
R. C. Luxembourg B 31.722.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1996, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(10188/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
IMMOCO, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3736 Rumelange, 1, rue St. Joseph.
R. C. Luxembourg B 22.854.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(10189/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
INTERPARCO HOLDING S.A., LUXEMBOURG, Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2086 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf février.
Par-devant Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, 28, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme holding INTERPARCO
HOLDING S.A. LUXEMBOURG, 23, avenue Monterey, constituée suivant acte reçu par le notaire Carlo Funck, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 1974, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions C, numéro 37 du 26 février 1975, modifié à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire Carlo Funck, prénommé, en date du 17 juillet 1978, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associa-
tions C, numéro 241 du 7 novembre 1978, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous
la section B et le numéro 12.676.
L’assemblée est ouverte sous la présidence de Mademoiselle Isabelle Schul, employée privée, demeurant à B-Aubange,
qui désigne comme secrétaire Mademoiselle Séverine Cordonnier, employée privée, demeurant à F-Hayange.
L’assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Laurence Mostade, employée privée, demeurant à Eselborn.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée a pour ordre du jour:
1. Décision de prononcer la dissolution anticipée de la société.
2. Décision de procéder à la mise en liquidation de la société.
3. Désignation d’un ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des publications contenant l’ordre du
jour, insérées au:
- Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C, numéro 35 du 21 janvier 1999 et numéro 54 du 30 janvier
1999,
- Tageblatt numéro 17 du 21 janvier 1999 et numéro 25 du 30 janvier 1999.
Les numéros justificatifs de ces publications sont déposés au bureau de l’assemblée.
15806
III.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau ainsi que par le notaire
instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentaire.
IV.- Qu’il résulte de ladite liste de présence, que sur les douze mille (12.000) actions représentant l’intégralité du
capital social, six (6) actions sont présentes ou représentés à la présente assemblée.
V.- Que la présente assemblée n’est pas régulièrement constituée et ne peut délibérer sur l’ordre du jour.
VI.- Qu’une deuxième assemblée générale extraordinaire des actionnaires devra donc être convoquée avec le même
ordre du jour, laquelle, régulièrement constituée, délibérera valablement quelle que soit la portion du capital repré-
sentée.
Dont acte, faite et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, les membres du bureau ont signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: I. Schul, S. Cordonnier, L. Mostade, E. Schlesser.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 114S, fol. 79, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations.
Luxembourg, le 22 février 1999.
E. Schlesser.
(10195/227/48) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
INTERNATIONAL TELECOM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 51.626.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 15 février 1999, vol. 519, fol. 84, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
<i>Pour ordrei>
FIDUCIAIRE ALBERT SCHILTZ S.C.
Signature
(10192/549/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
I.T.U., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 27.049.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 2 décembre 1998 acté sous le
n
o
763/98 par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
(10196/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
IXWORTH, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: LUF 500.000.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.570.
Acte constitutif publié à la page 16637 du Mémorial C n
o
347 du 3 juillet 1997.
—
Le bilan au 5 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 16, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
(10197/581/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
KODEMAC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 80, route de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 36.806.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Echternach, le 18 février 1999, vol. 132, fol. 22, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 19 février 1999.
Signatures.
(10204/551/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15807
J.S.G.B. HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
R. C. Luxembourg B 62.327.
—
Statuts coordonnés suite à une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 11 février 1999 actée sous le n°54/99
par-devant Maître Jacques Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
(10200/208/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
KERVERNE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital souscrit: LUF 500.000,-.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 58.571.
Acte constitutif publié à la page 16.641 du Mémorial C, n° 347 du 3 juillet 1997.
—
Le bilan au 5 avril 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 16, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
(10203/581/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
LE NOUVEAU CHEZ NOUS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 31, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 21.458.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signatures.
(10210/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE.
Gesellschaftssitz: D-24100 Kiel.
H. R. Luxemburg B 27292.
—
Die Gewährträgerversammlung der Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale hat die nachfolgenden Satzungsän-
derungen beschlossen.
1. § 3 Abs. 1 erhält folgenden Wortlauf:
(1) Am Stammkapital der Landesbank sind das Land, der Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein (im
folgenden «Verband» genannt), die Westdeutsche Landesbank Girozentrale (im folgenden «WestLB» genannt) sowie die
Landesbank Baden-Würtemberg (im folgenden «LBW» genannt) beteiligt.
2. In allen folgenden §§ wird die Bezeichnung «SüdwestLB» ersetzt durch die Bezeichnung «LBW».
3. § 6 Abs. 3 erhält den folgenden Wortlaut:
(3) Sie kann ferner eigene rechtlich oder wirtschaftlich selbstständige Einrichtungen begründen und unterhalten sowie
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Schiffe erwerben oder veräußern. Zum Erwerb und zur Veräußerung von
Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten, die den Wert von EUR 3 Mio überschreiten, sowie zum Erwerb von
Schiffen ist die Zustimmung des Verwaltungsrates erforderlich.
4. § 9 Abs. 1 Buchstabe f) erhält den folgenden Wortlaut:
f) die Bestellung des Abschlußprüfers und des Prüfers für die Prüfung der Meldepflichten und Verhaltensregeln nach
den Vorschriften des Wertpapierhandelsgesetzes sowie von Prüfen in besonderen Fällen,
5. § 10 Abs. 4 erhält den folgenden Wortlaut:
(4) Über die von der Gewährträgerversammlung gefaßten Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen, in der die
Verhandlungsgegenstände und das Beratungsergebnis verzeichnet sind. Die Niederschrift ist von der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden der Gewährträgerversammlung zu unterzeichnen.
6. § 11 Abs.3 erhält den folgenden Wortlaut:
(3) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des Verwaltungsrates sowie ihre Vertreterinnen oder Vertreter sind
befugt, sich im Verwaltungsrat und in dessen Ausschüssen - außer im Vorsitz - durch benannte Vertreterinnen oder
Vertrerter vertreten zu lassen. Sie sind berechtigt, diese Vertreterinnen oder Vertreter zu den Sitzungen des Verwal-
tungsrates hinzuzuziehen. Die gleiche Befugnis haben die in den Verwaltungsrat entsandten Mitglieder der Landesre-
gierung. Sie können sich durch eine Staatsekretärin oder einen Staatssekretär ihres Ministeriums vertreten lassen.
15808
7. § 13 Abs. 4 erhält den folgenden Wortlaut:
(4) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder gefaßt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden. Für Beschlüsse nach § 12 Abs. 2 Buchst.b)
und h) ist eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. Die Mitglieder des Verwaltungs-
rates geben ihre Stimme in eigener Verantwortung ab. Sie sind an Weisungen nicht gebunden. Auf Antrag eines Mitglieds
des Verwaltungsrates ist bei Wahlen geheim abzustimmen. Stimmenthaltungen werden bei der Ermittlung des Stimmen-
verhältnisses nicht mitgezählt.
8.§ 17 Abs. 1 erhält den folgenden Wortlaut:
(1) Der Kreditausschuß ist zuständig für die Zustimmung zu Organkrediten gemäß § 15 des Gesetzes über das Kredit-
wesen, soweit diese Befugnis nicht auf den Präsidialasusschuss übertragen worden ist. Er ist über Kreditanträge nach
Maßgabe der vim Verwaltungsrat aufzustellenden Richtlinien für die Zuständigkeit bei der Bewilligung von Krediten jeder
Art (Zuständigkeitsrichtlinien) zu unterrichten.
9. § 19 Abs. 1 erhält den folgenden Wortlaut:
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte in eigener Verantwortung im Rahmen der vom Verwaltungsrat erlassenen
Geschäftsanweisung. Er vertritt die Landesbank gerichtlich und außergerichtlich. Über die Geschäftsverteilung innerhalb
des Vorstandes entscheidet die oder der Vorsitzende, Im Hinblick auf das für die Investitionsbank zuständige Vorstands-
mitglied auf vorschlag der Finanzministerin oder des Finanzministers des Landes, im Hinblick auf seinen Vertreter im
Einvernehmen mit der Finanzministerin oder dem Finanzminister des Landes.
10.§ 20 Abs. 1 erhält den folgenden Wortlaut:
(1) Erklärungen im Namen der Landesbank werden unter der Bezeichnung «Landesbank Schleswig-Holstein Girozen-
trale» abgegeben und bedürfen der Unterschrift zweier Vorstandsmitglieder, für den Bereich der Landes-Bausparkasse,
unter der Bezeichnung «Landes-Bausparkasse, Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale», für den Bereich der
Investitionsbank unter der Bezeichnung «Investitionsbank Schleswig-Holstein, Zentralbereich der Landesbank Schleswig-
Holstein Girozentrale». Der Vorstand kann für den Laufenden Geschäftsverkehr eine andere Reglung treffen.
11.§ 29 wird gestrichen.
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 15, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10207/000/63) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
LE RUN, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 64, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 30.448.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signatures.
(10211/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
KWIZDA FINANZ A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1528 Luxemburg, 5, boulevard de la Foire.
—
Im Jahre eintausendneunhundertachtundneunzig, am einundreissigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Edmond Schroeder, mit dem Amtssitze zu Mersch.
Ist erschienen:
Herr John Seil, licencié en sciences économiques appliquées, wohnhaft in Contern,
handelnd auf Grund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 22. Dezember 1998,
welcher Beschluss gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.
Welcher Komparent den Notar ersucht Folgendes zu beurkunden:
I. Die Gesellschaft KWIZDA FINANZ A.G., mit dem Gesellschaftssitz zu Luxemburg, wurde gegründet laut Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar am 16. Februar 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des
Sociétés et Associations vom Sociétés et Associations C vom 25. Mai 1994, Nummer 204.
Die Satzungen wurden zuletzt abgeändert laut Urkunde aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, am 22. April
1994, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations C vom 8. September 1994, Nummer 328.
II. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt zwanzig Millionen Österreichische Schillinge (20.000.000,- ATS),
eingeteilt in zwanzigtausend (20.000) Aktien zu je eintausend Österreichische Schilinge (1.000,- ATS) Nennwert.
Das Gesellschaftskapital kann bis zum Betrag von dreissig Millionen Österreichische Schillinge (30.000.000.- ATS)
erhöht werden.
III. Auf Grund eines Verwaltungsratsbeschlusses vom 22. Dezember 1998 hat der Verwaltungsrat die Schaffung von
dreitausend (3.000) Aktien beschlossen. Diese Aktien wurden gezeichnet und voll eingezahlt, so dass die Summe von
drei Millionen Österreichische Schillinge (3.000.000,- ATS) der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dies dem instru-
mentierenden Notar nachgewiesen wurde.
IV. Auf Grund dieser Kapitalerhöhung wurde Absatz eins von Artikel fünf abgeändert wie folgt:
15809
«Art. 5. Absatz eins. Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft beträgt dreiundzwanzig Millionen Öster-
reichische Schillinge (23.000.0000,- ATS), eingeteilt in dreiundzwanzigtausend Österreichische Schillinge (1.000,- ATS),
voll eingezahlt.»
<i>Abschätzung der Kapitalerhöhungi>
Zum Zwecke der Einregistrierung wird die Kapitalerhöhung abgeschätzt auf acht Millionen siebenhundertvierund-
neunzigtausendneunhundertfünfunddreissing Luxemburger Franken (8.794.935,- LUF).
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass der Kapitalerhöhung entstehen, beläuft sich auf ungefähr einhundertfünfunddreissigtausend
Luxemburger Franken (135.000,- LUF).
Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, haben alle mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: J. Seil, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 8 janvier 1999, vol. 408, fol. 9, case 1. – Reçu 87.949 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Mersch, den 18. Januar 1999.
E. Schroeder.
(10205/228/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
KWIZDA FINANZ A.G., Aktiengesellschaft.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 22 février 1999.
E. Schroeder.
(10206/228/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
LE GRAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 79, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 16.872.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 28 janvier 1999i>
L’assemblée générale constate que le siège social de la société est transféré de L-1212 Luxembourg, 21, rue des Bains
à L-1450 Luxembourg, Côte d’Eich, 79.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 520, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10208/752/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
LE GRAND S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 79, Côte d’Eich.
R. C. Luxembourg B 16.872.
—
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société en date du 28 janvier 1999i>
L’assemblée générale constate que les démissions des administrateurs suivants:
Monsieur Stéphane Villalta, administrateur, Monsieur Marc Hassan, administrateur-délégué et Madame Cecilia da
Ponte, administrateur. Décharge leur est donné pour l’exécution de leur mandat.
L’assemblée générale décide de nommer comme nouveaux administrateurs les personnes suivantes:
Monsieur Michel Kahe, administrateur-délégué, Villerupt
Monsieur Laurent Suk, administrateur, Luxembourg;
Monsieur Aderito Ferreira De Sousa, administrateur, Luxembourg.
Monsieur Michel Kahe est nommé administrateur-délégué de la société. Il peut engager la société par sa signature
individuelle.
Pour extrait conforme
FIDUPLAN S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 520, fol. 1, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10209/752/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15810
LOTAKS S.A., Société Anonyme.
R. C. Luxembourg B 49.871.
—
EXTRAIT
Avec effet au 1
er
janvier 1999, l’agent domiciliataire DELOITTE & TOUCHE S.A., (anciennement FIDUCIAIRE
GENERALE DE LUXEMBOURG, avant l’acte de scission du 23 décembre 1998), a dénoncé le domicile établi en ses
locaux, sis au 35, rue Glesener, L-1631 Luxembourg, de la Société Anonyme LOTAKS S.A., de sorte que celle-ci se
trouve jusqu’à nouvel avis sans domicile ni résidence connus.
En outre, à la date susmentionnée, Monsieur Rodolphe Gerbes a donné sa démission en tant que commissaire aux
comptes.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.
DELOITTE & TOUCHE S.A.
Signature
<i>Le domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 17 février 1999, vol. 519, fol. 93, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10213/507/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
LUXGESTION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5752 Frisange, 6A, rue de Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 48.712.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signature.
(10214/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
LUXSOL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 3, rue des Artisans.
R. C. Luxembourg B 48.376.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signature.
(10215/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MALDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 53.183.
—
Le bilan au 30 juin 1998, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 15, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Signature
(10218/504/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MALDEN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 16, allée Marconi.
R. C. Luxembourg B 53.183.
—
Composition actuelle du Conseil d’Administration:
- Paul Lutgen, licencié en sciences économiques appliquées, demeurant à Luxembourg, Président du conseil d’adminis-
tration.
- Luc Braun, diplômé ès sciences économiques, demeurant à Luxembourg, Administrateur-Délégué.
- ARMOR S.A., 16, Allée Marconi, Luxembourg, Administrateur.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 15, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10219/504/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15811
MAHIFA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.081.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1999, vol. 518, fol. 51, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
C. Blondeau
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(10216/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MAHIFA INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 54.081.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 8 mai 1998i>
3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1815 sur les sociétés commerciales.
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 1997.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1999, vol. 518, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10217/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MA.LO S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 48.326.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 13, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
MA.LO S.A.
Signature
(10220/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
LETO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société WANSEY CONSULTANT INC., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par son président du conseil d’administration Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de
société, demeurant à Luxembourg.
Ladite comparante, représentée comme il est dit, a exposé ce qui suit:
1. - La Société Anonyme LETO HOLDING S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 2 décembre 1993, publié au Mémorial C n
o
77 du 28 février 1994.
2. - Le capital social actuel est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- Flux) représenté par dix mille
(10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- Flux) chacune.
3. - La comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société, ce dont la preuve a
été rapportée au notaire instrumentaire.
Ensuite la comparante, représentée comme il est dit et agissant comme seule et unique actionnaire de la société LETO
HOLDING S.A., a déclaré expressément vouloir dissoudre la société prédite.
A cet égard, elle expose au notaire que tout le passif social a été apuré avant les présentes, que tout l’actif se trouve
repris par elle et que dès lors la liquidation de la société se trouve achevée, le tout sans préjudice du fait qu’elle répond
personnellement de tous les engagements sociaux.
15812
Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à
ce jour.
Et aussitôt il a été procédé à la lacération des actions.
Les livres et documents de la société dissoute resteront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège
social de la société à L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, la comparante ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-P. Van Waelem, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 114S, fol. 79, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.
J.-P. Hencks.
(10212/216/38) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MAPOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 51.602.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1999, vol. 518, fol. 51, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
C. Blondeau
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(10221/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MAPOM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 51.602.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 janvier 1999i>
3. L’Assemblée constate que le capital social de la société est intégralement absorbé par des pertes.
Après délibérations et votes, l’Assemblée décide de poursuivre l’activité de la société, ceci conformément à l’article
100 de la loi du 10 août 1815 sur les sociétés commerciales.
4. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 1997 ainsi que pour la non-tenue de l’Assemblée
à sa date statutaire.
Les mandats d’Administrateurs de M. Christophe Blondeau, M. Rodney Haigh et de M. Nour-Eddin Nijar ainsi que
celui de Commissaire aux Comptes de HRT REVISION, S.à r.l. viendront à expiration à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire à tenir en l’an 2001.
Pour extrait conforme
C. Blondeau
R. Haigh
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 janvier 1999, vol. 518, fol. 51, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10222/565/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MASTERS TRADING GROUP S.A., Soparfi-Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
H. R. Luxemburg B 56.673.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den dritten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, mit dem Amtssitze in Luxemburg.
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre beziehungsweise deren Ertreter der
Aktiengesellschaft MASTERS TRADING GROUP S.A., mit Amtssitz zu L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-
Duchesse Charlotte, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 56.673,
gegründet gemäss Urkunde vom 10. Oktober 1996, veröffentlicht im Mémorial, Recueil Spécial C Seite 138 von 1997.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Patrick Van Hees, Jurist, wohnhaft in Messancy (Belgien).
Der Herr Vorsitzende beruft zum Schriftführer und Stimmzähler Herrn Hubert Janssen, Jurist, wohnhaft in Torgny
(Belgien).
Der so zusammengesetzte Versammlungsvorstand erstellt die Liste der anwesenden Aktionäre mit Angabe der Zahl
der vertretenen Aktien.
Die von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes als richtig bestätigte Anwesenheitsliste und die Vollmachten,
nachdem sie von den anwesenden Personen und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet worden sind,
bleiben der gegenwärtigen Urkunde als Anlagen beigefügt und werden mit derselben einregistriert.
15813
Sodann stellt der Herr Vorsitzende fest und beauftragt den amtierenden Notar zu beurkunden:
I.- Dass sich aus vorerwähnter Anwesenheitsliste ergibt, dass die 100 (einhundert) voll eingezahlten Aktien jeweils mit
einem Nennwert von LUF 12.500,- (zwölftausendfünfhundert Luxemburger Franken) die das gesamte Gesellschafts-
kapital von LUF 1.250.000,- (eine Million zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken) darstellen, rechtsgültig hier
vertreten sind und dass demzufolge die gegenwärtige ausserordentliche Generalversammlung rechtsgültig tagt und über
die Tagesordnung beraten und beschliessen kann, ohne förmliche Einberufung.
II.- Dass die Tagesordung wie folgt lautet:
<i>Tagesordnungi>
<i>Statutarische Ernennungeni>
Sodann stellt die Generalversammlung fest, dass sie rechtsgültig tagt, erklärt sich mit den Ausführungen des Herrn
Vorsitzenden einverstanden, schreitet zur Erledigung der Tagesordnung und fasst, nach Beratung, einstimmig folgende
Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden mit voller Entlastung, mit Wirkung vom heutigen Tage
an, des folgenden Verwaltungsratsmitgliedes:
Herrn Lambertus Gerardus Wijntjes, Unternehmer, wohnhaft in NL-1231 Lx Loosdrecht (Niederlande), 239A, Oud-
Loosdrechtsedijk.
Die Generalversammlung beschliesst mit Wirkung vom heutigen Tage an:
die Gesellschaft Englischen Rechtes SELINE MANAGEMENT LIMITED, mit Sitz in UK-W1Y9HD London, 27, New
Bond Street;
als neuen Verwaltungsratsmitglied zu bestellen.
Herr Johannes Gerardus Van Hooft, Unternehmer, wohnhaft in NL 1018 AV Amsterdam (Niederlande), 694 Sarpha-
tistraat, bleibt geschäftsführender Direktor, welcher Verbindlichkeiten für die Gesellschaft eingehen kann durch seine
einzige Unterschrift.
Diese Mandate enden mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2002.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung nimmt Kenntnis vom Ausscheiden mit voller Entlastung, mit Wirkung vom heutigen Tage
an, des Kommissars:
EUROLUX MANAGEMENT S.A., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
Die Generalversammlung beschliesst, mit Wirkung vom heutigen Tage an, als neuer Kommissar zu bestellen:
die Aktiengesellschaft DE RAADSLIJN (LUXEMBOURG) A.G., mit Sitz in L-2449 Luxemburg, 15, boulevard Royal.
Ihr Mandat endet mit der ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2002.
Da die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen zu Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem amtierenden Notar das vorliegende
Protokoll unterschrieben.
Gezeichnet: P. Van Hees, H. Janssen, J. Elvinger.
Enregistré à Luxembourg, le 4 février 1999, vol. 114S, fol. 63, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations,
Sondersammlung für Gesellschaften und Vereinigungen.
Luxemburg, den 9. Februar 1999.
J. Elvinger.
(10224/211/65) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MGM COMMERCE S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: Luxembourg.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le neuf février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
La société WANSEY CONSULTANT INC., avec siège social à Tortola, Iles Vierges Britanniques,
ici représentée par son président du conseil d’administration Madame Marie-Paul Van Waelem, administrateur de
société, demeurant à Luxembourg.
Ladite comparante, représentée comme il est dit, a exposé ce qui suit:
1. - La Société Anonyme Holding MGM COMMERCE S.A., avec siège social à Luxembourg, a été constituée suivant
acte reçu par le notaire Frank Baden, de résidence à Luxembourg en date du 12 mars 1991, publié au Mémorial C n
o
349
du 26 septembre 1991.
2. - Le capital social actuel est fixé à quatre-vingt mille Deutsch Mark (80.000,- DM) représenté par quatre-vingt (80)
actions d’une valeur nominale de mille Deutsch Mark (1.000,- DM) chacune.
3. - La comparante est devenue successivement propriétaire de toutes les actions de la société, ce dont la preuve a
été rapportée au notaire instrumentaire.
15814
Ensuite la comparante, représentée comme il est dit et agissant comme seule et unique actionnaire de la société MGM
COMMERCE S.A., a déclaré expressément vouloir dissoudre la société prédite.
A cet égard, elle expose au notaire que tout le passif social a été apuré avant les présentes, que tout l’actif se trouve
repris par elle et que dès lors la liquidation de la société se trouve achevée, le tout sans préjudice du fait qu’elle répond
personnellement de tous les engagements sociaux.
Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et commissaire pour l’exercice de leurs fonctions jusqu’à
ce jour.
Et aussitôt il a été procédé à la lacération des actions.
Les livres et documents de la société dissoute resteront conservés pendant une durée de cinq ans à l’ancien siège
social de la société à Luxembourg.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée, la comparante ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M.-P. Van Waelem, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 10 février 1999, vol. 114S, fol. 79, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.
J.-P. Hencks.
(10232/216/39) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MAROWINIA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.484.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 13, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
MAROWINIA HOLDING S.A.
Signature
(10223/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MAXIWEB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, rue de l’Avenir.
R. C. Luxembourg B 60.427.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1997, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 02, case 04, a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
Signature.
(10225/636/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MEDICAL SERVICES PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 57.409.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 02, case 04, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 9 juin 1998i>
L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur de:
- Monsieur Robert Van Droogenbroek;
- Madame Marie-Rose Nanson;
- Monsieur Marc Marteyn.
Et le mandat du commissaire aux comptes de la société EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG).
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1998.
EURO-SUISSE AUDIT
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(10228/636/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15815
MEDAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 42.957.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 12, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau:……………………………………………………………………
LUF (196.133)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 1999.
Signature.
(10226/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MEDAFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 42.957.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 11 février 1999 que:
- Madame Mireille Gehlen, Licenciée en administration des affaires, demeurant à Dudelange (L),
a été élue Administrateur en remplacement de Monsieur Franz Prost, Administrateur démissionnaire.
Luxembourg, le 12 février 1999.
Pour extrait conforme
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 12, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10227/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
M.H.R. TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 10.401.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 02, case 04, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(10233/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
M.H.R. TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 10.401.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 02, case 04, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale des Associés tenue à Luxembourg le 14 décembre 1998i>
L’Assemblée nomme comme nouveau gérant de la société Monsieur Pierre Schneider, administrateur de sociétés,
demeurant à Luxembourg.
Luxembourg, le 24 février 1999.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(10234/636/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
M.H.R. TRADING COMPANY, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 119, avenue Gaston Diderich.
R. C. Luxembourg B 10.401.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 02, case 04, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG)
Signature
(10235/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15816
MEDINGER NORBERT, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Remich, Piscine Plein Air.
R. C. Luxembourg B 51.557.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signature.
(10229/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
M.M. Warburg-LuxInvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R. C. Luxembourg B 29.905.
—
Le bilan au 30 septembre 1998, enregistré à Luxembourg, le 22 février 1999, vol. 520, fol. 10, case 7, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 février 1999.
M.M. Warburg-LuxInvest S.A.
Signatures
(10236/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MOLSHI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 46.602.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors du Conseil d’Administration du 18 janvier 1999i>
Conformément à l’article 51, alinéa 4 de la loi Fondamentale sur les sociétés commerciales, les administrateurs
restants procèdent à la nomination par voie de cooptation de Monsieur Georges Salmaso, demeurant au 31, rue Victor
Hugo à F-69002 Lyon, au titre d’administrateur provisoire en remplacement de Monsieur Jean Bintner, démissionnaire.
Cette nomination sera soumise à la prochaine assemblée générale aux fins d’élection définitive.
<i>Pour la Sociétéi>
MOLSHI S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 13, case 12. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10237/005/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MULFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 65.970.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, en remplacement de Maître Frank Baden,
notaire de résidence à Luxembourg, qui restera le dépositaire de la présente minute.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme MULFIN S.A., ayant son
siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 65.970,
constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 août 1998, publié
au Mémorial C, Recueil Spécial, numéro 801 du 3 novembre 1998.
L’Assemblée est ouverte à quinze heures trente sous la présidence de Monsieur Alain Vasseur, consultant, demeurant
à Holzem,
qui désigne comme secrétaire Madame Maggy Strauss, employée privée, demeurant à Garnich.
L’Assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Tanja Dahm, employée privée, demeurant à Diekirch.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I.- Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision sur la mise en liquidation de la Société.
2. Nomination dou ou de plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été
paraphées ne varietur par les comparants.
15817
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait
abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et
déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut
délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide la dissolution de la Société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de nommer comme liquidateur:
Monsieur Toby Herkrath, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée
générale dans les cas où elle est requise.
Il peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d’office; renoncer à tous droits réels,
privilèges, hypotèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées
ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu’il détermine et pour la durée qu’il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude de Maître Frank Baden, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: A. Vasseur, M. Strauss, T. Dahm, J.-J. Wagner.
Enregistré à Luxembourg, le 11 février 1999, vol. 114S, fol. 82, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande, aux fins de la publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 février 1999.
F. Baden.
(10242/200/59) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
M.P.H. PARTICIPATION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 57.871.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 02, case 04, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Extrait de l’Assemblée Générale Annuelle tenue à Luxembourg le 24 mars 1998i>
L’assemblée renouvelle les mandats d’administrateur:
- Monsieur Patrick Rochas;
- Monsieur Maurice Houssa;
- Mademoiselle Céline Stein.
Ainsi que le mandat du commissaire aux comptes de la société:
EURO-SUISSE AUDIT (LUXEMBOURG) et renouvelé.
Les mandats d’administrateurs et du commissaire aux comptes ainsi nommés viendront à échéance à l’issue de
l’Assemblée Générale Annuelle qui statuera sur les comptes 1998.
Luxembourg, le 24 février 1999.
EURO-SUISSE AUDIT
<i>Agent domiciliatairei>
Signature
(10241/636/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
M.P. INTERNATIONALE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 161, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 48.589.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signature.
(10240/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15818
MONTANTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.358.
—
Le bilan au 31 mars 1998, enregistré à Luxembourg, le 9 février 1999, vol. 519, fol. 68, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
N.-E. Nijar
C. Blondeau
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(10238/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MONTANTE HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 28.358.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 juillet 1998i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge aux Administrateurs et au
Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leurs mandats en 1998.
Les mandats de Messieurs Christophe Blondeau, Nour-Eddin Nijar et Rodney Haigh aux postes d’Administrateurs et
HRT REVISION, S.à r.l. au poste de Commissaire aux Comptes, viennent à expiration de l’an 2001.
Certifié conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1999, vol. 519, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10239/565/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MULTI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 70A, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.029.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le huit février.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire de la société anonyme établie à Luxembourg sous la dénomi-
nation de MULTI FINANCE S.A., R. C. B numéro 49.029, ayant son siège social à Howald, constituée suivant acte reçu
par Maître Paul Bettingen, alors notaire de résidence à Wiltz, le 11 octobre 1994, publié au Mémorial C, Recueil Spécial
des Sociétés et Associations Numéro 28 du 18 janvier 1995.
La séance est ouverte à dix heures trente sous la présidence de Monsieur Frank Stolz-Page, employé privé, demeurant
à Mamer.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Monsieur Raymond Thill, maître en droit, demeurant à Luxembourg.
L’Assemblée élit comme scrutateur Monsieur Marc Prospert, maître en droit, demeurant à Bertrange.
Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu’il résulte d’une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau que les cent actions
d’une valeur nominale de douze mille cinq cents (12.500,-) francs luxembourgeois chacune constituant l’intégraltié du
capital social d’un million deux cent cinquante mille (1.250.000,-) francs luxembourgeois sont dûment représentées à la
présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement
sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduit, sans convocations préalables, tous les membres de
l’Assemblée ayant consenti à se réunir sans autres formalités, après avoir eu connaissance de l’ordre du jour.
Ladite liste de présence portant les signatures des actionnaires présentes ou représentés et des membres du breau
restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
Restera pareillement annexée aux présentes la procuration de l’actionnaire représenté, après avoir été paraphée ne
varietur par les coparants.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1) Transfert du siège social vers L-8008 Strassen, 70A, route d’Arlon.
2) Modification du deuxième alinéa de l’article 7 des statuts de la société.
3) Divers.
L’Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et, apèrs s’être reconnue régulièrement
constituée, a abordé l’ordre du jour et, après s’être reconnue régulièrement constituée, a abordé l’ordre du jour et,
après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la socité de L-1842 Howald, 16, avenue Grand-Duc Jean
à L-8008 Strassen, 70A, route d’Arlon.
En conséquence le premier alinéa de article 3 des statuts de la société a désormais la teneur suivante:
«Art. 3. Premier alinéa. Le siège social est établi à Strassen.»
15819
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de modifier le deuxième alinéa de l’article 7 des statuts de la société pour lui donner la
teneur suivante:
«Art. 7. Deuxième alinéa. Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer que si la majorité des ses
membres en fonction sont présents ou représentés, le mandat donné par lettre, télex ou télégramme entre adminis-
trateur présents ou représentés.»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont singé avec Nous, Notaire, la présente minute.
Signé: F. Stolz-Page, R. Thill, M. Prospert, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 17 décember 1999, vol. 114S, fol. 90, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 décembre 1999.
A. Schwachtgen.
(10243/230/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MULTI FINANCE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 70A, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 49.029.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
A. Schwachtgen.
(10244/230/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
NEW ENTERPRISES S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1235 Luxembourg, 5, rue Emile Bian.
R. C. Luxembourg B 11.345.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 02, case 04, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG
Signature
(10247/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MULTI-HOUSE S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Esch an der Alzette, 145, rue Jean-Pierre Michels.
H. R. Luxemburg B 67.111.
—
Im Jahre eintausendneunhundertneunundneunzig, den achten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Karl-Günter König, Geschäftsmann, wohnhaft in L-1611 Luxemburg, 9, avenue de la Gare.
2.- Frau Claudia Margarete Nummer, Kauffrau im Gross- und Aussenhandel, Ehegattin von Herrn Karl-Günter König,
vorbenannt, wohnhaft in L-1611 Luxemburg, 9, avenue de la Gare.
Die vorbenannten Komparenten, in ihrer Eigenschaft als alleinige Aktieninhaber der Aktiengesellschaft MULTI-
HOUSE S.A. mit Sitz zu Esch an der Alzette, 145, rue Jean-Pierre Michels, eingetragen im Handelsregister beim Bezirks-
gericht Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 67.111,
gegründet gemäss Urkunde aufgenommen durch den instrumentierenden Notar am 26. Oktober 1998, welche noch
nicht im Mémorial veröffentlicht ist,
haben sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammengefunden mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnungi>
Änderung der Vertretungsbefugnis der Gesellschaft und entsprechende Änderung des Artikels 12 der Statuten.
Gemäss der Tagesordnung haben die Aktionäre einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst die Vertretungsbefugnis der Gesellschaft zu ändern und dementsprechend
Artikel 12 der Statuten abzuändern und ihm folgenden Wortlaut zu geben:
«Art. 12. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die in der nachfolgenden Generalversammlung
gefassten Beschlüsse. Im laufenden Verkehr mit den Behörden wird die Gesellschaft durch die individuelle Unterschrift
des Delegierten des Verwaltungsrates rechtsgültig vertreten.»
15820
<i>Zweiter Beschlussi>
In Bezug auf den vorerwähnten Beschluss, wird die Gesellschaft nach aussen verpflichtet durch die individuelle Unter-
schrift des Delegierten des Verwaltungsrates, Herrn Jean-Claude Benick, Privatbeamter, wohnhaft in Esch an der
Alzette.
<i>Kosteni>
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf zwanzigtausend Franken
(20.000,- LUF) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Niederanven, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen
Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: K. König, C. Nummer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 20 janvier 1999, vol. 114S, fol. 34, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Niederanven, den 5. Februar 1999.
P. Bettingen.
(10245/202/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
MULTI-HOUSE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 145, rue Jean-Pierre Michels.
R. C. Luxembourg B 67.111.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 5 février 1999.
P. Bettingen.
(10246/202/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
NEW STYLE HAIRDRESSER, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 161, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 52.490.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signature.
(10248/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
PNEUS MRECHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 26, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.985.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Marthe Thyes-Walch, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Christian Mreches, industriel, demeurant à Strassen,
agissant en sa qualité de gérant technique, et actuellement propriétaire de toutes les parts sociales de la société à
responsabilité limitée PNEUS MRECHES, S.à r.l., ayant son siège social à L-1130 Luxembourg, 37A, rue d’Anvers, inscrite
au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 26.985, constituée suivant acte reçu
par le notaire instrumentant en date du 31 mars 1990, publié au Mémorial C, numéro 365 du 9 octobre 1990, et dont
les statuts n’ont subi à ce jour aucune modification.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses déclarations et constatations.
<i>Cession de parts socialesi>
Il résulte:
a) d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés du 17 juin 1998, que Monsieur Pierre Mreches,
sans état particulier, demeurant à Cannes (France) a cédé et transporté, sous les garanties de fait et de droit, à Monsieur
Christian Mreches, prénommé, les cent (100) parts sociales de LUF 10.000,- (dix mille francs luxembourgeois) chacune,
qu’il détenait en propre dans la société PNEUS MRECHES, S.à r.l., préqualifiée;
pour et moyennant le prix de un franc (Fr. 1,-). Qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 17
juin 1998 prémentionnée, constatant la susdite cession de parts sociales, restera annexée aux présentes pour être
enregistrée avec elles.
15821
b) d’un acte de partage reçu par le notaire instrumentant en date du 15 décembre 1998, qu’il a été attribué à Monsieur
Christian Mreches, préqualifié, les six cents (600) parts sociales de la société à responsabilité limitée PNEUS MRECHES,
S.à r.l., prédésignée, précédemment en indivision pour moitié (1/2) entre Messieurs Christian et Pierre Mreches.
Ensuite Monsieur Christian Mreches, prénommé, agissant en sa qualité de gérant technique de la société à respons-
abilité limitée PNEUS MRECHES, S.à r.l., prédésignée, a déclaré accepter la cession de parts ainsi intervenue et la consi-
dérer comme dûment signifiée à la société, conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code Civil, et à l’article
190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Qu’il s’ensuit que Monsieur Christian Mreches, prénommé, est devenu propriétaire à compter du 15 décembre 1998
de la totalité des huit cents (800) parts sociales de la société à responsabilité limitée PNEUS MRECHES, S.à .r.l. et a droit
aux bénéfices à partir de la même date.
Qu’il est subrogé à partir de la même date dans tous les droits et obligations attachées aux parts cédées, respec-
tivement attribuées.
<i>Modification statutaires - Démission - Nominationi>
Ensuite Monsieur Christian Mreches prénommé, en sa qualité d’associé unique de la société PNEUS MRECHES S.à r.l.
prédésignée, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu’il suit ses résolutions, notamment en vue
d’adapter les statuts à la forme unipersonnelle de la société.
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article six des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de huit millions de francs luxembourgeois (LUF 8.000.000,-), représenté
par huit cents (800) parts sociales de dix mille francs luxembourgeois (LUF 10.000,-) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires.
Monsieur Christian Mreches, industriel, demeurant à L-8035 Strassen, 41, Cité Pescher est propriétaire de toutes les
parts sociales.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article premier des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 1
er
. Il existe entre le propriétaire actuel des parts sociales et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite,
une société à responsabilité limitée sous forme d’une société unipersonnelle et qui est régie par la loi du 10 août 1915,
telle que modifiée par la loi du 28 décembre 1992, ainsi que par les présents statuts.»
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article onze des statuts qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 2. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé unique ou de l’un des associés ne mettent pas
fin à la société.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide d’ajouter à l’article dixsept des statuts trois paragraphes supplémentaires qui auront la teneur
suivante:
«Art. 17. Paragraphes 2, 3 et 4. Pour les sociétés ne comportant qu’un seul associé, les dispositions visées à
l’alinéa qui précède ne sont pas applicables.
Il suffit que l’associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés et que ses décisions soient
inscrites dans un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits dans un procès-
verbal ou établis par écrit. Cette opération n’est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions
normales.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier le dernier alinéa de l’article vingt des statuts, qui aura désormais la teneur
suivante:
«Art. 20. Dernier alinéa. Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l’associé unique
ou des associés.»
<i>Sixième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier l’article vingt-deux des statuts, qui aura désormais la teneur suivante:
«Art. 22. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, l’associé unique, ou lorsqu’ils sont plusieurs, les
associés se réfèrent et se soumettent aux dispositions légales.»
<i>Septième résolutioni>
L’associé unique décide d’accepter la démission de Monsieur Christian Mreches de ses fonctions de gérant technique,
à compter de ce jour, de la société PNEUS MRECHES S.à r.l. préqualifiée et de lui accorder pleine et entière décharge
pour l’exécution de son mandat.
<i>Huitième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer comme gérant unique de la société PNEUS MRECHES, S.à r.l. préqualifiée
Monsieur Christian Mreches, prénommé.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
15822
<i>Neuvième résolutioni>
L’associé décide de transférer le siège social de la société de Luxembourg à Windhof et de modifier en conséquence
la première phrase de l’article cinq des statuts pour lui donner désormais la teneur suivante:
«Art. 5. Première phrase. Le siège social est établi à Windhof».
<i>Dixième résolutioni>
Les associés décident de fixer l’adresse de la société à L-8399 Windhof, 26, rue d’Arlon.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition des présentes pour les faire publier conformément à la loi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Et après lecture faite, le comparant prémentionné a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: C. Mreches, M. Walch.
Enregistré à Luxembourg, le 2 février 1999, vol. 114S, fol. 59, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
M. Thyes.
(10261/233/108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
PNEUS MRECHES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 26, rue d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 26.985.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 1999.
(10262/233/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
NIKKO EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital Social: LUF 14.847.000.
Registered office: Luxembourg, 16, rue Eugène Ruppert.
R. C. Luxembourg B 28.115.
—
<i>Resolutions of the Sole Partner of NIKKO EUROPE, S.à r.l.i>
On December 23, 1998 the Sole Partner of NIKKO EUROPE, S.à r.l. resolved:
1. to accept the resignation of Mr Wim Nubé from his position as manager of the Company occurred on December
23, 1998.
2. to appoint Mr Hideo Hotta, residing De Hoge Akker 2, 4741 TW Hoeven (Holland) as Manager of the Company
from December 23, 1998 for an undetermined duration in replacement of Mr Wim Nubé.
NIKKO EUROPE BV
H. Hotta
<i>Presidenti>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 16, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10249/581/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 30.373.
Constituée le 7 avril 1989 par-devant feu M
e
Marc Elter, alors notaire de résidence à Luxembourg, acte publié au
Mémorial C, n° 238 du 29 août 1989, modifiée par-devant M
e
Gérard Lecuit, notaire de résidence alors à Mersch
et maintenant à Hesperange, agissant en remplacement de M
e
Marc Elter, empêché, en date du 31 juillet 1990, acte
publié au Mémorial C, n° 51 du 7 février 1991, modifiée par-devant M
e
Marc Elter, préqualifié, en date du 17 juin
1991, acte publié au Mémorial C, n° 458 du 11 décembre 1991, modifiée par-devant le même notaire, en date du
15 novembre 1991, acte publié au Mémorial C, n° 173 du 30 avril 1992, modifiée par-devant le même notire en
date du 29 novembre 1995, acte publié au Mémorial C, n° 125 du 21 mars 1995.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1999, vol. 519, fol. 85, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour POLYGRAM HOLDING (LUXEMBOURG) S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(10264/528/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15823
OCARINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 59.595.
—
<i>Extrait de la réunion du Conseil d’Administration du 14 décembre 1998i>
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité:
- de nommer à côté des admnistrateurs-délégués actuels M. Erik Lazar comme administrateur-délégué (managing
director) de la Société avec pouvoir d’engager la Société par sa seule signature, pourvu qu’il agisse dans le cadre de ses
compétences du Conseil d’administration. La nomination de M. Erik Lazar devient effective à partir du 14 décembre
1998.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10251/253/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
OCARINA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 6, avenue Emile Reuter.
R. C. Luxembourg B 59.595.
—
<i>Extrait de l’Assemblée des Actionnaires du 14 décembre 1998i>
L’assemblée des actionnaires décide à l’unanimité:
- d’accepter la démission de M. Byron Kalogerou en tant qu’administrateur de la Société avec effet au 14 décembre
1998.
- de nommer avec effet à partir du 14 décembre 1998 M. Erik Lazar comme administrateur de la Société.
- d’autoriser la conseil d’administration a déléguer la gestion journalière à M. Erik Lazar.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un Mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 15, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10252/253/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
NORTH ATLANTIC FISHERY INVESTMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 61.637.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 13, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Sociétéi>
NORTH ATLANTIC FISHERY INVESTMENTS S.A.
Signature
(10250/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
OLDIE FM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 45-47, boulevard de la Pétrusse.
R. C. Luxembourg B 64.320.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du 21 décembre 1998 que la
démission de VGD LUXEMBOURG, S.à r.l., société ayant son siège social au 11, boulevard du Prince Henri, L-1724
Luxembourg en tant que commissaire aux comptes est acceptée et que la société DELOITTE & TOUCHE, ayant son
siège social au 21 rue Glesener, L-1631 Luxembourg, est élue nouveau commissaire aux comptes. Son mandat prendra
fin lors de l’Assemblée Générale Annuelle de l’an 2004.
Luxembourg, le 15 février 1999.
Pour extrait conforme
R. P. Pels
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 16, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10253/724/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15824
OMNIS GEFIBAT S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2611 Luxembourg, 85-91, route de Thionville.
R. C. Luxembourg B 46.745.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 27 janvier 1999, vol. 519, fol. 18, case 2, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour OMNIS GEFIBAT S.A.i>
OMNIS S.A.
(10254/000/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
OPTIMED, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5471 Wellenstein, 24A, rue de Remich.
R. C. Luxembourg B 57.564.
—
Le bilan au 31 décembre 1996, enregistré à Luxembourg, le 19 février 1999, vol. 520, fol. 2, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 octobre 1998.
MAZARS & GUERARD LUXEMBOURG S.A.
Signature
(10255/636/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
OTI HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R. C. Luxembourg B 60.248.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 23 février 1999, vol. 520, fol. 13, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
OTI HOLDING S.A.
Signature
(10256/005/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
PART HOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.605.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 9 février 1999, vol. 519, fol. 68, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 février 1999.
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Signature
Signature
(10257/565/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
PART HOTEL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 4, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 58.605.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 juin 1998i>
3. Par votes spéciaux, l’Assemblée Générale donne à l’unanimité des voix décharge pleine et entière aux Administra-
teurs et au Commissaire aux Comptes pour l’ensemble des mandats en 1997.
4. L’Assemblée renomme pour une durée de 6 ans:
Monsieur Christophe Blondeau, Monsieur Nour-Eddin Nijar et Monsieur Rodney Haigh Administrateurs et
HRT REVISION, S.à r.l. Commissaire aux Comptes.
Leurs mandats viendront à échéance lors de l’Assemblée Générale de 2004.
Pour extrait conforme
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 9 février 1999, vol. 519, fol. 68, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10258/565/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15825
PHARMINVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 145, rue de Trèves.
R. C. Luxembourg B 8.302.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 17 février 1999, vol. 312, fol. 36, case 6/5, a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 23 février 1999.
(10259/239/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
PK INTERTRADING, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5854 Alzingen, 33, rue Langheck.
R. C. Luxembourg B 58.790.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 18 février 1999, vol. 519, fol. 97, case 9, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 février 1999.
Signature.
(10260/753/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
ARIES FUNDING CORPORATION II.
Registered office: Grand Cayman, British West Indies, P.O. Box 309, Ugland House, George Town.
—
CERTIFICATE OF INCORPORATION
I, Anthony lan Goddard, Assistant Registrar of Companies of the Cayman Islands do hereby certify, pursuant to the
Companies Law (Revised), that all the requirements of the said Law in respect of registration were complied with by
ARIES FUNDING CORPORATION II, an Exempted Company incorporated in the Cayman Islands with Limited Liability
with effect from the 22nd Day of January one thousand nine hundred ninety-nine.
Given under my hand and Seal at George Town in the Island of Grand Cayman this twenty-second day of January one
thousand nine hundred ninety-nine.
Signature
<i>Assistant Registrari>
<i>of Companies, Cayman Islands, i>B.W.I.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION
1. The name of the Company is ARIES FUNDING CORPORATION II.
2. The Registered Office of the Company shall be at the offices of MAPLES AND CALDER, Attorneys-at-Law, Ugland
House, PO Box 309, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies or at such other place as the
Directors may, from time to time, decide.
3. The objects for which the Company is established are restricted to the following:
(i) To issue Floating or Fixed Rate Notes and to acquire assets including, but not limited to, bonds, swaps, mortgages,
receivables, trust certificates, beneficial interests in trusts, contract rights, claims, personal property, and general
intangibles from various originators or sellers and to enter into agreements for the acquisition and servicing of such
assets;
(ii) (a) To carry on the business of an investment company and execute all kinds of investment, financial, commercial,
mercantile, trading and other operations in order to carry out the objects specified in Clause 3(i) above;
(b) To receive moneys on deposits or loan and to borrow or raise money in any currency with or without security
and to secure or discharge any debt or obligation of or binding on the Company in any manner and to enter into any
swap or derivative and in particular but without limitation by the issue of debentures, notes or bonds and to secure the
repayment of any money borrowed, raised or owing by mortgage, charge or lien or pursuant to any swap or other
derivative against the whole or any part of the Company’s property or assets (whether present or future) including its
uncalled capital in order to carry out the objects specified in Clause 3(i);
(c) To advance, deposit or lend money, securities and/or property to or with such persons, and on such terms as may
seem expedient and to discount, buy, sell and deal in bills, notes, warrants, coupons and other negotiable or transferable
securities or documents in order to carry out the objects specified in Clause 3(i);
(d) To borrow money from NC TRANSFER CORPORATION, a Cayman Islands company, on a subordinated or
unsubordinated basis, and on such terms as may seem expedient;
(iii) To purchase or otherwise acquire, to sell, exchange, surrender, lease, mortgage, charge, convert, turn to account,
dispose of and deal with real and personal property and rights of all kinds and, in particular, bond, swap, other derivative,
mortgages, debentures, produce, concessions, options, contracts, patents, annuities, licences, stocks, shares, bonds,
policies, book debts, business concerns, undertakings, claims, privileges and choses in action of all kinds including Floating
Rate Bonds (the «Bonds») issued by NC TRANSFER CORPORATION in order to carry out the objects specified in
Clause 3(i);
15826
(iv) To subscribe for, conditionally or unconditionally, to underwrite, issue on commission or otherwise, take, hold,
deal in and convert stocks, shares and securities of all kinds and to enter into partnership or into any arrangement for
sharing profits, reciprocal concessions or cooperation with any person or company and to promote and aid in
promoting, to constitute, form or organise any company, syndicate or partnership of any kind, for the purpose of
acquiring and undertaking any property and liabilities of the Company or of advancing, directly or indirectly, the objects
of the Company or for any other purpose which the Company may think expedient in order to carry out the objects
specified in Clause 3(i);
(v) To stand surety for or to guarantee, support or secure the performance of all or any of the obligations of any
person, firm or company whether or not related or affiliated to the Company in any manner and whether by personal
covenant or by mortgage, charge or lien upon the whole or any part of the undertaking, property and assets of the
Company, both present and future, including its uncalled capital or by any such method and whether or not the
Company shall receive valuable consideration therefor in order to carry out the objects specified in Clause 3(i);
(vi) To engage in or carry on any other lawful trade, business or enterprise which may at any time appear to the
Directors of the Company capable of being conveniently carried on in conjunction with any of the aforementioned
businesses to carry out the objects specified in Clause 3(i).
In the interpretation of this Memorandum of Association in general and of this Clause 3 in particular no object,
business or power specified or mentioned shall be limited or restricted by reference to or inference from any other
object, business or power, or the name of the Company, or by the juxtaposition of two or more objects, businesses or
powers and that, in the event of any ambiguity in this clause or elsewhere in this Memorandum of Association, the
same shall be resolved by such interpretation and construction as will widen and enlarge and not restrict the objects,
businesses and powers of and exercisable by the Company.
4. Except as prohibited or limited by the Companies Law (1998 Revision), the Company shall have full power and
authority to carry out any object and shall have and be capable of from time to time and at all times exercising any and
all of the powers at any time or from time to time exercisable by a natural person or body corporate in doing in any part
of the world whether as principal, agent, contractor or otherwise whatever may be considered by it necessary for the
attainment of its objects and whatever else may be considered by it as incidental or conducive thereto or consequential
thereon, including, but without in any way restricting the generality of the foregoing, the power to make any alterations
or amendments to this Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company considered
necessary or convenient in the manner set out in the Articles of Association of the Company, and the power to do any
of the following acts or things, viz:
to pay all expenses of and incidental to the promotion, formation and incorporation of the Company; to register the
Company to do business in any other jurisdiction; to sell, lease or dispose of any property of the Company; to draw,
make, accept, endorse, discount, execute and issue promissory notes, debentures, bills of exchange, bills of lading,
warrants and other negotiable or transferable instruments; to lend money or other assets and to act as guarantors; to
borrow or raise money on the security of the undertaking or on all or any of the assets of the Company including
uncalled capital or without security; to invest monies of the Company in such manner as the Directors determine; to
promote other companies; to sell the undertaking of the Company for cash or any other consideration; to distribute
assets in specie to Members of the Company; to make charitable or benevolent donations; to pay pensions or gratuities
or provide other benefits in cash or kind to Directors, officers, employees, past or present and their families; to
purchase Directors and officers liability insurance and to carry on any trade or business and generally to do all acts and
things which, in the opinion of the Company or the Directors, may be conveniently or profitably or usefully acquired and
dealt with, carried on, executed or done by the Company in connection with the business aforesaid provided that the
Company shall only carry on the businesses for which a licence is required under the laws of the Cayman Islands when
so licensed under the terms of such laws.
5. The liability of each Member is limited to the amount from time to time unpaid on such Member’s shares.
6. The share capital of the Company is USD 1,000.-, divided into USD 1,000 shares of a nominal or par value of USD
1.00 each with power for the Company insofar as is permitted by law, to redeem or purchase any of its shares and to
increase or reduce the said capital subject to the provisions of the Companies Law (1998 Revision) and the Articles of
Association and to issue any part of its capital, whether original, redeemed or increased with or without any preference,
priority or special privilege or subject to any postponement of rights or to any conditions or restrictions and so that
unless the conditions of issue shall otherwise expressly declare every issue of shares whether declared to be preference
or otherwise shall be subject to the powers hereinbefore contained.
7. If the Company is registered as exempted, its operations will be carried on subject to the provisions of Section 193
of the Companies Law (1998 Revision) and, subject to the provisions of the Companies Law (1998 Revision) and the
Articles of Association, it shall have the power to register by way of continuation as a body corporate limited by shares
under the laws of any jurisdiction outside the Cayman Islands and to be deregistered in the Cayman Islands.
We, the several persons whose names and addresses are subscribed, are desirous of being formed into a company in
pursuance of this Memorandum of Association and We respectively agree to take the number of shares in the capital of
the Company set opposite our respective names.
Dated the 22nd day of January 1999.
Signature and address
Number of shares
of each subscriber
taken by each
Henry Smith, Atterney-at-Law, PO Box 309, Grand Cayman …………………………………………………………………
One
Jon Fowler, Attorney-at-Law, PO Box 309, Grand Cayman ……………………………………………………………………
One
Signature
<i>Witness to the above signaturesi>
15827
I, Anthony lan Goddard, Assistant Registrar of Companies in and for the Cayman Islands hereby certify that this is a
true and correct copy of the Memorandum of Association of this Company duly incorporated on the 22 day of January
1999.
Signature
<i>Assistant Registrar of Companiesi>
ARTICLES OF ASSOCIATION
I. In these Articles Table A in the Schedule to the Statute does not apply and, unless there be something in the subject
or context inconsistent therewith,
«Articles» means these Articles as originally framed or as from time to time altered by special Resolution.
«Auditors» means the persons for the time being performing the duties of auditors of the Company.
«Company means the above-named Company.
«debenture» means debenture stock, mortgages, bonds and any other such securities of the Company whether
constituting a charge on the assets of the Company or not.
«Directors» means the directors for the time being of the Company.
«dividend» includes bonus.
«Member» shall bear the meaning as ascribed to it in the Statute.
«month» means calendar month.
«paid up» means paid up and/or credited as paid up.
«registered office» means the registered office for the time, being of Company.
«Seal» means the common seal of the Company and includes every duplicate seal.
«Secretary» includes an Assistant Secretary and any person appointed to perform the duties of Secretary of the
Company.
«share» includes a fraction of a share.
«Special Resolution» has the same meaning as in the Statute and includes a resolution approved in writing as described
therein.
«Statute» means the Companies Law of the Cayman Islands as amended and every statutory modification or re-
enactment thereof for the time being in force.
«written» and «in writing» include all modes of representing or reproducing words in visible form.
Words importing the singular number only include the plural number and vice-versa.
Words importing the masculine gender only include the feminine gender.
Words importing persons only include corporations.
2. The business of the Company may be commenced as soon after incorporation as the Directors shall see fit,
notwithstanding that part only of the shares may have been allotted.
3. The Directors may pay, out of the capital or any other monies of the Company, all expenses incurred in or about
the formation and establishment of the Company including the expenses of registration.
Certificates for shares
4. Certificates representing shares of the Company shall be in such form as shall be determined by the Directors. Such
certificates may be under Seal. All certificates for shares shall be consecutively numbered or otherwise identified and
shall specify the shares to which they relate. The name and address of the person to whom the shares represented
thereby are issued, with the number of shares and date of issue, shall be entered in the register of Members of the
Company. All certificates surrendered to the Company for transfer shall be cancelled and no new certificate shall be
issued until the former certificate for a like number of shares shall have been surrendered and cancelled. The Directors
may authorise certificates to be issued with the seal and authorised signature(s) affixed by some method or system of
mechanical process.
5. Notwithstanding Article 4 of these Articles, if a share certificate be defaced, lost or destroyed, it may be renewed
on payment of a fee of one dollar (USD 1.00) or such lesser sum and on such terms (if any) as to evidence and indemnity
and the payment of the expenses incurred by the Company in investigating evidence, as the Directors may prescribe.
Issue of shares
6. Subject to the provisions, if any, in that behalf in the Memorandum of Association and to any direction that may be
given by the Company in general meeting and without prejudice to any special rights previously conferred on the holders
of existing shares, the Directors may allot, issue, grant options over or otherwise dispose of shares of the Company
(including fractions of a share) with or without preferred, deferred or other special rights or restrictions, whether in
regard to dividend, voting, return of capital or otherwise and to such persons, at such times and on such other terms as
they think proper. The Company shall not issue shares in bearer form.
7. The Company shall maintain a register of its Members and every person whose name is entered as a Member in
the register of Members shall be entitled without payment to receive within two months after allotment or lodgement
of transfer (or within such other period as the conditions of issue shall provide) one certificate for all his shares or
several certificates each for one or more of his shares upon payment of fifty cents (USD 0.50) for every certificate after
the first or such less sum as the Directors shall from time to time determine provided that in respect of a share or shares
held jointly by several persons the Company shall not be bound to issue more than one certificate and delivery of a
certificate for a share to one of the several joint holders shall be sufficient delivery to all such holders.
15828
Transfer of shares
8. The instrument of transfer of any share shall be in writing and shall be executed by or on behalf of the transferor
and the transferor shall be deemed to remain the holder of a share until the name of the transferee is entered in the
register in respect thereof.
9. The Directors may in their absolute discretion decline to register any transfer of shares without assigning any
reason therefor. If the Directors refuse to register a transfer they shall notify the transferee within two months of such
refusal.
10. The registration of transfers may be suspended at such time and for such periods as the Directors may, from time
to time, determine, provided always that such registration shall not be suspended for more than forty-five days in any
year.
Redeemable shares
11. (a) Subject to the provisions of the Statute and the Memorandum of Association, shares may be issued on the
terms that they are, or at the option of the Company or the holder are, to be redeemed on such terms and in such
manner as the Company, before the issue of the shares, may by Special Resolution determine.
(b) Subject to the provisions of the Statute and the Memorandum of Association, the Company may purchase its own
shares (including fractions of a share), including any redeemable shares, provided that the manner of purchase has first
been authorised by the Company in general meeting and may make payment therefor in any manner authorised by the
Statute, including out of capital.
Variation of rights of shares
12. If at any time the share capital of the Company is divided into different classes of shares, the rights attached to any
class (unless otherwise provided by the terms of issue of the shares of that class) may, whether or not the Company is
being wound-up, be varied with the consent in writing of the holders of three-fourths of the issued shares of that class,
or with the sanction of a Special Resolution passed at a general meeting of the holders of the shares of that class.
The provisions of these Articles relating to general meetings shall apply to every such general meeting of the holders
of one class of shares except that the necessary quorum shall be one person holding or representing by proxy at least
one-third of the issued shares of the class and that any holder of shares of the class present in person or by proxy may
demand a poll.
13. The rights conferred upon the holders of the shares of any class issued with preferred or other rights shall not,
unless otherwise expressly provided by the terms of issue of the shares of that class, be deemed to be varied by the
creation or issue of further shares ranking pari passu therewith.
Commission on sale of shares
14. The Company may in so far as the Statute from time to time permits pay a commission to any person in
consideration of his subscribing or agreeing to subscribe whether absolutely or conditionally for any shares of the
Company. Such commissions may be satisfied by the payment of cash or the lodgement of fully or partly paid-up shares
or partly in one way and partly in the other. The Company may also on any issue of shares pay such brokerage as may
be lawful.
Non-recognition of trusts
15. No person shall be recognised by the Company as holding any share upon any trust and the Company shall not
be bound by or be compelled in any way to recognise (even when having notice thereof) any equitable, contingent,
future, or partial interest in any share, or any interest in any fractional part of a share, or (except only as is otherwise
provided by these Articles or the Statute) any other rights in respect of any share except an absolute right to the
entirety thereof in the registered holder.
Lien on shares
16. The Company shall have a first and paramount lien and charge on all shares (whether fully paid up or not)
registered in the name of a Member (whether solely or jointly with others) for all debts, liabilities or engagements to or
with the Company (whether presently payable or not) by such Member or his estate, either alone or jointly with any
other person, whether a Member or not, but the Directors may at any time declare any share to be wholly or in part
exempt from the provisions of this Article. The registration of a transfer of any such share shall operate as a waiver of
the Company’s lien (if any) thereon. The Company’s lien (if any) on a share shall extend to all dividends or other monies
payable in respect thereof.
17. The Company may sell, in such manner as the Directors think fit, any shares on which the Company has a lien,
but no sale shall be made unless a sum in respect of which the lien exists is presently payable, nor until the expiration of
fourteen days after a notice in writing stating and demanding payment of such part of the amount in respect of which the
lien exists as is presently payable, has been given to the registered holder or holders for the time being of the share, or
the person, of which the Company has notice, entitled thereto by reason of his death or bankruptcy.
18. To give effect to any such sale the Directors may authorise some person to transfer the shares sold to the
purchaser thereof. The purchaser shall be registered as the holder of the shares comprised in any such transfer, and he
shall not be bound to see to the application of the purchase money, nor shall his title to the shares be affected by any
irregularity or invalidity in the proceedings in reference to the sale.
19. The proceeds of such sale shall be received by the Company and applied in payment of such part of the amount
in respect of which the lien exists as is presently payable and the residue, if any, shall (subject to a like lien for sums not
presently payable as existed upon the shares before the sale) be paid to the person entitled to the shares at the date of
the sale.
15829
Call on shares
20. (a) The Directors may, from time to time, make calls upon the Members in respect of any monies unpaid on their
shares (whether on account of the nominal value of the shares or by way of premium or otherwise) and not by the
conditions of allotment thereof made payable at fixed terms, provided that no call shall be payable at less than one month
from the date fixed for the payment of the last preceding call, and each Member shall (subject to receiving at least
fourteen days notice specifying the time or times of payment) pay to the Company at the time or times so specified the
amount called on the shares. A call may be revoked or postponed as the Directors may determine. A call may be made
payable by instalments.
(b) A call shall be deemed to have been made at the time when the resolution of the Directors authorising such call
was passed.
(c) The joint holders of a share shall be jointly and severally liable to pay all calls in respect thereof.
21. If a sum called in respect of a share is not paid before or on a day appointed for payment thereof, the persons
from whom the sum is due shall pay interest on the sum from the day appointed for payment thereof to the time of
actual payment at such rate not exceeding ten per cent per annum as the Directors may determine, but the Directors
shall be at liberty to waive payment of such interest either wholly or in part.
22. Any sum which by the terms of issue of a share becomes payable on allotment or at any fixed date, whether on
account of the nominal value of the share or by way of premium or otherwise, shall for the purposes of these Articles
be deemed to be a call duly made, notified and payable on the date on which by the terms of issue the same becomes
payable, and in the case of non-payment all the relevant provisions of these Articles as to payment of interest forfeiture
or otherwise shall apply as if such sum had become payable by virtue of a call duly made and notified.
23. The Directors may, on the issue of shares, differentiate between the holders as to the amount of calls or interest
to be paid and the times of payment.
24. (a) The Directors may, if they think fit, receive from any Member willing to advance the same, all or any part of
the monies uncalled and unpaid upon any shares held by him, and upon all or any of the monies so advanced may (until
the same would but for such advances, become payable) pay interest at such rate not exceeding (unless the Company in
general meeting shall otherwise direct) seven per cent per annum, as may be agreed upon between the Directors and
the Member paying such sum in advance.
(b) No such sum paid in advance of calls shall entitle the Member paying such sum to any portion of a dividend
declared in respect of any period prior to the date upon which such sum would, but for such payment, become presently
payable.
Forfeiture of shares
25. (a) If a Member fails to pay any call or instalment of a call or to make any payment required by the terms of issue
on the day appointed for payment thereof, the Directors may, at any time thereafter during such time as any part of the
call, instalment or payment remains unpaid, give notice requiring payment of so much of the call, instalment or payment
as is unpaid, together with any interest which may have accrued and all expenses that have been incurred by the
Company by reason of such non-payment. Such notice shall name a day (not earlier than the expiration of fourteen days
from the date of giving of the notice) on or before which the payment required by the notice is to be made, and shall
state that, in the event of non-payment at or before the time appointed the shares in respect of which such notice was
given will be liable to be forfeited.
(b) If the requirements of any such notice as aforesaid are not complied with, any share in respect of which the notice
has been given may at any time thereafter, before the payment required by the notice has been made, be forfeited by a
resolution of the Directors to that effect. Such forfeiture shall include all dividends declared in respect of the forfeited
share and not actually paid before the forfeiture.
(c) A forfeited share may be sold or otherwise disposed of on such terms and in such manner as the Directors think
fit and at any time before a sale or disposition the forfeiture may be cancelled on such terms as the Directors think fit.
26. A person whose shares have been forfeited shall cease to be a Member in respect of the forfeited shares, but shall,
notwithstanding, remain liable to pay to the Company all monies which, at the date of forfeiture were payable by him to
the Company in respect of the shares together with interest thereon, but his liability shall cease if and when the
Company shall have received payment in full of all monies whenever payable in respect of the shares.
27. A certificate in writing under the hand of one Director or the Secretary of the Company that a share in the
Company has been duly forfeited on a date stated in the declaration shall be conclusive evidence of the fact therein
stated as against all persons claiming to be entitled to the share. The Company may receive the consideration given for
the share on any sale or disposition thereof and may execute a transfer of the share in favour of the person to whom
the share is sold or disposed of and he shall thereupon be registered as the holder of the share and shall not be bound
to see to the application of the purchase money, if any, nor shall his title to the share be affected by any irregularity or
invalidity in the proceedings in reference to the forfeiture, sale or disposal of the share.
28. The provisions of these Articles as to forfeiture shall apply in the case of non-payment of any sum which, by the
terms of issue of a share, becomes payable at a fixed time, whether on account of the nominal value of the share or by
way of premium as if the same had been payable by virtue of a call duly made and notified.
Registration of empowering instruments
29. The Company shall be entitled to charge a fee not exceeding one dollar (USD 1.00) on the registration of every
probate, letters of administration, certificate of death or marriage, power of attorney, notice in lieu of distringas, or
other instrument.
15830
Transmission of shares
30. In case of the death of a Member, the survivor or survivors where the deceased was a joint holder, and the legal
personal representatives of the deceased where he was a sole holder, shall be the only persons recognised by the
Company as having any title to his interest in the shares, but nothing herein contained shall release the estate of any such
deceased holder from any liability in respect of any shares which had been held by him solely or jointly with other
persons.
31. (a) Any person becoming entitled to a share in consequence of the death or bankruptcy or liquidation or
dissolution of a Member (or in any other way than by transfer) may, upon such evidence being produced as may, from
time to time, be required by the Directors and subject as hereinafter provided, elect either to be registered himself as
holder of the share or to make such transfer of the share to such other person nominated by him as the deceased or
bankrupt person could have made and to have such person registered as the transferee thereof, but the Directors shall,
in either case, have the same right to decline or suspend registration as they would have had in the case of a transfer of
the share by that Member before his death or bankruptcy as the case may be.
(b) If the person so becoming entitled shall elect to be registered himself as holder he shall deliver or send to the
Company a notice in writing signed by him stating that he so elects.
32. A person becoming entitled to a share by reason of the death or bankruptcy or liquidation or dissolution of the
holder (or in any other case than by transfer) shall be entitled to the same dividends and other advantages to which he
would be entitled if he were the registered holder of the share, except that he shall not, before being registered as a
Member in respect of the share, be entitled in respect of it to exercise any right conferred by membership in relation to
meetings of the Company provided however that the Directors may at any time give notice requiring any such person
to elect either to be registered himself or to transfer the share and if the notice is not complied with within ninety days
the Directors may thereafter withhold payment of all dividends, bonuses or other monies payable in respect of the share
until the requirements of the notice have been complied with.
Amendment of Memorandum of Association, Alteration of capital and change of location of registered office
33. (a) Subject to and in so far as permitted by the provisions of the Statute, the Company may, from time to time by
Special Resolution, alter or amend its Memorandum of Association with respect to any objects, powers or other matters
specified therein provided always that the Company may by ordinary resolution:
(i) increase the share capital by such sum to be divided into shares of such amount or without nominal or par value
as the resolution shall prescribe and with such rights, priorities and privileges annexed thereto, as the Company in
general meeting may determine;
(ii) consolidate and divide all or any of its share capital into shares of larger amount than its existing shares;
(iii) by subdivision of its existing shares or any of them divide the whole or any part of its share capital into shares of
smaller amount than is fixed by the Memorandum of Association or into shares without nominal or par value;
(iv) cancel any shares which at the date of the passing of the resolution have not been taken or agreed to be taken by
any person.
(b) All new shares created hereunder shall be subject to the same provisions with reference to the payment of calls,
liens, transfer, transmission, forfeiture and otherwise as the shares in the original share capital.
(c) Without prejudice to Article 11 hereof and subject to the provisions of the Statute, the Company may by Special
Resolution reduce its share capital and any capital redemption reserve fund.
(d) Subject to the provisions of the Statute, the Company may by resolution of the Directors change the location of
its registered office.
Closing register of members or fixing record date
34. For the purpose of determining Members entitled to notice of or to vote at any meeting of Members or any
adjournment thereof, or Members entitled to receive payment of any dividend, or in order to make a determination of
Members for any other proper purpose, the Directors of the Company may provide that the register of Members shall
be closed for transfers for a stated period but not to exceed in any case forty days. If the register of Members shall be
so closed for the purpose of determining Members entitled to notice of or to vote at a meeting of Members such
register shall be so closed for at least ten days immediately preceding such meeting and the record date for such
determination shall be the date of the closure of the register of Members.
35. In lieu of or apart from closing the register of Members, the Directors may fix in advance a date as the record date
for any such determination of Members entitled to notice of or to vote at a meeting of the Members and for the purpose
of determining the Members entitled to receive payment of any dividend the Directors may, at or within 90 days prior
to the date of declaration of such dividend fix a subsequent date as the record date for such determination.
36. If the register of Members is not so closed and no record date is fixed for the determination of Members entitled
to notice of or to vote at a meeting of Members or Members entitled to receive payment of a dividend, the date on
which notice of the meeting is mailed or the date on which the resolution of the Directors declaring such dividend is
adopted, as the case may be, shall be the record date for such determination of Members. When a determination of
Members entitled to vote at any meeting of Members has been made as provided in this section, such determination shall
apply to any adjournment thereof.
General meeting
37. (a) Subject to paragraph (c) hereof, the Company shall within one year of its incorporation and in each year of its
existence thereafter hold a general meeting as its annual general meeting and shall specify the meeting as such in the
notices calling it. The annual general meeting shall be held at such time and place as the Directors shall appoint and if no
other time and place is prescribed by them, it shall be held at the registered office on the second Wednesday in
December of each year at ten o’clock in the morning.
15831
(b) At these meetings the report of the Directors (if any) shall be presented.
(c) If the Company is exempted as defined in the Statute it may but shall not be obliged to hold an annual general
meeting.
38. (a) The Directors may whenever they think fit, and they shall on the requisition of Members of the Company
holding at the date of the deposit of the requisition not less than one-tenth of such of the paid-up capital of the Company
as at the date of the deposit carries the right of voting at general meetings of the Company, proceed to convene a
general meeting of the Company.
(b) The requisition must state the objects of the meeting and must be signed by the requisitionists and deposited at
the registered office of the Company and may consist of several documents in like form each signed by one or more
requisitionists.
(c) If the Directors do not within twenty-one days from the date of the deposit of the requisition duly proceed to
convene a general meeting, the requisitionists, or any of them representing more than one-half of the total voting rights
of all of them, may themselves convene a general meeting, but any meeting so convened shall not be held after the
expiration of three months after the expiration of the said twenty-one days.
(d) A general meeting convened as aforesaid by requisitionists shall be convened in the same manner as nearly as
possible as that in which general meetings are to be convened by Directors.
Notice of general meetings
39. At least five days’ notice shall be given of an annual general meeting or any other general meeting. Every notice
shall be exclusive of the day on which it is given or deemed to be given and of the day for which it is given and shall
specify the place, the day and the hour of the meeting and the general nature of the business and shall be given in manner
hereinafter mentioned or in such other manner if any as may be prescribed by the Company provided that a general
meeting of the Company shall, whether or not the notice specified in this regulation has been given and whether or not
the provisions of Article 38 have been complied with, be deemed to have been duly convened if it is so agreed:
(a) in the case of a general meeting called as an annual general meeting by all the Members entitled to attend and vote
thereat or their proxies; and
(b) in the case of any other general meeting by a majority in number of the Members having a right to attend and vote
at the meeting, being a majority together holding not less than seventy-five per cent in nominal value or in the case of
shares without nominal or par value seventy-five per cent of the shares in issue, or their proxies.
40. The accidental omission to give notice of a general meeting to, or the non-receipt of notice of a meeting by any
person entitled to receive notice shall not invalidate the proceedings of that meeting.
Proceedings at general meetings
41. No business shall be transacted at any general meeting unless a quorum of Members is present at the time when
the meeting proceeds to business; two Members present in person or by proxy shall be a quorum provided always that
if the Company has one Member of record the quorum shall be that one Member present in person or by proxy.
42. A resolution (including a Special Resolution) in writing (in one or more counterparts) signed by all Members for
the time being entitled to receive notice of and to attend and vote at general meetings (or being corporations by their
duly authorised representatives) shall be as valid and effective as if the same had been passed at a general meeting of the
Company duly convened and held.
43. If within half an hour from the time appointed for the meeting a quorum is not present, the meeting, if convened
upon the requisition of Members, shall be dissolved and in any other case it shall stand adjourned to the same day in the
next week at the same time and place or to such other time or such other place as the Directors may determine and if
at the adjourned meeting a quorum is not present within half an hour from the time appointed for the meeting the
Members present shall be a quorum.
44. The Chairman, if any, of the Board of Directors shall preside as Chairman over every general meeting of the
Company, or if there is no such Chairman, or if he shall not be present within fifteen minutes after the time appointed
for the holding of the meeting, or is unwilling to act, the Directors present shall elect one of their number to be
Chairman of the meeting.
45. If at any general meeting no Director is willing to act as Chairman or if no Director is present within fifteen
minutes after the time appointed for holding the meeting, the Members present shall choose one of their number to be
Chairman of the meeting.
46. The Chairman may, with the consent of any general meeting duly constituted hereunder, and shall if so directed
by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at
any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the adjournment took place.
When a general meeting is adjourned for thirty days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the
case of an original meeting; save as aforesaid it shall not be necessary to give any notice of an adjournment or of the
business to be transacted at an adjourned general meeting.
47. At any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall be decided on a show of hands unless a
poll is, before or on the declaration of the result of the show of hands, demanded by the Chairman or any other Member
present in person or by proxy.
48. Unless a poll be so demanded a declaration by the Chairman that a resolution has on a show of hands been
carried, or carried unanimously, or by a particular majority, or lost, and an entry to that effect in the Company’s Minute
Book containing the Minutes of the proceedings of the meeting shall be conclusive evidence of that fact without proof
of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution.
49. The demand for a poll may be withdrawn.
15832
50. Except as provided in Article 52, if a poll is duly demanded it shall be taken in such manner as the Chairman directs
and the result of the poll shall be deemed to be the resolution of the general meeting at which the poll was demanded.
51. In the case of an equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the Chairman of the general meeting
at which the show of hands takes place or at which the poll is demanded, shall be entitled to a second or casting vote.
52. A poll demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment shall be taken forthwith. A poll
demanded on any other question shall be taken at such time as the Chairman of the general meeting directs and any
business other than that upon which a poll has been demanded or is contingent thereon may be proceeded with pending
the taking of the poll.
Votes of members
53. Subject to any rights or restrictions for the time being attached to any class or classes of shares, on a show of
hands every Member of record present in person or by proxy at a general meeting shall have one vote and on a poll
every Member of record present in person or by proxy shall have one vote for each share registered in his name in the
register of Members.
54. In the case of joint holders of record the vote of the senior who tenders a vote, whether in person or by proxy,
shall be accepted to the exclusion of the votes of the other joint holders, and for this purpose seniority shall be
determined by the order in which the names stand in the register of Members.
55. A Member of unsound mind, or in respect of whom an order has been made by any court, having jurisdiction in
lunacy, may vote, whether on a show of hands or on a poll, by his committee, receiver, curator bonis, or other person
in the nature of a committee, receiver or curator bonis appointed by that court, and any such committee, receiver,
curator bonis or other persons may vote by proxy.
56. No Member shall be entitled to vote at any general meeting unless he is registered as a shareholder of the
Company on the record date for such meeting nor unless all calls or other sums presently payable by him in respect of
shares in the Company have been paid.
57. No objection shall be raised to the qualification of any voter except at the general meeting or adjourned general
meeting at which the vote objected to is given or tendered and every vote not disallowed at such general meeting shall
be valid for all purposes. Any such objection made in due time shall be referred to the Chairman of the general meeting
whose decision shall be final and conclusive.
58. On a poll or on a show of hands votes may be given either personally or by proxy.
Proxies
59. The instrument appointing a proxy shall be in writing and shall be executed under the hand of the appointor or of
his attorney duly authorised in writing, or, if the appointor is a corporation under the hand of an officer or attorney duly
authorised in that behalf. A proxy need not be a Member of the Company.
60. The instrument appointing a proxy shall be deposited at the registered office of the Company or at such other
place as is specified for that purpose in the notice convening the meeting no later than the time for holding the meeting,
or adjourned meeting provided that the Chairman of the Meeting may at his discretion direct that an instrument of
proxy shall be deemed to have been duly deposited upon receipt of telex, cable or telecopy confirmation from the
appointor that the instrument of proxy duly signed is in the course of transmission to the Company.
61. The instrument appointing a proxy may be in any usual or common form and may be expressed to be for a
particular meeting or any adjournment thereof or generally until revoked. An instrument appointing a proxy shall be
deemed to include the power to demand or join or concur in demanding a poll.
62. A vote given in accordance with the terms of an instrument of proxy shall be valid notwithstanding the previous
death or insanity of the principal or revocation of the proxy or of the authority under which the proxy was executed,
or the transfer of the share in respect of which the proxy is given provided that no intimation in writing of such death,
insanity, revocation or transfer as aforesaid shall have been received by the Company at the registered office before the
commencement of the general meeting, or adjourned meeting at which it is sought to use the proxy.
63. Any corporation which is a Member of record of the Company may in accordance with its Articles or in the
absence of such provision by resolution of its Directors or other governing body authorise such person as it thinks fit
to act as its representative at any meeting of the Company or of any class of Members of the Company, and the person
so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the corporation which he represents as the
corporation could exercise if it were an individual Member of record of the Company.
64. Shares of its own capital belonging to the Company or held by it in a fiduciary capacity shall not be voted, directly
or indirectly, at any meeting and shall not be counted in determining the total number of outstanding shares at any given
time.
Directors
65. There shall be a Board of Directors consisting of not more than ten persons (exclusive of alternate Directors)
provided however that the Company may, from time to time, by ordinary resolution increase or reduce the limit in the
number of Directors. The first Directors of the Company shall be determined in writing by, or appointed by a resolution
of, the subscribers of the Memorandum of Association or a majority of them.
66. The remuneration to be paid to the Directors shall be such remuneration as the Directors shall determine. Such
remuneration shall be deemed to accrue from day to day. The Directors shall also be entitled to be paid their travelling,
hotel and other expenses properly incurred by them in going to, attending and returning from meetings of the Directors,
or any committee of the Directors, or general meetings of the Company, or otherwise in connection with the business
of the Company, or to receive a fixed allowance in respect thereof, as may be determined by the Directors from time
to time, or a combination partly of one such method and partly the other.
15833
67. The Directors may by resolution award special remuneration to any Director of the Company undertaking any
special work or services for, or undertaking any special mission on behalf of, the Company other than his ordinary
routine work as a Director. Any fees paid to a Director who is also counsel or solicitor to the Company, or otherwise
serves it in a professional capacity shall be in addition to his remuneration as a Director.
68. A Director or alternate Director may hold any other office or place of profit under the Company (other than the
office of Auditor) in conjunction with his office of Director for such period and on such terms as to remuneration and
otherwise as the Directors may determine.
69. A Director or alternate Director may act by himself or his firm in a professional capacity for the Company and he
or his firm shall be entitled to remuneration for professional services as if he were not a Director or alternate Director.
70. A shareholding qualification for Directors may be fixed by the Company in general meeting, but unless and until
so fixed no qualification shall be required.
71. A Director or alternate Director of the Company may be or become a director or other officer of or otherwise
interested in any company promoted by the Company or in which the Company may be interested as shareholder or
otherwise and no such Director or alternate Director shall be accountable to the Company for any remuneration or
other benefits received by him as a director or officer of, or from his interest in, such other company.
72. No person shall be disqualified from the office of Director or alternate Director or prevented by such office from
contracting with the Company, either as vendor, purchaser or otherwise, nor shall any such contract or any contract or
transaction entered into by or on behalf of the Company in which any Director or alternate Director shall be in any way
interested be or be liable to be avoided, nor shall any Director or alternate Director so contracting or being so
interested be liable to account to the Company for any profit realised by any such contract or transaction by reason of
such Director holding office or of the fiduciary relation thereby established. A Director (or his alternate Director in his
absence) shall be at liberty to vote in respect of any contract or transaction in which he is so interested as aforesaid
provided however that the nature of the interest of any Director or alternate Director in any such contract or
transaction shall be disclosed by him or the alternate Director appointed by him at or prior to its consideration and any
vote thereon.
73. A general notice or disclosure to the Directors or otherwise contained in the minutes of a Meeting or a written
resolution of the Directors or any committee thereof that a Director or alternate Director is a shareholder of any
specified firm or company and is to be regarded as interested in any transaction with such firm or company shall be
sufficient disclosure under Article 72 and after such general notice it shall not be necessary to give special notice relating
to any particular transaction.
Alternate directors
74. Subject to the exception contained in Article 82, a Director who expects to be unable to attend Directors’
Meetings because of absence, illness or otherwise may appoint any person to be an alternate Director to act in his stead
and such appointee whilst he holds office as an alternate Director shall, in the event of absence therefrom of his
appointor, be entitled to attend meetings of the Directors and to vote thereat and to do, in the place and stead of his
appointor, any other act or thing which his appointor is permitted or required to do by virtue of his being a Director as
if the alternate Director were the appointor, other than appointment of an alternate to himself, and he shall ipso facto
vacate office if and when his appointor ceases to be a Director or removes the appointee from office. Any appointment
or removal under this Article shall be effected by notice in writing under the hand of the Director making the same.
Powers and duties of directors
75. The business of the Company shall be managed by the Directors (or a sole Director if only one is appointed) who
may pay all expenses incurred in promoting, registering and setting up the Company, and may exercise all such powers
of the Company as are not, from time to time by the Statute, or by these Articles, or such regulations, being not
inconsistent with the aforesaid, as may be prescribed by the Company in general meeting required to be exercised by
the Company in general meeting provided however that no regulations made by the Company in general meeting shall
invalidate any prior act of the Directors which would have been valid if that regulation had not been made.
76. The Directors may, from time to time and at any time by powers of attorney, appoint any company, firm, person
or body of persons, whether nominated directly or indirectly by the Directors, to be the attorney or attorneys of the
Company for such purpose and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or
exercisable by the Directors under these Articles) and for such period and subject to such conditions as they may think
fit, and any such powers of attorney may contain such provisions for the protection and convenience of persons dealing
with any such attorneys as the Directors may think fit and may also authorise any such attorney to delegate all or any of
the powers, authorities and discretions vested in him.
77. All cheques, promissory notes, drafts, bills of exchange and other negotiable instruments and all receipts for
monies paid to the Company shall be signed, drawn, accepted, endorsed or otherwise executed as the case may be in
such manner as the Directors shall, from time to time, by resolution determine.
78. The Directors shall cause minutes to be made in books provided for the purpose:
(a) of all appointments of officers made by the Directors;
(b) of the names of the Directors (including those represented thereat by an alternate or by proxy) present at each
meeting of the Directors and of any committee of the Directors;
(c) of all resolutions and proceedings at all meetings of the Company and of the Directors and of committees of
Directors.
79. The Directors on behalf of the Company may pay a gratuity or pension or allowance on retirement to any
Director who has held any other salaried office or place of profit with the Company or to his widow or dependants and
may make contributions to any fund and pay premiums for the purchase or provision of any such gratuity, pension or
allowance.
15834
80. The Directors may exercise all the powers of the Company to borrow money and to mortgage or charge its
undertaking, property and uncalled capital or any part thereof and to issue debentures, debenture stock and other
securities whether outright or as security for any debt, liability or obligation of the Company or of any third party.
Management
81. (a) The Directors may, from time to time, provide for the management of the affairs of the Company in such
manner as they shall think fit and the provisions contained in the three next following paragraphs shall be without
prejudice to the general powers conferred by this paragraph.
(b) The Directors, from time to time and at any time, may establish any committees, local boards or agencies for
managing any of the affairs of the Company and may appoint any persons to be members of such committees or local
boards or any managers or agents and may fix their remuneration.
(c) The Directors, from time to time and at any time, may delegate to any such committee, local board, manager or
agent any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in the Directors and may authorise the
members for the time being of any such local board, or any of them to fill up any vacancies therein and to act notwith-
standing vacancies and any such appointment or delegation may be made on such terms and subject to such conditions
as the Directors may think fit and the Directors may at any time remove any person so appointed and may annul or vary
any such delegation, but no person dealing in good faith and without notice of any such annulment or variation shall be
affected thereby.
(d) Any such delegates as aforesaid may be authorised by the Directors to subdelegate all or any of the powers,
authorities, and discretions for the time being vested in them.
Managing directors
82. The Directors may, from time to time, appoint one or more of their body (but not an alternate Director) to the
office of Managing Director for such term and at such remuneration (whether by way of salary, or commission, or
participation in profits, or partly in one way and partly in another) as they may think fit but his appointment shall be
subject to determination ipso facto if he ceases from any cause to be a Director and no alternate Director appointed by
him can act in his stead as a Director or Managing Director.
83. The Directors may entrust to and confer upon a Managing Director any of the powers exercisable by them upon
such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit and either collaterally with or to the exclusion
of their own powers and may, from time to time, revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.
Proceedings of directors
84. Except as otherwise provided by these Articles, the Directors shall meet together for the despatch of business,
convening, adjourning and otherwise regulating their meetings as they think fit. Questions arising at any meeting shall be
decided by a majority of votes of the Directors and alternate Directors present at a meeting at which there is a quorum,
the vote of an alternate Director not being counted if his appointor be present at such meeting. In case of an equality of
votes, the Chairman shall have a second or casting vote.
85. A Director or alternate Director may, and the Secretary on the requisition of a Director or alternate Director
shall, at any time summon a meeting of the Directors by at least two days’ notice in writing to every Director and
alternate Director which notice shall set forth the general nature of the business to be considered unless notice is
waived by all the Directors (or their alternates) either at, before or after the meeting is held and provided further if
notice is given in person, by cable, telex or telecopy the same shall be deemed to have been given on the day it is
delivered to the Directors or transmitting organisation as the case may be. The provisions of Article 40 shall apply
mutatis mutandis with respect to notices of meetings of Directors.
86. The quorum necessary for the transaction of the business of the Directors may be fixed by the Directors and
unless so fixed shall be two, a Director and his appointed alternate Director being considered only one person for this
purpose, provided always that if there shall at any time be only a sole Director the quorum shall be one. For the
purposes of this Article an alternate Director or proxy appointed by a Director shall be counted in a quorum at a
meeting at which the Director appointing him is not present.
87. The continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body, but if and so long as their number is
reduced below the number fixed by or pursuant to these Articles as the necessary quorum of Directors the continuing
Directors or Director may act for the purpose of increasing the number of Directors to that number, or of summoning
a general meeting of the Company, but for no other purpose.
88. The Directors may elect a Chairman of their Board and determine the period for which he is to hold office; but
if no such Chairman is elected, or if at any meeting the Chairman is not present within five minutes after the time
appointed for holding the same, the Directors present may choose one of their number to be Chairman of the meeting.
89. The Directors may delegate any of their powers to committees consisting of such member or members of the
Board of Directors (including Alternate Directors in the absence of their appointors) as they think fit; any committee so
formed shall in the exercise of the powers so delegated conform to any regulations that may be imposed on it by the
Directors.
90. A committee may meet and adjourn as it thinks proper. Questions arising at any meeting shall be determined by
a majority of votes of the members present, and in the case of an equality of votes the Chairman shall have a second or
casting vote.
91. All acts done by any meeting of the Directors or of a committee of Directors (including any person acting as an
alternate Director) shall, notwithstanding that it be afterwards discovered that there was some defect in the
appointment of any Director or alternate Director, or that they or any of them were disqualified, be as valid as if every
such person had been duly appointed and qualified to be a Director or alternate Director as the case may be.
15835
92. Members of the Board of Directors or of any committee thereof may participate in a meeting of the Board or of
such committee by means of conference telephone or similar communications equipment by means of which all persons
participating in the meeting can hear each other and participation in a meeting pursuant to this provision shall constitute
presence in person at such meeting. A resolution in writing (in one or more counterparts), signed by all the Directors
for the time being or all the members of a committee of Directors (an alternate Director being entitled to sign such
resolution on behalf of his appointor) shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting of the Directors
or committee as the case may be duly convened and held.
93. (a) A Director may be represented at any meetings of the Board of Directors by a proxy appointed by him in
which event the presence or vote of the proxy shall for all purposes be deemed to be that of the Director.
(b) The provisions of Articles 59-62 shall mutatis mutandis apply to the appointment of proxies by Directors.
Vacation of office of director
94. The office of a Director shall be vacated:
(a) if he gives notice in writing to the Company that he resigns the office of Director;
(b) if he absents himself (without being represented by proxy or an alternate Director appointed by him) from three
consecutive meetings of the Board of Directors without special leave of absence from the Directors, and they pass a
resolution that he has by reason of such absence vacated office;
(c) if he dies, becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally;
(d) if he is found a lunatic or becomes of unsound mind.
Appointment and removal of directors
95. The Company may by ordinary resolution appoint any person to be a Director and may in like manner remove
any Director and may in like manner appoint another person in his stead.
96. The Directors shall have power, at any time and from time to time, to appoint any person to be a Director, either
to fill a casual vacancy or as an addition to the existing Directors but so that the total amount of Directors (exclusive of
alternate Directors) shall not at any time exceed the number fixed in accordance with these Articles.
Presumption of assent
97. A Director of the Company who is present at a meeting of the Board of Directors at which action on any
Company matter is taken shall be presumed to have assented to the action taken unless his dissent shall be entered in
the Minutes of the meeting or unless he shall file his written dissent from such action with the person acting as the
Secretary of the meeting before the adjournment thereof or shall forward such dissent by registered mail to such person
immediately after the adjournment of the meeting. Such right to dissent shall not apply to a Director who voted in favour
of such action.
Seal
98. (a) The Company may, if the Directors so determine, have a Seal which shall, subject to paragraph (c) hereof, only
be used by the authority of the Directors or of a committee of the Directors authorised by the Directors in that behalf
and every instrument to which the Seal has been affixed shall be signed by one person who shall be either a Director or
the Secretary or Secretary-Treasurer or some person appointed by the Directors for the purpose.
(b) The Company may have a duplicate Seal or Seals each of which shall be a facsimile of the Common Seal of the
Company and, if the Directors so determine, with the addition on its face of the name of every place where it is to be
used.
(c) A Director, Secretary or other officer or representative or attorney may without further authority of the
Directors affix the Seal of the Company over his signature alone to any document of the Company required to be
authenticated by him under Seal or to be filed with the Registrar of Companies in the Cayman Islands or elsewhere
wheresoever.
Officers
99. The Company may have a President, a Secretary or Secretary-Treasurer appointed by the Directors who may
also, from time to time, appoint such other officers as they consider necessary, all for such terms, at such remuneration
and to perform such duties, and subject to such provisions as to disqualification and removal, as the Directors from time
to time prescribe.
Dividends, Distributions and Reserve
100. Subject to the Statute, the Directors may, from time to time, declare dividends (including interim dividends) and
distributions on shares of the Company outstanding and authorise payment of the same out of the funds of the Company
lawfully available therefor.
101. The Directors may, before declaring any dividends or distributions, set aside such sums as they think proper as
a reserve or reserves which shall at the discretion of the Directors, be applicable for any purpose of the Company and
pending such application may, at the like discretion, be employed in the business of the Company.
102. No dividend or distribution shall be payable except out of the profits of the Company, realised or unrealised, or
out of the share premium account or as otherwise permitted by the Statute.
103. Subject to the rights of persons, if any, entitled to shares with special rights as to dividends or distributions, if
dividends or distributions are to be declared on a class of shares they shall be declared and paid according to the
amounts paid or credited as paid on the shares of such class outstanding on the record date for such dividend or
15836
distribution, as determined in accordance with these Articles, but no amount paid or credited as paid on a share in
advance of calls shall be treated for the purpose of this Article as paid on the share.
104. The Directors may deduct from any dividend or distribution payable to any Member all sums of money (if any)
presently payable by him to the Company on account of calls or otherwise.
105. The Directors may declare that any dividend or distribution be paid wholly or partly by the distribution of
specific assets and in particular of paid up shares, debentures, or debenture stock of any other company or in any one
or more of such ways and where any difficulty arises in regard to such distribution, the Directors may settle the same
as they think expedient and in particular may issue fractional certificates and fix the value for distribution of such specific
assets or any part thereof and may determine that cash payments shall be made to any Members upon the footing of the
value so fixed in order to adjust the rights of all Members and may vest any such specific assets in trustees as may seem
expedient to the Directors.
106. Any dividend, distribution, interest or other monies payable in cash in respect of shares may be paid by cheque
or warrant sent through the post directed to the registered address of the holder or, in the case of joint holders, to the
holder who is first named on the register of Members or to such person and to such address as such holder or joint
holders may in writing direct. Every such cheque or warrant shall be made payable to the order of the person to whom
it is sent. Any one of two or more joint holders may give effectual receipts for any dividends, bonuses, or other monies
payable in respect of the share held by them as joint holders.
107. No dividend or distribution shall bear interest against the Company.
Capitalisation
108. The Company may upon the recommendation of the Directors by ordinary resolution authorise the Directors
to capitalise any sum standing to the credit of any of the Company’s reserve accounts (including share premium account
and capital redemption reserve fund) or any sum standing to the credit of profit and loss account or otherwise available
for distribution and to appropriate such sum to Members in the proportions in which such sum would have been
divisible amongst them had the same been a distribution of profits by way of dividend and to apply such sum on their
behalf in paying up in full unissued shares for allotment and distribution credited as fully paid up to and amongst them in
the proportion aforesaid. In such event the Directors shall do all acts and things required to give effect to such
capitalisation, with full power to the Directors to make such provisions as they think fit for the case of shares becoming
distributable in fractions (including provisions whereby the benefit of fractional entitlements accrue to the Company
rather than to the Members concerned). The Directors may authorise any person to enter on behalf of all of the
Members interested into an agreement with the Company providing for such capitalisation and matters incidental
thereto and any agreement made under such authority shall be effective and binding on all concerned.
Books of account
109. The Directors shall cause proper books of account to be kept with respect to:
(a) all sums of money received and expended by the Company and the matters in respect of which the receipt or
expenditure takes place;
(b) all sales and purchases of goods by the Company;
(c) the assets and liabilities of the Company.
Proper books shall not be deemed to be kept if there are not kept such books of account as are necessary to give a
true and fair view of the state of the Company’s affairs and to explain its transactions.
110. The Directors shall, from time to time, determine whether and to what extent and at what times and places and
under what conditions or regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the
inspection of Members not being Directors and no Member (not being a Director) shall have any right of inspecting any
account or book or document of the Company except as conferred by Statute or authorised by the Directors or by the
Company in general meeting.
111. The Directors may, from time to time, cause to be prepared and to be laid before the Company in general
meeting profit and loss accounts, balance sheets, group accounts (if any) and such other reports and accounts as may be
required by law.
Audit
112. The Company may at any annual general meeting appoint an Auditor or Auditors of the Company who shall hold
office until the next annual general meeting and may fix his or their remuneration.
113. The Directors may before the first annual general meeting appoint an Auditor or Auditors of the Company who
shall hold office until the first annual general meeting unless previously removed by an ordinary resolution of the
Members in general meeting in which case the Members at that meeting may appoint Auditors. The Directors may fill
any casual vacancy in the office of Auditor but while any such vacancy continues the surviving or continuing Auditor or
Auditors, if any, may act. The remuneration of any Auditor appointed by the Directors under this Article may be fixed
by the Directors.
114. Every Auditor of the Company shall have a right of access at all times to the books and accounts and vouchers
of the Company and shall be entitled to require from the Directors and Officers of the Company such information and
explanation as may be necessary for the performance of the duties of the auditors.
115. Auditors shall at the next annual general meeting following their appointment and at any other time during their
term of office, upon request of the Directors or any general meeting of the Members, make a report on the accounts of
the Company in general meeting during their tenure of office.
15837
Notices
116. Notices shall be in writing and may be given by the Company to any Member either personally or by sending it
by post, cable, telex or telecopy to him or to his address as shown in the register of Members, such notice, if mailed, to
be forwarded airmail if the address be outside the Cayman Islands.
117. (a) Where a notice is sent by post, service of the notice shall be deemed to be effected by properly addressing,
pre-paying and posting a letter containing the notice, and to have been effected at the expiration of sixty hours after the
letter containing the same is posted as aforesaid.
(b) Where a notice is sent by cable, telex, or telecopy, service of the notice shall be deemed to be effected by
properly addressing, and sending such notice through a transmitting organisation and to have been effected on the day
the same is sent as aforesaid.
118. A notice may be given by the Company to the joint holders of record of a share by giving the notice to the joint
holder first named on the register of Members in respect of the share.
119. A notice may be given by the Company to the person or persons which the Company has been advised are
entitled to a share or shares in consequence of the death or bankruptcy of a Member by sending it through the post as
aforesaid in a pre-paid letter addressed to them by name, or by the title of representatives of the deceased, or trustee
of the bankrupt, or by any like description at the address supplied for that purpose by the persons claiming to be so
entitled, or at the option of the Company by giving the notice in any manner in which the same might have been given if
the death or bankruptcy had not occurred.
120. Notice of every general meeting shall be given in any manner hereinbefore authorised to:
(a) every person shown as a Member in the register of Members as of the record date for such meeting except that
in the case of joint holders the notice shall be sufficient if given to the joint holder first named in the register of Members;
and
(b) every person upon whom the ownership of a share devolves by reason of his being a legal personal representative
or a trustee in bankruptcy of a Member of record where the Member of record but for his death or bankruptcy would
be entitled to receive notice of the meeting.
No other person shall be entitled to receive notices of general meetings.
Winding up
121. If the Company shall be wound up the liquidator may, with the sanction of a Special Resolution of the Company
and any other sanction required by the Statute, divide amongst the Members in specie or kind the whole or any part of
the assets of the Company (whether they shall consist of property of the same kind or not) and may for such purpose
set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall
be carried out as between the Members or different classes of Members. The liquidator may with the like sanction, vest
the whole or any part of such assets in trustees upon such trusts for the benefit of the contributories as the liquidator,
with the like sanction, shall think fit, but so that no Member shall be compelled to accept any shares or other securities
whereon there is any liability.
122. If the Company shall be wound up, and the assets available for distribution amongst the Members as such shall
be insufficient to repay the whole of the paid-up capital, such assets shall be distributed so that, as nearly as may be, the
losses shall be borne by the Members in proportion to the capital paid up, or which ought to have been paid up, at the
commencement of the winding up on the shares held by them respectively. And if in a winding up the assets available for
distribution amongst the Members shall be more than sufficient to repay the whole of the capital paid up at the commence-
ment of the winding up, the excess shall be distributed amongst the Members in proportion to the capital paid up at the
commencement of the winding up on the shares held by them respectively. This Article is to be without prejudice to the
rights of the holders of shares issued upon special terms and conditions.
Indemnity
123. The Directors and officers for the time being of the Company and any trustee for the time being acting in relation
to any of the affairs of the Company and their heirs, executors, administrators and personal representatives respectively
shall be indemnified out of the assets of the Company from and against all actions, proceedings, costs, charges, losses,
damages and expenses which they or any of them shall or may incur or sustain by reason of any act done or omitted in
or about the execution of their duty in their respective offices or trusts, except such (if any) as they shall incur or sustain
by or through their own wilful neglect or default respectively and no such Director, officer or trustee shall be
answerable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other Director, officer or trustee or for joining in any
receipt for the sake of conformity or for the solvency or honesty of any banker or other persons with whom any monies
or effects belonging to the Company may be lodged or deposited for safe custody or for any insufficiency of any security
upon which any monies of the Company may be invested or for any other loss or damage due to any such cause as
aforesaid or which may happen in or about the execution of his office or trust unless the same shall happen through the
wilful neglect or default of such Director, Officer or trustee.
Financial year
124. Unless the Directors otherwise prescribe, the financial year of the Company shall end on 31st January in each
year and, following the year of incorporation, shall begin on 1st February in each year.
Amendments of articles
125. Subject to the Statute, the Company may, at any time and from time to time by Special Resolution, alter or
amend these Articles in whole or in part.
15838
Transfer by way of continuation
126. If the Company is exempted as defined in the Statute, it shall, subject to the provisions of the Statute and with
the approval of a Special Resolution, have the power to register by way of continuation as a body corporate under the
laws of any jurisdiction outside the Cayman Islands and to be deregistered in the Cayman Islands.
Grand Cayman, 19 February 1999.
Certified as true and correct copy of the original
<i>For and on behalf of MAPLES AND CALDERi>
Signature
Dated 22nd day of January 1999.
H. Smith
<i>Attorney-at-Lawi>
J. Fowler
<i>Attorney-at-Lawi>
Signature
<i>Witness to the above signaturesi>
I, Anthony Ian Goddard, Assistant Registrar of Companies in and for the Cayman Islands hereby certify that this is a
true and correct copy of the Articles of Association of this Company duly incorporated on the 22nd day of January 1999.
A. Goddard
<i>Assistant Registrar of Companiesi>
NOTICE
Déposée en exécution des articles 80 et 161 de la loi du 23 novembre 1972 portant adaptation de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales à l’occasion de l’introduction en Bourse de Luxembourg d’un emprunt
obligataire de EUR 150.000.000,- à un taux d’intérêt flottant «Secured Amortising Notes» émis par ARIES FUNDING
CORPORATION II échéant en 2003.
I. Constitution
ARIES FUNDING CORPORATION (ci-après dénommée la société) a été constituée le 22 janvier 1999 sous le
régime des lois des Iles Caymans. Son siège social est établi à P.O. Box 309, Ugland House, George Town, Grand
Cayman, Cayman lslands, British West Indies.
II. Durée
Les statuts de la société ne prévoient aucune limitation de sa durée.
III. Objet social
Conformément aux dispositions de ses statuts, le cadre d’activité de la société ne dépasse et ne dépassera pas celui
décrit dans les termes et conditions de l’emprunt. Les statuts de la société sont déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg où toute personne intéressée peut en prendre connaissance et en obtenir, même par corres-
pondance, copie intégrale.
IV. Capital social
Il y a 1.000 actions ordinaires émises et entièrement libérées d’une valeur de USD 1,- chacune (pour un total de USD
1.000,-).
V. Administration et Surveillance
A. Conseil d’administration
Les directeurs sont:
- Anthony Baker
- Philip Hinds
- Helen Allen
- Martin Couch
Excepté le fait d’agir en tant que directeurs dans d’autres sociétés des Iles Caymans, les directeurs n’ont pas d’activités
annexes significatives.
L’adresse du bureau administratif se trouve à c/o Queensgate SPV SERVICES LIMITED à P.O. Box 1093 GT, Compass
Centre, Crewe Road, Grand Cayman, Cayman Islands.
La société n’a pas d’organes de surveillance.
VI. Emprunts obligataires
A la date de la cotation, l’endettement de la société (les données étant ajustées afin de refléter l’émission du présent
emprunt) se présentait comme suit:
At the Issue Date, the capitalisation of the Note Issuer, after giving effect to the issue of the Notes, will be as follows:
Equity
lssued and fully paid 1,000 ordinary shares of USD 1 each …………………………………………………………………
USD
1,000
Total Equity: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
USD 1,000
Debt Capital
Notes…………………………………………………………………………………………………………………………
EUR 150,000,000
Total Capitalisation: ………………………………………………………………………………………………
EUR 150,000,000 and USD 1,000
15839
VII. Principales modalités de l’emprunt
1. Montant
EUR 150.000.000,- (représenté par 1.500 coupures au porteur de EUR 100.000,- chacune).
2. Durée
4 ans (échéance finale en Février 2003).
3. Prix d’émission
Les obligations sont émises à 100 % de leur valeur nominale.
4. Jouissance
Les obligations porteront intérêt à partir du 25 février 1999.
5. Intérêts
Le premier paiement se fera en avril 1999.
Les intérêts seront payables mensuellement tous les 6 de chaque mois.
Le taux d’intérêt est un taux d’intérêt flottant (1 mois EURIBOR).
6. Remboursement
La société s’engage à rembourser les obligations au pair de leur valeur à la date de paiement des intérêts tombant en
février 2003.
7. Remboursement anticipé
Prévu au pair pour la totalité de l’emprunt en cas de modification du régime fiscal régissant le présent emprunt.
8. Prescription
Les obligations et les coupons se prescrivent respectivement 10 ans ou 5 ans après la date à laquelle elles ou ils
deviennent remboursables ou payables.
9. Avis aux obligataires
Tous les avis à l’adresse des obligataires seront valides si publiés dans un quotidien de grande circulation (le Financial
Times à Londres et Luxemburger Wort à Luxembourg).
10. Cotation
L’admission des obligations à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg a été demandée.
11. Service financier
Le service financier sera assuré au Grand-Duché de Luxembourg par CHASE MANHATTAN BANK LUXEMBOURG
S.A.
VIII. Bilan et compte de pertes et profits
Depuis la date de constitution de la société, l’émetteur des obligations n’y a pas préparé d’états financiers. Il n’est pas
requis par les lois des Iles Caymans d’en préparer et il n’a pas l’intention d’en publier.
Luxembourg, le 23 février 1999.
The INDUSTRIAL BANK OF JAPAN
<i>Pour ARIES FUNDING CORPORATION IIi>
S. Fujiyoshi
<i>Assistant Manageri>
Enregistré à Luxembourg, le 24 février 1999, vol. 520, fol. 19, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(10387/999/940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 1999.
POLYGRAM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxemburg, 11A, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 31.293.
Constituée sous la dénomination de POLYGRAM FINANCE (LUXEMBOURG) S.A. en date du 8 août 1989 par-devant
M
e
Camille Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de M
e
Marc Elter, alors de
résidence à Luxembourg, acte publié au Mémorial C, n° 1 du 2 janvier 1990, modifiée par-devant M
e
Marc Elter,
préqualifié, en date du 8 mars 1991, acte publié au Mémorial C, n° 322 du 16 août 1991; modifiée par-devant M
e
Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 4 décembre 1996, acte publié au Mémorial C, n° 124
du 14 mars 1997.
—
Le bilan au 31 décembre 1997, enregistré à Luxembourg, le 16 février 1999, vol. 519, fol. 85, case 12, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour POLYGRAM S.A.i>
KPMG FINANCIAL ENGINEERING
Signature
(10263/528/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 1999.
15840
S O M M A I R E
ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND
ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND
ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND
ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND
EURO-INVENTEUR
EUROPART
EURO TELECOM
EX LIBRIS S.A.
EX LIBRIS S.A.
EX LIBRIS LUXEMBOURG S.A.
EX LIBRIS LUXEMBOURG S.A.
FARMA TRADING
FARMA TRADING
FELBRIGG
FELT
FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG S.A.
FLOUR S.A.
FLOUR S.A.
FOREX TRADING GROUP LUXEMBOURG S.A.
FINANCIERE CONCORDE S.A.
FRITURE DE LA MOSELLE
FINANCIAL ASSETS LUXEMBOURG
F.T.A. CONSULTING AND TRADING
GELLET INVEST S.A.
G.F. CONSULTANT
N. FOLSCHETTE
N. FOLSCHETTE
GENERAL VENTURE CAPITAL III HOLDING S.A.
GRAMANO HOLDING S.A.
GOODING CONSUMER ELECTRONICS LUXEMBOURG S.A.
GLOBAL CAR CONSULTING
GREENWOOD S.A.
GS RE
GREENPINE S.A.
GREENPINE S.A.
HEALTHFINANCE S.A.
GUMMI-ROLLER
GUMMI-ROLLER
GUMMI-ROLLER
GUMMI-ROLLER
GROUPE COFILUX COMPAGNIE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE S.A.
GUAPO S.A.
HAMEL HOLDING S.A.
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
HENNEAUX LUXEMBOURG S.A.
CITADEL ADMINISTRATION S.A.
I.C. PRODUCTIONS
IMMOBILIERE SCHEFFEN
INTERNATIONAL CREDIT MUTUEL LIFE S.A.
INTERNATIONAL FOOD INVEST S.A.
IMMOBAT
IMMOCO
INTERPARCO HOLDING S.A.
INTERNATIONAL TELECOM
I.T.U.
IXWORTH
KODEMAC
J.S.G.B. HOLDING S.A.
KERVERNE
Capital souscrit: LUF 500.000
LE NOUVEAU CHEZ NOUS
LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEIN GIROZENTRALE.
LE RUN
KWIZDA FINANZ A.G.
KWIZDA FINANZ A.G.
LE GRAND S.A.
LE GRAND S.A.
LOTAKS S.A.
LUXGESTION
LUXSOL
MALDEN S.A.
MALDEN S.A.
MAHIFA INVESTMENTS S.A.
MAHIFA INVESTMENTS S.A.
MA.LO S.A.
LETO HOLDING S.A.
MAPOM S.A.
MAPOM S.A.
MASTERS TRADING GROUP S.A.
MGM COMMERCE S.A.
MAROWINIA HOLDING S.A.
MAXIWEB S.A.
MEDICAL SERVICES PARTICIPATIONS S.A.
MEDAFIN S.A.
MEDAFIN S.A.
M.H.R. TRADING COMPANY
M.H.R. TRADING COMPANY
M.H.R. TRADING COMPANY
MEDINGER NORBERT
M.M. Warburg-LuxInvest S.A.
MOLSHI S.A.
MULFIN S.A.
M.P.H. PARTICIPATION S.A.
M.P. INTERNATIONALE S.A.
MONTANTE HOLDING S.A.
MONTANTE HOLDING S.A.
MULTI FINANCE S.A.
MULTI FINANCE S.A.
NEW ENTERPRISES S.A.
MULTI-HOUSE S.A.
MULTI-HOUSE S.A.
NEW STYLE HAIRDRESSER
PNEUS MRECHES
PNEUS MRECHES
NIKKO EUROPE
Capital Social: LUF 14.847.000.
POLYGRAM HOLDING LUXEMBOURG S.A.
OCARINA S.A.
OCARINA S.A.
NORTH ATLANTIC FISHERY INVESTMENTS S.A.
OLDIE FM S.A.
OMNIS GEFIBAT S.A.
OPTIMED
OTI HOLDING S.A.
PART HOTEL S.A.
PART HOTEL S.A.
PHARMINVEST S.A.
PK INTERTRADING
ARIES FUNDING CORPORATION II.
POLYGRAM S.A.