logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

433

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 10

13 janvier 1997

S O M M A I R E

Anite Systems Limited, Luxembourg………………

page

439

A.S.B. S.A., Strassen ………………………………………………………………

435

Astrobal, Sicav, Luxembourg ……………………………………………

435

Bagrat-Lux, S.à r.l., Roodt-sur-Syre…………………………………

437

BCH Horizons, Fonds Commun de Placement …………

453

Beim Franco, S.à r.l., Senningerberg ………………… 435,

436

BIL Luxpart, Sicav, Luxembourg ………………………………………

480

B.I.S., Bureau Immobilier du Sud, S.à r.l., Esch-sur-

Alzette ………………………………………………………………………………………

438

BMS Group S.A., Luxembourg …………………………………………

437

Bolux, Sicav, Luxembourg ……………………………………………………

438

Bord de Mer I S.A., Luxembourg………………………………………

444

Bord de Mer II S.A., Luxembourg ……………………………………

445

Businesstalk S.A., Luxembourg …………………………………………

438

Callander  Granville  Euromanagement  Fund  S.A.,

Luxembourg …………………………………………………………………………

439

Cariek S.A., Luxembourg ……………………………………………………

439

Central Hispano Gestion Luxembourg S.A., Luxem-

bourg …………………………………………………………………………………………

446

CFE S.A., Luxembourg …………………………………………………………

440

C.K. S.A., Steinfort …………………………………………………………………

444

Cleantec, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

444

COMINHOLDING, Compagnie Internationale Hol-

ding S.A., Luxembourg ……………………………………………………

438

Comptoir Anti-Feu Luxembourg S.A., Rodange ………

440

Comura S.A., Luxembourg …………………………………………………

440

Condor Lux Roadcargo, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……

441

Consortium Financier Africain S.A., Luxembourg……

442

Construction Nico Maréchal, S.à r.l., Kopstal ……………

444

Courierdienst Wilde, S.à r.l., Luxembourg …………………

445

Deconen S.A., Senningerberg ……………………………………………

445

Degner Malermeister, GmbH, Moutfort ………………………

445

Development Holding Company S.A., Luxembourg

446

Eptalux S.A., Luxembourg……………………………………………………

434

Events & Business Catering S.A., Luxembourg …………

437

Finanzplan International S.A., Machtum ………………………

443

Finsaturne S.A.H., Luxembourg ………………………………………

446

Fougères, S.à r.l., Roodt ………………………………………………………

442

Foxitec S.A., Luxembourg ……………………………………… 440,

441

Gad Holding S.A., Luxembourg…………………………………………

443

Gansen, GmbH, Lellig ……………………………………………………………

467

Garbuio International Holding S.A., Luxembg 466,

467

Gefa S.A., Luxembourg …………………………………………………………

467

Générale de Distribution S.A., Luxembourg ………………

466

G-Equity Fund, Sicav, Luxembourg …………………………………

480

Gérance Internationale de Fonds S.A., Luxembourg

466

Gessalux, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………

466

Gestion Financière International S.A., Luxembourg

443

Gope, S.à r.l., Luxembourg …………………………………………………

469

Greenback Holdings S.A., Strassen …………………………………

466

Gruppo Oria International S.A., Luxembourg

434,

465

GT Deutschland Fund, Sicav, Luxembourg …………………

469

Hawk Finance S.A., Luxembourg ………………………… 467,

468

Herse, S.à r.l., Luxembourg…………………………………………………

468

Incommerce S.A., Esch-sur-Alzette ………………………………

463

Indican Holding S.A., Luxembourg ……………………… 464,

465

Iteractusvia S.A., Luxembourg …………………………………………

471

Kidgam, S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………

434

Kühne und Nagel, Spedition, GmbH, Contern …………

476

Lamort Investissements S.A., Luxembourg ………………

434

Maître Mesure, S.à r.l., Luxembourg ………………………………

469

Merchbanc, Sicav, Luxembourg…………………………………………

479

Misty Fjords S.A., Luxembourg …………………………………………

473

Motwit S.A., Luxembourg ……………………………………………………

479

Pelleas S.A., Luxembourg ……………………………………………………

480

Radiocom S.A., Luxembourg………………………………………………

478

Safei Invest, Sicav ……………………………………………………………………

478

Tower Holdings S.A., Luxembourg …………………………………

479

KIDGAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 14, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 48.163.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 9 octobre 1996

S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société sous rubrique:
1. Monsieur Olivier Carlo, directeur financier, demeurant à I-05100 Terni, Vocabolo Collestacio 23, Gabelletta di

Cesi,

2. Madame Sylvie Pauchet, commerçante, demeurant à L-1660 Luxembourg, 56, Grand-rue,
agissant en leur qualité d’associés uniques de la prédite société ont pris en assemblée générale extraordinaire de la

société la résolution suivante:

<i>Résolution

Le siège social est transféré du  56, Grand-rue au 14, Grand-rue à Luxembourg.
Fait à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.

O. Carlo

S. Pauchet

Enregistré à Redange-sur-Attert, le 15 octobre 1996, vol. 142, fol. 43, case 5. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur ff. (signé): Signature.

(38798/237/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1996.

LAMORT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 43.420.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1

<i>er

<i>octobre 1996

– Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxem-

bourg, 50, route d’Esch.

– BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg a été

nommée au poste de commissaire aux comptes de la société en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA
COMMUNAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l’assemblée générale
annuelle qui se tiendra en 1999.

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour extrait conforme

<i>Pour la société

Signature

<i>Un mandataire

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1996, vol. 486, fol. 11, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38799/595/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 novembre 1996.

EPTALUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.

R. C. Luxembourg B 49.354.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 19, case 8,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

<i>EPTALUX S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(38881/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

GRUPPO ORIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 29.998.

Les comptes annuels au 31 décembre 1992, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 18, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

<i>Pour la S.A. GROUPPO ORIA

<i>INTERNATIONAL

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.c.

(38897/503/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

434

A.S.B. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 46.298.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 juillet 1995

Il résulte dudit procès-verbal que décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux

comptes de toute responsabilité résultant de l’exercice de leurs fonctions.

Le mandat de -

Mademoiselle Michèle Moes
Monsieur Carlo Bisenius
Monsieur Patrick Happe

en tant qu’administrateurs et celui de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés

pour un terme d’une année jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 20 juillet 1995.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38860/614/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

ASTROBAL, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 24.964.

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 21 août 1996

Monsieur Marc Moles le Bailly a été coopté Administrateur, en remplacement de Monsieur Jean-Louis Luyckx, démis-

sionnaire.

<i>La composition du Conseil d’Administration est dorénavant la suivante:

MM. Peter De Proft

Président

Juan de Callataÿ
Antoine Calvisi
Aymon Detroch
Philippe Druart
Marc Moles le Bailly
Robert Reckinger

<i>Le Conseil d’Administration

Réquisition aux fins d’inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38861/007/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

BEIM FRANCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 86, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 31.754.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt et un octobre.
Par-devant Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie.

Ont comparu:

1.- Monsieur Francesco Di Lauro, commerçant, demeurant à Foetz, rue du Brill;
2.- Monsieur Felice Salvia, garçon de restaurant, demeurant à Senningerberg, 86, route de Trèves;
3.- Monsieur Patrick Palma, cuisinier, demeurant à Luxembourg, 64, rue de Bourgogne.
Ces comparants ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
I.- Les comparants sub 1. et 2. sont les seuls associés de la société BEIM FRANCO, société à responsabilité limitée,

avec siège social à Senningerberg, 86, route de Trèves, constituée sous la dénomination BEIM FRANCO A CARMEN,
société à responsabilité limitée, suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 3 octobre 1989, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 65 du 28 février 1990, modifiée suivant deux actes reçus par le
notaire soussigné, le 1

er

août 1995, publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 529 du 16

octobre 1995, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 11 janvier 1996, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 177 du 9 avril 1996, modifiée suivant acte reçu par le notaire soussigné, le 15 février
1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 222 du 3 mai 1996, et modifiée suivant acte
reçu par le notaire soussigné, le 10 avril 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 313
du 27 juin 1996,

immatriculée au registre de commerce de Luxembourg sous la section B et le numéro 31.754.
II.- Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500) parts

sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune, entièrement souscrites et libérées et appartenant aux associés, comme
suit:

435

1) Monsieur Francesco Di Lauro, préqualifié, quatre cent soixante-cinq parts sociales …………………………………………

465

2) Monsieur Felice Salvia, préqualifié, trente-cinq parts sociales……………………………………………………………………………………

   35

Total: cinq cents parts sociales………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

III.- Monsieur Francesco Di Lauro, préqualifié, déclare par les présentes céder et transporter, sous les garanties

ordinaires de fait et de droit, trente-cinq (35) parts sociales de la société dont il s’agit à Monsieur Patrick Palma, préqua-
lifié, qui accepte, moyennant le prix global de deux millions cent mille francs (frs. 2.100.000,-), somme que le cédant
reconnaît avoir reçue du cessionnaire au moment de la signature des présentes, ce dont bonne et valable quittance.

IV.- Le cessionnaire se trouve subrogé dans tous les droits et obligations attachés aux parts cédées à partir de ce jour.
Le cessionnaire participera aux bénéfices à partir de ce jour.
Le cessionnaire déclare parfaitement connaître les statuts et la situation financière de la société et renonce à toute

garantie de la part du cédant.

V.- Monsieur Felice Salvia, préqualifié, agissant en sa qualité d’associé, déclare expressément renoncer à son droit de

préemption, approuver la susdite cession de parts sociales et accepter Monsieur Patrick Palma, préqualifié, comme
nouvel associé.

VI.- Monsieur Francesco Di Lauro, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant de la société, déclare se tenir, au nom

de la société, la susdite cession de parts sociales comme dûment signifiée.

VII.- Ensuite les associés représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en assemblée générale extraordi-

naire à laquelle ils se considèrent comme dûment convoqués et, à l’unanimité des voix, ils prennent les résolutions
suivantes:

<i>Première résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la cession de parts qui précède, les associés décident de modifier

l’article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de cinq cent mille francs (frs. 500.000,-), représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille francs (frs. 1.000,-) chacune.

Ces parts sociales sont réparties comme suit:
1.- Monsieur Francesco Di Lauro, commerçant, demeurant à Foetz, rue du Brill, quatre cent trente parts

sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

430

2.- Monsieur Felice Salvia, garçon de restaurant, demeurant à Senningerberg, 86, route de Trèves, trente-cinq

parts sociales……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

35

3.- Monsieur Patrick Palma, cuisinier, demeurant à Luxembourg, 64, rue de Bourgogne, trente-cinq parts

sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

   35

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Toutes les parts sociales sont entièrement souscrites et libérées.»

<i>Deuxième résolution

Les associés décident de confirmer Monsieur Francesco Di Lauro, préqualifié, en ses fonctions de gérant technique et

administratif de la société et de nommer Monsieur Patrick Palma, préqualifié, comme gérant technique pour la branche
hôtelière.

La société se trouve engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant technique et administratif,

Monsieur Francesco Di Lauro, préqualifié, à l’exception des opérations concernant la branche hôtelière, pour lesquelles
opérations la cosignature du gérant de cette branche, Monsieur Patrick Palma, préqualifié, est requise.

VIII.- Les frais, rémunérations et charges en raison des présentes, estimés sans nul préjudice à la somme de cinquante-

deux mille francs (frs. 52.000,-), sont à la charge de la société qui s’y oblige, tous les associés en étant solidairement tenus
envers le notaire.

IX.- Les associés élisent domicile au siège de la société.
Dont acte, fait et passé, date qu’en tête des présentes à Luxembourg-Bonnevoie en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée dans une langue d’eux connue aux comparants, connus du notaire

instrumentant par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, tous ont signé le présent acte avec Nous, notaire.

Signé: F. Di Lauro, F. Salvia, P. Palma, Tom Metzler.
Enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1996, vol. 93S, fol. 92, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg-Bonnevoie, le 30 octobre 1996.

T. Metzler.

(38863/222/83)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

BEIM FRANCO, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 86, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 31.754.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg-Bonnevoie, le 30 octobre 1996.

T. Metzler.

(38864/222/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

436

BAGRAT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 5, rue Haupeschhaff.

R. C. Luxembourg B 44.872.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 18, case 5,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

<i>Pour la S.à r.l. BAGRAT-LUX

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.C.

(38862/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

BMS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 36.311.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 17, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

(38865/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

BMS GROUP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1225 Luxembourg, 4, rue Béatrix de Bourbon.

R. C. Luxembourg B 36.311.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 21 octobre 1996

Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité

résultant de l’exercice de leurs fonctions.

- Le mandat de Maître Marc Theisen, Maître Pierrot Schiltz et Maître Henri Becker en tant qu’administrateurs et celui

de Monsieur Lex Benoy en tant que commissaire aux comptes ont été renouvelés pour un terme d’une année, jusqu’à
la prochaine assemblée générale ordinaire.

Luxembourg, le 21 octobre 1996.

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 17, case 8. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38866/614/17)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

EVENTS &amp; BUSINESS CATERING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1253 Luxembourg, 2, rue Nicolas Bové.

R. C. Luxembourg B 54.096.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 septembre 1996

<i>Nomination de nouveaux Administrateurs

L’Assemblée Générale a décidé de révoquer les Administrateurs suivants:
- Monsieur Jean-Luc Aschbacher, Cuisinier, demeurant à Grevenmacher;
- Monsieur Ionnis Cosmadakis, Chirurgien, demeurant à Mannheim.
En remplacement des deux Administrateurs révoqués, l’Assemblée Générale a décidé de nommer deux nouveaux

Administrateurs et ce, avec effet immédiat:

- Monsieur Didier Bode, Cuisinier, demeurant à Reisdorf;
- Monsieur Jimmy De Brabant, Directeur, demeurant à Luxembourg.
Le mandat des Administrateurs prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les

comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2000.

<i>Nomination d’un Administrateur-Délégué

Par décision prise par l’Assemblée Générale, Monsieur Didier Bode, Cuisinier, demeurant à Reisdorf, a été nommé

Administrateur-délégué avec pouvoir d’engager la société par sa signature individuelle en toute circonstance.

Luxembourg, le 16 septembre 1996.

Signatures.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(38882/720/23)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

437

BOLUX, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg  33.507.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 juillet 1996

Monsieur Antoine Calvisi a été nommé Administrateur.

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 16 septembre 1996

Monsieur François Hottinger a été nommé Président du Conseil d’Administration.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée Générale Ordinaire du 16 septembre 1996

Monsieur Jean-Conrad Hottinger a été nommé Administrateur.

<i>Composition du Conseil d’Administration

MM. François Hottinger Président

Antoine Calvisi
Olivier Heckenroth
Emmanuel Hottinger
Jean-Conrad Hottinger
Alain Peytral
Arnaud de Rouge

Madame Christine de Froment.

<i>Le Conseil d’Administration

Pour réquisition aux fins d’inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38867/007/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

B.I.S., BUREAU IMMOBILIER DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: Esch-sur-Alzette.

R. C. Luxembourg B 26.589.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Esch-sur-Alzette, le 18 octobre 1996, vol. 304, fol. 56, case 1, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 1996.

FIDUCIAIRE VIC COLLE &amp; ASSOCIES, S.à r.l.

Signature

(38868/612/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

BUSINESSTALK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2141 Luxembourg, 11, rue Emile Mayrisch.

R. C. Luxembourg B 37.932.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 17, case 8, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

(38869/614/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

COMINHOLDING, COMPAGNIE INTERNATIONALE HOLDING, Société Anonyme.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 16.404.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 19, case 7, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

AFFECTATION DU RESULTAT

Résultat de l’exercice ………………………………………………………… LUF 160.814.742,-
Affectation à la réserve légale…………………………………………… LUF

(5.837.048,-)

Dividende ……………………………………………………………………………… LUF   (10.000.000,-)
Report à nouveau………………………………………………………………… LUF 144.977.694,-

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Signature.

(38873/507/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

438

CALLANDER GRANVILLE EUROMANAGEMENT FUND, Société Anonyme

d’Investissement à Capital Fixe.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 103, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 26.512.

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 30 août 1996

CREDIET &amp; EFFECTENBANK N.V., représenté par Monsieur Pieter Jan Maria Van den Brink, a été coopté Adminis-

trateur, en remplacement de Monsieur John D. Th. Leenders, démissionnaire.

<i>Extrait des délibérations du Conseil d’Administration du 27 septembre 1996

Monsieur Charles Soulignac a été coopté Administrateur en remplacement de la COMPAGNIE FINANCIERE

GAMMA, démissionnaire.

<i>Extrait des délibérations de l’Assemblée générale du 30 septembre 1996

<i>Composition du Conseil d’Administration

MM. Hugues Lasseron

Chairman

Claude H. Cellier
Arthur de la Grandière
Regnier Haegelsteen
Arnaud Isnard
Peter Laszlo
Nicholas Moy
George Ortiz
Robert Reckinger
Charles Soulignac
Francis Tancrede

CREDIET &amp; EFFECTENBANK N.V.

représenté par M. Pieter Jan Maria Van den Brink

DS STRATEGEM MANAGEMENT SERVICES A.G.

représenté par M. David B. Kellermann

SWISS CANTOBANK (INTERNATIONAL)

représenté par M. Roland Staehli.

<i>Le Conseil d’Administration

Pour réquisition aux fins d’inscription au Mémorial et au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 20, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38870/007/36)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

ANITE SYSTEMS Limited,

(anc. CRAY SYSTEMS Limited).

Succursale au Grand-Duché de Luxembourg.

Capital social: GBP 2.242.214.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 151, rue des Muguets.

La nouvelle raison sociale est comme suit:
ANITE SYSTEMS Limited.

<i>Pour extrait conforme

FIDUCIAIRE SASSEL &amp; ZIMMER S.C.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 24 octobre 1996, vol. 485, fol. 92, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38878/000/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

CARIEK S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, Imacorp Business Centre, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 34.720.

Le bilan au 31 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 21, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

IMACORP S.A.

Signature

(38871/700/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

439

CFE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, Imacorp Business Centre, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 48.014.

Le bilan au 30 juin 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 21, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

IMACORP S.A.

Signature

(38872/700/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

COMPTOIR ANTI-FEU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4815 Rodange, 19A, route de la Fontaine.

R. C. Luxembourg B 45.071.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 4, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

LUXCOMPTA, S.à r.l.

Signature

(38874/679/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

COMURA S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 11, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 44.193.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, tels qu’approuvés par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires et

enregistrés à Luxembourg, le 28 octobre 1996, vol. 485, fol. 100, case 7, ont été déposés au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue à Luxembourg, le 13 septembre 1996

L’assemblée décide de renouveler le mandat des trois administrateurs suivants:
MM. Christian Gary

Henri Chatillon
Jean-Paul Ribert

et élit comme nouvel administrateur:
Monsieur Charles Besnehard en remplacement de Monsieur Leslie S. Doyle décédé. Leur mandat prendra fin à l’issue

de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social 1998.

L’assemblée décide, conformément aux dispositions de l’article 100 de la loi modifiée du 6 décembre 1991, de

nommer réviseur indépendant de la société

DELOITTE &amp; TOUCHE LUXEMBOURG, S.à r.l.
3, route d’Arlon
L-8009 Strassen
dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice social

1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

<i>Pour COMURA S.A.

Signature

(38875/267/27)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

FOXITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.276.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 4 avril 1996, le mandat des administrateurs, MM. Guy Baumann, Jean

Bodoni et Laurent Huss ainsi que celui du commissaire aux comptes, Mme Myriam Spiroux-Jacoby, ont été renouvelés
pour une durée de six ans, expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2002.

Luxembourg, le 31 octobre 1996.

<i>Pour FOXITEC S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38889/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

440

FOXITEC S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 35.276.

Par décision de l’assemblée générale ordinaire du 6 avril 1995, Monsieur Laurent Huss, fondé de pouvoir principal, 

L-Kehlen, a été appelé aux fonctions d’administrateur en remplacement de Mme Luisella Moreschi. Son mandat
s’achèvera avec ceux de ses collègues à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1996.

Luxembourg, le 31 octobre 1996.

<i>Pour FOXITEC S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38890/006/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

CONDOR LUX ROADCARGO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-4222 Esch-sur-Alzette, 214, route de Luxembourg.

<i>Aussergewöhnliche Generalversammlung der CONDOR LUX ROADCARGO, S.à r.l. vom 20. September 1996

zwischen den Unterzeichneten:
A1

MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg)
hier vertreten durch Herrn Kralowetz jun. …………………………………………………………………………………………………… 93 Anteile

einerseits und
B1

Horak Milan, wohnhaft in CZ-Pacice

B2

Svoboda Josef, wohnhaft in CZ-Budweis

B3

Freivolt Marian, wohnhaft in CZ-Roznava

B4

Hitka Ignac, wohnhaft in SK-Nitra

B5

Dado Pavel, wohnhaft in CZ-Banska Bystrica

B6

Dado Ladislav, wohnhaft in SK-Zvolen

B7

Sivon Peter, wohnhaft in CZ-Prachatice

B8

Nagy Anton, wohnhaft in SK-Komarno

B9

Toth Karel, wohnhaft in H-Tököl

B10 Miso Jiri, wohnhaft in CZ-Novy Jicin
B11 Kantor Robert, wohnhaft in Sk-Nove Zamky
B12 Mordac Igor, wohnhaft in SK-Dun-Streda
wurde unter einstimmigem Beschluß folgende Abmachung getroffen:
MEDICON S.A.H., vorgenannt unter A1 überträgt an
B1

Horak Milan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B2

Svoboda Josef, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B3

Freivolt Marian, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B4

Hitka Ignac, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B5

Dado Pavel, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B6

Dado Ladislav, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B7

Sivon Peter, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B8

Nagy Anton, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B9

Toth Karel, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B10 Miso Jiri, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B11 Kantor Robert, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B12 Mordac Igor, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

welche annehmen und worüber gleichzeitig Quittung erstellt ist, betreffend das vereinbarte Entgeld
abzüglich Abtretungen an MEDICON S.A.H. der Herren
D1 Kubovic Jan, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D2 Sadovsky Eduard, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D3 Jehlar Ivan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D4 Babka Zdenko, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D5 Kosicky Vladimir, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D6 Ham Ernest, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D7 Urban Karel, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D8 Kouky Vladimir, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D9 Bagoci Jozef, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D10 Csivre Vincent, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D11 Obona Josef, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D12 Jirka Jiran, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D13 Matiasko Lubos, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil
D14 Kriz Bohuslav, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -1 Anteil

441

Die Anteile sind wie folgt zugeteilt:
A1

MEDICON S.A.H., mit Sitz in Esch an der Alzette (Luxemburg)
hier vertreten durch Herrn Kralowetz jun. …………………………………………………………………………………………………… 81 Anteile

B1

Horak Milan, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B2

Svoboda Josef, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B3

Freivolt Marian, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B4

Hitka Ignac, vorgenannt……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B5

Dado Pavel, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B6

Dado Ladislav, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B7

Sivon Peter, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B8

Nagy Anton, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B9

Toth Karel, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B10 Miso Jiri, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B11 Kantor Robert, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

B12 Mordac Igor, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………………………

1 Anteil

C1

Kralowetz Martin, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………… 2 Anteile

C2

Zvalo Jozef, vorgenannt…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 Anteile

C3

Kunes Pavel, vorgenannt ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 Anteil

C4

Hrabacek Frantisek, vorgenannt …………………………………………………………………………………………………………………………… 1 Anteil

C5

Becka Emil, vorgenannt ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  1 Anteil  

100 Anteile

<i>Die Versammlung ernennt einstimmig die Herren

B1

Horak Milan, vorgenannt

B2

Svoboda Josef, vorgenannt

B3

Freivolt Marian, vorgenannt

B4

Hitka Ignac, vorgenannt

B5

Dado Pavel, vorgenannt

B6

Dado Ladislav, vorgenannt

B7

Sivon Peter, vorgenannt

B8

Nagy Anton, vorgenannt

B9

Toth Karel, vorgenannt

B10 Miso Jiri, vorgenannt
B11 Kantor Robert, vorgenannt
B12 Mordac Igor, vorgenannt
als administrative Geschäftsführer und Herrn Martin Kralowetz als technischen Geschäftsführer.
Jeder administrative Geschäftsführer kann die Gesellschaft nur in Verbindung mit der Unterschrift von Herrn Karl

Kralowetz jun. verpflichten.

Herr Karl Kralowetz jun. kann die Gesellschaft mit seiner alleinigen Unterschrift in unbeschränkter Höhe

verpflichten.

Es folgen 12 Unterschriften.

Unterschriften.

Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 22 octobre 1996, vol. 304, fol. 59, case 1/1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): M. Ries.

(38876/000/96)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pétange, le 5 novembre 1996.

G. d’Huart.

(38877/207/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

FOUGÈRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8398 Roodt.

R. C. Luxembourg B 25.217.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1993 et 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 30 octobre 1996,

vol. 486, fol. 10, case 10, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Signature

<i>Le gérant

(38888/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

442

FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6841 Machtum, 13, rue de l’Eglise.

R. C. Luxembourg B 39.737.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 19, case 2,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996. 

<i>Pour FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A.

(38883/720/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-6841 Machtum, 13, rue de l’Eglise.

H. R. Luxemburg B 39.737.

<i>Auszug aus den Beschlüssen der Ordentlichen Generalversammlung vom 7. April 1995

Am siebten April neunzehnhundertfünfundneunzig um elf Uhr haben sich die Aktionäre der Kapitalgesellschaft

FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A. in einer Ordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft in Machtum
versammelt.

Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

<i>Verwendung des Nettogewinns

Die Aktionäre stellen mit Zufriedenheit den Gewinn von 3.186.055,- LUF (Vorjahr: 2.513.891,- LUF) des vergangenen

Geschäftsjahres fest und beschliessen einstimmig den gesamten Gewinn auf des jetzige Geschäftsjahr vorzutragen.

<i>Wahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars

Die Aktionäre bestätigen einstimmig folgende Verwaltungsratsmitglieder für die Dauer eines Jahres:
1. Herrn Detlef Kraus, Obertshausen (D);
2. Herrn Jean Zeimet, Luxemburg;
3. Herrn Adrian de Feijter, Luxemburg.
Zum Kommissar für die Dauer eines Jahres wird die Firma FIDUCIAIRE ET SOCIETE DE GESTION EUROPEENNE

S.A., mit Sitz in Luxemburg, 11, avenue de la Liberté, gewählt.

Luxemburg, den 7. April 1995. 

Unterschriften.

Enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 19, case 2. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(38884/720/26)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

GAD HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

Siège social: Luxembourg, 8-10, rue Mathias Hardt.

R. C. Luxembourg B 18.737.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu au siège social

<i>le 15 septembre 1996

- Monsieur René Schmitter, comptable, demeurant à Luxembourg a été nommé comme commissaire à la liquidation:
- la date de l’assemblée de clôture de liquidation a été fixée.
Luxembourg, le 24 octobre 1996.

Signature

<i>Un mandtaire

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 21, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): Signature.

(38891/250/14)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 26.114.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 14 octobre 1996, vol. 485, fol. 50, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 1996.

<i>Pour GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(39247/006/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

443

BORD DE MER I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 48.453.

EXTRAIT

I. Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 octobre 1996 comme suit:
1) Le siège social a été transféré à l’adresse suivante:
82, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
2) En remplacement des précédents administrateurs, le nouveau conseil d’administration est composé comme suit:
1.- Monsieur Ardito Toson, agent d’affaires, demeurant à Luxembourg, administrateur;
2.- Madame Josette Muller, directrice administrative, demeurant à Luxembourg, administrateur;
3.- Madame Carla Alves Silva, attachée de direction, demeurant à Luxembourg, administrateur.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en l’an 2001.
3) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués.
4.- En remplacement du précédent commissaire aux comptes a été nommé comme nouveau commissaire aux

comptes:

Monsieur Fouad Ghozali, économiste, demeurant à Mamer, commissaire aux comptes.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en l’an 2001.
II. Il résulte du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration tenue le 28 octobre 1996 au nouveau siège

social que Monsieur Ardito Toson a été nommé administrateur-délégué.

Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité des voix.

<i>L’institut domiciliataire

COMPTABILITE GENERALE DE LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1996, vol. 486, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38576/553/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

C.K. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8440 Steinfort, 55, route de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 17.312.

Les comptes annuels aux 31 décembre 1995 et 1994, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 5,

case 7, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 1996.

<i>Pour la S.A. C.K.

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.C.

(38585/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

CLEANTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2734 Luxembourg, 47, rue de Wiltz

R. C. Luxembourg B 14.629.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 22 octobre 1996, vol. 485, fol. 82, case 8, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 1996.

<i>Le gérant

Signature

(38586/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

CONSTRUCTION NICO MARECHAL, Société à responsabilité limitée,

Siège social: L-8184 Kopstal, 1A, rue de Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 28.178.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1996, vol. 486, fol. 11, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 octobre 1996.

<i>Pour CONSTRUCTION NICO MARECHAL, S.à r.l.

FIDUCIAIRE DES P.M.E.

Signature

(38587/514/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

444

BORD DE MER II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 82, avenue Victor Hugo.

R. C. Luxembourg B 48.454.

EXTRAIT

I. Il résulte du procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 25 octobre 1996 comme suit:
1) Le siège social a été transféré à l’adresse suivante:
82, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
2) En remplacement des précédents administrateurs, le nouveau conseil d’administration est composé comme suit:
1.- Monsieur Ardito Toson, agent d’affaires, demeurant à Luxembourg, administrateur;
2.- Madame Josette Muller, directrice administrative, demeurant à Luxembourg, administrateur;
3.- Madame Carla Alves Silva, attachée de direction, demeurant à Luxembourg,aadministrateur.
Leur mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en l’an 2001.
3) Le conseil d’administration est autorisé à nommer un ou plusieurs administrateurs-délégués.
4.- En remplacement du précédent commissaire aux comptes a été nommé comme nouveau commissaire aux

comptes:

Monsieur Fouad Ghozali, économiste, demeurant à Mamer, commissaire aux comptes.
Son mandat viendra à échéance lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu en l’an 2001.
II. Il résulte du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration tenue le 28 octobre 1996 au nouveau siège

social que Monsieur Ardito Toson a été nommé administrateur-délégué.

Toutes les résolutions ont été prises à l’unanimité des voix.

<i>L’institut domiciliataire

COMPTABILITE GENERALE DE LUXEMBOURG

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1996, vol. 486, fol. 8, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38577/553/30)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

COURIERDIENST WILDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d’Arlon.

R. C. Luxembourg B 49.465.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 6, case 4, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 octobre 1996.

FIDUCIAIRE FERNAND KARTHEISER &amp; Cie

Signature

(38590/510/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

DECONEN S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6B, route de Trèves.

R. C. Luxembourg B 32.129.

Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 3, case 12, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 1996.

E. Maldifassi

<i>Responsable de la domiciliation

(38595/000/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

DEGNER MALERMEISTER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5330 Moutfort, 79, route de Remich.

R. C. Luxembourg B 51.802.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 5, case 9, ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 octobre 1996.

<i>Pour la GmbH DEGNER

<i>MALERMEISTER

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.C.

(38596/503/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

445

DEVELOPMENT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 5, boulevard de la Foire.

R. C. Luxembourg B 39.044.

EXTRAIT

Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 25 octobre 1996 que Monsieur Thierry

Fleming, licencié en sciences commerciales et financières, demeurant à Mamer, a été nommé comme nouvel adminis-
trateur, en remplacement de l’administrateur démissionnaire.

La nomination de Monsieur Thierry Fleming sera ratifiée lors de la prochaine assemblée. Monsieur Thierry Fleming

terminera le mandat de son prédécesseur.

Luxembourg, le 25 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 29 octobre 1996, vol. 486, fol. 5, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38599/534/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 1996.

FINSATURNE S.A.H., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 41.545.

Il résulte des résolutions de l’Assemblée Générale des Actionnaires en date du 1

er

août 1996 que:

Le terme de trois ans des mandats des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes étant échu, l’Assemblée

nomme à nouveau les Administrateurs et Commissaire sortants jusqu’à la réunion de l’Assemblée Générale statuant sur
le résultat de l’exercice 1997, à savoir:

<i>Administrateurs:

MM. Giancarlo Moroni, Dirigeant de sociétés, demeurant à Rome (Italie);

Franco Pizzuti, Dirigeant de sociétés, demeurant à Rome (Italie);
Giuseppe Natola, Dirigeant de sociétés, demeurant à Rome (Italie).

<i>Commissaire aux comptes:

M. Federico Malorni, Expert-comptablie, demeurant à Rome (Italie).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société

Signatures

<i>Le Domiciliataire

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 21, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38885/058/22)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

CENTRAL HISPANO GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Registered office: L-2132 Luxembourg, 16, avenue Marie-Thérèse.

STATUTES

In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-ninth of November.
Before Us, Maître Edmond Schroeder, notary residing in Luxembourg.

There appeared the following:

1) CENTRAL HISPANO GESTION, S.A., a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office

at 11, Juan Esplandiu, 28007 Madrid (Spain), here represented by Mr Francis Pedrini, Vice-President, residing in Luxem-
bourg, by virtue of a proxy given under private seal;

2) CENTRAL HISPANO HOLDING S.A., a company incorporated under the laws of Spain, having its registered office

at Plaza Canalejas, 1, 28008 Madrid (Spain), here represented by Mr Francis Pedrini, prenamed, by virtue of a proxy given
under private seal.

These proxies, signed by all the appearing persons and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, acting in the above stated capacities, have drawn up the following articles of incorporation of

a company which they declared organized among themselves:

Art. 1.  There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter

issued, a corporation (the «Corporation») in the form of a société anonyme under the denomination of CENTRAL
HISPANO GESTION LUXEMBOURG S.A.

Art. 2.

The Corporation is established for an unlimited duration. It may be dissolved by a resolution of the

shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles, as described in Article 22 hereof.

Art. 3.  The object of the Corporation is the management of a Luxembourg collective investment undertaking

presently denominated BCH HORIZONS (the «Fund»), and the administration of its assets and activities, including the 

446

issue, exchange or redemption of Units of several classes (the «Units») on behalf of the Fund, and the representation
and defence of the interests of the holders of Units, in accordance with the provisions of the Luxembourg law of 30th
March, 1988 on collective investment undertakings as amended from time to time. The Corporation may also administer
its own assets and carry out any operations which it may deem useful in the accomplishment and development of its
purposes, subject to all applicable laws.

Art. 4. The registered office of the Corporation is established in Luxembourg City, in the Grand Duchy of Luxem-

bourg. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the Board of
Directors (the «Board»).

In the event that the Board determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred

or are imminent, that could interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with the
ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred
abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measure shall have no effect on
the nationality of the Corporation, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a
Luxembourg corporation.

Art. 5. The corporate capital is set at five million Luxembourg francs (5,000,000.-), represented by five thousand

(5,000) shares with a par value of one thousand Luxembourg francs (1,000.-) each (the «Shares»), all fully paid in.

Art. 6. The Shares shall be and remain in registered form. Share certificates (hereafter «Certificates») will be issued

upon request. Such Certificates shall be signed by two directors whose signatures may be by facsimile.

Payments of dividends to shareholders will be made to their addresses in the register of shareholders (the

«Register»). No interest will be paid on dividends declared, pending their collection, or relating to Shares held by the
Corporation.

All issued Shares shall be registered in the Register, which shall be kept by the Corporation.
Each shareholder must provide the Corporation with an address. All notices and announcements from the Corpor-

ation to Shareholders may be sent to such address which will also be entered in the Register.

Art. 7. The capital of the Corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in

the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in Article 22 hereof.

Art. 8. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Corporation shall represent the entire body of

shareholders of the Corporation.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relative to the operations of the Corporation.

Art. 9. The annual general meeting of shareholders shall be held in accordance with Luxembourg law, in Luxem-

bourg at the registered office of the Corporation, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice
of meeting, on the second Tuesday in the month of March at 2.00 p.m. and for the first time in 1998. If such day is a legal
holiday in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general
meeting may be held outside the Grand Duchy of Luxembourg, if, in the absolute and final judgement of the Board,
exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and the conduct of the meetings of shareholders of

the Corporation, unless otherwise provided herein.

Each Share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A shareholder may act at any

meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by cable or telegram or telex.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a

simple majority of the Shares present or represented and voting.

The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part in any

meeting of shareholders.

Art. 10. Shareholders will meet upon a call of the Board or of the statutory auditor pursuant to a notice setting

forth the agenda, sent by registered mail at least eight days prior the date of the general meeting to the shareholder’s
address in the Register.

However, if all shareholders are present or represented at a shareholders’ meeting and if they declare to be informed

of its agenda, the meeting may be held without convening notice or prior publications.

Art. 11. The Corporation shall be managed by a Board composed of at least three members, who need not be

shareholders of the Corporation.

The directors shall be elected by the shareholders at a general meeting, for a period ending at the next annual general

meeting and until their successors are elected and qualify; provided, however, that a director may be removed with or
without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the shareholders. In the event of vacancy in the
office of director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by
majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of shareholders.

Art. 12. The Board shall elect from among its members a chairman and may appoint a managing director. It may

also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings
of the Board and of the shareholders. The Board shall meet upon call by the chairman or two directors, at the place
indicated in the notice of the meeting.

The chairman shall preside over all meetings of shareholders and of the Board, but in his absence the shareholders or

the Board may appoint another person as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

447

The Board may from time to time appoint a general manager, an administrative manager, or other officers considered

necessary for the operation and management of the Corporation.

Any such appointment may be revoked at any time by the Board.
Officers need not be directors or shareholders of the Corporation.
The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given to them

by the Board.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the

hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of the circumstances shall be
set forth in the notice of meeting.

This notice may be waived by the consent in writing or by cable, telegram, telex or telecopier of each director.
Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule

previously adopted by resolution of the Board.

A director may act at a meeting of the Board by appointing in writing or by cable or telegram or telex or telecopier

another director as his proxy.

Except as stated below, the Board can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are in attend-

ance (which may be by way of a conference telephone call) or represented at a meeting of the Board.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
The directors may also approve by unanimous vote a circular resolution, by expressing their consent on one or

several separate instruments in writing or by telex, telegram or telecopier, confirmed in writing, which shall all together
constitute appropriate minutes evidencing such decision.

Art. 13. The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore who presided over such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the

chairman or by two directors.

Art. 14.  The Board is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the

Corporation’s interest.

All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are in the

competence of the Board.

The Board has in particular power to determine the corporate policy and the course of conduct of the management

and business affairs of the Corporation.

The Board may, with the approval of the statutory auditor, declare and pay an interim dividend, based on the semi-

annual accounts.

Art. 15. No contract or other transaction between the Corporation and any other corporation or firm shall be

affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation are interested
in, or are directors, associates, officers or employees of such other corporation or firm.

Any director or officer of the Corporation who serves as a director, associate, officer or employee of any corpor-

ation or firm with which the Corporation shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such
affiliation with such other corporation or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters
with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Corporation may have a personal interest in any transaction of the

Corporation, such director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or
vote on any such transaction, and such transaction and such director’s or officer’s interest therein shall be reported to
the next succeeding meeting of shareholders.

Art. 16. The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against

expenses, reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party
by reason of his being or having been a director or officer of the Corporation or at its request, of any other Corporation
of which the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in
relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross
negligence or willful misconduct; in the event of a settlement indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indem-
nified did not commit such a breach of duty.

The foregoing right or indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 17. The Corporation will be bound by the joint signatures of any two directors of the Corporation, or by the

joint signatures of a director and of any duly authorized person, or in any other way determined by a resolution of the
Board.

Art. 18. The operations of the Corporation including particularly its books of accounts and the filing of any tax

returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by a statutory auditor who shall not
otherwise be affiliated with the Corporation.

The statutory auditor other than the first statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of

shareholders for a period ending at the date of the next annual general meeting of shareholders and shall remain in office
until re-elected or until his successor is elected and qualifies.

The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.

Art. 19. The accounting year of the Corporation shall begin on the first day of January and shall terminate on the

thirty-first day of December of the same year.

448

The first accounting year shall start on the date of incorporation and shall end on the thirty-first December nineteen

hundred and ninety-seven.

Art. 20. From the annual net profits of the Corporation, five per cent shall be allocated to the reserve required by

law.

This allocation shall cease to be required as soon as and as long as such legal reserve amounts to ten per cent of the

issued capital of the Corporation as stated in article five hereof or as increased or reduced from time to time as
provided in article seven hereof. The general meeting of shareholders, upon recommendation of the Board, shall
determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and may declare stock dividends or cash
dividends from time to time.

Any Shares of the Corporation held by it shall be excluded from receiving dividends or from participating in the net

liquidation proceeds.

Art. 21. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liqui-

dators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders effecting such dissolution
and which shall determine their powers and their compensation.

Art. 22. These Articles may be amended by a resolution of an extraordinary shareholders’ meeting, subject to the

quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

Art. 23. All funds to which shareholders are entitled pursuant to the liquidation of the Company and which shall

not have been claimed by those entitled thereto before the close of the liquidation operations shall be deposited in
favour of whom it may concern at the Caisse des Consignations in Luxembourg.

Art. 24. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the law of 10th August,

1915 on Commercial Companies and amendments thereto.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in Article 26 of the law of August 10th, 1915 on

commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Subscription and payment

The articles of incorporation of the Company having thus been drawn up by the appearing parties, these parties have

subscribed for the number of shares and have paid in cash the amounts mentioned hereafter:

Shareholders

Subscribed

Number of

Amount

capital

shares

paid in

1) CENTRAL HISPANO GESTION, S.A.……………………………………… 4,999,000.- LUF

4,999

4,999,000.- LUF

2) CENTRAL HISPANO HOLDING S.A. ……………………………………

      1,000.- LUF

      1

      1,000.- LUF

Total:……………………………………………………………………………………………………… 5,000,000.- LUF

5,000

5,000,000.- LUF

Proof of all such payments has been given to the undersigned notary who states that the conditions provided for in

article 26 of the law of August 10th, 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses, Valuation

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatever, which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one hundred and thirty thousand francs (130,000.- LUF).

<i>Extraordinary General Meeting

The above-named parties, representing the entire subscribed capital and considering themselves as duly convened,

have immediately proceeded to hold an Extraordinary General Meeting.

Having first verified that the meeting was regularly constituted, they have passed the following resolutions, each time

by unanimous vote:

1. - Resolved to fix at four (4) the number of directors and further resolved to elect the following as directors for a

period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 1998:

1) Mr Gustavo Suarez Cuesta, Managing Director of CENTRAL HISPANO GESTION, S.A., Madrid;
2) Mr Gerardo Neyra Suarez, General Manager of CENTRAL HISPANO GESTION, S.A., Madrid;
3) Mr Antonio Senas Valbuena, Senior Sales Manager of BANCO CENTRAL HISPANO, Madrid;
4) Mr Luis Abraira de Arana, International Investments Manager of CENTRAL HISPANO GESTION, S.A., Madrid.
2. - Resolved to fix at one the number of statutory auditors and further resolved to elect the following as statutory

auditor for a period ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 1998:

– COOPERS &amp; LYBRAND, Luxembourg.
3. - Pursuant to the provisions of the articles of incorporation and of the company law the shareholders’ meeting

hereby authorises the board of directors to delegate the daily management of the Company and the representation of
the Company within such daily management to one or more members of the board of directors.

4. - The registered office shall be at 16, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
In faith of which We, the undersigned notary, have set our hand and seal, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the persons appearing, who requested that the deed should be documented in the

English language, the said persons appearing signed the present original deed together with Us, the notary, having
personal knowledge of the English language.

The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergencies between the

English and the French texts, the English version will prevail.

449

Suit la traduction française:

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-neuf novembre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de residence à Mersch.

Ont comparu:

1) CENTRAL HISPANO GESTION, S.A., une société de droit espagnol, ayant son siège social à 11, Juan Esplandiu,

28007 Madrid (Espagne), ici représentée par Monsieur Francis Pedrini, Vice-President, demeurant à Luxembourg, en
vertu d’une procuration sous seing privé;

2) CENTRAL HISPANO HOLDING S.A., une société de droit espagnol, ayant son siège social à Plaza Canalejas, l,

28008 Madrid (Spain), ici représentée par Monsieur Francis Pedrini, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing
privé.

Ces procurations, signées par les comparants et le notaire instrumentaire, resteront annexées au présent acte aux

fins de formalisation.

Lesquels comparants, agissant en leurs susdites qualités, ont arrêté, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils

déclarent constituer entre eux:

Art. 1

er

Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société (la «Société») sous la forme d’une société anonyme sous la dénomination de CENTRAL HISPANO
GESTION LUXEMBOURG S.A.

Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision des actionnaires prise

de la manière requise pour la modification des présents Statuts, tel que décrit à l’article 22 des présentes.

Art. 3. La Société a pour objet la gestion d’un fonds commun de placement luxembourgeois qui porte actuellement

la dénomination de BCH HORIZONS (le «Fonds») et l’administration des avoirs et des activités de celui-ci, y inclus
l’émission, l’échange ou le rachat des parts des différentes classes (les «Parts») pour le compte du Fonds et la
représentation et la défense des intérêts des porteurs de Parts, conformément aux dispositions de la loi luxembour-
geoise du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif. La Société peut aussi gérer ses propres avoirs et
effectuer toutes opérations qu’elle estimera utiles à l’accomplissement et au développement de son objet social, sous
réserve de l’observation de toutes les lois applicables.

Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, au Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être créé

par simple résolution du Conseil d’Administration (le «Conseil») des succursales ou autres bureaux, tant au Luxem-
bourg qu’à l’étranger.

Au cas où le Conseil estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique ou social, de

nature à compromettre l’activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée entre ce siège et
l’étranger, se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger jusqu’à la
cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure temporaire n’aura toutefois aucun effet sur la natio-
nalité de la Société, laquelle, nonobstant le transfert provisoire de son siège, restera une entité luxembourgeoise.

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq millions de francs luxembourgeois (5.000.000,- LUF) représenté par cinq mille

(5.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune (les «Actions»), toutes
entièrement libérées.

Art. 6. Les Actions sont et resteront nominatives. Les certificats d’Actions (ci-après «Certificats») seront émis sur

demande. Ces Certificats seront signés par deux administrateurs dont les signatures pourront être apposées en fac-
similé.

Le paiement de dividendes aux actionnaires se fera à leur adresse inscrite au registre des actionnaires (le «Registre»).

Aucun intérêt ne sera payé sur des dividendes mis en paiement et non réclamés ou sur des Actions détenues par elle.

Toutes les Actions seront inscrites dans le Registre qui sera tenu par la Société.
Tout actionnaire devra fournir à la Société une adresse. Toute notification et tout avis de la Société à des actionnaires

pourront être envoyés à cette adresse qui sera également inscrite au Registre.

Art. 7. Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision des actionnaires adoptée de la manière requise

pour les modifications des Statuts, selon ce qui est prescrit à l’article 22 ci-après.

Art. 8.

Toute assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représentera l’ensemble des

actionnaires de la Société.

Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous actes relatifs aux opérations de la Société.

Art. 9.

L’assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue, conformément à la loi luxembourgeoise, à

Luxembourg au siège social de la Société, ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que désigné dans l’avis de convo-
cation, le 2

ème

mardi du mois de mars à quatorze heures et pour la première fois en 1998. Si ce jour est un jour férié

légal à Luxembourg, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L’assemblée générale
pourra se tenir en dehors du Grand-Duché de Luxembourg si, selon l’appréciation définitive et souveraine du Conseil,
des circonstances exceptionnelles le requièrent.

D’autres assemblées d’actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convocation.
Sauf disposition contraire des statuts, les quorum et délai prévus par la loi s’appliqueront aux convocations et à la

tenue des assemblées d’actionnaires de la Société.

Toute action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions imposées par les présents statuts. Tout actionnaire

pourra prendre part aux assemblées d’actionnaires en désignant par écrit ou par câble, télégramme ou télex une autre
personne comme son mandataire.

450

Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions prises lors d’assemblées générales

d’actionnaires dûment convoquées seront approuvées à la majorité simple des actions présentes ou représentées et
participant au vote.

Le Conseil peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part à toute

assemblée générale.

Art. 10. Les actionnaires se réuniront sur convocation du Conseil ou du commissaire aux comptes à la suite d’une

convocation contenant l’ordre du jour, envoyée par lettre recommandée au moins huit jours avant la date de l’assemblée
à chaque actionnaire à l’adresse indiquée dans le Registre.

Toutefois, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée d’actionnaires et s’ils déclarent avoir

été informés de l’ordre du jour de la réunion, celle-ci pourra se tenir sans avis de convocation ou publications préalables.

Art. 11. La Société sera administrée par un Conseil composé d’au moins trois membres, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires réunis en assemblée générale, pour un terme expirant lors de la

prochaine assemblée générale et jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus et aient accepté leurs fonctions, sauf
qu’un administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif et/ou remplacé à tout moment par résolution approuvée
par les actionnaires. En cas de vacance d’un poste d’administrateur pour cause de décès, démission ou autrement, les
administrateurs restants pourront se réunir et élire à la majorité des voix un administrateur pour remplir cette vacance
de poste jusqu’à la prochaine assemblée des actionnaires.

Art. 12. Le Conseil désignera parmi ses membres un administrateur-délégué. Il pourra aussi désigner un secrétaire

qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil
et des assemblées générales d’actionnaires. Le Conseil se réunira sur la convocation de l’administrateur délégué ou de
deux administrateurs au lieu indiqué dans l’avis de convocation.

L’administrateur délégué présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et du Conseil, mais, en son

absence, les actionnaires ou le Conseil pourront désigner une autre personne comme président de la réunion, par un
vote à la majorité de ceux présents lors d’une telle réunion.

Le Conseil pourra de temps à autre nommer un directeur général, un directeur administratif, un secrétaire ou tous

autres fondés de pouvoir qu’il jugera nécessaires à l’activité et à l’administration de la Société.

Ces nominations pourront être révoquées à tout moment par le Conseil.
Les fondés de pouvoir n’ont pas besoin d’être administrateurs ou actionnaires de la Société.
Les fondés de pouvoir auront, sauf disposition contraire des présents Statuts, les pouvoirs et devoirs qui leur auront

été conférés par le Conseil.

Avis écrit de toute réunion du Conseil sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant

l’heure prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation.

On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex ou

message télécopié de chaque administrateur.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du Conseil se tenant à une heure et à un endroit

déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil.

Un administrateur pourra se faire représenter lors d’une réunion du Conseil en désignant par écrit, par télex,

télégramme ou message télécopié un autre administrateur comme son mandataire.

Sous réserve de ce qui sera dit ci-après, le Conseil ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des

administrateurs participe à la réunion (ce qui pourra se faire au moyen d’une conférence organisée par téléphone) ou y
est représentée.

Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors d’une telle

réunion.

Les administrateurs pourront également approuver par vote unanime le texte d’une résolution circulaire, en

exprimant leur accord sur un ou plusieurs documents séparés par écrit, télex, télégramme ou message télécopié,
confirmés par écrit, lesquels constitueront tous ensemble le procès-verbal approprié documentant une telle décision.

Art. 13. Les procès-verbaux des réunions du Conseil seront signés par l’administrateur-délégué ou, en son absence,

par l’administrateur qui aura assumé la présidence de la réunion.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par l’administrateur-

délégué ou par le secrétaire ou par deux administrateurs.

Art. 14.  Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes d’administration et de

disposition dans l’intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts sont à l’assemblée générale des

actionnaires de la compétence du Conseil.

Le Conseil a en particulier le pouvoir de déterminer la politique générale et la conduite des affaires de la Société.
Le Conseil pourra, avec l’accord du commissaire aux comptes, déclarer et mettre en paiement des dividendes

intérimaires, sur base d’états financiers semestriels.

Art. 15.  Aucun contrat ni autre transaction entre la Société et d’autres sociétés ou firmes ne seront affectés ou

invalidés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société y seront intéressés, ou en
seront administrateurs, associés, fondés de pouvoir ou employés.

Un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui remplira en même temps des fonctions d’administrateur,

associé, fondé de pouvoir ou employé d’une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera
autrement en relations d’affaires, ne sera pour le motif de cette appartenance à cette société ou firme, pas empêché de
donner son avis et de voter ou d’agir quant à toutes questions relatives à de tels contrat ou opération.

451

Au cas où un administrateur ou fondé de pouvoir de la Société aurait un intérêt personnel dans une opération de la

Société, il en informera le Conseil et il ne donnera pas d’avis ni ne votera sur une telle opération et cette opération ainsi
que l’intérêt qu’un administrateur ou fondé de pouvoir y a, sont portés à la connaissance de la prochaine assemblée
générale des actionnaires.

Art. 16. La Société pourra indemniser tout administrateur ou fondé de pouvoir ainsi que leurs héritiers, exécuteurs

testamentaires ou administrateurs légaux des dépenses raisonnablement encourues par eux en relation avec toute
action, procédure ou tout procès auxquels ils seront partie ou auront été impliqués en raison de la circonstance qu’ils
sont ou ont été administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société, ou en raison du fait qu’ils l’ont été à la demande de
la Société dans une autre société, dans laquelle la Société est actionnaire ou créancière, dans la mesure où ils ne sont
pas en droit d’être indemnisés par cette autre entité, sauf relativement à des matières dans lesquelles ils seront
finalement condamnés pour négligence grave ou mauvaise administration délibérée dans le cadre d’une pareille action ou
procédure; en cas d’arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société est informée par
son conseil que la personne à indemniser n’a pas commis un tel manquement à ses devoirs.

Le droit prédécrit à indemnisation n’exclura pas d’autres droits individuels dans le chef de ces personnes.

Art. 17.

La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs de la Société, ou par

la signature conjointe d’un administrateur et d’une personne dûment autorisée, ou encore de toute autre manière déter-
minée par une résolution du Conseil.

Art. 18.  La surveillance des opérations de la Société, y inclus en particulier la tenue de ses livres comptables et les

déclarations fiscales et autres requises par la loi luxembourgeoise, sera confiée à un commissaire aux comptes
indépendant.

Le commissaire aux comptes, sauf le premier d’entre eux, sera élu par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires

de la Société pour un terme expirant à la prochaine assemblée annuelle et restera en fonction jusqu’à ce qu’il soit réélu
ou que son successeur ait été élu et ait accepté ses fonctions.

Le commissaire aux comptes peut être révoqué à tout moment avec ou sans motif par les actionnaires.

Art. 19.  L’année sociale de la Société commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de

la même année.

La première année sociale commencera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre mil neuf

cent quatre-vingt-dix-sept.

Art. 20. Sur les bénéfices nets annuels de la Société il sera prélevé cinq pour cent qui seront attribués à la réserve

légale.

Cette attribution cessera d’être requise dès que et aussi longtemps que cette réserve légale s’élèvera à dix pour cent

du capital social émis par la Société, tel qu’énoncé à l’article cinq des présents statuts ou tel qu’augmenté ou réduit de
temps en temps selon ce qui est prévu à l’article sept ci-dessus.

L’assemblée générale des actionnaires décidera, sur recommandation du Conseil, de l’usage à faire du solde du

bénéfice net annuel et pourra de temps à autres déclarer des dividendes sous forme d’actions gratuites ou sous forme
de répartitions en espèces.

Les actions qui seront détenues par la Société seront exclues du droit de toucher des dividendes et du droit de parti-

ciper au produit net de la liquidation.

Art. 21. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs, qui pourront être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée générale des actionnaires
décidant cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22.

Ces statuts pourront être modifiés par une décision d’une assemblée générale extraordinaire des

actionnaires, aux conditions de quorum et de majorité prévues par la loi luxembourgeoise.

Art. 23. Tous fonds auxquels les actionnaires auront droit à la suite de la liquidation de la Société et qui n’auront

pas été réclamés par ceux auxquels ils reviennent avant la clôture des opérations de liquidation, seront déposés en
faveur de qui il appartiendra auprès de la Caisse des Consignations à Luxembourg.

Art. 24. Toutes matières non prévues par les présents Statuts seront régies par les dispositions de la loi du 10 août

1915, telle que modifiée, sur les sociétés commerciales.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Souscription et paiement

Les parties comparantes ayant ainsi arrêté les statuts de la Société, ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en

espèces les montants ci-après énoncés:

Actionnaires

Capital

Nombre

Libération

souscrit

d’actions

1) CENTRAL HISPANO GESTION S.A. ……………………………………… 4.999.000,- LUF

4.999

4.999.000,- LUF

2) CENTRAL HISPANO HOLDING S.A. ……………………………………

      1.000,- LUF

      1

      1.000,- LUF

Total:……………………………………………………………………………………………………… 5.000.000,- LUF

5.000

5.000.000,- LUF

La preuve de tous ces paiements a été apportée au notaire instrumentaire qui constate que les conditions prévues à

l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.

452

<i>Coût, Evaluation

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison de sa

constitution sont estimés à environ cent trente mille francs (130.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital social souscrit, se sont constitués en assemblée

générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués.

Après avoir vérifié que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, chaque fois à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

1. - Le nombre des administrateurs est fixé à quatre (4).
Sont nommés administrateurs:
1) M. Gustavo Suarez Cuesta, Managing Director de CENTRAL HISPANO GESTION, S.A., Madrid;
2) M. Gerardo Neyra Suarez, General Manager de CENTRAL HISPANO GESTION, S.A., Madrid;
3) M. Antonio Senas Valbuena, Senior Sales Manager de BANCO CENTRAL HISPANO, Madrid;
4) M. Luis Abraira de Arana, International Investments Manager de CENTRAL HISPANO GESTION, S.A., Madrid.
Leur mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1998.
2. Le nombre des commissaires est fixé à un.
Est nommée commissaire aux comptes:
– COOPERS &amp; LYBRAND, Luxembourg.
Son mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 1998.
3. - Conformément aux dispositions des présents statuts et de la loi, l’assemblée générale autorise le conseil

d’administration à déléguer la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce
qui concerne cette gestion à un ou plusieurs membres du conseil d’administration.

4. - Le siège social est fixé au 16, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite aux personnes comparantes qui ont requis le notaire de documenter le

présent acte en langue anglaise, les personnes comparantes ont signé le présent acte avec le notaire, qui déclare avoir
connaissance personnelle de la langue anglaise.

Les présents statuts, rédigés en langue anglaise, sont suivis d’une traduction française. En cas de divergences entre le

texte anglais et le texte français, le texte anglais primera.

Signé: F. Pedrini, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 4 décembre 1996, vol. 400, fol. 80, case 4. – Reçu 50.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 9 décembre 1996.

E. Schroeder.

(43717/228/457)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 décembre 1996.

BCH HORIZONS, Fonds Commun de Placement.

MANAGEMENT REGULATIONS

1. The Fund.
BCH HORIZONS (the «Fund) as an open-ended mutual investment fund (Fonds Commun de Placement), is an

unincorporated coproprietorship of the securities and other assets of the Fund, managed for the account and in the
exclusive interest of its co-owners (hereinafter referred to as the «Unitholders») by CENTRAL HISPANO GESTION
LUXEMBOURG S.A. (the «Management Company»), a company incorporated as a «société anonyme» under the laws
of Luxembourg and having its registered office in Luxembourg. In the relations between Unitholders, each Portfolio (as
defined hereafter) will be deemed to be a separate entity. However, claims of third parties against the Fund directed
against the Management Company shall be accounted for in the relevant Portfolio and shall, save as otherwise agreed
with creditors, be supported by the total assets of the Fund.

The Management Company issues Units (all such Units hereinafter individually and collectively referred to as the

«Units»), each corresponding to a separate portfolio of assets (a «Portfolio»), the issuance of which Units shall be
recorded in the Unit register of the Fund and acknowledged by unit confirmations («Unit Confirmations»).

The Management Company may decide to terminate existing Portfolios and/or to create new Portfolios, in each case

subject to prior notice being given to the Unitholders and to amendment of the Prospectus.

The Units are issued in registered form only.
The assets of the Fund shall be held in custody by a custodian bank (hereinafter referred to as the «Custodian»), and

shall be segregated from the assets of the Management Company. CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A. is appointed as the
Custodian.

The consolidated accounts of the Fund shall be maintained in U.S. dollars; the accounts of each Portfolio shall be

maintained in such currency (the «Payment Currency»). As the board of directors of the Management Company (the
«Board») may determine with respect to the relevant Portfolio.

The Offering Price per Unit will be based on a calculation made by the Management Company or its designated Agent

converting the Net Asset Value per Unit into the Payment Currency of the relevant Portfolio.

The rights and obligations of the Unitholders, the Management Company and the Custodian are contractually

determined by these Management Regulations, a copy of which will be provided to Unitholders on request. The

453

Management Regulations are published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations (the «Mémorial») and a
restated version thereof is available for inspection and a copy thereof may be obtained on request at the registered office
of the Management Company and in such other place or places as applicable laws or regulations may require. By
acquiring a Unit, the holder thereof agrees to these Management Regulations and to any and all duly approved
amendments hereto.

2. The Management Company.
The Fund is managed by the Management Company for the exclusive account of the Unitholders. The Management

Company is vested with the broadest powers to administer and manage the Fund, subject to the restrictions contained
in these Management Regulations, particularly the restrictions in clause 6 hereafter, in the name and for the account of
the Unitholders, including (without limitation) the right to:

– purchase, subscribe, sell or otherwise receive or dispose of selected and diversified investments permitted for each

Portfolio including, without limitation and where relevant, transferable securities, transferable debt securities and
ancillary liquid assets as may be permitted in the case of each Portfolio;

– supervise and manage such investments;
– exercise, while the holder of any such investments, all the rights, powers and privileges appertaining to the holding

or ownership thereof to the same extent that an individual could do;

– conduct investment research and to secure information pertinent to the investment and employment of the assets

of the Fund’s Portfolios;

– procure research, investigations and information from any investment advisor;
– do everything necessary or suitable and proper for the accomplishment of any of the purposes and powers herein-

above set forth, either alone or in conjunction with others; and

– do every other act or thing incidental to the purposes aforesaid, provided the same are not inconsistent with the

laws of Luxembourg and of any jurisdictions where the Fund may be registered.

The Board shall determine the investment policy of the Fund for its several Portfolios within the investment limi-

tations set forth herein, as amended from time to time by the Board in accordance with all applicable laws and regula-
tions.

The Board may, under its responsibility, appoint an investment committee consisting of members of the Board and/or

other persons to advise the Board with respect to general investment policy. The Board may, under its responsibility,
appoint a manager or managers to carry out, on behalf of the Management Company, the investment policy and/or the
day-to-day administration and management of the assets of the Fund, including as provided hereafter.

The Management Company shall be entitled to receive from the Fund an annual fee as described below under

«Charges of the Fund», payable monthly and computed on each Valuation Date, based on the Net Assets of the Fund
(defined below).

The Management Company may appoint agents (individually and collectively referred to hereinafter as «Agents») to

perform such services in connection with its obligations under these Management Regulations as it deems necessary or
convenient for its performance hereunder, subject to any limitations under the laws of Luxembourg or contained herein,
on such terms and conditions as are reasonable in the circumstances.

The removal of the Management Company shall be subject to the condition that a substitute management company

(a «Substitute Management Company») shall have in writing agreed with the Custodian to assume all obligations of the
Management Company under these Management Regulations to any Unitholder. In the event of such removal these
Management Regulations shall be amended so as to replace the name of the Management Company by that of the
Substitute Management Company. If no Substitute Management Company can be found, the Fund shall be liquidated in
accordance with the provisions of clause 19 below.

3. The Custodian.
The Management Company shall appoint, and may terminate the appointment of, a Custodian of the Fund’s assets.

The name of the Custodian shall be mentioned in the prospectuses, financial reports and similar documents relating to
the Fund.

The Custodian shall be appointed for an undetermined period of time and the Custodian or the Management

Company may terminate the appointment of the Custodian at any time upon ninety days’ written notice delivered by
either such party to the other, provided, however, that such termination by the Management Company is subject to the
suspensive condition that another bank accepts the responsibilities and duties of the Custodian under these Management
Regulations and provided further that the appointment of the Custodian shall, if terminated by the Management
Company, continue thereafter for such period as may be necessary for the complete divestiture of all assets of the Fund
held by the Custodian. In case of termination by the Custodian, the Management Company will appoint a new custodian
who shall accept the responsibilities and functions of the Custodian under these Management Regulations, provided,
however, that prior to the departing Custodian’s termination becoming effective and pending the effectiveness of the
appointment of a new custodian by the Management Company, the Custodian shall fulfil all of its obligations hereunder.

The Custodian may, under its responsibility, designate other banks and financial institutions established abroad or

clearing systems such as CEDEL BANK S.A. or EUROCLEAR (hereinafter referred to individually as a «Correspondent»
and collectively as the «Correspondents») to fulfil certain obligations of the Custodian under these Management
Regulations.

The Custodian will have the normal duties of a bank with respect to the Fund’s deposits of cash and other assets.
All securities, cash and other assets constituting the assets of the Fund shall be held by - or to the order of - the

Custodian on behalf of the Unitholders and all registered securities comprised in any Portfolio shall be held in the name
of the Custodian or to its order by its nominee. The Custodian shall assume the liability with respect to the safekeeping
of all assets of the Fund, whether held by the Custodian itself or by its nominee or by Correspondents.

454

Upon instruction from or as previously instructed by the Management Company, the Custodian shall perform all acts

of disposal with respect to the assets of the Fund and make payments to third parties on behalf of the Fund.

The Custodian shall sign and be a party to these Management Regulations. The Custodian shall verify the compliance

by the Management Company with these Management Regulations with respect to the assets of the Fund and the receipt
under custody of all documentation of the Fund for all transactions made on its behalf.

Insofar as permitted by law the Custodian is entitled to and obligated to, in its own name:
– make claims on behalf of Unitholders against the Management Company or a former custodian;
– object to - or proceed against - measures of seizure initiated by third parties, if these are levied against the assets

of the Fund on grounds which are not attributable to the Fund.

The Custodian must moreover:
(a) ensure that the sale, issue, redemption and cancellation of Units effected on behalf of the Fund or by the

Management Company are carried out in accordance with the Luxembourg Law of 30th March, 1988 on Investment
Funds as amended (the «1988 Law») and the Management Regulations;

(b) ensure that the value of the Units is calculated in accordance with the 1988 Law and the Management Regulations;
(c) carry out the instructions of the Management Company, unless they conflict with the 1988 Law or the

Management Regulations;

(d) ensure that in transactions involving the assets of the Fund, the countervalue is remitted to it within the usual time

limits;

(e) ensure that the income of the Fund is applied in accordance with the Management Regulations.
4. Investment Manager.
The Management Company may enter into one or more written contracts with one or more persons (which term,

for purposes of this clause 4, includes any individual, partnership, corporation, trust or association) (hereinafter referred
to each as an «Investment Manager») to manage or furnish advisory services in relation to some or all of the investments
of the Fund in any of its Portfolio and to furnish such other services as may be agreed upon by the Management
Company and such Investment Manager. Said contract may contain such terms and conditions and provide for such fees
as the parties thereto shall deem fit, including, without limitation, granting the Investment Manager discretionary powers
with respect to investment and reinvestment of the Fund’s assets, subject to the overall responsibility of the Board and
to the investment limitations set forth hereafter. The Investment Manager may enter into agreements with other
persons pursuant to which certain management, advisory or administrative services will be provided to the Fund or the
Investment Manager in relation to any Portfolio, compensation for which shall be paid from the fees of the Investment
Manager or of the Management Company, as the case may be. The Management Company shall procure that in any such
agreement provisions shall be contained:

(1) restricting the relevant entity appointed by it or by the Investment Manager and (in each case) any of its or their

respective Connected Persons (as defined in clause 6) from dealing with the Fund as beneficial owner on the sale or
purchase of investments to or from the Fund, except on a basis approved by the Board from time to time and from
otherwise dealing with the Fund as principal, except with the consent of the Board; and

(2) specifying the level of management fee payable by the Management Company or the Investment Manager, as the

case may be, to the relevant entity, which level of fee may not exceed that provided for below in this clause.

5. Investment Objectives and Policies.
The purpose of the Fund is to make available to investors investments in different Portfolios with different investment

objectives which the Management Company may decide to create from time to time and as described in the prospectus
published by the Management Company.

To achieve the investment aims, it is intended that the assets of each Portfolio will be invested in a diversified portfolio

of transferable securities as described below. Each Portfolio may at all times hold ancillary liquid assets.

Certain Portfolios may also make use of warrants on transferable securities and options on securities and other

financial instruments, though this will in each case be effected only to a limited extent and not as a prime objective of the
relevant Portfolio. In implementing these general policies and those described below in respect of each Portfolio, the
Fund will observe certain investment restrictions governing the Portfolios’ operations, as set forth under «Investment
Limitations».

6. Investment Limitations.
The Fund shall observe the Investment Limitations below in respect of each Portfolio:
(1) (a) The Fund may only invest in:

(i) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in an Eligible State; and/or

(ii) transferable securities dealt in on another regulated market in an Eligible State which operates regularly and is

recognized and open to the public (a «Regulated Market»); and/or

(iii) recently issued transferable securities, provided that the terms of issue include an undertaking that application

will be made for admission to official listing on a stock exchange or a Regulated Market and such admission is achieved
within a year of the issue.

(For this purpose an «Eligible State» shall mean a member state of the Organisation for the Economic Co-operation

and Development (OECD) and all other countries of Europe, North America, South America, Africa, Asia and
Australasia).

(All such securities under (i), (ii) and (iii) above being hereby defined as «Eligible Transferable Securities»).
Provided that the Fund may also invest in transferable securities which are not Eligible Transferable Securities or in

debt instruments which, because of their characteristics being, inter alia, transferable, liquid assets and having a value
which can be accurately determined on each Valuation Date (as defined hereafter), are treated as equivalent to Eligible

455

Transferable Securities; and provided further that the total of such debt instruments and of investments other than the
Eligible Transferable Securities shall not exceed 10 % of the net assets attributable to any Portfolio.

(1) (b)The Fund may also hold in each Portfolio ancillary liquid assets.
(1) (c) (i) The Fund will invest no more than 10 % of the net assets of any Portfolio in transferable securities issued

by the same issuing body. Moreover, where the Fund holds on behalf of a Portfolio investments in transferable securities
of any issuing body which individually exceed 5 % of the net assets of such Portfolio, the total of all such investments
must not account for more than 40 % of the total net assets of such Portfolio;

(ii) the Fund may invest for any Portfolio up to a maximum of 35 % of its net assets in transferable securities which

are issued or guaranteed by a member state of the European Union (a «Member State»), its local authorities, or by
another Eligible State or by public international bodies of which one or more Member States are members, and such
securities shall not be included in the calculation of the limit of 40 % stated in paragraph (1) (c) (i) above;

the limits set out in sub-paragraphs (i) and (ii) may not be aggregated and, accordingly, investments in transferable

securities issued by the same issuing body effected in accordance with sub-paragraphs (i) and (ii) above may not, in any
event, exceed a total of 35 % of any Portfolio’s net assets;

(iii) Notwithstanding sub-paragraphs (1) (c) (i) and 1(c) (ii) above, the Fund may invest in accordance with the

principle of risk spreading up to 100 % of the net assets of each Portfolio in transferable securities issued or guaranteed
by a Member State, by its local authorities, or by another member State of the OECD or by public international bodies
of which one or more Member States are members, provided that the relevant Portfolio must hold securities from at
least six different issues and securities from one issue do not account for more than 30 % of the total net assets of such
Portfolio.

(1) (d) The Fund may not acquire:

(i) any shares carrying voting rights which would enable it to exercise significant influence over the management

of an issuing body;

(ii) more than
– 10 % of the non-voting shares of the same issuer;
– 10 % of the debt securities of the same issuer;
– 10 % of the shares of the same undertaking for collective investment,

provided that such limits shall not apply to transferable securities issued or guaranteed by a Member State, its local

authorities or by another Eligible State or issued by public international bodies of which one or more Member States are
members and that the limits under (1) (d) (ii) second and third indent may be disregarded at the time of acquisition, if at
that time the gross amount of debt securities or the net amount of the securities in issues cannot be calculated.

The limits in (1) (d) above further shall not apply to investments by a Portfolio in one or more wholly-owned (except

for qualifying shares) company or companies incorporated in a non-Member State which invests its assets mainly in the
securities of issuing bodies of that State, where, under the legislation of that State, such a holding represents the only
way in which the Fund can invest in the securities of issuing bodies of that State, provided that in its investment policy
of the company from the non-Member State complies with the limits laid down in the investment policies and restric-
tions referred to in the current prospectus of the Fund as amended from time to time.

The Fund will further not:
(2) make investments in - or enter into transactions involving - precious metals, commodities or certificates rep-

resenting them;

(3) purchase or sell real estate or any option, right or interest therein, provided that the Fund may invest in securities

secured by real estate or interest therein or issued by companies which invest in real estate or interests therein;

(4) invest more than 5 % of the net assets attributable to any Portfolio in securities of other collective investment

undertakings of the open-ended type. Such investments may be made by the Fund, only if:

(a) such collective investment undertaking of the open-ended type is recognized as an undertaking for collective

investment in transferable securities (a «UCITS») within the meaning of the first and second indent of Article 1(2) of the
EEC Directive 85/611 of 20th December, 1985;

(b) in the case of a UCITS linked to the Management Company by common management or control or by a substantial

direct or indirect holding, or managed by a management company linked to the entity appointed by the Management
Company (an «Investment Manager») («Linked Funds») (i) the UCITS, in accordance with its constitutional documents,
must be one that specialises in investment in a specific geographical area or economic sector; and (ii) no fees or costs
on account of the transactions relating to the units in the UCITS may be charged to the Fund;

(5) purchase any securities on margin (except that the Fund may obtain such short-term credit as may be necessary

for the clearance of purchases and sales of securities) or make short sales of securities or maintain a short position;
deposits or other accounts in connection with option, forward or financial futures contracts, permitted within the limits
referred to below, are not considered margin for this purpose;

(6) make loans to or act as guarantor on behalf of third parties, provided that for the purpose of this restriction (i)

the acquisition of Eligible Transferable Securities in fully or partly paid form (ii) the permitted lending of portfolio
securities and (iii) the purchase of foreign currency by way of back-to-back loans shall not be deemed to constitute the
making of a loan;

(7) borrow for the account of any Portfolio amounts in excess of 10 % of the total net assets of that Portfolio taken

at market value, any borrowing to be from a bank and to be effected only as a temporary measure for extraordinary or
emergency purposes including the redemption of Units;

(8) mortgage, pledge, hypothecate or in any other manner transfer as security for indebtedness any securities owned

or held by the Fund, except as may be necessary in connection with the borrowings permitted by paragraph (7) above,
on terms that the total market value of the securities so mortgaged, pledged, hypothecated or transferred shall not

456

exceed that proportion of the total net assets of the relevant Portfolio of the Fund necessary to secure such borrowings;
the deposit of securities or other assets in a separate account in connection with option or financial futures transactions
shall not be considered mortgage, pledge, hypothecation or encumbrance for this purpose;

(9) make investments in any assets involving the assumption of unlimited liability.
If the limitations in (1) (4) (7) and (8) above are exceeded for reasons beyond the control of the Fund or as a result

of the exercise of subscription rights, it must adopt as a priority objective for its sales transactions the remedying of that
situation, taking due account of the interests of its Unitholders.

Investment Techniques and Instruments

<i>I. Investment techniques and instruments relating to transferable securities
The Fund may, under the conditions and within the limits laid down by law, regulation and administrative practice,

employ techniques and instruments relating to transferable securities, provided that such techniques and instruments
are used for the purpose of efficient portfolio management.

1. Options on transferable securities
The Fund shall purchase and sell call and put options on transferable securities only if traded on a regulated market,

which operates regularly and is recognized and open to the public or over-the-counter with broker-dealers who make
markets in these options and who are first class financial institutions with a high rating specializing in these types of
transactions and are participants in the over-the-counter market.

At the time of selling call options on securities, the Fund must hold in the relevant Portfolio either the underlying

securities or equivalent call options or other instruments which may be used to adequately cover the liabilities arising
therefrom, such as warrants. The securities underlying to said call options sold may not be realized as long as the options
thereon shall not have expired, unless these are covered by matching options or by other instruments which may be
used to this effect. The same applies to matching call options or other instruments held by the Fund, if it does not hold
the underlying securities at the time of selling relevant options.

Where put options on securities are sold, they should be covered either by equivalent put options already purchased

(closing sales) or by cash or liquid assets of an equivalent value.

If the Fund sells call options relating to portfolio securities, the aggregate value of all such options sold may not exceed

25 % of the net assets of any Portfolio when valued at their exercise price and the Fund must at any time be in a position
to ensure the coverage of the position taken as a result of the selling of such options.

The total commitment arising on the sale of call and put options (excluding the sale of call options for which the Fund

has adequate coverage) and the total commitment arising from financial futures and from transactions undertaken for
purposes other than hedging, may at no time exceed the total net asset value of the relevant Portfolio, having netted
long position against short positions as defined below.

2. Transactions relating to Futures and Options on Financial Instruments
Except for transactions on a mutual agreement basis as described below, transactions relating to futures and options

on financial instruments may only relate to contracts which are dealt in on a regulated market, operating regularly,
recognised and open to the public.

2.1. Hedging operations relating to the risks attached to the general movements of stock markets
As a global hedge against the risk of unfavourable stock market movements, the Fund may, to the extent permitted

by all applicable laws, sell futures on stock market indices, sell call options on stock market indices or buy put options
on stock market indices, provided there exists in each case a sufficient correlation between the composition of the index
used and the portfolio securities of the relevant Portfolio.

The total commitment relating to futures and option contracts on stock market indices may not exceed the global

valuation of securities held in the relevant Portfolio in the market corresponding to each index.

2.2. Transactions relating to interest rate hedging
The Fund may also deal in financial futures and in option contracts in order to protect the value of debt securities held

by any Portfolio against interest rate risks.

As a global hedge against interest rate fluctuations the Fund may (to the extent permitted by applicable laws and

regulations of all countries where the Units are registered for public offer and sale) sell interest rate futures contracts
or sell call options or buy put options on interest rates or make interest rate swaps which may be on a mutual agreement
basis with first class financial institutions specialized in this type of transactions.

The total commitment on financial futures contracts, option contracts and interest rate swaps may not exceed the

total value of the assets to be hedged, held by the relevant Portfolio and expressed in the currency corresponding to
these contracts.

2.3. Transactions which are undertaken for purposes other than hedging
Apart from option contracts on transferable securities and contracts relating to currencies, the Fund may, for a

purpose other than hedging, buy and sell futures contracts and option contracts on any type of financial instrument,
provided that the total commitment arising on these purchase and sale transactions together with the total commitment
arising on the sale of call and put options on transferable securities at no time exceeds the net asset value of the relevant
Portfolio, having netted all long positions against short positions, as defined above.

Sales of call options on transferable securities for which the Portfolio has sufficient coverage are not included in the

calculation of the total commitment referred to above.

The commitment arising on futures contracts is equal to the liquidation value of the net positon of contracts relating

to similar financial instruments (after netting between purchase and sale position), without taking into account the
respective maturities.

457

The commitment relating to options bought and sold is equal to the sum of the exercise prices of those options

representing the net position in respect of the same underlying asset, without taking into account the respective
maturities.

2.4. General
The total of the premiums paid to acquire put and call options on transferable securities or any warrants on trans-

ferable securities, together with the total of the premiums paid to acquire call and put options on other financial futures
and all financial instruments may not exceed 15 % of the total net assets of the relevant Portfolio.

3. Lending of Portfolio Securities
Subject to investment restriction (6), the Fund may lend portfolio securities to third persons (for not more than 30

days and not in excess of 50 % of the total valuation of the relevant securities’ portfolio) through a standardized
securities lending system organized by EUROCLEAR, CEDEL BANK S.A. or other recognized clearing institutions or
through a first class financial institution and will receive through such clearing agency collateral in cash or securities
issued or guaranteed by a governmental entity of the OECD or by their local authorities or by supranational institutions.
Such collateral will be maintained at all times in an amount equal to at least 100 % of the total valuation of the securities
and for the duration of the Ioan.

<i>II. Techniques and instruments to hedge exchange risks
The Fund may further, under the conditions and within the limits laid down by law, regulations and administrative

practice, employ techniques and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the
hedging of the Fund’s assets and liabilities.

To this effect the Fund may enter into transactions the purpose of which is the sale of forward currency contracts,

the sale of call options on currencies or the purchase of put options on currencies effected through contracts which are
dealt in on a regulated market, operating regularly, recognised and open to the public. For the same purpose the Fund
may also sell currencies forward or exchange currencies on a mutual agreement basis with first class financial institutions
specialised in this type of transaction.

The Fund will deal in foreign exchange transactions only to hedge against exchange risks and provided that the value

of such contracts does not exceed the total value of the assets denominated in the currency of such contracts and for a
duration which shall normally not exceed that during which the relevant assets are held.

<i>Definition of the expression «Connected Person»
The expression «Connected Person» in relation to the Management Company, any investment manager appointed by

the Management Company (an «Investment Manager») or any company appointed for the purpose of distributing Units
(a «Distributor») or the Custodian (the relevant such company being referred to below as «the relevant company»)
means:

(a) any person or company beneficially owning, directly or indirectly, 20 % or more of the ordinary share capital of

the relevant company, or able to exercise directly or indirectly 20 % or more of the total votes in the relevant company;

(b) any person or company controlled by a person who falls within (a) above;
(c) any company where 20 % or more of the ordinary share capital is beneficially owned, directly or indirectly, by the

relevant company and each of the others of the Management Company, Investment Manager and Distributor taken
together or by the Custodian and any company where 20 % or more of the total votes of which can be exercised,
directly or indirectly, by the relevant company and each of the others of the Management Company, Investment Manager
and Distributor taken together or by the Custodian; and

(d) any director or officer of the relevant company or any Connected Person of the relevant company, as defined in

(a), (b) or (c) above.

7. Issuance of Units.
Units shall be issued by the Management Company without undue delay upon receipt of full payment therefor by or

on behalf of the Custodian. The issuance of Units shall be evidenced by recording it on the Unit register of the Fund and
acknowledged by Unit Confirmations. The Units may be issued in fractions of up to four decimal places. If any Unitholder
shall establish to the satisfaction of the Management Company that his Unit Confirmation has been lost or destroyed, a
duplicate may be issued at the request of such Unitholder under such conditions and guarantees as the registrar
appointed by the Management Company (the «Registrar») shall determine. By the issuance of the new Unit confirmation
(on which it shall be recorded that it is a duplicate), the old confirmation in place of which the new confirmation has
been issued shall automatically become null and void. The Management Company may also authorize the exchange of
mutilated Unit confirmations for new Unit confirmations. In such case, the mutilated confirmations shall be delivered to
the Registrar and shall be cancelled at the time that the new confirmations are issued.

Units shall be offered for sale on each Valuation Date (defined below) at a price (the «Offering Price per Unit») which

shall be based on the Net Asset Value per Unit calculated on the next Valuation Date, increased by a sales charge of up
to a maximum of 5 % of the Net Asset Value, if applicable, as described in the current Prospectus.

Units will be issued on the relevant Valuation Date, subject to the receipt by or on behalf of the Custodian of the

Offering Price in the relevant currency corresponding to the Portfolio, as described in the current Prospectus. All funds
received, net of subscription fees, if applicable, will be invested in full and, if necessary, fractional Units will be issued.

The Management Company may at its sole discretion refuse or delay subscription orders and at any time redeem

Units held by Unitholders prohibited from acquiring or holding Units of the Fund. The Management Company may elect
at its discretion to accept in certain cases subscriptions in kind by contribution of transferable securities, provided that
they correspond to the investment policy of the relevant Portfolio and that their market value in an amount equivalent
to the Offering Price for such Units, or part thereof, will be verified by a special report of the auditor of the Fund.

458

Any stamp taxes or other charges which may be due in the various countries where Units are sold and subscribed

shall be for the account of the Unitholder and the Offering Price per Unit may be increased by the amount of any such
taxes or charges.

The Registrar shall send a written confirmation, by fax or telex stating the number of Units of the relevant Portfolio

subscribed and accepted, or the balance thereof in case of conversion or redemption, and the price paid in the relevant
Payment Currency.

The Management Company may enter into a Distribution Agreement with one or more persons (hereinafter referred

to as the «Distributor») (which term, for purposes of this clause 7, includes any individual, partnership, corporation,
trust or association), to act as a distributor of Units. Said contract may contain such terms and conditions and provide
for such fees as the parties thereto shall deem fit, subject as below. The Distributor may, with the consent of the
Management Company, enter into agreements with other persons acting as Sub-Distributors for the offer and sale of
Units in various countries.

8. Transfer of Units, Unitholders’ Meetings.
Every transfer or devolution of a registered Unit shall be entered in the Unit register of the Fund.
Transfer of registered Units shall take effect by serving upon the Registrar an instrument of assignment signed by the

transferor and the transferee or their respective brokers or by the written acknowledgement of the transfer signed by
the Management Company or by one or more persons designated therefor by the Management Company. The trans-
feree may present to the Registrar the Unit confirmation of the Transferor, duly signed, in order that the Registrar may
issue a new Unit confirmation in the name of the Transferee.

Each Unit represents an indivisible interest in the Fund. When a Unit is jointly held by several persons or is benefi-

cially owned by one or more persons other than the Unitholder of record, each joint owner or each beneficial owner
(together with the registered owner) as the case may be, must designate to the Registrar or to the person or persons
designated therefor by the Management Company the same person to represent such joint or beneficial owners in their
relations with the Management Company and the Registrar and, in the case of jointly owned Units, the Management
Company may suspend in whole or in part the exercise of the rights relating to such Units until receipt of such
designation of a single representative of the joint owners. Subject to the second sentence of this paragraph, the
Management Company and the Custodian may regard, and shall be fully protected in dealing with the person in whose
name Units are registered in the Unit register as being the absolute owner of such Units, and shall be entitled to
disregard, and take no notice of, any right, interest or claim of any other person in or to such Units.

Every holder of Units at or before the registration in his name in the Unit register of the Units owned by him, and

every subscriber to Units, at or before the acceptance of his subscription, shall furnish to the Registrar, or to the person
or persons designated therefor by the Management Company, his address to be entered in the Unit register of the Fund
and to which all notices and communications to him from the Management Company and the Registrar are to be sent;
should any Unitholder fail to furnish such address as aforesaid, it shall be entered in the Unit register as being «c/o the
Registrar» until he shall have furnished another address to the Registrar. A Unitholder may, at any time, by written
notice to the Registrar, change his registered address in the Unit register.

There will be no meetings of Unitholders.

9. Pre-emptive rights relating to Units, conversion of Units into another Portfolio, minimum

investment in Units.

No Unitholder, by virtue of being a Unitholder, shall have any preferential right to purchase or subscribe to any Units

which may thereafter be sold or issued, except as below.

Rights attached to the fractions of Units are exercised for the duration of the Fund and upon its liquidation in

proportion to the fraction of a Unit held.

The Unitholders are entitled to convert all or part of their investment in a Portfolio into another Portfolio, by a

request addressed to the Management Company or its designated agent directly or through the Distributor or a Sub-
Distributor, provided that if such Units have been held less than 6 months in those cases where it would otherwise be
free of charge, the Unitholder will be charged a fee of 1 % of the Net Asset Value of the former Units.

The value at which Units shall be converted into Units of another Portfolio shall be based on their respective Net

Asset Values on the same day, if the conversion order is received by a time specified by the Board (the «Specified Time»)
on such day, or otherwise on the next Valuation Date, as the case may be.

The Board may from time to time determine a minimum investment in Units of any one of the Portfolios, in case such

minimum is not maintained due to a conversion and/or redemption, compulsorily redeem or convert the remaining
lower number of Units at their current Net Asset Value and make payment of the proceeds thereof to the Unitholder.

10. Restrictions on Ownership of Units.
The Management Company shall comply, with respect to the issuance of Units, with the laws and regulations of the

countries where the Units are offered or sold. The Management Company may, at its discretion, discontinue
temporarily, cease definitively or limit the issuance of Units at any time to any person (which term, for purposes of this
clause, includes any individual, partnership, corporation, trust or association) resident or established in certain countries
and territories. The Management Company may exclude certain persons from the acquisition of Units if such measure
is necessary for the protection of the Fund and the Unitholders as a whole.

In this connection, the Management Company may:
(a) reject at its discretion any subscription for Units;
(b) redeem at any time the Units held by the Unitholders who are excluded from purchasing or holding Units under

this clause.

459

Neither the Management Company nor the Custodian or any other person (including any individual, corporation,

partnership, association or other entity) shall offer or sell any Units to any other person for reoffering or resale directly
or indirectly, to any United States person.

As used in this clause «United States person» means any national or person resident or normally resident in the

United States of America or a partnership organized or existing in any State, territory or possession of the United States,
or a corporation organized under the laws of the United States of America or of any State, territory or possession
thereof, or any estate or trust, other than an estate or trust the income of which from sources outside the United States
(which is not effectively connected with the conduct of a trade or business within the United States) is not included in
gross income for the purpose of computing United States federal income tax. All offers and issuances of Units will be in
conformity with the foregoing.

Neither the Management Company nor any other person shall take any action that would permit or result in a public

offering of Units in any country or any other jurisdiction where action or approval for that purpose is required, or shall
directly or indirectly offer or sell any Units or distribute or publish any prospectus or other offering material in any
country or other jurisdiction, except in conformity with the laws and regulations relating to the placement of securities
in the jurisdiction where so made.

11. Determination of Net Asset Value Per Unit and of Offering Price.
The net asset value per Unit (herein referred to as the «Net Asset Value per Unit») and the Offering and Redemption

Prices are determined on each Business Day (as defined below).

The Net Asset Value per Unit shall be expressed in the payment currency of the relevant Fund. The Offering and

Redemption Prices per Unit shall be determined as provided herein by or through the facilities of the Registrar and
Administration Agent or by the agent appointed for such purpose by the Management Company. Such determination
shall be made in the case of all Units on each day (a «Business Day») which is a bank business day in Luxembourg (such
day being for this purpose also herein referred to as a «Valuation Date»), except in case of suspension of the Net Asset
Value determination of such Units or of the issue of such Units as described herein.

The calculation of the Net Asset Value per Unit for any Portfolio shall be made in each case as of a time fixed by

resolution of the Board, by dividing:

(i) the total net value of the assets of the relevant Portfolio of the Fund (herein referred to individually as the «Net

Assets of the Fund»), meaning the value of all the securities and all other assets of such Portfolio, determined on the
Valuation Date according to the principles described below, less (to the extent determined by or pursuant to the
direction of the Management Company on the basis of the Portfolio’s size as compared to the other Portfolios and other
objective criteria which, in the opinion of the Management Company, are fair and reasonable), all debts, obligations and
liabilities of the Fund with respect to the relevant Portfolio, as described below under «Charges of the Fund»; by

(ii) the total number of Units (full and fractional) of the corresponding Portfolio then outstanding.
Interest earned on certificates of deposit, commercial paper purchased at par or on demand notes shall be included

in accrued interest receivable. Investment transactions shall be accounted for on the trade date.

Subject as below, investments which are admitted to official listing on a stock exchange are valued at the last known

price on the principal markets on which such securities are listed, will normally be valued on an amortized cost basis.
Securities and options thereon and/or financial futures traded on other Regulated Markets are valued at the last known
price or at prices based on the yield equivalent obtained from one or more dealers in such markets at the time of
valuation. If such prices are not representative of their fair value, all such securities, options and/or financial futures and
all other permitted assets shall be valued at the fair value for which it is expected that they may be resold, as determined
in good faith by or under the direction of the Board. The cash equivalent or money market instruments with a remaining
maturity of 90 days or less are stated at amortized cost, which approximates to market value. Any assets or liabilities
initially expressed in terms of foreign currencies will be translated into the relevant currency of the Fund, at the market
rates prevailing at the time of valuation.

The Board may adopt other fair valuation methods when circumstances or market conditions so warrant.
The decisions by the Board referred to above will be made in accordance with policies adopted from time to time by

the Board setting forth general guidelines for the interim calculation of fair value by officers or other persons designated
by the Board.

12. Suspension of Unit Issuance, Exchange and Redemption and of Calculation of the Net Asset Value.
The Management Company may suspend temporarily the issuance and the redemption of Units of any Portfolio as

well as the right to convert Units into those of another Portfolio and the calculation of the Net Asset Value per Unit of
any Portfolio:

(a) during any period when any market or stock exchange, which is a principal market or stock exchange, on which a

material part of the Fund’s investments of the relevant Portfolio for the time being is quoted, is closed (otherwise than
for ordinary holidays), or during which dealings are substantially restricted or suspended; or

(b) during the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal of invest-

ments of the relevant Portfolio by the Fund is not possible; or

(c) during any breakdown in the means of communication normally employed in determining the price of any of the

Portfolio’s investments or the current prices on any market or stock exchange; or

(d) during any period when remittance of money which will or may be involved in the realization of, or in the payment

for, any of the Portfolio’s investments is not possible.

The Management Company shall cease the issue, conversion and redemption of the Units forthwith upon the occur-

rence of an event causing the Fund to enter into liquidation or upon the order of the Luxembourg supervisory authority.

Unitholders having requested the conversion or redemption of their Units will be notified in writing of any such

suspension within seven days of their request and will be promptly notified upon termination of such suspension.

460

13. Redemption.
Unitholders may request the redemption of any of their Units on the relevant Valuation Date. Units may also be

redeemed as provided in clause 9 of these Management Regulations.

The Redemption Price shall be based on the Net Asset Value per Unit of the relevant Portfolio as determined on the

Valuation Date on which a valid redemption order is received prior to the Specified Time or otherwise on the next
Valuation Date.

Where a redemption request is expressed with respect to Units which have been held less than 6 months, in those

cases when it would otherwise be free of charge, the Unitholder will be charged a redemption fee of 1 % of the Net
Assets Value of the Units redeemed which will be deducted from the price payable by the Fund in relation to the
redemption of Units and which shall revert to the relevant former Portfolio.

The Redemption Price shall be payable in the Payment Currency of the relevant Fund.
Payment for redeemed Units shall be made within five Business Days after the relevant day on which the redemption

order is executed. Payment of the redemption price shall be made in the relevant Payment Currency by sending a
cheque to the addresses of the Unitholders in the Unit register or, if so requested by a Unitholder and at his expense,
by bank transfer to an account with a bank. Payments will be made only if no legal provision, such as exchange controls
or other circumstances outside the control of the Custodian, prohibit the making of a payment.

The Management Company may in certain cases, subject to fair and equal treatment of the remaining Unitholders of

any Portfolio and by agreement with redeeming Unitholders, effect payment for redeemed Units of Portfolios in the
form of an assignment in kind of portfolio securities and other assets of the relevant Portfolio, provided that their
market value in an amount equivalent to the Redemption Price, or part thereof, will be verified by a special report of the
auditor of the Fund; provided that no redemption in kind shall be effected in the case of Unitholders resident in Spain.

The Management Company shall use its best efforts to maintain an appropriate level of liquidity in the assets of the

Portfolios so that redemption of the Units of the Portfolios under normal circumstances may be made without undue
delay after request by Unitholders. The Management Company shall, however, in exceptional circumstances when
sufficient liquidity is not available, be entitled, subject to obtaining the approval of the Custodian, to implement
redemption order only after the sale of corresponding assets of the relevant Portfolio of the Fund shall have been
effected without delay.

14. Charges of the Fund.
The Fund will bear the following charges:
– all taxes (including, without limitation, all income and franchise taxes) which may be due on or with respect to the

assets and the income of the Fund, including, without limitation, payment of the applicable Luxembourg «taxe d’abon-
nement», payable quarterly on the basis of the Value of the Net Assets of the Fund at the end of the relevant quarter;

– the usual banking fees due on transactions involving the securities or other assets held in the Portfolios of the Fund,

the cost of any brokerage commissions and the transactions related charges of any other banks or financial institutions
or clearing systems entrusted with custody of assets of the Fund;

– the remuneration of the Management Company (which shall include the fee payable by the Management Company

to the Investment Manager), expressed as a percentage (up to a maximum of 3 %) of the Net Assets of the Fund as
disclosed in the Prospectus, computed on each Valuation Date and payable monthly;

– the Registrar and Administration Agent shall be entitled from the Fund to their customary fees as agreed from time

to time in writing, including for services rendered in the determination of the Net Asset Value per Unit of all the
Portfolios and of the Offering and Redemption Prices per Unit of the relevant Portfolios in an authorized Payment
Currency;

– the reimbursement of all reasonable out-of-pocket expenses of the Registrar and Administration Agent and of the

Management Company and the reasonable fees and travel expenses of directors of the Management Company for
attending meetings of the Board;

– the remuneration (expressed as a percentage of the Net Asset of the Fund) and reimbursement of expenses of the

Custodian at customary rates, including the remuneration (other than transaction related charges) of Correspondents
and of clearing systems;

– legal expenses (including, without limitation, the fees and disbursements of counsel and other litigation costs) that

may be incurred by the Management Company, the Custodian, the Correspondents and the Registrar and
Administration Agent while acting in the interest of the Unitholders;

– the cost of any liability insurance or fidelity bonds covering any costs, expenses or losses arising out of any liability

of, or claim for damage or other relief asserted against, the Management Company, the Custodian, the Correspondents,
the Investment Manager or the Registrar and Administration Agent for violation of any law or failure to comply with
their respective obligations under these Management Regulations or otherwise with respect to the Fund;

– the cost of issuing Unit confirmations; the cost of preparing and/or filing, translating and publishing these

Management Regulations and all other documents concerning the Fund, including, without limitation, registration state-
ments, prospectuses and explanatory memoranda and any amendments thereto with the authorities (including, without
limitation, local securities dealers’ associations) in countries where Units are offered or sold in the relevant languages in
view of or with respect to any offering or sale of Units; the cost of preparing in such language as are required and
necessary for the benefit of the Unitholders, including, without limitations, the beneficial holders of the Units, and
distributing annual, semi-annual and such other reports or documents as may be required under these Management
Regulations or under the applicable laws or regulations of the above-cited authorities; the cost of accounting and
bookkeeping and of the calculation of the Net Asset Value per Unit in any Portfolio and their publications; the cost of
preparing, distributing and publishing notices to the Unitholders; lawyers’ and auditors’ and other experts’ fees in
connection with the foregoing; registration and listing fees and all similar administrative charges or taxes, including

461

without limitation, any stamp duties or other charges on Unit confirmations in those countries where applicable (except,
however, all advertising expenses and other expenses directly incurred in the offering or distribution of the Units
including, without limitation, the portion of printing costs of copies of the above-mentioned documents or reports which
are utilized by the Distributors of the Units in the course of their business activities).

Charges shall be allocated to the relevant Portfolio for which they were incurred or otherwise prorated to each of

them, based on objective criteria laid down in the Valuation Regulations approved by the Board.

All recurring charges will be charged first against income, then against capital gains, if any, and then against assets.

Organizational expenses and other similar charges may be amortized over a period not exceeding five years.

Disbursement for all charges shall be made by the Custodian (as instructed by the Management Company).
The Custodian shall pay to the Management Company, by debiting the accounts, only the remuneration provided for

in these Management Regulations. The Custodian shall debit the accounts, only with the consent of the Management
Company, for the remuneration and reimbursements owed to the Custodian under these Management Regulations,
provided this does not relate to those other expenses which are to be borne by the Fund pursuant to the provisions of
this clause 14 of these Management Regulations.

All costs (including brokerage fees) of purchasing or selling assets of the Fund and any losses incurred in connection

therewith, are for the account of the Fund in the relevant Portfolio.

15. Fiscal Year, Audit.
The Management Company shall maintain and supervise the records and books of accounts of the Fund. The fiscal

year and the books of the Fund will close each year on 31st December. The first fiscal year will begin on the date of
creation of the Fund and end on December 31, 1997.

The accounts and assets of the Management Company and of the Fund will be audited in respect of each fiscal year

by an auditor who shall be appointed by the Management Company and who will qualify as a «réviseur d’entreprises» in
Luxembourg and act independently. Within four months after the end of each fiscal year, the Management Company
shall have prepared and included as part of the annual report of the Fund the audited annual accounts of the Fund and
the results of operations for each of its Portfolios.

16. Dividends.
At the moment, the Management Company does not intend to make any distribution on account of any Portfolio and

any income will be accumulated to the relevant Portfolio. The Board may, however, decide if the Board considers that
it is in the best interests of the Unitholders, to pay annual dividends in respect of one or more Portfolios of Units
without limitations on the amount of the dividends, subject to the net assets of the Fund remaining within the amount
prescribed by law.

17. Amendment of the Management Regulations.
The Management Company and the Custodian may amend in whole or in part the Management Regulations by mutual

agreement between the Management Company and the Custodian. Each amendment will become effective five days after
its publication in the Mémorial.

Subject as provided here above, the Management Company, with the approval ot the Custodian, may take such action

and effect such modifications of the investment objective of a Portfolio and/or of the Investment Limitations as may be
permissible and/or necessary in order to qualify the Units for sale in various countries.

18. Notices and Publications.
The Net Asset Value per Unit and the Offering and Redemption Prices of each Portfolio on each Valuation Date will

be on display and may be obtained on request at the offices of the Registrar and Administration Agent. A statement of
account will be provided to each Unitholder at regular intervals as determined by the Board, and in no case, less than
once every year, showing all purchases, exchanges, redemptions, or stock dividends with respect to Units held by the
Unitholders during the preceding period, the Unit balance and the Net Asset Value per Unit for each Portfolio of Units
held by the Unitholders at the relevant date.

Within four months following the close of each fiscal year, the Management Company shall make available to the

Unitholders an audited annual report, and, within two months after the end of the first semi-annual period of each
financial year, the Management Company shall make available an unaudited semi-annual report, which reports shall
describe the assets, operations and results of each Portfolio and a summary of the consolidated results of the Fund;
copies shall be made available to the Unitholders by the Management Company or its designated agent as described in
the current prospectus.

The annual, semi-annual and any other reports (if any) of the Fund shall also be made available to the Unitholders at

the registered offices of the Registrar and Administration Agent.

Notices to Unitholders of the Fund will either be published in the Luxemburger Wort and in newspapers of countries

where the Units are offered or sold (insofar as required by applicable regulations), or sent to the Unitholders at their
addresses indicated in the register of Unitholders.

19. Duration of the Fund, Liquidation, Merger of Portfolios.
There is no limit to the duration of the Fund. The Fund may, however, be liquidated or any of its portfolios dissolved

or merged by reasons of changes in the economic environment, at any time by a decision of the Management Company
in agreement with the Custodian.

In case the net assets of the Fund have fallen below two thirds of the legal minimum, which is the equivalent in dollars

of 50 million Luxembourg francs, the Luxembourg supervisory authority may, having regard to all circumstances, compel
the Management Company to put the Fund into liquidation.

Furthermore, liquidation of the Fund shall take place if required according to Article 21 of the 1988 Law. As soon as

the event giving rise to liquidation occurs, no units of the underlying portfolios may be issued or redeemed (or

462

converted). Notice shall be published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations of Luxembourg and in at
least three newspapers with appropriate distribution to be determined by the Management Company or the Custodian,
one of which must be a newspaper issued in Luxembourg.

In the event of liquidation, the net liquidation proceeds of the Fund will be distributed to unitholders in proportion

to their respective holdings in the underlying portfolios in accordance with the 1988 Law. Liquidation proceeds which
cannot be distributed to unitholders shall be deposited at the close of liquidation with the «Caisse des Consignations»
for a period of 30 years.

As soon as the decision has been taken to close a Portfolio, no more Units of the Portfolio will be issued, converted

or redeemed. Notice to Unitholders of the respective Portfolio will be given in accordance with «Reports and Notices
to Unitholders» (see above). The Management Company will redeem the outstanding Units and reimburse the
Unitholders in proportion to their respective holdings as at the date of closure. Proceeds which cannot be distributed,
will be deposited at the close of liquidation of the Portfolio with the «Caisse des Consignations» for a period of 30 years.

By decision of the Management Company, in agreement with the Custodian, two or more Portfolios may be merged

together or with another Luxembourg undertaking for collective investments in transferable securities qualifying under
Part I of the 1988 Law. At least one month’s prior notice will be given to unitholders of the respective Portfolios in
accordance with the «Reports and Notices to Unitholders» (see above). Following the decision to merge no more units
of the respective portfolios will be issued. Unitholders not wishing to participate in the merger may request reimbur-
sement of their respective holdings during a period of one month following publication of the Notice, by contacting the
Management Company in writing and will be reimbursed, free of charge, at the applicable net asset value determined on
the day such instructions are deemed to have been received.

The liquidation or the partition of the Fund may not be requested by any Unitholder or by his heirs or beneficiaries.

20. Statute of Limitation.
Claims of the Unitholders against the Management Company or the Custodian will lapse five years after the date of

the event which gave rise to such claims, except as described under clause 19 with respect to the proceeds of liquidation.

21. Applicable Law, Jurisdiction and Governing Language.
These Management Regulations are governed by and shall be construed in accordance with the laws of Luxembourg.
Any legal disputes arising among or between the Unitholders, the Management Company and the Custodian or any

of them, shall be subject to the jurisdiction of the district court in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, provided
that the Management Company and the Custodian may agree to or elect to submit themselves and the Fund to the juris-
diction of courts of the countries in which Units are offered and sold, with respect to claims by investors resident in such
countries and with respect to matters relating to the subscription, exchange and redemption of Units by investors or
Unitholders resident in or evidently solicitated from such countries, to the laws of such countries.

These Management Regulations have been established in the English language. In case of a conflict between the English

text and a text in any other language, the English text shall prevail.

22. Responsibility of the Management Company and of the Custodian.
The Management Company and the Custodian shall be responsible in accordance with Articles 14 and 18 of the 1988

Law respectively.

December 9, 1996

CENTRAL HISPANO GESTION LUXEMBOURG S.A.

CITIBANK (LUXEMBOURG) S.A.

Signature

P. Goodman

<i>Vice-Président

Enregistré à Luxembourg, le 23 décembre 1996, vol. 488, fol. 2, case 10. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(46592/267/672)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 1996.

INCOMMERCE S.A., Aktiengesellschaft.

Gesellschaftssitz: L-4081 Esch-sur-Alzette, 5, rue Dicks.

Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am zwanzigsten September.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtswohnsitz in Niederanven,
Versammelten sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter, beziehungsweise deren

Vertreter, der Aktiengesellschaft INCOMMERCE S.A., mit Sitz in Bettemburg, gegründet gemäss Urkunde, aufge-
nommen durch den amtierenden Notar, am 11. März 1996, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés
et Associations, Nummer 271 vom 4. Juni 1996.

Die Versammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Herrn Théodore Bradara, Privatbeamter, wohnhaft in

Bettemburg.

Der Vorsitzende beruft zum Schriftführer Frau Zulfija Pramenkovic, Hausfrau, Ehegattin von Herrn Nailj Desta-Novic,

wohnhaft in Wiltz, 79, Aneschbach.

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmenzähler Herrn Nailj Destaovic, Kaufmann, wohnhaft in Wiltz, 79,

Aneschbach.

Der Vorsitzende stellt unter der Zustimmung der Versammlung fest:
1. Die Aktionäre sowie deren etwaigen bevollmächtigte Vertreter, sind unter der Stückzahl der vertretenen Aktien

auf einer Anwesenheitsliste eingetragen.

463

2. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Aktienkapital in gegenwärtiger Versammlung vertreten

ist, und dass somit die Versammlung befugt ist, über nachstehende Tagesordnung, welche den Aktionären bekannt ist,
zu beschliessen.

Die Anwesenheitsliste, von den Mitgliedern des Versammlungsvorstandes und dem instrumentierenden Notar ne

varietur unterzeichnet, bleibt ebenso wie die von den Parteien und dem instrumentierenden Notar ne varietur unter-
zeichneten etwaigen Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregis-
triert werden, als Anlage beigebogen.

3. Die Tagesordnung hat folgenden Wortlaut:

<i>Tagesordnung: 

1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-3249 Bettembourg, 119, rue J. F. Kennedy nach L-4081 Esch-sur-Alzette,

5, rue Dicks.

2. Abänderung des ersten Absatzes von Artikel zwei der Satzung.
3. Ersetzung eines der beiden delegierten Verwaltungsratsmitgliedern.
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz von L-3249 Bettembourg, 119, rue J. F. Kennedy nach L-4081

Esch-sur-Alzette, 5, rue Dicks, zu verlegen.

<i>Zweiter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, den ersten Absatz von Artikel zwei abzuändern wie folgt:
«Art. 2. Erster Absatz. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Esch-sur-Alzette.»

<i>Dritter Beschluss

Die Versammlung beschliesst die Ersetzung einer der delegierten Verwaltungsratsmitglieder, Frau Zulfija Pramen-

kovic, vorgenannt, und erteilt ihr hiermit Quittung und Entlast.

An deren Stelle wird ernannt, Herrn Zekerija Zenovic, Maschinenbauer, wohnhaft in Wiltz, 73, Aneschbach.
Alle Beschlüsse wurden einzeln und einstimmig gefasst.
Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf fünfundzwanzigtausend

Franken (25.000,-) abgeschätzt.

Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Niederanven, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Komparenten, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vomamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: T. Bradara, Z. Pramenkovic, N. Destanovic, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 25 septembre 1996, vol. 390S, fol. 45, case 3. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Für gleichlautende Ausfertigung der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Niederanven, den 18. Oktober 1996.

P. Bettingen.

(38898/202/60)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.882.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize octobre.
Par-devant Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société INDICAN HOLDING S.A., avec siège

social à Luxembourg, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 23 septembre 1994, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 5 janvier 1995, numéro 6.

La séance est présidée par Monsieur Richard De Giorgi, employé privé, demeurant à B-Arlon,
qui désigne comme secrétaire, Madame Martine Mergen, employée privée, demeurant à Luxembourg.
L’assemblée élit comme scrutateur:
Madame Eliane Irthum, employée privée, demeurant à Walferdange.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter que:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d’actions qu’ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence, signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et
le notaire instrumentaire. La liste de présence ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui à la formalité de l’enregistrement.

II.- Il résulte de la liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1.250) actions, représentant l’intégralité

du capital social, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que
l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.

III.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

464

<i>Ordre du jour:

1.- Acceptation de la démission des administrateurs et nomination de leurs remplaçants.
2.- Décharge des administrateurs.
3.- Ajout à la fin de l’article 10:
«Le conseil d’administration a besoin de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires pour

prendre les décisions suivantes:

a) consentir des avances et des prêts à ses filiales ou succursales;
b) acquérir ou vendre toute participation dans des sociétés de capitaux;
c) conférer des garanties à ses filiales ou succursales.»
4.- Divers.
L’assemblée ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend, à l’unanimité, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée accepte la démission des administrateurs, à savoir:
1.- Monsieur Paolo Rossi, 
2.- Monsieur Paolo Dermitzel,
3.- Madame Liliane Bettoldi. 
L’assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
1.- Monsieur François Mesenburg, employé privé, demeurant à Biwer,
2.- Monsieur Jean-Robert Bartolini, employé privé, demeurant à Differdange,
3.- Monsieur Jacques-Emmanuel Lebas, licencié en droit, demeurant à Luxembourg.
Leur mandat expirera immédiatement après l’assemblée générale statutaire de 2000.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée donne pleine et entière décharge aux administrateurs.

<i>Troisième résolution

L’assemblée décide d’ajouter à la fin de l’article 10 l’alinéa suivant:
«Le conseil d’administration a besoin de l’autorisation préalable de l’assemblée générale des actionnaires pour

prendre les décisions suivantes:

a) consentir des avances et des prêts à ses filiales ou succursales;
b) acquérir ou vendre toute participation dans des sociétés de capitaux;
c) conférer des garanties à ses filiales ou succursales.»
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom, état

et demeure, les comparants ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: R. De Giorgi, M. Mergen, E. Irthum, E. Schroeder.
Enregistré à Mersch, le 18 octobre 1996, vol. 400, fol. 41, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): W. Kerger.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 novembre 1996.

E. Schroeder.

(38899/228/66)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 48.882.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Mersch, le 4 novembre 1996.

E. Schroeder.

(38900/228/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

GRUPPO ORIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R. C. Luxembourg B 29.998.

Les comptes annuels au 31 décembre 1991, enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 1996, vol. 486, fol. 25, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 1996.

<i>Pour la S.A. GRUPPO ORIA

<i>INTERNATIONAL

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.C.

(39250/503/12)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

465

GENERALE DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, Imacorp Business Centre, 25B, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 51.950.

Le bilan au 31 juillet 1996, enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 21, case 3, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

IMACORP S.A.

Signature

(38894/700/10)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

GERANCE INTERNATIONALE DE FONDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 31, Grand-rue.

R. C. Luxembourg B 46.062.

Par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 1996, la démission de l’administrateur M. Marcel

Weicker a été acceptée. Il n’a pas été pourvu à son remplacement. KPMG, Luxembourg, a été appelée aux fonctions de
commissaire aux comptes en remplacement de Mme Myriam Spiroux-Jacoby, démissionnaire. Son mandat s’achèvera à
l’issue de l’assemblée générale ordinaire de 1999.

Luxembourg, le 31 octobre 1996.

<i>Pour GERANCE

<i>INTERNATIONALE

<i>DE FONDS S.A.

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

S. Wallers

J.-M. Schiltz

Enregistré à Luxembourg, le 4 novembre 1996, vol. 486, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(38895/006/19)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

GESSALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2665 Luxembourg, 8, rue du Verger.

R. C. Luxembourg B 38.279.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 31 octobre 1996, vol. 486, fol. 17, case 2, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 novembre 1996.

Signature.

(38896/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 novembre 1996.

GREENBACK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 124, rue du Kiem.

R. C. Luxembourg B 45.593.

<i>Extrait des résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 26 avril 1996

«. . . La société SCHAER ET ASSOCIES S.A., Genève, a été nommée commissaire aux comptes en remplacement de

GRANT THORNTON REVISION ET CONSEILS S.A., Luxembourg.»

<i>Pour la société

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 17 octobre 1996, vol. 485, fol. 67, case 11. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39249/668/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

GARBUIO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 44.770.

Les comptes annuels au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 6 novembre 1996, vol. 486, fol. 29, case 2,

a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 1996.

<i>GARBUIO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

(39243/545/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

466

GARBUIO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.

R. C. Luxembourg B 44.770.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l’Assemblée Générale Statutaire du 20 juin 1996

Messieurs C. Tognana, A. de Bernardi et L. Bonani sont renommés administrateurs pour une nouvelle période de

trois ans. Monsieur A. Schaus est renommé commissaire aux comptes pour la même période. Leurs mandats viendront
à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1999.

Pour extrait sincère et conforme

<i>GARBUIO INTERNATIONAL HOLDING S.A.

FIDUCIAIRE MANACO S.A.

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1996, vol. 486, fol. 29, case 1. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39244/545/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

GANSEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6839 Lellig, 1, Neie Wée.

R. C. Luxembourg B 49.835.

Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Grevenmacher, le 4 novembre 1996, vol. 165, fol. 6, case 3, a été déposé

au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lellig, le 31 octobre 1996.

Signature.

(39242/000/9)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

GEFA S.A., Gesellschaft für Fassadenreinigung, Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 62A, rue des Muguets.

R. C. Luxembourg B 41.844.

EXTRAIT

L’assemblée générale du 4 octobre 1996 a nommé Mme Vve Elyse Leroi, demeurant à Luxembourg comme adminis-

trateur de la société en remplacement de Monsieur Gilbert Grosbusch.

Il résulte du procès-verbal du Conseil d’Administration tenue en date du 21 octobre 1996 que Monsieur Robert

Weyland, demeurant à L-2145 Luxembourg, rue Cyprien Merjai, a été nommé administrateur-délégué de la société et
est par conséquent autorisé à exercer la gestion journalière de la société avec effet rétroactif au 1

er

juin 1996.

Luxembourg, le 30 octobre 1996.

Pour extrait conforme

Signature

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1996, vol. 486, fol. 28, case 9. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39245/507/16)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

HAWK FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le seize septembre.
Par-devant Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, soussigné.
S’est réunie l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme HAWK FINANCE S.A.,

avec siège social à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 13 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 138 du 28 mars 1995.

L’assemblée est présidée par Monsieur Gérard Matheis, MBA, demeurant à Olm.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Monsieur Dennis Bosje, comptable demeurant à Luxembourg
et désigne comme secrétaire, Monsieur Cornelius Bechtel, employé privé, demeurant à Howald.
Le bureau ayant été ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d’acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour 

<i>Ordre du jour:

1) Augmentation du capital social à raison de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- Frs), pour le porter de

son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- Frs) à la somme de trois millions sept cent
cinquante mille francs (3.750.000,- Frs), par la création et l’émission de deux mille cinq cents (2.500) actions nouvelles
d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- Frs) chacune.

2) Renonciation des actionnaires actuels à leur droit de souscription préférentiel.
3) Souscription et libération en numéraire des deux mille cinq cents (2.500) actions nouvellement créées.

467

4) Modification afférente de l’article 3 des statuts.
Il.- Que les actionnaires présents ainsi que le nombre d’actions qu’ils détiennent sont indiqués sur une liste de

présence, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires présents et les membres du bureau, restera
annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Qu’il résulte de ladite liste de présence que l’intégralité du capital social est représentée.
III.- Qu’en conséquence, la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les

points portés à l’ordre du jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette demière, après délibération, prend, à l’unanimité, les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide d’augmenter le capital social à raison de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- Frs), pour

le porter de son montant actuel d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- Frs) à la somme de trois
millions sept cent cinquante mille francs (3.750.000,- Frs), par la création et l’émission de deux mille cinq cents (2.500)
actions nouvelles d’une valeur nominale de mille francs (1.000,- Frs) chacune.

Pour autant que de besoin, les actionnaires actuels déclarent expressément renoncer à leur droit de souscription

préférentiel.

<i>Souscription et libération

Les deux mille cinq cents (2.500) actions nouvellement émises sont intégralement souscrites de l’accord de tous les

actionnaires par la société anonyme INTERTRUST (LUXEMBOURG) S.A., ayant son siège social à L-2520 Luxembourg,
21, allée Scheffer.

Le montant de deux millions cinq cent mille francs (2.500.000,- Frs.) a été apporté en numéraire, de sorte que le

prédit montant se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire qui le
constate expressément.

<i>Deuxième résolution

A la suite de la décision qui précède, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3 des statuts qui aura désormais

la teneur suivante:

«Art. 3.  Le capital social est fixé à trois millions sept cent cinquante mille francs (3.750.000,- Frs), divisé en trois mille

sept cent cinquante (3.750) actions de mille francs (1.000,- Frs) chacune.»

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes, s’élève

approximativement à cinquante mille francs.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs nom, prénom usuel,

état et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. Matheis, D. Bosje, C. Bechtel, J. Seckler. 
Enregistré à Grevenmacher, le 18 septembre 1996, vol. 498, fol. 88, case 9. – Reçu 25.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 5 novembre 1996.

J. Seckler.

(39252/231/65)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

HAWK FINANCE S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 7 novembre 1996.

J. Seckler.

(39253/231/7)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

HERSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 30, rue Beaumont.

R. C. Luxembourg B 43.321.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 5 novembre 1996, vol. 486, fol. 25, case 12,

ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 novembre 1996.

<i>Pour la S.à r.l. HERSE

FIDUCIAIRE CENTRALE DU

LUXEMBOURG S.C.

(39254/503/11)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

468

GOPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 27, rue Philippe II.

R. C. Luxembourg B 41.026.

Il résulte d’un acte sous-seing privé en date du 31 octobre 1996, portant cession de parts sociales de la S.à r.l. GOPE,

enregistré à Luxembourg, le 1

er

novembre 1996, vol. 486, fol. 30, case 1

que les parts sociales sont réparties comme suit:
1. Monsieur Joao Manuel Gasparinho Pedro, agent d’assurances, demeurant à Howald, 306A, route de Thionville,

quatre-vingt-dix parts ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

90

2. Mademoiselle Maria Da Conceicao Rodrigues Barbosa, serveuse, demeurant à Luxembourg, 32, rue Michel

Rodange, dix parts sociales ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    10

Total: cent parts sociales …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100
et que sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1. Mademoiselle Maria Da Conceicao Rodrigues Barbosa, préqualifiée, comme gérante technique.
2. Monsieur Joao Manuel Gasparinho Pedro, préqualifié, comme gérant administratif.
La société sera engagée par la signature conjointe de ses deux gérants.

M

e

C. Scott.

(39248/000/18)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

GT DEUTSCHLAND FUND, SICAV, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2953 Luxembourg, 2, boulevard Royal.

R. C. Luxembourg B 25.023.

Le bilan au 31 mars 1996, enregistré à Luxembourg, le 23 octobre 1996, vol. 485, fol. 85, case 1, a été déposé au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 novembre 1996.

<i>Pour GT DEUTSCHLAND FUND, SICAV

BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG

Société Anonyme

Signatures

(39251/006/13)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

MAITRE MESURE, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2721 Luxembourg, rue Alphonse Weicker (Centre Auchan).

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Reginald Neuman, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1.- Monsieur Jean-Michel Tournoys, gérant de société, demeurant à Villeneuve d’Ascq (France),
2.- Monsieur Jacques Leurs, directeur de société, demeurant à Villeneuve d’Ascq (France),
ici représenté par Monsieur Jean-Michel Tournoys, préqualifié, aux termes d’une procuration sous seing privé donnée

à Lille (France), le 22 octobre 1996, ci-annexée.

Lesquels comparants, ès qualités qu’il agissent, ont requis le notaire instrumentaire de documenter, ainsi qu’il suit, les

statuts d’une société à responsabilité limitée qu’ils déclarent constituer entre eux.

Art. 1

er

Entre les parties ci-avant désignées et toutes celles qui deviendraient par la suite propriétaires des parts

sociales ci-après créées, il est formé une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, régie par les présents
statuts et la législation luxembourgeoise afférente.

Art. 2. La société prend la dénomination de MAITRE MESURE.
Art. 3. La société a pour objet:
L’achat, la vente, la confection, en gros ou en détail, de tous articles textiles dans le domaine de l’habillement homme,

femme, enfant et de tous accessoires se rapportant à la parure de la personne;

Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher direc-

tement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes;

La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à crééer, pouvant se

rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandite, souscription ou
rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation ou groupement d’intérêts économique
ou de location gérance.

Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une décision des

associés.

469

Art. 5. Le capital social est fixé à cinq cent mille (500.000,-) francs luxembourgeois, représenté par cinq cents (500)

parts sociales de mille (1.000,-) francs luxembourgeois chacune.

Ces parts ont été soucrites comme suit par:
1.- Monsieur Jean-Michel Tournoys, gérant de société, demeurant à Villeneuve d’Ascq (France), quatre cent

quatre-vingt-quinze parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

495

2.- Monsieur Jacques Leurs, directeur de société, demeurant à Villeneuve d’Ascq (France), cinq parts sociales

    5

Total: cinq cents parts sociales ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

500

Les associés déclarent et reconnaissent que le montant du capital est entièrement libéré en numéraire et se trouve

dès à présent à la disposition de la société.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses mains, la société est une société

unipersonnelle au sens de l’article 179(2) de la loi sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité, les articles 200-
1 et 200-2 entre autres, de la même loi sont d’application.

Art. 6. Les copropriétaires indivis de parts sociales, les nus-propriétaires et les usufruitiers sont tenus de se faire

représenter auprès de la société par une seule et même personne agréée préalablement par décision des associés, prise
à la majorité des trois quarts du capital. L’agrément ne pourra être refusé que pour de justes motifs.

Art. 7. La société est constituée pour une durée illimitée.
Sans préjudice de ce qui précède, la société pourra être dissoute à tout instant par décision des associés.
Art. 8. Les parts sociales sont librement transmissibles pour cause de mort, même par disposition de dernières

volontés, à condition que ce soit en ligne directe ou au conjoint survivant. Tout autre bénéficiaire devra être agréé par
une décision prise à la majorité de trois quarts du capital social appartenant aux associés survivants. En cas de refus, le
bénéficiaire devra procéder conformément à l’article neuf des statuts, à l’exclusion de l’alinéa d), et sera lié par le résultat
de l’expertise. Au cas où aucun associé n’est disposé à acquérir les parts au prix fixé, le bénéficiaire sera associé de plein
droit.

Art. 9. a) Si un associé se propose de céder tout ou partie de ses parts sociales, de même que dans les cas prévisés

à l’article huit, il doit les offrir à ses coassociés proportionnellement à leur participation dans la société.

b) En cas de désaccord persistant des associés sur le prix après un délai de deux semaines, le ou les associés qui

entendent céder les parts, le ou les associés qui se proposent de les acquérir et le président du tribunal de commerce
de Luxembourg chargeront de part et d’autre un expert pour fixer la valeur de cession, en se basant sur la valeur vénale
des parts.

c) La société communique par lettre recommandée le résultat de l’expertise à tous les associés, en les invitant à faire

savoir dans un délai de quatre semaines s’ils sont disposés à acheter ou céder les parts au prix arrêté. Si plusieurs
associés déclarent vouloir acquérir les parts proposées à la vente, elles seront offertes aux associés qui entendent les
acquérir en proportion de leur participation dans la société. Le silence des associés pendant le prédit délai de quatre
semaines équivaut à un refus.

d) Dans ce cas, l’associé qui entend les céder peut les offrir à des non-associés, étant entendu qu’un droit de

préemption est encore réservé aux autres associés en proportion de leur participation pendant un délai de deux
semaines à partir de la date de la communication de l’accord avec des tiers et suivant les conditions de celui-ci. L’article
189 de la loi sur les sociétés commerciales est remplacé par les articles huit et neuf des présents statuts.

e) Les dispositions qui précèdent seront applicables à tous les cas de cession, même à celles qui auraient lieu par

adjudication publique, en vertu de décision de justice ou autrement.

Art. 10. La société peut, sur décision de l’assemblée générale, prise à la majorité du capital social, procéder au rachat

de ses propres parts sociales au moyen de réserves libres ainsi qu’à leur revente. Ces parts sociales, aussi longtemps
qu’elles se trouvent dans le patrimoine de la société, ne donnent droit ni à un droit de vote, ni à des dividendes, ni à une
part du produit de la liquidation et elles ne sont pas prises en considération pour l’établissement d’un quorum. En cas de
revente, la société procédera suivant les dispositions de l’article neuf.

Art. 11. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Ils sont nommés et peuvent être

révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions, et qui statue
à la majorité du capital. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.

Les gérants ont le droit, mais seulement collectivement et à l’unanimité, de déléguer une partie de leurs pouvoirs à

des fondés de pouvoirs et/ou à des directeurs.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles soient adoptées par des

associés représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des
statuts ne pourront être prises qu’à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

Art. 13. Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment dans la localité du siège social

par chaque gérant et chaque commissaire, et par des associés représentant ensemble un dixième au moins du capital
social.

Les convocations à toute assemblée générale se font par envoi de lettres recommandées envoyées huit jours francs

avant la date prévue et doivent indiquer l’ordre du jour.

Art. 14. La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, si des associés détenant

ensemble un quart du capital le demandent.

Art. 15. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les gérants en exercice, à moins que

l’assemblée générale des associés n’en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après apurement de l’inté-
gralité du passif, sera réparti entre les propriétaires des parts sociales, au prorata du nombre de leurs parts.

470

Art. 17. Pour tout ce qui n’est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commence le jour de la constitution de la société et se terminera le 31 décembre 1997.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève à environ trente mille (30.000.-) francs luxembourgeois.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature:
Monsieur Jean-Michel Tournoys, gérant de société, demeurant à Villeneuve d’Ascq (France).
- L’adresse du siège social est fixée à L-2721 Luxembourg, rue Alphonse Weicker (Centre Auchan).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs nom, prénom usuel, état

et demeure, ils ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J.-M. Tournoys, R. Neuman.
Enregistré à Luxembourg, le 25 octobre 1996, vol. 93S, fol. 100, case 10. – Reçu 5.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour copie conforme, délivrée à ladite société aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-

tions.

Luxembourg, le 5 novembre 1996.

R. Neuman.

(39352/226/125)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 1996.

ITERACTUSVIA S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue J.P. Pescatore.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-quatre octobre.
Par-devant Maître Paul Frieders, notaire de résidence à Luxembourg.

Ont comparu:

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324

Luxembourg, 4, avenue Jean Pierre Pescatore,

représentée par Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg;
2) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d’acter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme

qu’ils vont constituer entre eux:

Titre I

er

.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1

er

Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ITERACTUSVIA S.A.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg.
Lorsque des événements extraordinaires d’ordre politique ou économique, de nature à compromettre l’activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l’étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l’étranger jusqu’à cessation complète de ces circonstances
anormales.

Toutefois, cette mesure ne pourra pas avoir d’effet sur la nationalité de la société. Cette déclaration de transfert du

siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l’organe de la société le mieux placé pour agir dans de
telles circonstances.

Art. 3. La société est établie pour une durée illimitée.
Art. 4. La société a pour objet la prise d’intérêts, sous quelque forme ce soit, dans d’autres entreprises luxembour-

geoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription et de toute autre
manière ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de toutes valeurs mobilières et de toutes
espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts. La société pourra prendre part à l’établis-
sement et au développement de toute entreprise industrielle ou commerciale et pourra prêter assistance à pareille
entreprise au moyen de prêts, de garanties ou autrement. Elle pourra prêter ou emprunter avec ou sans intérêts,
émettre des obligations et autres reconnaissances de dettes.

Elle pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières

au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger, qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en partie,
à son objet social.

Elle peut réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association en effectuant toute opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

471

D’une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et de son but.

Titre II.- Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF), représenté par mille

(1.000) actions d’une valeur nominale de mille deux cent cinquante francs (1.250,- LUF) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire. La société peut procéder au rachat de ses

propres actions sous les termes et conditions prévus par la loi.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Titre III.- Conseil d’administration

Art. 6. La société est administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, actionnaires

ou non, nommés pour un terme qui ne peut pas excéder six ans par l’assemblée générale des actionnaires qui peut les
révoquer à tout moment.

Le nombre des administrateurs, la durée de leur mandat et leur rémunération seront fixés par l’assemblée générale

des actionnaires.

Art. 7. Le conseil d’administration élira parmi ses membres un président.
Le conseil d’administration sera convoqué par le président, aussi souvent que l’intérêt de la société le requiert. Il doit

être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d’administration et

de disposition en conformité avec l’objet social.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l’assemblée générale des actionnaires

sont de la compétence du conseil d’administration. Le conseil d’administration est autorisé à payer des acomptes sur
dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 9. La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs, à moins

que des décisions spéciales n’aient été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de
procurations données par le conseil d’administration conformément à l’article 10 des présents statuts.

Art. 10. Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs pour la gestion journalière de la société à un ou

plusieurs administrateurs, qui peuvent être nommés administrateurs-délégués.

Il peut aussi conférer la gestion de toutes les affaires de la société ou d’un département spécial à un ou plusieurs direc-

teurs et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses
propres membres ou non, actionnaires ou non.

La délégation à un membre du conseil d’administration est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée

générale.

Art. 11. Tous procès impliquant la société tant en demandant qu’en défendant, seront traités au nom de la société

par le conseil d’administration, représenté par son président ou par un administrateur délégué à cet effet.

Titre IV.- Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l’assemblée générale des actionnaires

qui fixera leur nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur fonction qui ne pourra pas excéder six ans.

Titre V.- Assemblée générale

Art. 13. L’assemblée générale annuelle se tiendra à Luxembourg, à l’endroit indiqué dans les convocations, le 10 mars

de chaque année à 10.00 heures et pour la première fois en 1997.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices

Art. 14. L’année sociale de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

à l’exception du premier exercice social, qui commence le jour de la constitution de la société et qui finira le trente et
un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Art. 15. L’excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges de la société et des amortissements, forme

le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net, cinq pour cent (5%) seront affectés à la réserve légale; ce prélèvement
cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devra être repris
jusqu’à entière reconstitution si, à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve a été
entamé.

Le solde est à la disposition de l’assemblée générale.

Titre VII.- Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l’assemblée générale des actionnaires. En cas de dissolution de

la société, la liquidation s’effectuera par un ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par
l’assemblée générale des actionnaires, qui déterminera leurs pouvoirs et fixera leur rémunération.

Titre VIII.- Dispositions générales

Art. 17. Pour tous les points non réglés par les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du

10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses lois modificatives.

472

<i>Souscription et libération

Les statuts de la société ayant été ainsi constitués, les comparants déclarent souscrire l’intégralité du capital comme

suit:

1) LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, préqualifiée, neuf
cent quatre-vingt-dix-neuf actions ………………………………………………………………………………………………………………………………………

999

2) Monsieur Federigo Cannizzaro, préqualifié, une action ……………………………………………………………………………………………       1
Total: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.000
Toutes les actions ont été intégralement libérées par des apports en espèces, de sorte que la somme d’un million

deux cent cinquante mille francs (1.250.000,- LUF) se trouve dès maintenant à la libre et entière disposition de la société,
la preuve ayant été fournie au notaire instrumentaire.

<i>Constatation

Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué approximativement à cinquante mille francs (50.000,-
LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant l’intégralité du capital social souscrit et se considérant comme dûment

convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris, à l’unanimité, les résolu-

tions suivantes:

1.- Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires à un.
2.- Sont nommés administrateurs:
a) Monsieur Alexis Kamarowsky, directeur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
b) Monsieur Federigo Cannizzaro, juriste, demeurant à Luxembourg,
c) Monsieur Jean-Marc Debaty, directeur de sociétés, demeurant à Ans (Belgique).
3.- Est nommée commissaire aux comptes:
LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A., en abrégé INTERCONSULT, avec siège social à L-2324

Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.

4.- Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de l’an 2001.
5.- Le siège social de la société est fixé à L-2324 Luxembourg, 4, avenue Pescatore.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par leurs nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Kamarowsky, F. Cannizzaro, P. Frieders.
Enregistré à Luxembourg, le 30 octobre 1996, vol. 94S, fol. 9, case 3. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

Pour expédition conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations.

Luxembourg, le 6 novembre 1996.

P. Frieders.

(39350/212/156)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 1996.

MISTY FJORDS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.

STATUTS

L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le trente octobre.
Par-devant Maître Alphonse Lentz, notaire de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. CARFOLD TRADING S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République de Panama),

ici représentée par Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procu-
ration donnée à Panama, le 9 juin 1994;

2. AMAKA FINANCING S.A., société de droit panaméen, ayant son siège social à Panama (République de Panama),

ici représentée par Monsieur Yves Schmit, comptable, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à
Panama, le 7 mai 1996.

Lesquels comparants, aux termes de la capacité avec laquelle ils agissent, ont requis le notaire instrumentaire

d’arrêter, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société qu’ils déclarent constituer entre eux comme suit:

Art. 1

er

Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,

une société sous forme d’une société anonyme, sous la dénomination de MISTY FJORDS S.A.

473

La société est constituée pour une durée indéterminée.
Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché

de Luxembourg qu’à l’étranger.

Art. 2. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placement, l’acquisition par achat, souscription ou de toute
autre manière, ainsi que l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets
et autres valeurs de toutes espèces, l’administration, le contrôle et le développement de telles participations.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, et lui prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.

La société peut prêter ou emprunter sous toutes les formes, avec ou sans intérêts, et procéder à l’émission d’obliga-

tions, toutes activités bancaires exceptées.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations mobilières et immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d’immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement, en son nom propre ou pour le compte de tiers, seule ou

en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.

Plus particulièrement, la société pourra acquérir tous meubles et immeubles principalement à caractère commercial.
D’une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opéra-

tions qu’elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.

Art. 3.

Le capital social de la société est fixé à un million deux cent cinquante mille francs luxembourgeois

(1.250.000,- LUF), représenté par mille deux cent cinquante (1.250) actions d’une valeur nominale de mille francs luxem-
bourgeois (1.000,- LUF) chacune, entièrement libérées.

Le capital autorisé est fixé à dix millions de francs luxembourgeois (10.000.000,- LUF), représenté par dix mille

(10.000) actions d’une valeur nominale de mille francs luxembourgeois (1.000,- LUF) chacune.

Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts, ainsi qu’il est précisé à l’article 6 ci-
après.

En outre, le conseil d’administration est, pendant une période de cinq ans à partir de la date des présents statuts,

autorisé à augmenter en temps qu’il appartiendra le capital souscrit à l’intérieur des limites du capital autorisé, même par
des apports autres qu’en numéraire. Ces augmentations du capital peuvent être souscrites et émises avec ou sans prime
d’émission, ainsi qu’il sera déterminé par le conseil d’administration en temps qu’il appartiendra. Le conseil d’adminis-
tration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires antérieurs un droit
préférentiel de souscription des actions à émettre.

Le conseil d’administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir, ou toute autre personne

dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir en paiement le prix des actions représentant tout ou
partie de cette augmentation.

La société peut racheter ses propres actions dans les termes et aux conditions prévus par la loi.

Art. 4. Les actions de la société sont nominatives ou au porteur, ou en partie dans l’une ou l’autre forme, au choix

des actionnaires, sauf dispositions contraires de la loi.

La société ne reconnaît qu’un propriétaire par action. S’il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit

de suspendre l’exercice de tous les droits y attachés jusqu’à ce qu’une seule personne ait été désignée comme étant à
son égard propriétaire.

Art. 5. L’assemblée des actionnaires de la société régulièrement constituée représentera tous les actionnaires de la

société. Elle aura les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la
société.

Art. 6. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra à Luxembourg, au siège social de la société, ou à

tout autre endroit à Luxembourg qui sera fixé dans l’avis de convocation, le premier lundi du mois de mars à 15.00
heures et pour la première fois en mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Si ce jour est un jour férié légal, l’assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi, les décisions d’une assemblée des actionnaires dûment

convoqués sont prises à la majorité simple des actionnaires présents et votants.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés lors d’une assemblée des actionnaires, et s’ils déclarent

connaître l’ordre du jour, l’assemblée pourra se tenir sans avis de convocation ni publication préalables.

Art. 7. La société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois membres au moins, qui n’ont

pas besoin d’être actionnaires de la société.

Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle pour une période qui ne

pourra pas excéder six ans et resteront en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs aient été élus.

Art. 8. Le conseil d’administration peut choisir en son sein un président et un vice-président. Il pourra également

choisir un secrétaire qui n’a pas besoin d’être administrateur et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des
réunions du conseil d’administration et des assemblées générales des actionnaires.

474

Le conseil d’administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué

dans l’avis de convocation.

Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou

par câble, télégramme, télex ou téléfax un autre administrateur comme son mandataire.

Le conseil d’administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des
administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

En cas de parité des voix, la voix du président sera prépondérante.
Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu’une

décision prise à une réunion du conseil d’administration.

Art. 9. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus larges pour passer tous actes d’administration et

de disposition dans l’intérêt de la société. Tous pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale
des actionnaires sont de la compétence du conseil d’administration.

Le conseil d’administration pourra déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière des affaires de la société et à

la représentation de la société pour la conduite des affaires, avec l’autorisation préalable de l’assemblée générale des
actionnaires, à un ou plusieurs membres du conseil ou à un comité (dont les membres n’ont pas besoin d’être adminis-
trateurs), agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le conseil déterminera. Il pourra également conférer tous
pouvoirs et mandats spéciaux à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être administrateurs, nommer et révoquer tous
fondés de pouvoir et employés, et fixer leurs émoluments.

Art. 10. La société sera engagée par la signature collective de deux administrateurs ou la seule signature de toute

personne à laquelle pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil d’administration.

Art. 11. Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires aux comptes qui n’ont pas

besoin d’être actionnaires. L’assemblée générale des actionnaires désignera les commissaires aux comptes et déter-
minera leur nombre, leur rémunération et la durée de leurs fonctions qui ne pourra pas excéder six ans.

Art. 12. L’exercice social commencera le premier janvier de chaque année et se terminera le trente et un décembre

de la même année, sauf toutefois le premier exercice social qui commencera le jour de la constitution et se terminera
le trente et un décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize. 

Art. 13. Sur le bénéfice annuel net de la société, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour le fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social, tel que
prévu à l’article 3 des statuts ou tel qu’il aura été augmenté ou réduit tel que prévu à l’article 3 des présents statuts.

L’assemblée générale des actionnaires déterminera, sur proposition du conseil d’administration, de quelle façon il sera

disposé du solde du bénéfice annuel net.

Dans le cas d’actions partiellement libérées, des dividendes seront payables proportionnellement au montant libéré

de ces actions.

Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.

Art. 14. En cas de dissolution de la société, il sera procédé à la liquidation par les soins d’un ou de plusieurs liqui-

dateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) nommés par l’assemblée générale des actionnaires qui
déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se réfèrent aux disposi-

tions de la loi du dix août mil neuf cent quinze concernant les sociétés commerciales et aux lois modificatives.

<i>Souscription et libération

Les comparants ont souscrit un nombre d’actions et ont libéré en espèces les montants suivants:

Actionnaires

Capital

Capital

Nombre

souscrit

libéré

d’actions

1. CARFOLD TRADING S.A., prénommée …………………………………………………………

1.249.000

1.249.000

1.249

2. AMAKA FINANCING S.A., prénommée……………………………………………………………

      1.000

      1.000

      1

Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………

1.250.000

1.250.000

1.250

Preuve de tous ces paiements a été donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme d’un million deux cent

cinquante mille francs luxembourgeois (1.250.000,- LUF) se trouve à l’entière disposition de la Société.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du dix août mil

neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est approximativement estimé à la somme de soixante mille
francs (60.000,- LUF).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les personnes ci-avant désignées, représentant l’intégralité du capital souscrit et se considérant comme dûment

convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que cette assemblée était régulièrement constituée, elles ont pris, à l’unanimité, les résolutions

suivantes:

475

1. Le nombre des administrateurs est fixé à trois et celui des commissaires aux comptes à un.
2. Ont été appelés aux fonctions d’administrateur:
- Madame Carine Bittler, administrateur de sociétés, demeurant à Luxembourg,
- Monsieur Johan Dejans, directeur, demeurant à Steinfort,
- Monsieur Eric Vanderkerken, employé privé, demeurant à Rumelange.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
La BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
4. L’adresse de la société est fixée au 50, route d’Esch, L-1470 Luxembourg.
5. La durée du mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes sera de six ans et prendra fin à l’assemblée

générale des actionnaires qui se tiendra en l’an deux mille un.

6. Le conseil d’administration est autorisé à déléguer les pouvoirs de gestion journalière conformément à l’article 9

des statuts.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom, prénom usuel, état et

demeure, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, la présente minute.

Signé: C. Bittler, Y. Schmit, A. Lentz.
Enregistré à Remich, le 31 octobre 1996, vol. 459, fol. 21, case 4. – Reçu 12.500 francs.

<i>Le Receveur (signé): P. Molling.

Pour copie conforme, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de la publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Remich, le 7 novembre 1996.

A. Lentz.

(39353/221/172)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 novembre 1996.

KÜHNE UND NAGEL, SPEDITION, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 9.085.

Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am zweiten Oktober.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Gloden, mit Amtswohnsitz in Grevenmacher.

Sind erschienen:

1) Die Aktiengesellschaft KÜHNE &amp; NAGEL INTERNATIONAL A.G., mit Sitz zu Pfäffikon (CH),
hier vertreten durch Herrn Thierry Mottet, directeur financier, wohnhaft in Biwer,
auf Grund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Schindelly am 9. Juli 1996.
2) Die Aktiengesellschaft KÜHNE &amp; NAGEL MANAGEMENT A.G., mit Sitz in Pfäffikon (CH),
hier vertreten durch Herrn Thierry Mottet, directeur financier, wohnhaft in Biwer,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, gegeben in Schindelly am 9. Juli 1996,
welche Vollmachten, nach ne varietur-Unterzeichnung durch die Komparenten und den amtierenden Notar gegen-

wärtiger Urkunde als Anlagen beigebogen bleiben, um mit derselben formalisiert zu werden.

Welche Komparentinnen, vertreten wie hiervor erwähnt, den unterzeichneten Notar ersuchen, folgendes zu

beurkunden:

Die Komparentinnen KÜHNE &amp; NAGEL INTERNATIONAL AG und KÜHNE &amp; NAGEL MANAGEMENT AG sind

die alleinigen Gesellschafterinnen der Gesellschaft mit beschränkter Haftung KÜHNE und NAGEL, SPEDITION GmbH,
mit Sitz in L-1273 Luxemburg, 7, rue de Bitbourg, eingetragen im Handelsregister Luxemburg, unter der Nummer B
9.085,

ursprünglich gegründet unter der Bezeichnung KÜHNE UND NAGEL, S.à r.l., laut Urkunde unter Privatschrift vom

20. April 1970, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations, Nummer 171 vom 25.
September 1970; die Satzung wurde mehrmals abgeändert.

Die Bezeichnung der Gesellschaft wurde abgeändert in KÜHNE UND NAGEL, SPEDITION GmbH, gemäss Urkunde,

aufgenommen durch den damals in Bettemburg residierenden Notar Aloyse Weirich, am 26. Oktober 1981, veröffent-
licht im Mémorial C, Recueil Special des Sociétés et Associations, Nummer 271 vom 9. Dezember 1981.

Die letzte Änderung der Satzung geschah gemäss Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 28. Juli

1995, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 552 vom 27. Oktober 1995.

Die Komparentinnen erklären, eine Gesellschafterversammlung der Gesellschaft KÜHNE UND NAGEL, SPEDITION

GmbH, abzuhalten mit folgender Tagesordnung:

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um siebzig Millionen Luxemburger Franken (70.000.000,- LUF) zwecks Herauf-

setzung von einhundertsechzig Millionen Luxemburger Franken (160.000.000,- LUF) auf zweihundertdreissig Millionen
Luxemburger Franken (230.000.000,- LUF) durch die Ausgabe von zweihundertachtzig (280) neuen Anteilen mit einem
Nennwert von zweihundertfünfzigtausend Luxemburger Franken (250.000,- LUF), welche mit den gleichen Rechten
ausgestattet sind wie die bestehenden Anteile und welche am Gewinn teilnehmen mit Wirkung vom 1. Januar 1996.

2. Beschluss über die Zeichnung und die Einzahlung dieser neuen Anteile.
3. Abänderung von Artikel vier und fünf der Satzung, um denselben mit der vorgenommenen Kapitalerhöhung in

Einklang zu bringen.

4. Abänderung von Artikel sieben der Satzung, welcher nunmehr folgenden Wortlaut haben soll:
«Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die

Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

476

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, im Namen und für Rechnung der Gesellschaft

zu handeln, einschliesslich des Verfügungsrechtes, sowie des Rechtes die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich
zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es aufgrund der Satzung, sei

es durch die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt die Gesellschafterversammlung, bei Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und

die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann

geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen der Gesellschafter-
versammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die Gesellschafterver-

sammlung festgesetzt wird.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflich-

tungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.»

5. Verlegung des Gesellschaftssitzes an folgende Adresse: 1, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern.
Nach Beratung erklären die Komparentinnen einstimmig folgende Beschlüsse zu fassen:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, das Gesellschaftskapital um siebzig Millionen Luxemburger

Franken (70.000.000,- LUF) zu erhöhen, um es von seinem jetzigen Stand von einhundertsechzig Millionen Luxemburger
Franken (160.000.000,- LUF) auf zweihundertdreissig Millionen Luxemburger Franken (230.000.000,- LUF) zu bringen,
durch Ausgabe von zweihundertachtzig (280) neuen Anteilen mit einem Nennwert von zweihundertfünfzigtausend
Luxemburger Franken (250.000,- LUF) pro Anteil.

Die neuen Anteile sind mit den gleichen Rechten und Vorteilen ausgestattet wie die bestehenden Anteile und nehmen

am Gewinn, rückwirkend mit Wirkung vom 1. Januar 1996 an, teil.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterin KÜHNE &amp; NAGEL MANAGEMENT AG vorgenannt, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt, auf

ihr Vorzugsrecht zwecks Zeichnung der neuen Anteile zu verzichten und die andere Gesellschafterin KÜHNE &amp; NAGEL
INTERNATIONAL AG zur Zeichnung von den neuen Anteile zuzulassen.

Sodann erklärt die Komparentin, die Aktiengesellschaft KÜHNE &amp; NAGEL INTERNATIONAL AG, vorgenannt,

vertreten wie hiervor erwähnt, die zweihundertachtzig (280) neuen Anteile zu zeichnen und voll und in bar einzuzahlen.

Die Summe von siebzig Millionen Luxemburger Franken (70.000.000,- LUF) betreffend die hiervor vorgenommene

Kapitalerhöhung steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, wie dies dem amtierenden Notar nachgewiesen wurde.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der hiervor vorgenommenen Kapitalerhöhung werden Artikel vier und fünf der Satzung abgeändert, um

nunmehr folgenden Wortlaut zu haben:

«Art. 4. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf die Summe von zweihundertdreissig Millionen Luxemburger

Franken (230.000.000,- LUF). Es wird dargestellt von neunhundertzwanzig (920) Anteilen zu je zweihundertfünfzig-
tausend Luxemburger Franken (250.000,- LUF).

Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist wie folgt gezeichnet und zugeteilt:
1) an die Gesellschaft KÜHNE &amp; NAGEL INTERNATIONAL AG, mit Sitz in Pfäffikon (CH), neunhundert

Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

900

2) an die Gesellschaft KÜHNE &amp; NAGEL MANAGEMENT AG, mit Sitz in Pfäffikon (CH), zwanzig Anteile ……

20

____

Total: neunhundertzwanzig Anteile ………………………………………………………………………………………………………………………………………

920

Alle Anteile sind vollständig und in bar eingezahlt.»

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, Artikel sieben der Satzung gänzlich abzuändern, um ihm

nunmehr folgenden Wortlaut zu geben:

«Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet und verwaltet. Der oder die

Geschäftsführer können Gesellschafter oder Nichtgesellschafter sein.

Der oder die Geschäftsführer haben die ausgedehntesten Befugnisse, im Namen und für Rechnung der Gesellschaft

zu handeln, einschliesslich des Verfügungsrechtes, sowie des Rechtes, die Gesellschaft gerichtlich oder aussergerichtlich
zu vertreten.

Der oder die Geschäftsführer werden auf befristete oder unbefristete Dauer ernannt, sei es auf Grund der Satzung,

sei es durch die Gesellschafterversammlung.

In letzterem Falle setzt die Gesellschafterversammlung, bei Ernennung des oder der Geschäftsführer, ihre Zahl und

die Dauer ihres Mandates fest; bei der Ernennung mehrerer Geschäftsführer werden ebenfalls ihre Befugnisse festgelegt.

Die Gesellschafterversammlung kann die Abberufung der Geschäftsführer beschliessen. Die Abberufung kann

geschehen nicht nur für rechtmässig begründete Ursachen, sondern ist dem souveränen Ermessen der Gesellschafter-
versammlung überlassen.

Der Geschäftsführer kann für seine Tätigkeit durch ein Gehalt entlohnt werden, das durch die Gesellschafterver-

sammlung festgesetzt wird.

477

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktionen keine persönlichen Verpflich-

tungen bezüglich der Verbindlichkeiten der Gesellschaft ein. Sie sind nur für die ordnungsgemässe Ausführung ihres
Mandates verantwortlich.»

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, den Gesellschaftssitz von L-1273 Luxemburg, 7, rue de

Bitbourg, nach L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter, zu verlegen.

Die Gesellschafterversammlung beschliesst einstimmig, Artikel eins der Satzung durch folgenden Abschnitt zu vervoll-

ständigen:

«Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Contern.»
Die Kosten und Honorare dieser Urkunde sind zu Lasten der Gesellschaft.
Worüber Urkunde aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt,
Und nach Vorlesung an die dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannten

Komparenten, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. Mottet, J. Gloden.
Enregistré à Grevenmacher, le 4 octobre 1996, vol. 498, fol. 95, case 6. – Reçu 700.000 francs.

<i>Le Receveur (signé): G. Schlink.

Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf stempelfreiem Papier auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröf-

fentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 31. Oktober 1996.

J. Gloden.

(39263/213/130)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

KÜHNE UND NAGEL, SPEDITION, GmbH, société à responsabilité limitée.

Gesellschaftssitz: L-5326 Contern, 1, rue Edmond Reuter.

H. R. Luxemburg B 9.085.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Grevenmacher, le 7 novembre 1996.

J. Gloden.

(39264/213/8)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

SAFEI INVEST, Sicav à compartiments multiples.

1. Modification des conditions de souscriptions

Le Conseil d’Administration a décidé de supprimer la commission de 0,50 % acquise à la Société lors des souscrip-
tions. La commission d’émission restera à 3 % maximum et sera acquise aux Institutions chargées du placement
des actions.

Cette modification est entrée en vigueur le 1

er

janvier 1997.

2. Modification de la commission de conseiller en investissement

Le Conseil d’Administration a décidé d’augmenter la commission de conseil en investissement de 1 % à 1,5 %.
Cette modification entrera en vigueur le 14 février 1997.

Le dernier prospectus en vigueur pourra être obtenu, sur simple demande, au siège social de la Société, 10A,

boulevard Royal, Luxembourg.

Pour le Conseil d’Administration

V. Migeot

(00069/755/15)

<i>Directeur Général

RADIOCOM, Société coopérative.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R. C. Luxembourg B 35.544.

A la suite de l’assemblée générale annuelle de la société RADIOCOM qui s’est tenue le 1

er

décembre 1995,

- le conseil d’administration de la société se compose comme suit:
Président:

Jean-Marie Arens, administrateur de sociétés

Membres:

Claude Deitz, ingénieur diplômé
Gust Teusch, gérant

Luxembourg, le 6 novembre 1996.

<i>Pour le conseil d’administration

G. Teusch

<i>Gérant

Enregistré à Luxembourg, le 6 novembre 1996, vol. 486, fol. 31, case 12. – Reçu 500 francs.

<i>Le Receveur (signé): J. Muller.

(39297/514/15)  Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 novembre 1996.

478

MOTWIT S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R. C. Luxembourg B 8.351.

Le Conseil d’Administration a l’honneur de convoquer Messieurs les actionnaires par le présent avis, à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>29 janvier 1997 à 10.30 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits au 31 décembre 1996, et affectation du résultat.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes pour l’exercice de leur mandat au

31 décembre 1996.

4. Nominations statutaires.
5. Divers.

I  (00055/005/16)

<i>Le Conseil d’Administration.

TOWER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg.

R. C. Luxembourg B 31.609.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui aura lieu le <i>29 janvier 1997 à 11.00 heures à Luxembourg, 6, rue Zithe, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1) Lecture des comptes arrêtés au 31 décembre 1995.
2) Lecture des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 1995.
3) Lecture du rapport consolidé du conseil d’administration concernant l’exercice social 1995 des comptes arrêtés

au 31 décembre 1995 et des comptes consolidés arrêtés à la même date.

4) Lecture du rapport du commissaire aux comptes concernant les comptes arrêtés au 31 décembre 1995 et

lecture du rapport du réviseur d’entreprises sur les comptes consolidés.

5) Quitus du fait du retard à tenir l’assemblée.
6) Approbation des comptes.
7) Affectation des résultats.
8) Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes, ainsi qu’au réviseur d’entreprises.
9) Prorogation du mandat des administrateurs.

10) Prorogation du mandat du commissaire aux comptes et du réviseur d’entreprises.
11) Questions diverses.

I  (00056/280/23)

<i>Le Conseil d’Administration.

MERCHBANC, Société d’Investissement à Capital Variable.

Registered office: L-1470 Luxembourg, 69, route d’Esch.

T. R. Luxembourg B 51.646.

To our shareholders, 
We have the honour to invite you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the company, which will take place at the offices of BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route
d’Esch, L-1470 Luxembourg, on <i>January 29, 1997 at 3.00 p.m. for the purpose of considering and voting upon the
following agenda:

<i>Agenda:

– Submission of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
– Approval of the Statement of Net Assets and of the Statement of Operations for the period from the date of

incorporation to September 30, 1996; appropriation of the results;

– Discharge to the Directors;
– Renewal of the mandate of the Directors;
– Miscellaneous.

The shareholders are advised that no quorum is required for the items on the agenda of the Annual General Meeting

and the decisions will be taken on a simple majority of the shares present or represented at the meeting.

In order to attend the meeting, the owners of bearer shares will have to deposit their shares five clear days before

the meeting at the registered office of the company.
I  (04447/584/23)

<i>The Board of Directors.

479

PELLEAS S.A., Société Anonyme.

Siège social: Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R. C. Luxembourg B 39.561.

Avis de convocation pour

l’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires de la société qui sera tenue le <i>31 janvier 1997 à 11.00 heures au siège social, avec l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution anticipée de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs.
3. Détermination des pouvoirs et émoluments du liquidateur.
4. Divers.

I  (00040/317/14)

<i>Un mandataire.

BIL LUXPART, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 69, route d’Esch.

R. C. Luxembourg B 52.211.

Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 janvier 1997 à 11.00 heures, à la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, 69, route d’Esch,
Luxembourg, pour délibérer sur le suivant

<i>Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d’Administration et du Réviseur d’Entreprises;
2. Approbation du bilan et du compte de pertes et profits pour l’exercice clôturé au 30 septembre 1996; affectation

du résultat;

3. Décharge à donner au Conseil d’Administration;
4. Nominations statutaires;
5. Divers.

Aucun quorum n’est requis pour les points à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle et les décisions seront

prises à la majorité des actions présentes ou représentées à l’assemblée.

Pour être admis à l’assemblée, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer leurs actions cinq jours

francs avant l’assemblée aux guichets de la BANQUE INTERNATIONALE, 69, route d’Esch, Luxembourg.
II  (04445/584/22)

<i>Le Conseil d’Administration.

G-EQUITY FUND, Société d’Investissement à Capital Variable.

Siège social: Luxembourg, 14, rue Aldringen.

R. C. Luxembourg B 42.375.

L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

des actionnaires de G-EQUITY FUND se tiendra dans les locaux de la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A.,
50, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, le <i>22 janvier 1997 à 14.30 heures, pour délibérer sur l’ordre du jour
suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration sur l’exercice clos le 30 septembre 1996;
2. Lecture du rapport du Réviseur d’Entreprises;
3. Approbation des comptes de l’exercice clos le 30 septembre 1996; 
4. Affectation des résultats;
5. Décharge aux Administrateurs pour l’exercice clos le 30 septembre 1996;
6. Nominations statutaires;
7. Divers.

Pour pouvoir assister à l’assemblée générale ordinaire, les propriétaires d’actions au porteur sont priés de déposer

leurs actions cinq jours francs avant la date de l’assemblée auprès de:

– la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., 50, avenue J. F. Kennedy à Luxembourg;
– la GENERALE DE BANQUE, 3, Montagne du Parc à Bruxelles;
– la BANQUE BELGO-ZAÏROISE, 1, Cantersteen à Bruxelles.
Les résolutions à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire ne requièrent pas de quorum spécial et seront

adoptées si elles sont votées par la majorité des actions présentes ou représentées.
II  (04446/584/26)

<i>Le Conseil d’Administration.

480


Document Outline

S O M M A I R E

KIDGAM, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

LAMORT INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.

EPTALUX S.A., Société Anonyme.

GRUPPO ORIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

A.S.B. S.A., Société Anonyme.

ASTROBAL, Société d Investissement à Capital Variable.

BEIM FRANCO, Société à responsabilité limitée.

Art. 6.

BEIM FRANCO, Société à responsabilité limitée.

BAGRAT-LUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BMS GROUP S.A., Société Anonyme.

EVENTS &amp; BUSINESS CATERING S.A., Société Anonyme.

BOLUX, Société d Investissement à Capital Variable.

B.I.S., BUREAU IMMOBILIER DU SUD, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

BUSINESSTALK S.A., Société Anonyme.

COMINHOLDING, COMPAGNIE INTERNATIONALE HOLDING, Société Anonyme.

CALLANDER GRANVILLE EUROMANAGEMENT FUND, Société Anonyme d Investissement à Capital Fixe.

ANITE SYSTEMS Limited, (anc. CRAY SYSTEMS Limited). Succursale au Grand-Duché de Luxembourg. Capital social: GBP 2.242.214.

CARIEK S.A., Société Anonyme.

CFE S.A., Société Anonyme.

COMPTOIR ANTI-FEU LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

COMURA S.A., Société Anonyme.

FOXITEC S.A., Société Anonyme.

FOXITEC S.A., Société Anonyme.

CONDOR LUX ROADCARGO, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

CONSORTIUM FINANCIER AFRICAIN S.A., Société Anonyme.

FOUGÈRES, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

FINANZPLAN INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.

GAD HOLDING S.A., Société Anonyme (en liquidation).

GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

BORD DE MER I S.A., Société Anonyme.

C.K. S.A., Société Anonyme.

CLEANTEC, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

CONSTRUCTION NICO MARECHAL, Société à responsabilité limitée,

BORD DE MER II S.A., Société Anonyme.

COURIERDIENST WILDE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

DECONEN S.A., Société Anonyme.

DEGNER MALERMEISTER, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

DEVELOPMENT HOLDING COMPANY S.A., Société Anonyme.

FINSATURNE S.A.H., Société Anonyme Holding.

CENTRAL HISPANO GESTION LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.

Art. 1.  

Art. 2.

Art. 3.  

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.  

Art. 15.

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.

Art. 19.

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

Suit la traduction française:

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.  

Art. 15.  

Art. 16.

Art. 17.

Art. 18.  

Art. 19.  

Art. 20.

Art. 21.

Art. 22.

Art. 23.

Art. 24.

BCH HORIZONS, Fonds Commun de Placement.

The Fund.

The Management Company.

The Custodian.

Investment Manager.

Investment Objectives and Policies.

Investment Limitations.

Investment Techniques and Instruments

Issuance of Units.

Transfer of Units, Unitholders  Meetings.

Pre-emptive rights relating to Units, conversion of Units into another Portfolio, minimum investment in Units.

Restrictions on Ownership of Units.

Determination of Net Asset Value Per Unit and of Offering Price.

Suspension of Unit Issuance, Exchange and Redemption and of Calculation of the Net Asset Value.

Redemption.

Charges of the Fund.

Fiscal Year, Audit.

Dividends.

Amendment of the Management Regulations.

Notices and Publications.

Duration of the Fund, Liquidation, Merger of Portfolios.

Statute of Limitation.

Applicable Law, Jurisdiction and Governing Language.

Responsibility of the Management Company and of the Custodian.

INCOMMERCE S.A., Aktiengesellschaft.

Art. 2. Erster Absatz.

INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

INDICAN HOLDING S.A., Société Anonyme.

GRUPPO ORIA INTERNATIONAL S.A., Société Anonyme.

GENERALE DE DISTRIBUTION S.A., Société Anonyme.

GERANCE INTERNATIONALE DE FONDS S.A., Société Anonyme.

GESSALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

GREENBACK HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

GARBUIO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

GARBUIO INTERNATIONAL HOLDING S.A., Société Anonyme.

GANSEN, G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.

GEFA S.A., Gesellschaft für Fassadenreinigung, Société Anonyme.

HAWK FINANCE S.A., Société Anonyme.

Art. 3.  

HAWK FINANCE S.A., Société Anonyme.

HERSE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

GOPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

GT DEUTSCHLAND FUND, SICAV, Société d Investissement à Capital Variable.

MAITRE MESURE, Société à responsabilité limitée.

Art. 1.

Art. 2. Art. 3.

Art. 4. 

Art. 5.

Art. 6. 

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9. 

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15. Art. 16. 

Art. 17.

ITERACTUSVIA S.A., Société Anonyme.

Titre I.- Dénomination, Siège social, Objet, Durée Art. 1. Art. 2.

Art. 3. Art. 4.

Titre II.- Capital, Actions Art. 5.

Titre III.- Conseil d administration Art. 6. 

Art. 7.

Art. 8. 

Art. 9. 

Art. 10. 

Art. 11. 

Titre IV.- Surveillance Art. 12. 

Titre V.- Assemblée générale Art. 13. 

Titre VI.- Année sociale, Affectation des bénéfices Art. 14. 

Art. 15. 

Titre VII.- Dissolution, Liquidation Art. 16. 

Titre VIII.- Dispositions générales Art. 17. 

MISTY FJORDS S.A., Société Anonyme.

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

Art. 8.

Art. 9.

Art. 10.

Art. 11.

Art. 12.

Art. 13.

Art. 14.

Art. 15.

KÜHNE UND NAGEL, SPEDITION, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Art. 7.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 7.

KÜHNE UND NAGEL, SPEDITION, GmbH, société à responsabilité limitée.

SAFEI INVEST, Sicav à compartiments multiples.

RADIOCOM, Société coopérative.

MOTWIT S.A., Société Anonyme.

TOWER HOLDINGS S.A., Société Anonyme.

MERCHBANC, Société d Investissement à Capital Variable.

PELLEAS S.A., Société Anonyme.

BIL LUXPART, Société d Investissement à Capital Variable.

G-EQUITY FUND, Société d Investissement à Capital Variable.