This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
12001
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 251
21 mai 1996
S O M M A I R E
Asia Plus Fund, Fonds Commun de Placement page 12002
Asia Plus Fund Management Company S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 12010
Astrum S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12046
Cantrade Fund Management Company S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 12042
Centre François Baclesse, (Centre National de
Radiothérapie), A.s.b.l., Esch-sur-Alzette 12043, 12044
Connex Unternehmensgruppe AG ……………………………… 12046
Hypo Deutschland Garantie 12/1999…………………………… 12019
Hypo Emerging Markets Garantie 06/2001 ……………… 12021
Hypo Japan Garantie 06/2000 ………………………………………… 12023
I.E.M., S.à r.l., Luxembourg ……………………………………………… 12047
Ilias S.A., Luxembourg ……………………………………………………… 12047
International Advisors and Consultants S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………… 12026
International Brake S.A. Holding, Luxembourg …… 12026
Invest Immobilière S.A., Luxembourg ……………………… 12027
Joliu S.A., Luxembourg ……………………………………… 12027, 12028
Kalne S.A., Luxembourg …………………………………………………… 12028
Kaloa Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 12029
Kerma S.A., Luxembourg ………………………………… 12028, 12029
(Toni) Lazzara, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Luxembourg 12026
Lusemol S.A., Luxembourg……………………………………………… 12025
Luxstreet S.A., Luxembourg …………………………………………… 12029
Maxime, S.à r.l., Noertzange…………………………………………… 12029
MBS-L, S.à r.l., Strassen …………………………………………………… 12030
MC European Capital (Holdings) S.A., Luxembourg 12032
Mondego Holding S.A., Luxembourg ………… 12029, 12030
Naturata, S.à r.l., Luxemburg ………………………… 12030, 12032
Necker S.A., Luxembourg………………………………………………… 12033
New Fashion, S.à r.l., Esch-sur-Alzette ……………………… 12033
Norisco Holding S.A., Luxembourg …………………………… 12032
Open Deal, S.à r.l., Dippach …………………………………………… 12033
Orientteppich Oase, S.à r.l., Luxembourg ……………… 12033
Palos S.A., Luxembourg …………………………………………………… 12034
Pec Europe, S.à r.l., Roodt-sur-Syre …………………………… 12033
Peckels JP & Fils, S.à r.l., Mersch…………………………………… 12035
Pivoine S.A., Luxembourg………………………………………………… 12034
Plasttechnik-Vertriebsgesellschaft (P.T.V.), S.à r.l.,
Senningerberg ……………………………………………………………………… 12048
Plusfin S.A., Luxembourg ………………………………………………… 12048
P.O.S. Marketing & Consult, GmbH, Luxbg 12034, 12035
Promac S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12025
Propcons AG, Senningerberg ………………………………………… 12036
Pure S.A., Luxembourg……………………………………………………… 12036
Reg Grundy Productions (Luxembourg) S.A., Lu-
xembourg ……………………………………………………………………………… 12037
Sachverständigenbüro für Kraftfahrzeugtechnik /
Euro-Trust Service, GmbH ………………………………………… 12046
San Marino Gestion S.A., Luxembourg……………………… 12038
Sanpaolo Bank S.A., Luxembourg………………………………… 12036
Sefinlux S.A., Luxembourg ……………………………………………… 12039
S.G.T., Société de Gestion et Travaux S.A., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 12039
SMC Holding S.A., Luxembourg …………………… 12037, 12038
SMC Real Estate S.A., Luxembourg …………………………… 12040
Snob, S.à r.l., Differdange ………………………………………………… 12040
Société Européenne d’Aquaculture, S.à r.l., Luxem-
bourg ……………………………………………………………………………………… 12038
SOVAPAR, Société Varoise de Participations S.A.,
Luxembourg ………………………………………………………………………… 12038
Spectrum S.A., Luxembourg…………………………………………… 12041
Talos Holding S.A., Luxembourg ………………………………… 12039
TBG International S.A., Luxemburg …………………………… 12042
Terra Consult AG, Senningerberg ……………………………… 12040
Trend Fashion, S.à r.l., Luxembourg …………………………… 12044
Triofalux, S.à r.l., Contern ……………………………………………… 12044
Ty Bordardoue S.A., Senningerberg …………………………… 12044
Union de Financement et de Participation de
Luxembourg S.A., Luxembourg ………………………………… 12046
Vantage Investissements S.A., Luxembourg …………… 12044
Vienna International, Sicaf, Luxemburg …………………… 12045
Vira Volga Holding S.A., Senningerberg …………………… 12046
VP Bank (Luxembourg) S.A., Luxemburg………………… 12041
12002
ASIA PLUS FUND, Fonds Commun de Placement.
—
MANAGEMENT REGULATIONS APRIL 1996
1. The Fund
ASIA PLUS FUND (hereinafter referred to as the «Fund») is organized under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg as a mutual investment fund («fonds commun de placement») and is an unincorporated coproprietorship of the
transferable securities and other assets (hereinafter referred to as «securities») of the Fund, managed in the interest of
its co-owners (hereafter referred to as the «Unitholders») by ASIA PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
(hereafter referred to as the «Management Company»), a company incorporated under the laws of Luxembourg and
having its registered office in Luxembourg. The assets of the Fund, which are held in custody by CREDIT AGRICOLE
LUXEMBOURG S.A. (hereafter referred to as the «Custodian») are segregated from those of the Management
Company. By the acquisition of units of the Fund, any Unitholder fully accepts these management regulations which
determine the contractual relationship between the Unitholders, the Management Company and the Custodian.
2. The Management Company
The Fund is managed on behalf of the Unitholders by the Management Company which shall have its registered office
in Luxembourg.
The Management Company is vested with the broadest powers to administer and manage the Fund, subject to the
restrictions set out in article 6 hereafter, on behalf of the Unitholders, including but not limited to the purchase, sale,
subscription, exchange and receipt of securities and the exercise of all the rights attached directly or indirectly to the
assets of the Fund. The Management Company issues units on behalf of the Fund.
The board of directors of the Management Company (hereinafter the «board of directors») shall determine the
investment policy of the Fund within the restrictions set out hereafter.
The board of directors may appoint a general manager or manager and/or administrative agents to implement the
investment policy and administer and manage the assets of the Fund.
The Management Company may obtain investment information, advice and other services, remuneration which will
be at its own charge to the extent provided herein.
3. The Custodian
The Management Company shall appoint the Custodian. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., a corporation
organized under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its head office in Luxembourg, has been appointed
Custodian.
The Custodian, on behalf of the Unitholders of the Fund, holds all securities, cash and other assets constituting the
assets of the Fund and shall assume all other duties prescribed by the law of 30th March 1988 on collective investment
undertakings. The Custodian may, with the approval of the Management Company, entrust third parties with custodian-
ship of such securities as are not listed on the Luxembourg Stock Exchange or currently traded in Luxembourg. The
Custodian may hold securities in fungible and non-fungible account with such clearing houses as the Custodian with the
approval of the Management Company shall determine. It will have the normal duties of a bank with respect to the
deposits of cash and securities. Demand and short-term deposits, however, may be made by the Custodian on behalf of
the Fund with any bank of good standing chosen by the Management Company.
The Custodian shall not purchase, dispose of, deliver or pay with respect to the Fund’s assets unless it receives
instructions from the Management Company or its duly authorized agents to that effect and unless such instructions
comply with these management regulations and the relevant provisions of law.
Further the Custodian shall, as paying agent, pay dividends and proceeds of repurchase.
The Custodian is entitled to a fee calculated and payable at the end of each quarter at an amount, being in accordance
with customary banking practice in Luxembourg, as agreed from time to time with the Management Company.
Under receipt of instructions from the Management Company or its authorized agents, the Custodian will perform
all acts of disposal with respect to the assets of the Fund.
The Custodian or the Management Company may terminate the appointment of the Custodian upon three months’
notice, provided, however, that such termination is subject to the condition that within two (2) months a new custodian
assumes the responsibilities and functions of the Custodian under these management regulations and provided further
that the appointment of the custodian shall, if terminated by the Management Company, continue thereafter for such
period as may be necessary to the complete divestiture of all assets of the Fund held by the Custodian.
In case of termination by the Custodian, the Management Company shall equally within two (2) months appoint a new
custodian to assume the responsibilities and functions of the Custodian under these management regulations, provided
that, upon the Custodian’s termination becoming effective, and pending the appointment of a new custodian by the
Management Company, the Custodian shall take all necessary steps to ensure that the interests of the Unitholders are
safeguarded.
4. Investment objective and strategy
The Management Company aims at offering investors a way of achieving steady returns in the short/medium term in
the volatile Asian markets through diversified exposure and a unique approach to optimising the risk - return trade-off
by investing mainly in transferable securities.
The Fund’s investment universe comprises the fast-growth economies of the Asia-Pacific Basin: China, Hong Kong,
India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, the Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan and Thailand. Levels of
exposure are contingent on each market’s contribution toward the Fund’s overall objectives.
12003
To enhance the Fund’s ability to reach these objectives, investment may be made, from time to time, in the mature
markets of the Asia-Pacific Basin such as Australia, Japan and New Zealand for diversification purposes. Exposures to
these markets would in any case remain limited given their comparatively higher degree of maturity and efficiency, which
translates into lower return and volatility.
The Fund’s diversified portfolio will mainly comprise quoted equity securities in the world’s major stock exchanges
or other regulated securities, markets, as well as equity based financial products (f.i. depository receipts). It may further
invest in debt instruments (re. 5, 2 (b)), notes as well as convertible bonds and other securities, which shall be treated,
because of their characteristics, as equivalent to transferable securities.
The Fund may further hold liquid assets on an ancillary basis. Such assets may be kept in current accounts, time
deposits or in short-term regularly negotiated money market instruments, having a remaining maturity of less than 12
months and issued or guaranteed by first class issuers or guarantors.
For the purpose of efficient portfolio management, the Fund may employ techniques and instruments relating to
transferable securities. In that respect, the Fund may participate, at the conditions and within the limits set forth in the
investment restrictions, in transactions relating to options, financial futures and related options, securities lending and
repurchase agreements. Attention is drawn to the fact that the use of derivatives involves positions in markets which
may be more volatile than the traditional securities’ markets.
Investment in securities issued by companies and governments of different nations and denominated in different
currencies involves certain risks. These risks include exchange rate fluctuations, international and regional political and
economic developments and the possible imposition of exchange controls or other local governmental laws or restric-
tions applicable to such investments. The Fund may therefore engage, within the limits set forth in the investment
restrictions, in various portfolio strategies to hedge against currency risks.
5. Investment Policy
The investments of the Fund shall consist of:
1.(a) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in a Member State of the European Union
(EU);
(b) transferable securities dealt in on another regulated market that is operating regularly, is recognised and open to
the public of a Member State of the European Union;
(c) transferable securities admitted to official listing on a stock exchange in any country in Europe (other than those
belonging to the EU) as well as Asia, Oceania, the two American continents and Africa;
(d) transferable securities dealt in on another regulated market that is operating regularly, is recognised and open to
the public of any European country (other than those belonging to the EU) as well as Asia, Oceania, the two American
continents and Africa;
(e) recently issued transferable securities provided that:
- the terms of the issue include an undertaking that application will be made for admission to the official listing on one
of the stock exchanges as specified in a) and c) or to regulated markets that are operating regularly, are recognised and
open to the public as specified in b) and d);
- such admission is secured within one year of issue.
2. Furthermore, the Fund may:
(a) invest a maximum of 10 % of its net assets in transferable securities other than those referred to in sub-paragraph
1(a) to (e);
(b) invest a maximum of 10 % of its net assets in debt instruments which shall be treated as equivalent to transferable
securities because of their characteristics and which are notably transferable, liquid and have a value which can be
accurately determined at any time but at least when the net asset value is calculated.
The debt instruments referred to are regularly traded money market instruments with a residual term exceeding 12
months.
Whatever the case, the investments referred to in sub-paragraphs a) and b) may never jointly exceed 10 % of the
Fund’s net assets.
3. The Fund may invest up to 5 % of its net assets in the units of other undertakings for collective investment of the
open-ended type within the meaning of the Directive of the Council of the European Community of December 20, 1985.
4. The Fund may hold liquid assets on an ancillary basis. Money market instruments dealt in on a regular basis with a
final maturity of less than 12 months are to be considered as liquid assets.
5. The Fund may acquire, on an accessory basis, warrants on transferable securities. Unitholders should be aware of
the greater volatility of warrant prices and the possible corresponding increased volatility of the Fund’s unit prices.
6. Investment restrictions:
A. The Fund undertakes not to invest the assets in securities of any one issuer in a proportion exceeding the limits
set out below:
1.a) the Fund may not invest more than 10 % of its net assets in transferable securities issued by the same issuer.
Moreover, the total value of transferable securities held by the Fund in issuers in which it invests more than 5 % of its
net assets may not exceed 40 % of the value of its net assets.
b) The limit of 10 % laid down in sub-paragraph a) above is increased to a maximum of 35 % of its net assets, when
the transferable securities are issued or guaranteed by an EU Member State, by its local authorities, by a State not a
Member State of the EU or by public international institutions of which one or several Member States of the EU are
members.
c) The limit of 10 % laid down in sub-paragraph a) may be of a maximum of 25 % for certain debt securities if they
are issued by a credit institution whose registered office is situated in an EU-Member State and which is subject, by virtue
12004
of law, to particular public supervision for the purpose of protecting the holders of such debt securities. In particular,
the amounts resulting from the issue of such debt securities must be invested, pursuant to the law in assets which suffi-
ciently cover, during the whole period of validity of such debt securities, the liabilities arising therefrom and which are
assigned to the preferential repayment of capital and accrued interest in the case of default by the issuer. If the Fund
invests more than 5 % of its net assets in such debt securities as referred to in sub-paragraph a) and issued by the same
issuer, the total value of such investments may not exceed 80 % of the value of the Fund’s net assets.
d) The transferable securities referred to in sub-paragraphs b) and c) are not included in the calculation of the limit
of 40 % laid down in sub-paragraph a).
The limits stipulated in the sub-paragraphs 1 a), b) and c) may not be aggregated and, accordingly, investments in trans-
ferable securities issued by the same issuer executed in accordance with sub-paragraphs a), b) and c) may not, in any
event, exceed a total of 35 % of the Fund’s net assets.
2. By way of derogation from point (1), the Fund is authorized to invest in accordance with the principle of risk-
spreading up to 100 % of the Fund’s net assets in various issues of transferable securities, issued or guaranteed by the
member States of the UE or their local authorities, any member State of the OECD and public international bodies of
which one or more EU Member States are members, as well as Hong Kong, Singapore, Taiwan, South Korea, Malaysia,
Indonesia, Thailand, India and the Philippines.
If the Fund avails itself of this last option, it must then hold transferable securities of at least six different issues, but
securities from any one issue may not account for more than 30 % of its total net assets.
3. The Fund may acquire units in other open-ended undertakings for collective investment in transferable securities
only if they are considered as undertakings for collective investment within the meaning of the Directive of the Council
of the European Community of December 20th, 1985 («UCITS»). It may only invest 5 % of its net assets in such UCITS.
The acquisition of units in another undertaking for collective investment with which the Fund is linked by common
management or control or through a substantial direct or indirect holding shall be permitted only in the case of an
undertaking for collective investment, in accordance with its management regulations or articles of incorporation, if it is
specialised in investments in a specific geographic or economic sector.
The Management Company may not charge any fee or cost on account of transactions relating to units of the Fund
where some of the Fund’s assets are invested in the units of another collective investment fund managed by the same
Management Company or by any other company with which the Management Company is linked by common
management or control or by a substantial direct or indirect holding.
4.a) The Fund may only invest in shares with voting rights where these do not allow it to exercise a significant
influence over the management of the issuer.
b) The Fund undertakes not to acquire more than 10 % of the shares with non-voting rights of one and the same
issuer.
c) The Fund undertakes not to acquire more than 10 % of the debt securities of one and the same issuer.
d) The Fund undertakes not to acquire more than 10 % of the units of one and the same undertaking for collective
investment.
The limits stipulated in sub-paragraphs c) and d) above may be disregarded at the time of acquisition if, at that time,
the gross amount of debt securities or the net amount of securities issued cannot be calculated.
The limits stipulated in sub-paragraphs a) to d) above do not apply to:
- transferable securities issued or guaranteed by an EU Member State or its local authorities;
- transferable securities issued or guaranteed by a non-EU Member State;
- transferable securities issued by public international institutions to which one or more EU Member States belong;
- shares held by the Fund in the capital of a fund incorporated in a non-Member State of the EU which invests its
assets mainly in the securities of issuing bodies having their registered office in that State, where under the legislation of
that State, such a holding represents the only way in which the Fund can invest in the securities of issuing bodies of that
State. This derogation, however, shall apply only if in its investment policy the Fund from the non-Member State of the
EU complies with the limits laid down heretofore;
- shares held by the Fund in the capital of subsidiary companies carrying on the business of management, advice or
marketing exclusively on its behalf.
5.a) The Fund need not comply with the limits laid down heretofore when exercising subscription rights attaching to
transferable securities which form part of its assets.
While ensuring observance of the principle of risk-spreading, the Fund may derogate from paragraphs (1) and (2) for
a period of six months following the date of its authorisation.
b) If the limits referred to in sub-paragraph (a) are exceeded for reasons beyond the control of the Fund or as a result
of the exercise of subscription rights, it must adopt as a priority objective for its sales transactions the remedying of that
situation, taking due account of the interests of the investors.
6. The Fund may not borrow; however the Fund may acquire foreign currency by means of a back-to-back loan.
By way of derogation however, the Fund may borrow the equivalent of up to 10 % of its net assets provided that the
borrowing is on a temporary basis.
7. The Fund may not mortgage, pledge, hypothecate or in any manner transfer as security for indebtedness, any
securities which it owns, except as may be necessary in connection with borrowings mentioned in (6) above and
provided that the purchase or sale of securities on a when issued or delayed-delivery basis, and collateral arrangements
with respect to the writing of options or the purchase or sale of forward of future contracts are not deemed the pledge
of the assets.
The Fund may however be allowed to acquire transferable securities which are not fully paid.
8. The Fund may not carry out uncovered sales of transferable securities.
12005
9. The Fund may not acquire either precious metals or certificates representing them.
10. The Fund may not use its assets to underwrite or subunderwrite any securities, except to the extent that, in
connection with the disposition of portfolio securities, it may be deemed to be an underwriter under applicable
securities laws.
B. The Fund may employ the following techniques and instruments relating to transferable securities under the condi-
tions and within the limits laid down by law, regulation and administrative practice:
I. Techniques and instruments relating to transferable securities
For the purpose of efficient portfolio management, the Fund may participate in transactions relating to:
- options;
- financial futures and related options;
- securities lending;
- repurchase agreements.
<i>1. Transactions relating to options on transferable securitiesi>
The purchase and writing of call and put options by the Fund is permitted provided such options are traded on a
regulated market which is operating regularly, recognised and open to the public.
When entering into these transactions, the Fund must comply with the following rules:
1.1. Rules applicable to the purchase of options.
The total premiums paid for the acquisition of call and put options outstanding and referred to herein may not
together with the total of the premiums paid for the purchase of call and put options outstanding and referred to in
heading 2.3. below, exceed 15 % of the Fund’s net assets.
1.2. Rules to ensure the coverage of the commitments resulting from option transactions.
Upon the conclusion of contracts whereby call options are written, the Fund must hold either the underlying
securities, or equivalent call options or other instruments capable of ensuring adequate coverage of the commitments
resulting from such contracts, such as warrants. The underlying securities related to call options written may not be
disposed of as long as these options are in existence unless such options are covered by matching options or by other
instruments that can be used for that purpose. The same applies to equivalent call options or other which the Fund must
hold where it does not have the underlying securities at the time of the writing of such options.
As an exception to this rule, the Fund may write call options on securities it does not hold at the entering into the
option contract provided the following conditions are met:
- the aggregate exercise (striking) price of such uncovered call options written shall not exceed 25 % of the Fund’s
net assets;
- the Fund must at any time be in the position to ensure the coverage of the position taken as a result of the writing
of such options.
Where it writes put options, the Fund must be covered during the entire duration of the option contract by adequate
liquid assets that may be used to pay for the securities which could be delivered to it in case of the exercise of the option
by the counterpart.
1.3. Conditions and limits for the writing of call and put options.
The aggregate of the commitments arising from the writing of put and call options (excluding call options written in
respect of which the Fund has adequate coverage) and the aggregate of the commitments from the transactions referred
to in heading 2.3. hereafter may not, at any time, exceed the value of the Fund’s net assets.
In this context, the commitment on call and put options written is deemed to be equal to the aggregate of the
exercise (striking) prices of those options.
1.4. Rules concerning the regular information of the public.
In its financial reports, the Fund must identify the portfolio securities which are the subject of an option and indivi-
dually indicate the writing of call options on securities which are not held in the portfolio. It must also breakdown by
category of options the aggregate of the exercise (striking) prices of options outstanding as at the reference date of the
relevant reports.
<i>2. Transactions relating to futures and option contracts relating to financial instrumentsi>
Except for transactions by private contract mentioned under heading 2.2. below, the transactions described herein
may only relate to contracts that are dealt in on a regulated market which is operating regularly, recognised and open
to the public, including recognised over-the-counter (OTC) markets although these may not be regulated by a formal
exchange or association. In the latter case, the Fund will only trade with highly rated institutions, specialized in that type
of operations and transactions and participating in the OTC markets. Futures contracts must however be dealt in on a
regulated market.
Subject to the conditions specified below, these transactions may be made for hedging or other purposes.
2.1. Transactions with the purpose of hedging risks connected to the evolution of stock markets.
The Fund may sell stock index futures for the purpose of hedging against a global risk of an unfavourable evolution of
stock markets. For the same purpose, it may also write call options on stock indices or purchase put options thereon.
The hedging purpose of these transactions presupposes that there exists a sufficient correlation between the compo-
sition of the index used and the corresponding portfolio.
In principle, the aggregate commitments resulting from futures contracts and stock index options may not exceed the
aggregate estimated market value of the securities held by the Fund in the corresponding market. This regulation applies
12006
also to swaps on stock indices by private agreement with highly rated financial institutions, specialised in that type of
operations.
2.2. Transactions with the purpose ofhedgin e interest rates.
The Fund may sell interest rate futures contracts for the purpose of achieving a global hedge against interest rate
fluctuations. It may also for the same purpose write call options or purchase put options on interest rates or enter into
interest rate swaps by private agreement with highly rated financial institutions specialised in this type of operations.
In principle, the aggregate of the commitments relating to futures contracts, options and swap transactions on interest
rates may not exceed the aggregate estimated market value of the assets to be hedged and held by the Fund in the
currency corresponding to those contracts.
2.3. Transactions made for a purpose other than hedging.
Besides option contracts on transferable securities and contracts on currencies, the Fund may, for a purpose other
than hedging, purchase and sell financial futures contracts and options on any kind of financial instruments provided that
the aggregate commitments in connection with such purchase and sale transactions together with the amount of the
commitments relating to the writing of call and put options on transferable securities does not exceed at any time the
value of the Fund’s net assets.
The writing of call options on transferable securities for which the Fund has adequate coverage are not considered
for the calculation of the aggregate amount of the commitments referred to above.
In this context, the concept of the commitments relating to transactions other than options on transferable securities
is defined as follows:
- the commitment arising from futures contracts is deemed equal to the value of the underlying net positions payable
on those contracts which relate to identical financial instruments (after setting off all sale positions against purchase
positions), without taking into account the respective maturity dates; and
- the commitment deriving from options purchased and written is equal to the aggregate of the exercise (striking)
prices of net uncovered sales positions which relate to single underlying assets without taking into account respective
maturity dates.
It is reminded that the aggregate amount of premiums paid for the acquisition of call and put options outstanding
which are referred to herein, may not, together with the aggregate of the premiums paid for the acquisition of call and
put options on transferable securities mentioned in heading 1.1. above, exceed 15 % of the Fund’s net assets.
2.4. Periodical information of the public.
In its financial reports, the Fund must separately indicate for each of the categories of transactions mentioned in
headings 2.1., 2.2. and 2.3. above the total amount of commitments deriving from operations outstanding as at the date
of reference of the relevant reports.
<i>3. Securities lending transactionsi>
The Fund may enter into securities lending transactions provided the following rules are complied with:
3.1. Rules intended to ensure proper completion of lending transactions.
The Fund may only participate in securities lending transactions within a standardised lending system organised by a
recognised securities clearing institution or by a highly rated financial institution specialised in that type of transactions.
In relation to its lending transactions, the Fund must in principle receive security of a value which, at the conclusion
of the lending agreement, must be at least equal to the value of the global valuation of the securities lend.
This collateral must be given in the form of cash and/or of securities issued or guaranteed by member States of the
OECD or by their local authorities or by supranational institutions and organisations with EU, regional or world-wide
scope and blocked in favour of the Fund until termination of the lending contract.
3.2. Conditions and limits of lending transactions.
Lending transactions may not be carried out on more than 50 % of the aggregate market value of the securities in the
Fund’s portfolio. This limit is not applicable where the Fund has the right, at any time, to terminate the contract and
obtain restitution of the securities lent.
Lending transactions may not extend beyond a period of 30 days.
3.3. Periodical information of the public.
The Fund must indicate in its financial reports the global valuation of securities lent at the date of reference of the
relevant reports.
<i>4. Repurchase agreementsi>
The Fund may enter from time to time into repurchase agreements which consist in the purchase and sale of
securities hereby the terms of the agreement entitle the seller to repurchase from the purchaser the securities at a price
and at a time agreed amongst the two parties at the conclusion of the agreement.
The Fund may act either as purchaser or seller in repurchase transactions. This entering in such agreements is
however subject to the following rules:
4.1. Rules intended to ensure the proper completion of repurchase agreements.
The Fund may purchase or sell securities in the context of a repurchase agreement only if its counterpart is a highly
rated financial institution specialised in this type of transactions.
4.2. Conditions and limits of repurchase transactions.
During the lifetime of a repurchase agreement, the Fund may not sell the securities which are the object of the
agreement (i) either before the repurchase of the securities by the counterpart has been carried out or (ii) the
repurchase period has expired.
12007
The Fund must ensure to maintain the importance of purchased securities subject to a repurchase obligation at a level
such that it is able, at all times, to meet its obligations to redeem its own units.
4.3. Periodical information of the public.
In its financial reports, the Fund must separately indicate for purchases and sales subject to repurchase obligations,
the total amount of repurchase agreements outstanding at the date of reference of the relevant reports.
II. Techniques and instruments intended to hedge currency risks to which the fund is exposed to
in the management of its assets and liabilites
In order to protect its assets against currency fluctuations, the Fund may enter into transactions the objects of which
are currency forward contracts as well as the writing of call options and the purchase of put options on currencies. The
transactions referred to herein may only concern contracts which are traded on a regulated market which is operating
regularly, recognised and open to the public.
For the same purpose, the Fund may also enter into forward sales of currencies or exchange currencies on the basis
of private agreements with highly rated financial institutions specialised in this type of transactions.
The heretofore mentioned transactions’ objective of achieving a hedge presupposes the existence of a direct relati-
onship between them and the assets to be hedged. This implies that transactions made in one currency may in principle
not exceed the valuation of the aggregate assets denominated in that currency nor exceed the period during which such
assets are held.
In its financial reports, the Fund must indicate, for the different types of transactions made, the aggregate amount of
commitments relating to transactions outstanding as at the date of reference of the relevant reports.
<i>7. Issue of unitsi>
Units of the Fund will be issued by the Management Company as dividend and non dividend bearing units, subject to
payment therefore to the Custodian within such period as the Management Company may from time to time determine.
The conversion from dividend bearing units into non dividend bearing units and vice versa will not be allowed.
Certificates for units or confirmations may be delivered by the Management Company provided the payment
therefore shall have been received by the Custodian.
The Management Company shall comply, with respect to the issuing of units, with the laws and regulations of the
countries where those units are offered. The Management Company may, at any time, at its discretion discontinue, cease
definitely or limit the issue of units to persons or corporate bodies resident or established in certain countries or terri-
tories. The Management Company may also prohibit certain persons or corporate bodies from acquiring units, if such a
measure is necessary for the protection for the Unitholders as a whole and the Fund.
Furthermore, the Management Company may:
a) reject at its discretion any application for units;
b) repurchase at any time the units held by unitholders who are excluded from purchasing or holding units.
The Fund’s units carry no voting rights and no meetings of Unitholders will be held.
The terms of the initial offering will be determined by the Management Company.
<i>8. Issue Pricei>
The issue price per unit will be the net asset value per unit as determined in accordance with the provisions set out
hereafter, on the Valuation Day on which the application for subscription is received by the Management Company
provided it shall have been received on such earlier time as the Management Company by regulation may determine.
The issue price may be increased by a sales charge not exceeding 5.0 % of the net asset value per unit in favour of
banks and financial institutions acting in connection with the placing of the units.
Payment must be made within five bank business days following the determination of the issue price.
<i>9. Determination of the net asset valuei>
The net asset value of the Fund is, expressed in United States Dollars (except then, when there exist any state of
monetary affairs which, in the opinion of the board of directors, makes the determination in Dollars either not
reasonably practical or prejudicial to the Unitholders).
The net asset value per unit will be determined by the Management Company from time to time, but at least twice a
month, on such day, i.e. Valuation Day, by dividing the value of the assets less the liabilities (including any provisions
considered by the Management Company to be necessary or prudent) by the total number of units outstanding. To the
extent feasible, investment income, interest payable, fees and other liabilities (including management fee) will be accrued.
In the case of dividend and non dividend bearing units, the first category will be entitled to distributions, whereas the
other category of units shall not be entitled to distributions, but shall be entitled to an increase in the proportion of the
net assets attributable to such category. The net asset value of a unit of a given category will be determined by dividing
the value of the net assets allocated to the category in question by the total number of units of that category then
outstanding.
On each occasion when a distribution is effected to the category of dividend bearing units, the net asset value of the
units in this category shall be reduced by the amount of the distribution (causing a reduction in the percentage of the
net asset value which is allocated to the category dividend bearing units) whereas the net asset value of units of non
dividend bearing units shall remain unchanged (causing an increase in the percentage of the net asset value which is
allocated to the category of non dividend bearing units). On each occasion when units are issued or redeemed, the net
asset value which is allocated to the respective category of units shall be increased or reduced by the amounts received
or paid out.
The assets of the Fund will be valued as follows:
12008
a) securities listed on a stock exchange or traded on any other regulated market will be valued at the last available
price on such exchange or market. If a security is listed on several stock exchanges or markets, the last available price
at the stock exchange or market which constitutes the main market for such securities, will be determining;
b) securities not listed on any stock exchange or traded on any regulated market will be valued at their last available
market price;
c) securities for which no price quotation is available or for which the price referred to in a) and/or b) is not repre-
sentative of the fair market value, will be valued prudently and in good faith on the basis of their reasonable foreseeable
sales prices;
d) the value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued and not yet received shall be marked to market and deemed to be the
full amount thereof, unless the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof is arrived
at after making such discount as may be considered appropriate in such case to reflect the true value of the asset;
e) values expressed in the currency other than the United States Dollars, shall be translated to United States Dollars
at the average of the last available buying and selling price for such currency.
The Management Company may however adopt other fair valuation methods, when circumstances or market condi-
tions so warrant.
<i>10. Temporary suspension of the determination of the net asset valuei>
The Management Company may temporarily suspend the determination of the net asset value of the Fund’s units and,
as a result, the issue and redemption of units in any of the following events:
1) when one or more stock exchanges or markets, which provide the basis for valuing a substantial portion of the
assets of the Fund, or when one or more foreign exchange markets in the currency in which the units of the Fund or a
substantial portion of the assets of the Fund are denominated, are closed otherwise than for ordinary holidays or if
dealings therein are restricted or suspended;
2) when, as a result of political, economic, military or monetary events or any circumstances outside the responsi-
bility and the control of the Management Company, disposal of the assets of the Fund is not reasonably or normally
practicable without being seriously detrimental to the interests of the unitholders;
3) in case of breakdown in the normal means of communication used for the valuation of any investment of the Fund
or if, for any reason, the value of any asset of the Fund may not be determined as rapidly or accurately as required;
4) any period when the Management Company is unable to repatriate funds for the purpose of making payments on
the redemption or conversion of the units or during which any transfer of funds involved in the realisation or acquisition
of investments or payments due on redemption of units cannot in the opinion of the Management Company be effected
at normal rates of exchange;
5) if, as a result of exchange restrictions or other restrictions affecting the transfer of funds, transactions on behalf of
the Fund are rendered impracticable.
In case of any such suspension, the Management Company shall notify unitholders having tendered their units for
subscription or redemption and, if appropriate, shall publish such suspension as provided hereafter.
<i>11. Redemptioni>
Unitholders may request the Management Company to redeem their units on any Valuation Day against delivery of
their unit certificates, if any. Redemption will be made at the net asset value per unit determined on the Valuation Day
on which the request for repurchase is received by the Management Company provided it shall have been received on
such earlier time as the Management Company by regulation may determine.
Requests for repurchases will be accepted by the Management Company in the same manner as applications for
subscriptions.
The Management Company shall ensure that the Fund maintains an appropriate level of liquidity, so that under normal
circumstances payment of the repurchase price may be made without undue delay, normally not later than within five
bank business days after the determination of the redemption price.
The Management Company shall however not be bound to redeem on any Valuation Day more than 10 % of the units
issued. If the Management Company has received on any Valuation Day request for a net redemption of more than
10 % of the units issued, it may declare that redemption requests received in excess of 10 % be deferred in whole or in
part until the following Valuation Day, whereby earlier request will be treated with priority to later requests.
The Custodian shall not be liable for failure to make remittance abroad if foreign exchange control regulations or
other circumstances beyond its control render impracticable the transfer of the proceeds of repurchase as requested.
<i>12. Management feei>
The Management Company is entitled to receive from the Fund a management fee, payable quarterly, and amounting
to the annual rate of 1 %, calculated on the net assets of the Fund during the relevant quarter.
The Fund will further pay to the Management Company an incentive fee of 20 % on any increase of the net asset value
per unit of the Fund during the period from January 1 to December 31 in each year, exceeding the following reference:
the reference of the calculation of the incentive fee will be the 3 months LIBOR USD rate bimonthly average plus 100
basis points or over (as decided by the board of directors of the Management Company).
For the purpose of calculation of the incentive fee, the net asset value per unit as of January 1 shall be the highest of
the net asset values per unit up to that day and the highest net asset value per unit of the Fund on any January 1 since
the incorporation of the Fund.
The incentive fee is determined by allocating provisionally on each bimonthly Valuation Day 20 % on the increase
(decrease) in the net asset value per unit (provided that the performance exceeds the above-mentioned reference) over
12009
the relevant two weeks multiplied by the number of outstanding units on such Valuation Day. The total fee is the sum
of the amounts so allocated in the relevant year but if the total amount allocated shall fall to zero, then no incentive fee
shall be payable.
For the purpose of calculating the incentive fee for the dividend bearing units any dividends paid during the period
shall be taken into account.
The Management Company shall be responsible for the remuneration of the advisors appointed for the Fund, if any.
<i>13. Charges of the Fundi>
The Fund will bear the following charges:
- all the start-up expenses,
- taxes due on the assets and the income of the Fund,
- usual banking fees due on transactions involving securities held in the Fund’s portfolio,
- the remuneration of the Management Company;
- the remuneration and reasonable out-of-pocket expenses (including without limitation telephone, telex, cable and
postage expenses) of the Custodian and other banks and financial institutions entrusted by the Custodian with custody
of assets of the Fund, and of the registrar, transfer, administrative and paying agent, which shall be agreed upon by the
Management Company in the light of market rates prevailing in Luxembourg,
- legal expenses incurred by the Management Company or the Custodian while acting in the interests of the
Unitholders,
- the cost of printing certificates, if any,
- the cost of preparing and/or filing and printing of the Management Regulations and all other documents concerning
the Fund, including registration statements and prospectuses and explanatory memoranda with all authorities (including
local securities dealers, associations, having jurisdiction over the Fund or the offering of units of the Fund),
- the cost of preparing, in such languages as are necessary for the benefit of the Unitholders, including the beneficial
holders of the units and distributing annual and semi-annual reports and such other reports or documents as may be
required under the applicable laws or regulations of the authorities,
- the cost of accounting, bookkeeping and calculating the net asset value,
- the cost of preparing and distributing public notices to the Unitholders, lawyers’ and auditors’ fees,
- and all similar administrative charges, except, unless otherwise decided by the Management Company, including all
advertising expenses and other expenses directly incurred in offering or distributing the units.
<i>14. Publicationi>
The net asset value, the issue price and the repurchase price per unit may be obtained from the offices of the
Management Company and the Custodian.
Audited annual and unaudited semi-annual reports of the Fund shall be made available to the Unitholders at the
registered offices of the Management Company and the Custodian. Copy of the Management Regulations may also be
obtained at the registered office of the Fund.
Copy of the management regulations may be obtained, free of charge, at the Fund’s registered office. Any amend-
ments to those management regulations will be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of
Luxembourg.
The amendments and notices to Unitholders may also be published, as the Management Company may decide, in
newspapers of countries where the units of the Fund are offered and sold.
<i>15. Accounting year and auditi>
The accounting year of the Fund begins on January 1st of each year and ends on December 31st of the same year.
The accounts of the Management Company will be audited by auditors appointed by the Management Company. The
Management Company shall also appoint an auditor who shall, with respect to the assets of the Fund, carry out the
duties prescribed by the law on March 30th, 1988 regarding collective investment undertakings.
<i>16. Allotment of resultsi>
Each year, upon the closing of the Fund’s annual accounts, the Management Company shall decide on the allotment
of the Fund’s results.
The yearly net profits of the non dividend bearing units will be capitalised in favor of these units. For the dividend
bearing units, a dividend will normally be decided; the Management Company may further decide to distribute interim
dividends for the dividend bearing units.
Dividends can be distributed irrespective of realized or unrealized profits or losses. Dividends may include distri-
bution of capital, provided that the net asset value of the Fund exceeds the equivalent in USD of LUF 50,000,000.- after
such distribution.
Dividend payment notices shall be published in a Luxembourg newspaper and in any other newspaper that the
directors deem appropriate.
Distributions shall be paid in USD or in such other currency as the Management Company shall from time to time
determine, upon request of the unitholders. In the latter case, the Management Company may make a final determi-
nation of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.
Unitholders will be paid by cheque, sent to their address indicated in the register of unitholders or by bank transfer
in accordance with their instructions.
Distributions not claimed within five years from their due date will lapse and revert to the Fund.
12010
The Fund shall not be liable for failure to arrange remittance abroad if foreign exchange control regulations or other
circumstances beyond its control render impracticable the transfer of dividends to any countries outside Luxembourg.
<i>17. Amendment to the management regulationsi>
The Management Company may, upon approval of the Custodian, amend these management regulations in whole or
in part at any time.
Amendments to the management regulations will become effective the day of their publication in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
<i>18. Duration of the Fund and terminationi>
The Fund is created for an undetermined period provided however, that it shall be terminated and totally
repurchased, subject to the publication of a notice of termination, if (i) in the judgement of the Management Company
and the Custodian, the termination of the Fund can best serve the interest of the Unitholders, (ii) in the judgement of
the Management Company and the Custodian circumstances beyond their control compel them to terminate the Fund,
(iii) the Management Company is to be dissolved and liquidated and (iv) in any other cases provided for by Luxembourg
law. Unitholders may not request dissolution or partition of the Fund.
The notice of dissolution shall be published without undue delay in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions of Luxembourg and in at least three newspapers with appropriate distribution, at least one of which must be a
Luxembourg newspaper, to be determined jointly by the Management Company and the Custodian. Issuance and
redemption of units will cease at the time of the decision or event leading to the dissolution. The Management Company
will realise the assets of the Fund in the best interests of the Unitholders and, upon instructions given by the
Management Company, the Custodian will distribute the net proceeds of the liquidation among the Unitholders in
proportion to their rights, after deduction of liquidation fees and expenses. The sums and assets payable in respect of
units whose holders failed to present themselves at the time of the closure of the liquidation, shall be paid to the «Caisse
de Consignation» to be held for the benefit of the persons entitled thereto.
<i>19. Applicable law, jurisdiction and governing languagei>
Disputes arising between the Unitholders, the Management Company and the Custodian shall be settled according to
Luxembourg law and subject to the jurisdiction of the District Court of Luxembourg, provided however, that the
Management Company and the Custodian may subject themselves and the Fund to the jurisdiction of courts of the
countries, in which the units of the Fund are offered and sold, with respect to claims by investors resident in such
countries and with respect to matters relating to subscriptions and repurchases by Unitholders resident in such
countries, to the laws of such countries.
These management regulations will become effective on April 17, 1996.
ASIA PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A.
Signatures
Signatures
<i>as Management Companyi>
<i>as Custodiani>
Enregistré à Luxembourg, le 23 avril 1996, vol. 478, fol. 71, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(14139/255/573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 avril 1996.
ASIA PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
—
STATUTES
In the year one thousand nine hundred and ninety-six on the seventeenth of April.
Before Us, Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
1. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., société anonyme with registered office in Luxembourg, 13, avenue de
la Porte-Neuve, represented by Maître Pierre Berna, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy issued in Luxembourg, on April 12th, 1996;
2. Mrs Françoise Dumont, sous-directeur, residing in Léglise (B), represented by Maître Pierre Berna, prenamed,
by virtue of a proxy issued in Luxembourg, on April 12th, 1996.
The said proxies, signed ne varietur, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration author-
ities.
Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the notary to state as follows the articles of
incorporation of a société anonyme which they form between themselves:
Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who become owners of shares hereafter issued, a
company in the form of a société anonyme under the name of ASIA PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (the
«Company»).
Art. 2. Duration. The Company is established for an indefinite period. The Company may, at any moment, be
dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the conditions of quorum and vote required for amendment of
these articles of incorporation, as specified hereafter.
12011
Art. 3. Purpose. The purpose of the Company is the creation, the administration and the management of ASIA
PLUS FUND, a mutual investment fund (the «Fund») under Luxembourg law and the issue of certificates or statements
of confirmation evidencing undivided coproprietorship interests in the Fund.
The Company shall manage any activities connected with the management, administration and promotion of the Fund.
It may on behalf of the Fund, enter into any contracts, purchase, sell, exchange and deliver any securities, process to any
registrations and transfers into its own name or in third parties, names in the register of shares or debentures of any
Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the Fund and the holders of the Fund’s units, all rights and
privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting the Fund’s assets. The foregoing powers shall
not be considered as exhaustive, but only as declaratory.
The Company may carry on any activities linked directly or indirectly and deemed useful for the accomplishment of
its object, remaining however within the limitations set forth by the law of thirtieth March nineteen hundred and eighty-
eight governing collective investment undertakings.
Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg. It may be transferred to any place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general
meeting of shareholders.
In the event that the board of directors considers that extraordinary political, economic or social developments have
occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with
the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg Company.
Such a declaration relating to the transfer of the registered office will be published, according to the legal require-
ments in force in the country where the registered office has been transferred by one of the directors or agents of the
Company, being designated to represent the Company on the acts concerning the day-to-day management.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by simple resolution of the board of
directors.
Corporate capital - Certificates - Transfer of shares -
Increase and reduction of capital - Undivided proprietorship
Art. 5. Corporate capital. The corporate capital is set at five million (5,000,000) Luxembourg francs, consisting of
five thousand (5,000) shares with a nominal value of thousand (1,000) Luxembourg francs per share.
Art. 6. Certificates. The Company will issue nominative certificates representing shares of the Company.
A register of shareholders shall be kept at the registered office of the Company. Such register shall set forth the name
of each shareholder, his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each
such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers.
Art. 7. Transfer of shares. The transfer of a share shall be effected by a written declaration of transfer inscribed
on the register of shareholders, such declaration of transfer has to be dated and signed by the transferor and the trans-
feree or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore. The Company may also accept as evidence of
transfer other instruments of transfer deemed satisfactory by the Company.
If at any time any shareholder desires to sell or transfer part or all of his shares, he shall first offer the said shares to
the other shareholders at the net asset value at the date of application and in proportion to the ratio of their
shareholding. If, upon this first offer, any shareholder rejects the offer, or fails to accept it in full within one month, his
rights shall pass to the accepting shareholders in proportion to the first offer. The shares not accepted within two
months may be sold to a third person within further three months provided, however, that the party thus offering the
shares to a third party shall first notify the other shareholders of the identity of the prospective purchaser and that,
within fifteen days of such notification, the shareholders may exercise their right of purchasing the shares at the net asset
value as specified above, and provided further that the party thus offering the shares must obtain the approval by the
board of directors of the sale to such third party. The shareholders may consult to agree upon a manner of transfer
other than that provided above.
No transfer mortis causa is valid towards the Company without prior approval of the beneficiary by the board of
directors. Whenever such authorisation or approval is withheld, the board of directors shall purchase the shares for the
Company or appoint another shareholder or other shareholders who shall purchase them at their net asset value as
aforesaid.
Art. 8. Increase and reduction of share capital. The capital of the Company may be increased or reduced by a
resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these articles of incorporation.
The execution of such an increase or reduction of capital may be delegated by the shareholders to the board of
directors.
Art. 9. Undivided proprietorship of the shares. The Company will only recognise one holder per share. The
Company shall have the right at any time to suspend the exercise of any rights attached to any share until one person is
designated to be, for the Company’s purposes, owner of the shares.
Directors and statutory auditor
Art. 10. Directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3)
members, who need not be shareholders of the Company.
The directors shall be elected by the shareholders at their annual general meeting, for a period not exceeding six (6)
years from the date of their appointment. They may be re-elected and always be removed with or without cause and/or
replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.
12012
Art. 11. Vacancy of a director’s post. In the event of vacancy in the office of director because of death,
retirement, revocation or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by a majority vote, a director to
fill such vacancy until the next meeting of shareholders. This nomination will be submitted for ratification by the next
annual general meeting of shareholders.
Art. 12. Chairman of the board of directors. The board of directors may choose from among its members a
chairman, and may choose from among its members one or more vice-chairmen. The board of directors may also
choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the
board of directors and of the shareholders. The board of directors shall meet upon call by the chairman, or two
directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside over all meetings of shareholders and the board of directors, but in his absence the
shareholders or the board of directors may appoint another director, and in respect of shareholders’ meetings any other
person, as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
In the event, that in any meeting, the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall
have a casting vote.
Art. 13. Meetings and deliberations of the board of directors. Written notice of any meeting of the board of
directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the hour set for such meeting, except in
circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting.
This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telex or telefax of each director. Separate
notice shall not be required for individual meetings hold at times and places prescribed in a schedule previously adopted
by resolution of the board of directors.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telefax
or telex another director as his proxy.
The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or repre-
sented at a meeting of the board of directors. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present
or represented and voting at such meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed in writing and may consist
of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a
resolution shall be the date of the first signature.
Art. 14. Minutes of the deliberations of the board of directors. The minutes of any meeting of the board of
directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore, who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two directors.
Art. 15. Powers of the board of directors. The board of directors shall have broadest powers to execute all acts
of administration and disposition for the Company, under the sole restrictions provided for by law, by the present
articles of incorporation or by the management regulations of the ASIA PLUS FUND. All acts not specifically reserved
to the general meeting by law or by the present articles, will be of the board of directors’ competence.
The directors may only act at duly convened meetings of the board of directors. Directors may not, however, bind
the Company by their individual signature, except as specifically permitted by resolution of the board of directors.
Art. 16. Delegation of the board’s powers. The board of directors may delegate all or part of its powers to
conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the
corporate policy and purpose, to one or several directors, managers, officers or other agents of the Company, who
need not to be shareholders.
The board of directors shall determine the powers and special remuneration attached to this delegation of authority.
If authority is delegated to one or more directors for the day to day management, the prior consent of the general
meeting is required.
The Board may also confer any special powers upon one or more attorneys or agents of its choice.
Art. 17. Personal interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or
firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is
interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
Any director or officer of the Company, who serves as a director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business, shall not, by reason of such affiliation with such other
Company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract
or other business.
In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such director or officer shall make known to the board of directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s or officer’s interest therein, shall
be reported to the next succeeding meeting of shareholders.
The term «personal interest», as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in
any matter, position or transaction involving CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., or any subsidiary or any affiliate
thereof or such other company or entity as may from time to time be determined by the board of directors in its
discretion.
Art. 18. Indemnification of the directors. The Company may indemnify any director or officer, and his heirs,
executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or
proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company,
12013
or, at its request, of any other company of which, the Company is a shareholder or creditor and from which he is not
entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or
proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.
Art. 19. Statutory auditor. The operations of the Company shall be supervised by a statutory auditor. The
statutory auditor shall be elected by the annual general meeting of shareholders for a period not exceeding six (6) years
following this appointment. The statutory auditor shall remain in office until re-elected or until his successor is elected.
The statutory auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.
General meetings of shareholders
Art. 20. General meeting. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent
the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts
relating to the operations of the Company.
Art. 21. Holding of the general meetings. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accor-
dance with Luxembourg law, in Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in Luxem-
bourg as may be specified in the notice of meeting, on the twenty-eighth (28) of February at eleven (11) a.m. If such day
is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. The annual general meeting
may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of directors, exceptional circumstances so
require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 22. Modalities of general meetings’ holding. The quorum and delays required by law, shall govern the
notice for and conduct of the meetings of shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote, excepted the restrictions set forth by law. A shareholder may act at any meeting
of shareholders by appointing another person as his proxy in writing, by cable, telegram, telex or telefax.
Except as otherwise required by law or by these articles of incorporation, resolutions at a meeting of shareholders
duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.
The board of directors may determine all other conditions that must be filfilled by shareholders for them to take part
in any meeting of shareliolders.
Art. 23. Notice of general meetings. Shareholders will meet upon call by the board of directors or the statutory
auditor, pursuant to notice setting forth the agenda sent by registered mail at least eight (8) days prior to the meeting
to each shareholder at the shareholder’s address in the register of shareholders, and publicized in accordance with the
requirements of law.
Art. 24. General meetings without convening notice. If, however, all of the shareholders are present or
represented at a meeting of shareholders, and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting,
the meeting may be held without prior notice or publication.
Corporate signature
Art. 25. Corporate signature. The Company will be bound by the joint signature of any two directors of the
Company, or by the individual signature of any person to whom such signatory authority has been delegated by the
board of directors.
Within the day to day management, the Company may be bound by the soIe signature of the managing director within
the limits of his powers.
Accounting year
Art. 26. Accounting year. The accounting year of the Company shall begin on January 1st of each year and shall
terminate on December 31st.
Allocation of results
Art. 27. Allocation of results. From the annual net profit of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to
the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve
amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company as stated in article 5 hereof or as increased or reduced
from time to time as provided in article 8 hereof.
The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of
and may alone declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate purpose and
policy.
The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the board of directors. The board of directors may make a final determination of
the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment.
Any dividends, that have not been claimed within five years of its declaration, shall be forfeited and revert to the
Company.
The board of directors may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down by
law.
Liquidation of the Company
Art. 28. Liquidation of the Company. In the event of a dissolution of the Company liquidation shall be carried
out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
and which shall determine their powers and their compensation.
12014
Amendment of the articles of incorporation
Art. 29. Amendment of the articles of incorporation. These articles may be amended from time to time by a
meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided for by the laws of Luxembourg.
Applicable law
Art. 30. Applicable law. All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accord-
ance with the law of tenth August nineteen hundred and fifteen on commercial companies and amendments thereto as
well as with the law of March thirtieth, nineteen hundred and eighty-eight relating to collective investment undertakings.
<i>Transitory dispositionsi>
The first accounting year will begin on the date of the formation of the Company and will end on December 31st,
1996.
The first annual general meeting will be held in 1997.
<i>Subscription and paymenti>
The subscribers have subscribed to five thousand (5,000) shares and have paid cash the following amounts:
Shareholder
Subscribed capital
Number of shares
1. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A. ………………………………………………………
4,999,000
4,999
2. Mrs Françoise Dumont …………………………………………………………………………………………
1,000
1
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………
5,000,000
5,000
Evidence of the above payments was given to the undersigned notary, who expressly recognizes.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth,
nineteen hundred and fifteen, on commercial companies, have been observed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a
result of its formation, are estimated approximately at one hundred and fifty thousand (150,000) Luxembourg francs.
<i>General meeting of shareholdersi>
The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received
due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.
Having first verified that it was regularly constituted, the meeting took the following decisions unanimously:
<i>First resolutioni>
The following persons have been elected directors for the period expiring immediately after the annual general
meeting to be held in 1999, deliberating on the annual accounts on December 31st, 1998:
- Mr Denis Mauss, directeur général, residing in Luxembourg,
- Mrs Françoise Dumont, prenamed,
- Mr Benoît Descourtieux, Senior investment manager, residing in Hong Kong.
<i>Second resolutioni>
Has been elected as auditor for the period expiring immediately after the annual general meeting to be held in 1999,
deliberating on the annual accounts on December 31st, 1998: FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, 21, rue
Glesener, L-1631 Luxembourg.
<i>Third resolutioni>
The registered office of the Company is fixed in L-2227 Luxembourg, 13, avenue de la Porte-Neuve.
<i>Fourth resolutioni>
According to article 60 of the law on commercial companies and the article 16 of the present articles, the board of
directors of the Company is authorized to elect one or several of its members, who will be empowered to bind the
Company by their individual signature in all acts relating to the day-to-day management.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same
appearing persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will be
prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing persons, the said persons appearing signed together with Us, the
notary, the present original deed.
Suit la traduction française:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-sept avril.
Par-devant Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg.
Ont comparu:
1. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., société anonyme avec siège social à Luxembourg, 13, avenue de la
Porte-Neuve, ici représentée par Maître Pierre Berna, avocat, demeurant à Luxembourg,
12015
en vertu d’une procuration émise à Luxembourg en date du 12 avril 1996;
2. Madame Françoise Dumont, sous-directeur, demeurant à Léglise (B), ici représentée par Maître Pierre Berna,
préqualifié,
en vertu d’une procuration émise à Luxembourg en date du 12 avril 1996,
lesquelles procurations, après signature ne varietur resteront annexées au présent acte pour être enregistrées en
même temps.
Les parties comparantes, ès qualités en vertu desquelles elles agissent, ont demandé au notaire d’arrêter les statuts
d’une société anonyme (la «Société») qu’elles forment entre elles:
Nom - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Nom. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après
créées, une société anonyme sous la dénomination de ASIA PLUS FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. (la
«Société»).
Art. 2. Durée. La Société est établie pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute, à tout moment, par décision
d’une assemblée générale extraordinaire statuant dans les conditions de présence et de majorité requises pour une
modification des statuts, ainsi qu’il est précisé ci-après.
Art. 3. Objet. La Société a pour objet la création, l’administration et la gestion de ASIA PLUS FUND, un fonds
commun de placement de droit luxembourgeois (le «Fonds») et l’émission de certificats ou de confirmations repré-
sentant et documentant des parts de copropriété indivise dans ce Fonds.
La Société se chargera de toute action en rapport avec l’administration, la direction et la promotion du Fonds. Elle
pourra, pour le compte du Fonds, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toutes valeurs mobilières,
procéder à toutes inscriptions et tous transferts en son nom et aux noms de tiers dans les registres d’actions ou d’obli-
gations de toutes sociétés luxembourgeoises et étrangères et exercer pour le compte du Fonds et des propriétaires des
parts du Fonds tous droits et privilèges, en particulier, tous droits de vote attachés aux valeurs mobilières constituant
les avoirs du Fonds, cette énumération n’étant pas limitative, mais simplement exemplative.
La Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et estimées utiles à
l’accomplissement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la loi luxembourgeoise du 30 mars 1988
relative aux organismes de placement collectif.
Art. 4. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra
être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une décision de l’assemblée générale des
actionnaires.
Au cas où le conseil d’administration estimerait que des événements extraordinaires d’ordre politique, économique
ou social, de nature à compromettre l’activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce
siège avec l’étranger, se sont produits ou sont iniminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l’étranger
jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n’aura toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise.
Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et publiée selon les modalités légales en vigueur dans le pays
dans lequel le siège aura été transféré par l’un des administrateurs ou agents de la société ayant qualité de l’engager pour
les actes de gestion courante et journalière.
Il peut être créé, par simple décision du conseil d’administration, des succursales ou bureaux, tant au Grand-Duché
de Luxembourg qu’à l’étranger.
Capital social - Certificats - Transfert d’actions -
Augmentation et réduction du capital social - Propriété indivise des actions
Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à cinq millions (5.000.000) de francs luxembourgeois, représenté par
cinq mille (5.000) actions d’une valeur nominale de mille (1.000) francs luxembourgeois par action.
Art. 6. Certificats. La Société émettra des certificats nominatifs représentant les actions de la Société.
Un registre des actionnaires sera tenu au siège social de la Société. Ce registre contiendra le nom de chaque
actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d’actions qu’il détient, la somme libérée pour chacune de ces
actions ainsi que le transfert des actions et les dates de ces transferts.
Art. 7. Transfert d’actions. Le transfert d’une action se fera par une déclaration écrite de transfert inscrite au
registre des actionnaires, cette déclaration de transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou
par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet. La Société pourra
également accepter en guise de preuve du transfert d’autres instruments de transfert jugés suffisants par la Société.
Lorsqu’un actionnaire désire vendre ou transférer tout ou partie de ses actions, il devra les offrir en premier lieu aux
autres actionnaires à la valeur d’inventaire au jour de son offre et l’offre étant à faire en proportion des participations
de ces autres actionnaires. Au cas où un ou plusieurs actionnaires n’acceptent pas cette première offre ou omettent de
l’accepter dans le délai d’un mois, leurs droits passent aux actionnaires qui l’ont acceptée en proportion de leurs parti-
cipations, telles qu’elles résultent de leur acceptation de la première offre. Les actions qui n’auront pas été acceptées
dans un délai de deux mois pourront être vendues à un tiers dans un nouveau délai de trois mois, étant entendu
toutefois que l’actionnaire offrant devra d’abord notifier aux autres actionnaires l’identité de l’éventuel acquéreur et que
dans la quinzaine de cette notification, les actionnaires pourront exercer leur droit de préférence à la valeur d’inventaire
selon les termes spécifiés ci-avant; étant en outre entendu que l’actionnaire offrant devra obtenir l’approbation par le
conseil d’administration de la vente audit tiers acquéreur. Les actionnaires pourront se concerter et s’entendre sur des
conditions de transfert autres que celles définies ci-dessus.
12016
Aucun transfert à cause de mort n’est opposable à la Société, sans que le bénéficiaire ait été approuvé par le conseil
d’administration. Au cas où le conseil d’administration refuse l’approbation, il devra, soit acquérir les actions pour le
compte de la Société, soit désigner un ou plusieurs actionnaires qui les acquerront à la valeur d’inventaire dans les condi-
tions énoncées ci-avant.
Art. 8. Augmentation et réduction du capital social. Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit
par résolution des actionnaires prise conformément aux dispositions exigées pour la modification des présents statuts.
L’exécution d’une telle augmentation ou réduction de capital peut être confiée par l’assemblée générale au conseil
d’administration.
Art. 9. Propriété indivise des actions. La Société ne reconnaît qu’un seul titulaire par action. La Société a la
faculté de suspendre, à tout moment, l’exercice des droits afférents à toute action jusqu’à ce qu’une seule personne ait
été désignée comme étant à son égard titulaire de ces droits.
Administrateurs et commissaire
Art. 10. Administrateurs. La Société sera administrée par un conseil d’administration composé de trois (3)
membres au moins lesquels n’auront pas besoin d’être actionnaires de la Société.
Les administrateurs seront élus par les actionnaires lors de l’assemblée générale pour une période ne dépassant pas
six (6) ans suivant la date de leur nomination. Ils sont rééligibles et toujours révocables, avec ou sans motif, et/ou
peuvent être remplacés, à tout moment, par décision des actionnaires.
Art. 11. Vacance d’un poste d’administrateur. Au cas où le poste d’un administrateur devient vacant à la suite
de décès, de démission, de révocation ou autrement, les administrateurs restants pourront se réunir et élire à la
majorité des voix un administrateur pour remplir les fonctions attachées au poste devenu vacant, jusqu’à la prochaine
assemblée des actionnaires. Cette nomination sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Art. 12. Président du conseil d’administration. Le conseil d’administration pourra choisir parmi ses membres
un président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le conseil d’administration pourra désigner
également un secrétaire qui n’a pas besoin d’être un administrateur et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration ainsi que des assemblées des actionnaires. Le conseil d’administration se réunira sur la
convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans l’avis de convocation.
Le président du conseil d’administration présidera les assemblées générales des actionnaires et les réunions du conseil
d’administration, mais, en son absence, les actionnaires ou le conseil d’administration désigneront, à la majorité, un autre
administrateur, et pour les assemblées générales des actionnaires, toute autre personne, pour assumer la présidence de
ces assemblées et réunions.
Au cas où, lors d’une réunion du conseil, il y a égalité de voix en faveur ou en défaveur d’une résolution, le président
aura voix prépondérante.
Art. 13. Réunions et délibérations du conseil d’administration. Avis écrit de toute réunion du conseil
d’administration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue pour la
réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convo-
cation. On pourra passer outre à cette convocation à la suite de l’assentiment par écrit ou par câble, télégramme, télex
ou télécopie de chaque administrateur. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
d’administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans un calendrier adopté préalablement par une
résolution du conseil d’administration.
Tout administrateur pourra se faire présenter à toute réunion du conseil d’administration en désignant par écrit ou
par câble, télégramme, télex ou télécopieur un autre administrateur comme son mandataire.
Le conseil d’administration ne pourra délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des administrateurs est
présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés
et votants.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil d’administration peut également être prise par
voie circulaire et résulter d’un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du conseil d’administration sans exception. La date d’une telle décision sera la date de la première signature.
Art. 14. Procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration. Les procès-verbaux des réunions du
conseil d’administration seront signés par le président ou, en son absence, l’administrateur qui aura assumé la présidence
à une telle réunion.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par
le secrétaire ou par deux administrateurs.
Art. 15. Pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus pour
faire tous les actes d’administration ou de disposition qui intéressent la Société; sous les seules restrictions prévues par
la loi, les présents statuts ou le règlement de gestion de ASIA PLUS FUND. Tout ce qui n’est pas expressément réservé
à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du conseil d’administration régulièrement convo-
quées. Les administrateurs ne pourront pas engager la Société par leur signature individuelle, à moins d’y être autorisés
par une résolution du conseil d’administration.
Art. 16. Délégation de pouvoirs du conseil d’administration. Le conseil d’administration pourra déléguer
tout ou partie de ses pouvoirs relatifs à la gestion journalière et à l’exécution d’opérations en vue de l’accomplissement
de son objet et de la poursuite de l’orientation générale de sa gestion à un ou plusieurs administrateurs, directeurs,
gérants ou autres agents, actionnaires ou non.
12017
Il appartient au conseil d’administration de déterminer les pouvoirs et la rémunération particulière attachés à cette
délégation de pouvoir.
Si le conseil d’administration délègue à un ou plusieurs administrateurs le pouvoir d’assurer la gestion journalière.
l’autorisation préalable de l’assemblée générale est requise.
Le conseil d’administration peut également consentir des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou agents
de son choix.
Art. 17. Intérêt personnel. Aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres
sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou fondés
de pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait
administrateur, associé. directeur, fondé de pouvoir ou employé.
L’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou
employé d’une société ou firme avec laquelle la Société passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en
relation d’affaires, ne sera pas, par là même, privé du droit de délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des
matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la
Société, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil d’administration de son intérêt
personnel et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette
affaire et de l’intérêt personnel de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des
actionnaires.
Le terme «intérêt personnel», tel qu’il est utilisé à la phrase qui précède, ne s’appliquera pas aux relations ou aux
intérêts qui pourront exister de quelque manière, en quelque qualité, ou à quelque titre que ce soit, en rapport avec
CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A., ses filiales ou sociétés affiliées ou encore en rapport avec toutes autres
personnes, sociétés ou entités juridiques que le conseil d’administration pourra déterminer à son entière discrétion.
Art. 18. Indemnité des administrateurs. La Société pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé
de pouvoir, ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par
lui pour tous actions ou procès auxquels il aura été partie en sa qualité d’administrateur, directeur ou fondé de pouvoir
de la Société ou pour avoir été, à la demande de la Société, administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de toute autre
société dont la Société est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas indemnisé, sauf au cas où dans pareils
actions ou procès, il sera finalement condamné pour négligence grave ou mauvaise administration.
Art. 19. Commissaire. Les opérations de la Société seront surveillées par un commissaire. Le commissaire sera
élu par l’assemblée générale annuelle des actionnaires pour une période ne dépassant pas six ans suivant la date de sa
nomination. Le commissaire restera en fonction jusqu’à sa réélection ou l’élection de son successeur.
Le commissaire en fonction petit être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l’assemblée des actionnaires.
Assemblées générales des actionnaires
Art. 20. Assemblée générale. L’assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente
tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs
aux opérations de la Société.
Art. 21. Tenue des assemblées générales. L’assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra, confor-
mément à la loi, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg, qui sera fixé dans
l’avis de convocation, le vingt-huit (28) février à onze (11) heures. Si ce jour est un jour férié, l’assemblée générale
annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L’assemblée générale annuelle pourra se tenir à l’étranger, si le
conseil d’administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.
Les autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux heure et lieu spécifiés dans les avis de convo-
cation.
Art. 22. Modalités de la tenue des assemblées. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de
convocation et la conduite des assemblées des actionnaires de la Société dans la mesure où il n’en est pas autrement
disposé dans les présents statuts.
Toute action donne droit à une voix, sauf les restrictions imposées par la loi. Tout actionnaire pourra prendre part
aux assemblées des actionnaires en désignant par écrit, câble, télégramme, télex ou télécopie une autre personne
comme mandataire.
Dans la mesure où il n’en est pas autrement disposé par la loi ou les présents statuts, les décisions de l’assemblée
générale des actionnaires, dûment convoqués, sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés
et votants.
Le conseil d’administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à l’assemblée générale.
Art. 23. Convocation des assemblées. Les assemblées des actionnaires seront convoquées par le conseil d’admi-
nistration ou le commissaire à la suite d’un avis énonçant l’ordre du jour, publié conformément à la loi et envoyé par
lettre recommandée, au moins huit (8) jours avant l’assemblée, à tout actionnaire à son adresse portée au registre des
actionnaires.
Art. 24. Assemblées générales sans convocation. Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou repré-
sentés à une assemblée générale et s’ils affirment avoir été informés de l’ordre du jour de l’assemblée, celle-ci pourra
être tenue sans avis ou publication préalables.
12018
Engagement de la Société
Art. 25. Engagement de la Société. La Société sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs
ou par la signature individuelle de toute autre personne à qui des pouvoirs de signature auront été spécialement
délégués par le conseil d’administration.
Dans le cadre de la gestion journalière. la Société peut être engagée par la signature individuelle d’un administrateur-
délégué dans les limites de ses pouvoirs.
Exercice social
Art. 26. Exercice social. L’exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de
chaque année.
Affectation des résultats
Art. 27. Affectation des résultats. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5 %) qui
seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d’être obligatoire lorsque la réserve aura atteint
dix pour cent (10 %) du capital social, tel qu’il est prévu à l’article 5 des statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou
réduit ainsi qu’il est dit à l’article 8 ci-avant.
L’assemblée générale des actionnaires décidera de l’usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera seule de
la répartition des dividendes quand elle le jugera conforme à l’objet et aux buts de la Société.
Les dividendes annoncés pourront être payés en toute devise choisie par le conseil d’administration, et pourront être
payés aux temps et lieux choisis par le conseil d’administration. Le conseil d’administration déterminera souverainement
le taux de change applicable à l’échange des dividendes en la monnaie de paiement.
Tout dividende déclaré qui n’aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution.
ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société.
Le conseil d’administration peut décider de payer des dividendes intérimaires selon les conditions et les restrictions
prévues par la loi.
Liquidation de la Société
Art. 28. Liquidation de la Société. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins
d’un ou de plusieurs liquidateurs qui peuvent être des personnes physiques ou morales, et qui seront nommés par
l’assemblée générale des actionnaires qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Modification statutaire
Art. 29. Modification des statuts. Les présents statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu’il appartiendra
par une assemblée générale des actionnaires aux conditions de quorum et de majorité fixées par la loi luxembourgeoise.
Loi applicable
Art. 30. Loi applicable. Pour toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents statuts, les parties se
réfèrent aux dispositions de la loi du dix août mil neuf cent quinze sur les sociétés commerciales et des lois modifica-
tives, ainsi qu’à la loi du trente mars mille neuf cent quatre-vingt-huit relative aux organismes de placement collectif.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se termine le 31 décembre 1996.
L’assemblée générale annuelle se réunira pour la première fois en 1997.
<i>Souscription et paiementi>
Les souscripteurs ont souscrit cinq mille (5.000) actions et ont payé comptant les montants indiqués ci-après:
Actionnaire
Capital souscrit
Nombre d’actions
1. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG S.A. ………………………………………………………
4.999.000
4.999
2. Madame Françoise Dumont …………………………………………………………………………………
1.000
1
Total: ………………………………………………………………………………………………………………………………
5.000.000
5.000
La preuve de tous ces paiements a été donnée, ainsi que le constate expressément le notaire soussigné.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné constate que les conditions exigées par l’article vingt-six de la loi du dix août mil neuf cent quinze
sur les sociétés commerciales ont été observées.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, coûts, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société
comme résultant de sa formation, sont estimés approximativement à cent cinquante mille (150.000) francs luxembour-
geois.
<i>Assemblée générale des actionnairesi>
Les personnes sus-indiquées, représentant l’entièreté du capital souscrit et se considérant comme dûment convo-
quées, ont immédiatement procédé à une assemblée générale extraordinaire.
Après avoir vérifié qu’elle était régulièrement constituée, elle a adopté, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les personnes suivantes ont été nommées administrateurs pour une période se terminant immédiatement après
l’assemblée générale annuelle de 1999, délibérant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998:
12019
- Monsieur Denis Mauss. directeur général, demeurant à Luxembourg,
- Madame Françoise Dumont, préqualifiée,
- Monsieur Benoît Descourtieux, Senior investment manager, demeurant à Hong Kong.
<i>Deuxième résolutioni>
A été nommé commissaire pour une période se terminant immédiatement après l’assemblée générale annuelle de
1999, délibérant sur les comptes annuels au 31 décembre 1998: FIDUCIAIRE GENERALE DE LUXEMBOURG, 21, rue
Glesener, L-1631 Luxembourg.
<i>Troisième résolutioni>
Le siège social le la Société est établi à L-2227 Luxembourg. 13, avenue de la Porte-Neuve.
<i>Quatrième résolutioni>
Conformément à l’article 60 de la loi sur les sociétés et à l’article 16 des présents statuts, le conseil d’administration
de la Société est autorisé à élire un ou plusieurs administrateurs-délégués qui auront le pouvoir d’engager la Société en
ce qui concerne les opérations de gestion journalière par la signature individuelle d’un d’entre eux.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande des comparants, le présent acte a
été rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la demande des mêmes personnes et en cas de divergence entre
les textes anglais et français, le texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: P. Berna, A. Schwachtgen.
Enregistré à Luxembourg, le 19 avril 1996, vol. 90S, fol. 46, case 11. – Reçu 50.000 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 avril 1996.
A. Schwachtgen.
(14398/230/584) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 avril 1996.
HYPO DEUTSCHLAND GARANTIE 12/1999.
—
SONDERREGLEMENT
Für den Fonds HYPO DEUTSCHLAND GARANTIE 12/1999 (der «Fonds») gelten ergänzend zu bzw. abweichend
von dem Verwaltungsreglement (Artikel 1 - 19) die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements:
Art. 1. Anlagepolitik des Fonds.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik für den Fonds und wird dabei von dem beratenden Anlage-
ausschuß und dem Anlageberater unterstützt.
Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht darin, an den Kurssteigerungen des deutschen Aktienmarktes zu partizipieren
und gleichzeitig sicherzustellen, daß zum Laufzeitende des Fonds am 30.12.1999 der Liquidationserlös nicht unter 100,00
DEM liegt.
Um die Risiken, welche durch die Kursentwicklung auf den Aktienmärkten entstehen, zu minimieren, wird das Fonds-
vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere
(einschließlich Zerobonds), Wertpapiere, die eine Beteiligung an dem deutschen Aktienindex (DAX) verbriefen (DAX-
Indexpartizipationsscheine), sowie in sonstige zulässige Vermögenswerte investiert. Das Fondsvermögen wird daher zu
Beginn der Anlageperiode in der Weise in diesen Wertpapieren angelegt, daß der Inventarwert pro Anteil in bezug auf
diesen Teil des Fondsvermögens einschließlich der hieraus resultierenden Erträge zum Laufzeitende des Fonds möglichst
100,00 DEM pro Anteil entspricht.
Das Hauptziel der Anlagepolitik wird durch den Kauf von Optionsscheinen oder Kaufoptionen auf deutsche Aktien-
indizes oder deutsche Aktien verwirklicht. Dabei darf der Gesamtbetrag der für den Kauf von Optionsscheinen auf
deutsche Aktienindizes sowie von Kauf- und Verkaufsoptionen gezahlten Preise bzw. Prämien in Abweichung von der
Regelung in Artikel 5 Absatz 5.5.1.2.2. des Verwaltungsreglements 35 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen.
Freihändig gehandelte Devisentermingeschäfte dürfen nur dann getätigt werden und freihändig gehandelte Options-
scheine auf deutsche Aktienindizes und Optionen auf deutsche Aktienindizes («over-the-counter» oder «OTC-
Optionen») können nur dann erworben werden, wenn die entsprechenden Vertragspartner des Fonds erstklassige, auf
derartige Geschäfte spezialisierte Finanzeinrichtungen sind.
Für den Fonds dürfen daneben flüssige Mittel gehalten oder als Festgelder angelegt werden.
Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Deutsche Mark oder andere Währungen lauten, erfolgen. Das Fonds-
vermögen darf auch aus Investitionen einer einzigen dieser Währungen bestehen. Um das Währungsrisiko zu
reduzieren, werden alle Vermögenswerte, die nicht auf Deutsche Mark lauten, gegen die Deutsche Mark weitgehend
abgesichert.
Um der Verringerung des Anlagerisikos soweit wie möglich gerecht zu werden, unterliegt die Verwaltungsgesellschaft
bei der Anlage des Fondsvermögens besonderen Beschränkungen (siehe beiliegendes Verwaltungsreglement).
Für die Absicherung der im Fonds enthaltenen Wertpapiere können diese ganz oder teilweise im Rahmen freihändiger
Termin- oder Optionsgeschäfte verkauft werden, vorausgesetzt, daß derartige Geschäfte mit Finanzinstitutionen
erstklassiger Bonität getätigt werden, die sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert haben. Diese Regel gilt auch für
DAX-Indexpartizipationsscheine, welche zu Absicherungszwecken im Rahmen von Termingeschäften verkauft werden.
12020
Mit Ausnahme der Garantie, daß zum Laufzeitende des Fonds am 30.12.1999 der Liquidationserlös nicht unter 100,00
DEM liegt, kann keine Zusicherung gemacht werden, daß die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Diese Garantie
ermäßigt sich für den Fall, daß steuerliche Änderungen während der Laufzeit des Fonds dazu führen, daß dem Fonds-
vermögen Zinsen oder Kapital nicht in voller Höhe zufließen. Der garantierte Mindestrücknahmepreis ermäßigt sich in
Höhe dieser Verringerung der Erträge des Fonds einschließlich entgangener Zinsen aus der Wiederanlage.
Der Erwerb von Anteilen des Fonds sollte vorrangig längerfristigen Charakter haben.
Art. 2. Fondswährung, Ausgabe und Rücknahmepreis, Inventarwertberechnung.
1. Die Fondswährung, in welcher für den Fonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis
berechnet werden, ist die Deutsche Mark (DEM).
2. Ausgabepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsregle-
ments des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 3,0 % davon. Zur Berechnung
des Inventarwertes werden nicht notierte Optionen sowie Optionsscheine auf Aktienindizes zu den Geldkursen
bewertet, die von hierauf spezialisierten Finanzinstituten erster Ordnung gestellt werden. Die Ausgabe von Anteilen
erfolgt am 15. Juli 1996 und wird anschließend eingestellt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen jedoch auch danach jederzeit bis spätestens 30. Juni 1999
wieder aufnehmen.
Können die Anteile nach der Einzahlung des Ausgabepreises nicht unverzüglich zugeteilt und übertragen werden, so
wird der Einzahlungsbetrag unverzüglich an den Anleger zurücküberwiesen.
3. Rücknahmepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 11 des Verwaltungsre-
glements abzüglich einer Rücknahmegebühr, welche wie folgt festgelegt wird und zugunsten des Fonds erhoben wird:
Zeitraum
Rücknahmepreis
16. 07. 1996 bis 30. 06. 1997
Inventarwert abzüglich 2,0 %
01. 07. 1997 bis 30. 06. 1998
Inventarwert abzüglich 1,5 %
01. 07. 1998 bis 30. 06. 1999
Inventarwert abzüglich 1,0 %
01. 07. 1999 bis 29. 12. 1999
Inventarwert abzüglich 0,5 %
30. 12. 1999
Liquidationswert = Inventarwert
Bei Auflösung des Fonds erfolgt die Rücknahme von Anteilen zum Inventarwert pro Anteil ohne einen Abschlag.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einstellen, insbe-
sondere falls wesentliche Änderungen auf den Kapitalmärkten oder andere unvorhersehbare Ereignisse politischer,
wirtschaftlicher oder steuerlicher Art dies gebieten oder wenn ihr die Anlage von weiteren Mittelzuflüssen im Hinblick
auf die jeweilige Lage an den Kapitalmärkten nicht angebracht erscheint und das Anlageziel gefährden könnte. Die Artikel
7 und 10 des Verwaltungsreglements bleiben unberührt.
5. Ergänzend zu der in Art 9 d) des Verwaltungsreglements enthaltenen Regelung können Festgelder mit einer
Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entspre-
chender Vertrag zwischen der Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, daß diese Festgelder zu jeder Zeit
kündbar sind und ihr Nettorealisierungswert dem Bewertungswert entspricht.
6. In Abweichung von der Regelung in Artikel 11 Absatz 1 (Rücknahme von Anteilen) des Verwaltungsreglements gilt
für die Berechnung des Rücknahmepreises folgende Regelung:
Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert) eingegangen
sind, werden zum Rücknahmepreis (Inventarwert abzüglich Rücknahmegebühr) pro Anteil des jeweils nächsten Bewer-
tungstages abgerechnet.
Art. 3. Entgelt der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 2,00 % p.a. zu erhalten, das
jeweils quartalsweise auf das Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Quartals im voraus zu berechnen und auszuzahlen ist.
Zudem erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale von 0,15 %, aus
welcher die Verwaltungsgesellschaft die Kosten aus Artikel 12 mit Ausnahme der Vergütungen für die Verwaltungsge-
sellschaft, die Depotbank und allen Steuern, die auf das Fondsvermögen erhoben werden, begleicht. Diese Kostenpau-
schale wird ebenfalls zu Beginn des Quartals auf das Netto-Fondsvermögen im voraus berechnet und ausgezahlt.
Für den Fonds darf das mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarte Entgelt der Depotbank folgende Höchstgrenzen
nicht überschreiten:
– ein Entgelt für die Verwahrung des Fondsvermögens in Höhe von bis zu 0,10 % p.a., das jeweils quartalsweise auf
das Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Quartals im voraus zu berechnen und auszuzahlen ist.
Art. 4. Ausschüttungspolitik.
Die Netto-Erträge des Fonds aus Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinnen sowie Erlöse aus dem Verkauf von
Subskriptionsrechten und sonstige Erträge nicht wiederkehrender Art werden kapitalisiert und im Fonds wiederan-
gelegt. Eine Ausschüttung ist grundsätzlich nicht vorgesehen.
Art. 5. Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich zum 30. Juni, erstmals zum 30. Juni 1997.
Art. 6. Dauer des Fonds.
1. Die Laufzeit des Fonds ist auf den 30. Dezember 1999 befristet. Abweichend von Artikel 17 des Verwaltungsregle-
ments hat die Verwaltungsgesellschaft während der Dauer des Fonds nicht das Recht, den Fonds aufzulösen. Zwingende
gesetzliche Auflösungsgründe bleiben hiervon unberührt.
2. Die Verwaltungsgesellschaft wird drei Monate vor Auflösung des Fonds damit beginnen, die Vermögensgegenstände
des Fonds zu veräußern und die Verbindlichkeiten des Fonds zu tilgen. Nach Ende der Laufzeit des Fonds wird die
12021
Depotbank den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder
gegebenenfalls der von der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank im Einvernehmen mit der zuständigen
Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilsinhaber des Fonds im Verhältnis der jeweiligen Anteile
verteilen. Liquidationserlöse, die zum Abschluß des Liquidationsverfahrens nicht eingefordert worden sind, werden,
soweit dann gesetzlich notwendig, in luxemburgische Franken umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der
berechtigten Anteilsinhaber nach Abschluß des Liquidationsverfahrens bei der «Caisse des Consignations» in Luxemburg
hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. Die
Liquidationskosten werden in die tägliche Berechnung des Anteilwertes eingehen.
3. Fondsanteile können letztmals zum 29.12.1999 über die Depotbank, die Verwaltungsgesellschaft oder die
Zahlstellen zurückgegeben werden. Danach können die Anteilsinhaber bei der Depotbank gegen Rückgabe der Anteil-
zertifikate die Auszahlung des anteiligen Erlöses aus der Abwicklung des Fondsvermögens verlangen.
Art. 7. Inkrafttreten.
Das Verwaltungsreglement wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt
des Großherzogtums Luxembourg, am 25. Juli 1991, letztmals am 17. April 1996 veröffentlicht.
Das Sonderreglement, welches am 21. Mai 1996 im Mémorial veröffentlicht wird, tritt am Tag seiner Unterzeichnung
in Kraft.
Dreifach ausgefertigt in Luxemburg, am 24. April 1996.
HYPO CAPITAL MANAGEMENT
HYPOBANK INTERNATIONAL S.A.
INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 479, fol. 9, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(15566/250/129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1996.
HYPO EMERGING MARKETS GARANTIE 06/2001.
—
SONDERREGLEMENT
Für den Fonds HYPO EMERGING MARKETS GARANTIE 06/2001 (der «Fonds») gelten ergänzend zu bzw.
abweichend von dem Verwaltungsreglement (Artikel 1 - 19) die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements:
Art. 1. Anlagepolitik des Fonds.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik für den Fonds und wird dabei von dem beratenden Anlage-
ausschuß und dem Anlageberater unterstützt.
Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht darin, an den Kurssteigerungen der Aktienmärkte von Schwellenländern
(Emerging Markets) zu partizipieren und gleichzeitig sicherzustellen, daß zum Laufzeitende des Fonds am 29.06.2001 der
Liquidationserlös pro Anteil nicht unter 100,00 DEM liegt.
Um die Risiken, welche durch die Kursentwicklung auf den Aktienmärkten entstehen, zu minimieren, wird das Fonds-
vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere
(einschließlich Zerobonds), Wertpapiere an die eine Beteiligung, dem deutschen Aktienindex (DAX) verbriefen (DAX-
Indexpartizipationsscheine), sowie in sonstige zulässige Vermögenswerte investiert. Das Fondsvermögen wird daher zu
Beginn der Anlageperiode in der Weise in diesen Wertpapieren angelegt, daß der Inventarwert pro Anteil in bezug auf
diesen Teil des Fondsvermögens einschließlich der hieraus resultierenden Erträge zum Laufzeitende des Fonds möglichst
100,00 DEM pro Anteil entspricht.
Das Hauptziel der Anlagepolitik wird durch den Kauf von Optionsscheinen oder Kaufoptionen auf Aktienindizes oder
Aktien von Schwellenländern verwirklicht. Dabei kann es sich um Indizes auf einzelne Länder handeln oder auch Indizes,
die als Korb die Wertentwicklung der Aktienmärkte mehrerer Schwellenländer zusammenfassen. Dabei darf der
Gesamtbetrag der für den Kauf von Optionsscheinen auf Aktienindizes von Schwellenländern sowie von Kauf- und
Verkaufsoptionen gezahlten Preise bzw. Prämien in Abweichung von der Regelung in Artikel 5 Absatz 5.5.1.2.2. des
Verwaltungsreglements 35 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen.
Freihändig gehandelte Devisentermingeschäfte dürfen nur dann getätigt werden und freihändig gehandelte Options-
scheine auf Aktienindizes von Schwellenländern und Optionen auf Aktienindizes von Schwellenländern («over-the-
counter» oder «OTC-Optionen») können nur dann erworben werden, wenn die entsprechenden Vertragspartner des
Fonds erstklassige, auf derartige Geschäfte spezialisierte Finanzeinrichtungen sind.
Für den Fonds dürfen daneben flüssige Mittel gehalten oder als Festgelder angelegt werden.
Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Deutsche Mark oder andere Währungen lauten, erfolgen. Das Fonds-
vermögen darf auch aus Investitionen einer einzigen dieser Währung bestehen. Um das Währungsrisiko zu reduzieren,
werden alle Vermögenswerte, die nicht auf Deutsche Mark lauten, gegen die Deutsche Mark weitgehend abgesichert.
Um der Verringerung des Anlagerisikos soweit wie möglich gerecht zu werden, unterliegt die Verwaltungsgesellschaft
bei der Anlage des Fondsvermögens besonderen Beschränkungen (siehe beiliegendes Verwaltungsreglement).
Für die Absicherung der im Fonds enthaltenen Wertpapiere können diese ganz oder teilweise im Rahmen freihändiger
Termin- oder Optionsgeschäfte verkauft werden, vorausgesetzt, daß derartige Geschäfte mit Finanzinstitutionen
erstklassiger Bonität getätigt werden, die sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert haben. Diese Regel gilt auch für
DAX-Indexpartizipationsscheine, welche zu Absicherungszwecken im Rahmen von Termingeschäften verkauft werden.
12022
Mit Ausnahme der Garantie, daß zum Laufzeitende des Fonds am 29.06.2001 der Liquidationserlös pro Anteil nicht
unter 100,00 DEM liegt, kann keine Zusicherung gemacht werden, daß die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Diese Garantie ermäßigt sich für den Fall, daß steuerliche Änderungen während der Laufzeit des Fonds dazu führen, daß
dem Fondsvermögen Zinsen oder Kapital nicht in voller Höhe zufließen. Der garantierte Mindestrücknahmepreis
ermäßigt sich in Höhe dieser Verringerung der Erträge des Fonds einschließlich entgangener Zinsen aus der Wieder-
anlage.
Der Erwerb von Anteilen des Fonds sollte vorrangig längerfristigen Charakter haben.
Art. 2. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Inventarwertberechnung.
1. Die Fondswährung, in welcher für den Fonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis
berechnet werden, ist die Deutsche Mark (DEM).
2. Ausgabepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungsregle-
ments des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 5,0 % davon. Zur Berechnung
des Inventarwertes werden nicht notierte Optionen sowie Optionsscheine auf Aktienindizes oder Aktien zu den
Geldkursen bewertet, die von hierauf spezialisierten Finanzinstituten erster Ordnung gestellt werden. Die Ausgabe von
Anteilen erfolgt am 15. Juli 1996 und wird anschließend eingestellt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen jedoch auch danach jederzeit bis spätestens zum 30.
Dezember 2000 wieder aufnehmen.
Können die Anteile nach der Einzahlung des Ausgabepreises nicht unverzüglich zugeteilt und übertragen werden, so
wird der Einzahlungsbetrag unverzüglich an den Anleger zurücküberwiesen.
3. Rücknahmepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 11 des Verwaltungsre-
glements abzüglich einer Rücknahmegebühr, welche wie folgt festgelegt wird und zugunsten des Fonds erhoben wird:
Zeitraum
Rücknahmepreis
16. 07. 1996 bis 30. 06. 1997
Inventarwert abzüglich 2,5 %
01. 07. 1997 bis 30. 06. 1998
Inventarwert abzüglich 2,0 %
01. 07. 1998 bis 30. 06. 1999
Inventarwert abzüglich 1,5 %
01. 07. 1999 bis 30. 06. 2000
Inventarwert abzüglich 1,0 %
01. 07. 2000 bis 28. 06. 2001
Inventarwert abzüglich 0,5 %
29. 06. 2001
Liquidationserlös = Inventarwert
Bei Auflösung des Fonds erfolgt die Rücknahme von Anteilen zum Inventarwert pro Anteil ohne einen Abschlag.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einstellen, insbe-
sondere falls wesentliche Änderungen auf den Kapitalmärkten oder andere unvorhersehbare Ereignisse politischer,
wirtschaftlicher oder steuerlicher Art dies gebieten oder wenn ihr die Anlage von weiteren Mittelzuflüssen im Hinblick
auf die jeweilige Lage an den Kapitalmärkten nicht angebracht erscheint und das Anlageziel gefährden könnte. Die Artikel
7 und 10 des Verwaltungsreglements bleiben unberührt.
5. Ergänzend zu der in Art 9 d) des Verwaltungsreglements enthaltenen Regelung können Festgelder mit einer
Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entspre-
chender Vertrag zwischen der Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, daß diese Festgelder zu jeder Zeit
kündbar sind und ihr Nettorealisierungswert dem Bewertungswert entspricht.
6. In Abweichung von der Regelung in Artikel 11 Absatz 1 (Rücknahme von Anteilen) des Verwaltungsreglements gilt
für die Berechnung des Rücknahmepreises folgende Regelung:
Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert) eingegangen
sind, werden zum Rücknahmepreis (Inventarwert abzüglich Rücknahmegebühr) pro Anteil des jeweils nächsten Bewer-
tungstages abgerechnet.
Art. 3. Entgelt der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 2,00 % p.a. zu erhalten, das
jeweils quartalsweise auf das Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Quartals im voraus zu berechnen und auszuzahlen ist.
Zudem erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale von 0,15%, aus
welcher die Verwaltungsgesellschaft die Kosten aus Artikel 12 mit Ausnahme der Vergütungen für die Verwaltungsge-
sellschaft, die Depotbank und allen Steuern, die auf das Fondsvermögen erhoben werden, begleicht. Diese Kostenpau-
schale wird ebenfalls zu Beginn des Quartals auf das Netto-Fondsvermögen im voraus berechnet und ausgezahlt.
Für den Fonds darf das mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarte Entgelt der Depotbank folgende Höchstgrenzen
nicht überschreiten:
– ein Entgelt für die Verwahrung des Fondsvermögens in Höhe von bis zu 0,10 % p.a., das jeweils quartalsweise auf
das Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Quartals im voraus zu berechnen und auszuzahlen ist.
Art. 4. Ausschüttungspolitik.
Die Netto-Erträge des Fonds aus Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinnen sowie Erlöse aus dem Verkauf von
Subskriptionsrechten und sonstige Erträge nicht wiederkehrender Art werden kapitalisiert und im Fonds wiederan-
gelegt. Eine Ausschüttung ist grundsätzlich nicht vorgesehen.
Art. 5. Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich zum 30. Juni, erstmals zum 30. Juni 1997.
Art. 6. Dauer des Fonds.
1. Der Laufzeit des Fonds ist auf den 29. Juni 2001 befristet. Abweichend von Artikel 17 des Verwaltungsreglements
hat die Verwaltungsgesellschaft während der Dauer des Fonds nicht das Recht, den Fonds aufzulösen. Zwingende gesetz-
liche Auflösungsgründe bleiben hiervon unberührt.
12023
2. Die Verwaltungsgesellschaft wird drei Monate vor Auflösung des Fonds damit beginnen, die Vermögensgegenstände
des Fonds zu veräußern und die Verbindlichkeiten des Fonds zu tilgen. Nach Ende der Laufzeit des Fonds wird die
Depotbank den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder
gegebenenfalls der von der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank im Einvernehmen mit der zuständigen
Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilsinhaber des Fonds im Verhältnis der jeweiligen Anteile
verteilen. Liquidationserlöse, die zum Abschluß des Liquidationsverfahrens nicht eingefordert worden sind, werden,
soweit dann gesetzlich notwendig, in Iuxemburgische Franken umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der
berechtigten Anteilsinhaber nach Abschluß des Liquidationsverfahrens bei der Caisse des Consignations in Luxemburg
hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. Die
Liquidationskosten werden in die tägliche Berechnung des Anteilwertes eingehen.
3. Fondsanteile können letztmals zum 28. Juni 2001 über die Depotbank, die Verwaltungsgesellschaft oder die
Zahlstellen zurückgegeben werden. Danach können die Anteilsinhaber bei der Depotbank gegen Rückgabe der Anteil-
zertifikate die Auszahlung des anteiligen Erlöses aus der Abwicklung des Fondsvermögens verlangen.
Art. 7. Inkrafttreten.
Das Verwaltungsreglement wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt
des Großherzogtums Luxembourg, am 25. Juli 1991, Ietztmals am 17. April 1996 veröffentlicht.
Das Sonderreglement, welches am 21. Mai im Mémorial veröffentlicht wird, tritt am Tag der Unterzeichnung in Kraft.
Dreifach ausgefertigt in Luxemburg, am 24. April 1996.
HYPO CAPITAL MANAGEMENT
HYPOBANK INTERNATIONAL S.A.
INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 479, fol. 9, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(15567/250/131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1996.
HYPO JAPAN GARANTIE 06/2000.
—
SONDERREGLEMENT
Für den Fonds HYPO JAPAN GARANTIE 06/2000 (der «Fonds») gelten ergänzend bzw. abweichend zu dem Verwal-
tungsreglement (Artikel 1 - 19) die Bestimmungen des nachstehenden Sonderreglements:
Art. 1. Anlagepolitik des Fonds.
Die Verwaltungsgesellschaft bestimmt die Anlagepolitik für den Fonds und wird dabei von dem beratenden Anlage-
ausschuß und dem Anlageberater unterstützt.
Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht darin, an den Kurssteigerungen des japanischen Aktienmarktes zu partizi-
pieren und gleichzeitig sicherzustellen, daß zum Laufzeitende des Fonds am 30.06.2000 der Liquidationserlös pro Anteil
nicht unter 100,00 DEM liegt.
Um die Risiken, welche durch die Kursentwicklung auf den Aktienmärkten entstehen, zu minimieren, wird das Fonds-
vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere
(einschließlich Zerobonds), Wertpapiere, die eine Beteiligung an dem deutschen Aktienindex (DAX) verbriefen (DAX-
Indexpartizipationsscheine), sowie in sonstige zulässige Vermögenswerte investiert. Das Fondsvermögen wird daher zu
Beginn der Anlageperiode in der Weise in diesen Wertpapieren angelegt, daß der Inventarwert pro Anteil in bezug auf
diesen Teil des Fondsvermögens einschließlich der hieraus resultierenden Erträge zum Laufzeitende des Fonds möglichst
100,00 DEM pro Anteil entspricht.
Das Hauptziel der Anlagepolitik wird durch den Kauf von Optionsscheinen oder Kaufoptionen auf japanische Aktien-
indizes oder japanische Aktien verwirklicht. Dabei darf der Gesamtbetrag der für den Kauf von Optionsscheinen auf
japanische Aktienindizes sowie von Kauf- und Verkaufsoptionen gezahlten Preise bzw. Prämien in Abweichung von der
Regelung in Artikel 5 Absatz 5.5.1.2.2. des Verwaltungsreglements 35 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen.
Freihändig gehandelte Devisentermingeschäfte dürfen nur dann getätigt werden und freihändig gehandelte Options-
scheine auf japanische Aktienindizes und Optionen auf japanische Aktienindizes («over-the-counter» oder «OTC-
Optionen») können nur dann erworben werden, wenn die entsprechenden Vertragspartner des Fonds erstklassige, auf
derartige Geschäfte spezialisierte Finanzeinrichtungen sind.
Für den Fonds dürfen daneben flüssige Mittel gehalten oder als Festgelder angelegt werden.
Die Anlage kann in Vermögenswerten, die auf Deutsche Mark oder andere Währungen lauten, erfolgen. Das Fonds-
vermögen darf auch aus Investitionen einer einzigen dieser Währungen bestehen. Um das Währungsrisiko zu
reduzieren, werden alle Vermögenswerte, die nicht auf Deutsche Mark lauten, gegen die Deutsche Mark weitgehend
abgesichert.
Um der Verringerung des Anlagerisikos soweit wie möglich gerecht zu werden, unterliegt die Verwaltungsgesellschaft
bei der Anlage des Fondsvermögens besonderen Beschränkungen (siehe beiliegendes Verwaltungsreglement).
Für die Absicherung der im Fonds enthaltenen Wertpapiere können diese ganz oder teilweise im Rahmen freihändiger
Termin- oder Optionsgeschäfte verkauft werden, vorausgesetzt, daß derartige Geschäfte mit Finanzinstitutionen
erstklassiger Bonität getätigt werden, die sich auf diese Art von Geschäften spezialisiert haben. Diese Regel gilt auch für
DAX-lndexpartizipationsscheine, welche zu Absicherungszwecken im Rahmen von Termingeschäften verkauft werden.
12024
Mit Ausnahme der Garantie, daß zum Laufzeitende des Fonds am 30.06.2000 der Liquidationserlös pro Anteil nicht
unter DEM 100,00 liegt, kann keine Zusicherung gemacht werden, daß die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden.
Diese Garantie ermäßigt sich für den Fall, daß steuerliche Änderungen während der Laufzeit des Fonds dazu führen, daß
dem Fondsvermögen Zinsen oder Kapital nicht in voller Höhe zufließen. Der garantierte Mindestrücknahmepreis
ermäßigt sich in Höhe dieser Verringerung der Erträge des Fonds einschließlich entgangener Zinsen aus der Wieder-
anlage.
Der Erwerb von Anteilen des Fonds sollte vorrangig längerfristigen Charakter haben.
Art. 2. Fondswährung, Ausgabe- und Rücknahmepreis, Inventarwertberechnung.
1. Die Fondswährung, in welcher für den Fonds der Inventarwert, der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis
berechnet werden, ist die Deutsche Mark (DEM).
2. Ausgabepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 6 in Verbindung mit Artikel 9 des Verwaltungs-
reglements des entsprechenden Bewertungstages zuzüglich einer Verkaufsprovision von bis zu 3,0 % davon. Zur
Berechnung des Inventarwertes werden nicht notierte Optionen sowie Optionsscheine auf Aktienindizes oder Aktien
zu den Geldkursen bewertet, die von hierauf spezialisierten Finanzinstituten erster Ordnung gestellt werden. Die
Ausgabe von Anteilen erfolgt am 15. Juli 1996 und wird anschließend eingestellt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen jedoch auch danach jederzeit bis spätestens 30.
Dezember 1999 wieder aufnehmen.
Können die Anteile nach der Einzahlung des Ausgabepreises nicht unverzüglich zugeteilt und übertragen werden, so
wird der Einzahlungsbetrag unverzüglich an den Anleger zurücküberwiesen.
3. Rücknahmepreis ist der Inventarwert pro Anteil gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 11 des Verwaltungsre-
glements abzüglich einer Rücknahmegebühr, welche wie folgt festgelegt wird und zugunsten des Fonds erhoben wird:
Zeitraum
Rücknahmepreis
16. 07. 1996 bis 30. 06. 1997
Inventarwert abzüglich 2,0 %
01. 07. 1997 bis 30. 06. 1998
Inventarwert abzüglich 1,5 %
01. 01. 1998 bis 30. 06. 1999
Inventarwert abzüglich 1,0 %
01. 07. 1999 bis 29. 06. 2000
Inventarwert abzüglich 1,0 %
30. 06. 2000
Liquidationserlös = Inventarwert
Bei Auflösung des Fonds erfolgt die Rücknahme von Anteilen zum Inventarwert ohne einen Abschlag.
4. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder vollständig einstellen, insbe-
sondere falls wesentliche Änderungen auf den Kapitalmärkten oder andere unvorhersehbare Ereignisse politischer,
wirtschaftlicher oder steuerlicher Art dies gebieten oder wenn ihr die Anlage von weiteren Mittelzuflüssen im Hinblick
auf die jeweilige Lage an den Kapitalmärkten nicht angebracht erscheint und das Anlageziel gefährden könnte. Die Artikel
7 und 10 des Verwaltungsreglements bleiben unberührt.
5. Ergänzend zu der in Art 9 d) des Verwaltungsreglements enthaltenen Regelung können Festgelder mit einer
Ursprungslaufzeit von mehr als 60 Tagen mit dem jeweiligen Renditekurs bewertet werden, vorausgesetzt, ein entspre-
chender Vertrag zwischen der Depotbank und der Verwaltungsgesellschaft sieht vor, daß diese Festgelder zu jeder Zeit
kündbar sind und ihr Nettorealisierungswert dem Bewertungswert entspricht.
6. In Abweichung von der Regelung in Artikel 11 Absatz 1 (Rücknahme von Anteilen) des Verwaltungsreglements gilt
für die Berechnung des Rücknahmepreises folgende Regelung:
Rücknahmeanträge, die an einem Bewertungstag (wie in Artikel 9 des Verwaltungsreglements definiert) eingegangen
sind, werden zum Rücknahmepreis (Inventarwert abzüglich Rücknahmegebühr) pro Anteil des jeweils nächsten Bewer-
tungstages abgerechnet.
Art. 3. Entgelt der Verwaltungsgesellschaft und der Depotbank.
Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, aus dem Fondsvermögen ein Entgelt von bis zu 2,00 % p.a. zu erhalten, das
jeweils quartalsweise auf das Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Quartals im voraus zu berechnen und auszuzahlen ist.
Zudem erhält die Verwaltungsgesellschaft aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale von 0,15 %, aus
welcher die Verwaltungsgesellschaft die Kosten aus Artikel 12 mit Ausnahme der Vergütungen für die Verwaltungsge-
sellschaft, die Depotbank und allen Steuern, die auf das Fondsvermögen erhoben werden, begleicht. Diese Kostenpau-
schale wird ebenfalls zu Beginn des Quartals auf das Netto-Fondsvermögen im voraus berechnet und ausgezahlt.
Für den Fonds darf das mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarte Entgelt der Depotbank folgende Höchstgrenzen
nicht überschreiten:
– ein Entgelt für die Verwahrung des Fondsvermögens in Höhe von bis zu 0,10 % p.a., das jeweils quartalsweise auf
das Netto-Fondsvermögen zu Beginn des Quartals im voraus zu berechnen und auszuzahlen ist.
Art. 4. Ausschüttungspolitik.
Die Netto-Erträge des Fonds aus Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinnen sowie Erlöse aus dem Verkauf von
Subskriptionsrechten und sonstige Erträge nicht wiederkehrender Art werden kapitalisiert und im Fonds wiederan-
gelegt. Eine Ausschüttung ist grundsätzlich nicht vorgesehen.
Art. 5. Rechnungsjahr.
Das Rechnungsjahr des Fonds endet jährlich zum 30. Juni, erstmals zum 30. Juni 1997.
Art. 6. Dauer des Fonds.
1. Die Laufzeit des Fonds ist auf den 30. Juni 2000 befristet. Abweichend von Artikel 17 des Verwaltungsreglements
hat die Verwaltungsgesellschaft während der Dauer des Fonds nicht das Recht, den Fonds aufzulösen.
Zwingende gesetzliche Auflösungsgründe bleiben hiervon unberührt.
2. Die Verwaltungsgesellschaft wird drei Monate vor Auflösung des Fonds damit beginnen, die Vermögensgegenstände
des Fonds zu veräußern und die Verbindlichkeiten des Fonds zu tilgen. Nach Ende der Laufzeit des Fonds wird die
12025
Depotbank den Liquidationserlös abzüglich der Liquidationskosten auf Anweisung der Verwaltungsgesellschaft oder
gegebenenfalls der von der Verwaltungsgesellschaft oder der Depotbank im Einvernehmen mit der zuständigen
Aufsichtsbehörde ernannten Liquidatoren unter die Anteilsinhaber des Fonds im Verhältnis der jeweiligen Anteile
verteilen. Liquidationserlöse, die zum Abschluß des Liquidationsverfahrens nicht eingefordert worden sind, werden,
soweit dann gesetzlich notwendig, in luxemburgische Franken umgerechnet und von der Depotbank für Rechnung der
berechtigten Anteilsinhaber nach Abschluß des Liquidationsverfahrens bei der Caisse des Consignations in Luxemburg
hinterlegt, wo diese Beträge verfallen, wenn sie nicht innerhalb der gesetzlichen Frist dort angefordert werden. Die
Liquidationskosten werden in die tägliche Berechnung des Anteilwertes eingehen.
3. Fondsanteile können letztmals zum 29. Juni 2000 über die Depotbank, die Verwaltungsgesellschaft oder die
Zahlstellen zurückgegeben werden. Danach können die Anteilsinhaber bei der Depotbank gegen Rückgabe der Anteil-
zertifikate die Auszahlung des anteiligen Erlöses aus der Abwicklung des Fondsvermögens verlangen.
Art. 7. Inkrafttreten.
Das Verwaltungsreglement wurde im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations («Mémorial»), dem Amtsblatt
des Großherzogtums Luxembourg, am 25. Juli 1991, letztmals am 17. April 1996 veröffentlicht.
Das Sonderreglement, welches am 21. Mai 1996 im Mémorial veröffentlicht wird, tritt am Tag seiner Unterzeichnung
in Kraft.
Dreifach ausgefertigt in Luxemburg, am 24. April 1996.
HYPO CAPITAL MANAGEMENT
HYPOBANK INTERNATIONAL S.A.
INVESTMENTGESELLSCHAFT LUXEMBOURG S.A.
<i>Die Verwaltungsgesellschafti>
<i>Die Depotbanki>
Unterschriften
Unterschriften
Enregistré à Luxembourg, le 6 mai 1996, vol. 479, fol. 9, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(15568/250/130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 mai 1996.
LUSEMOL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2230 Luxembourg, 33, rue du Fort Neipperg.
R. C. Luxembourg B 53.089.
—
Lors de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société LUSEMOL S.A., qui s’est tenue à Luxem-
bourg, 6, rue Dicks, le 4 mars 1996, les associés ont adopté, à l’unanimité, les résolutions suivantes:
1. Madame Elise Leroy, veuve Mattiussi, a été démise, avec effet immédiat et pour motifs graves, de ses fonctions
d’administrateur de la société.
2. A été nommée administrateur en remplacement de Madame Leroy, Madame Christiane Seyler, employée privée,
demeurant à Hovelange, 1A, Bockwé.
3. A été déchargé de ses fonctions de commissaire aux comptes, avec effet immédiat et pour motifs graves, Monsieur
Pascal Weyland, étudiant, demeurant à Luxembourg, 62A, rue des Muguets.
4. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes, en remplacement de Monsieur Pascal Weyland, la
FIDUCIAIRE EPIS S.A., établie à L-2340 Luxembourg, 32, rue Philippe II.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
<i>Pour la sociétéi>
M.-R. Barboni
M. Schmit
J.-M. Schmit C. Seyler
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 39, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09511/000/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
PROMAC S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1627 Luxembourg, 16, rue Giselbert.
R. C. Luxembourg B 46.290.
—
<i>Extrait du procès -verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue à Luxembourg en date du 20 novembre 1995i>
Il résulte dudit procès-verbal que:
- décharge pleine et entière a été donnée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de toute responsabilité
résultant de l’exercice de leurs fonctions.
- le mandat des administrateurs, Madama Sylvie Sibenaler, Madame Sylvette Kropp et Monsieur Lex Benoy, ainsi que
celui du commissaire aux comptes, Monsieur Guy Waltener, a été renouvelé pour un terme d’un an, jusqu’à la prochaine
assemblée générale ordinaire.
Luxembourg, le 20 novembre 1995.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 35, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09531/614/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
12026
INTERNATIONAL ADVISORS AND CONSULTANTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 37.444.
—
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la société, tenue en date du 8 février 1996, que:
- Le siège social de la société a été transféré de L-2330 Luxembourg, 134, boulevard de la Pétrusse à L-1470 Luxem-
bourg, 50, route d’Esch.
- BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG, ayant son siège social 50, route d’Esch à L-1470 Luxembourg, a été
nommée commissaire aux comptes de la société, en remplacement de la SOCIETE FIDUCIAIRE DE LA COMMU-
NAUTE S.A., commissaire aux comptes démissionnaire.
Son mandat prendra fin à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.
- La cooptation de Monsieur Yves Schmit au poste d’administrateur de la société a été ratifiée. Son mandat prendra
fin à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en 1997.
Pour extrait conforme, délivré aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 1996.
<i>Pour la sociétéi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09364/595/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
INTERNATIONAL BRAKE S.A. HOLDING, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 28.727.
—
Il résulte de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 10 février 1995, que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Roberto Carbotti, demeurant à Torino
(Italie), de ses fonctions de président du conseil d’administration de la société.
L’assmblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Lino Fiocco, demeurant à Torino (Italie), de
sa fonction d’administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée prend acte et accepte la démission présentée par Monsieur Stéphane Bosi, de ses fonctions de commis-
saire aux comptes.
<i>Troisième résolutioni>
En remplacement des administrateurs démissionnaires, l’assemblée décide de nommer les administrateurs suivants:
- Monsieur Mario Speranza, dirigeant, demeurant à Milano, via Corregio, 3,
- Monsieur Angelo Bestente, dirigeant, demeurant à Cunico, via Burzio, 15.
Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l’assemblée générale annuelle à tenir en 1997.
<i>Quatrième résolutioni>
En remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, l’assemblée décide de nommer la société REVISION
ET CONSEILS ASSOCIES, ayant son siège social, 2, boulevard de la Grande-Duchesse Charlotte, L-1332 Luxembourg.
Le mandat du commissaire aux comptes ainsi nommé expirera à l’assemlbée générale annuelle à tenir en 1997.
Pour réquisition aux fins de modification au registre de commerce et des sociétés et de publication au Mémorial,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
INTERNATIONAL BRAKE S.A. HOLDING
M. Speranza A. Bestente T. Kashiyama Y. Kashiyama
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 24, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09365/043/32) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
TONI LAZZARA, S.à r.l. et Cie, S.e.c.s., Société en commandite simple.
Siège social: L-1536 Luxembourg, 7, rue du Fossé.
—
L’entreprise a changé l’adresse de son siège social, qui se trouve désormais au 7, rue du Fossé à L-1536 Luxembourg.
Luxembourg, le 1
er
septembre 1994.
Enregistré à Luxembourg, le 14 février 1996, vol. 476, fol. 55, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M.-N. Kirchen.
(09373/000/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12027
INVEST IMMOBILIERE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2635 Luxembourg, 1, rue Henri Tudor.
R. C. Luxembourg B 36.392.
—
<i>Démission d’administrateursi>
Pour cause d’irrégularités, les soussignés, Mlle Annie Feybesse, domiciliée à F-57110 Basse Ham, et M. Francis
Zakostelsky, domicilié à L-5408 Bous, démissionnent de leur mandat d’administrateur avec effet au 15 janvier 1995.
Fait à Luxembourg.
A. Feybesse
F. Zakostelsky
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 23, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09366/999/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
JOLIU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.191.
—
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le quinze février.
Par-devant Maître Jean-Paul Hencks, notaire de résidence à Luxembourg.
S’est réunie l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme JOLIU S.A., avec siège social
à Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire en date du 15 décembre 1993, publié au Mémorial C, n°
107 du 23 mars 1994 et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu
par le notaire instrumentaire en date du 22 mars 1995, publié au Mémorial C, n° 336 du 24 juillet 1995.
L’assemblée est présidée par Monsieur Claude Faber, licencié en sciences économiques, demeurant à Luxembourg,
qui désigne comme secrétaire, Monsieur José Ney, employé privé, demeurant à Steinsel.
L’assemblée choisit comme scrutateur, Mademoiselle Sylvie Colling, employée privée, demeurant à Diekirch.
Le bureau étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d’acter ce qui suit:
I.- L’ordre du jour de l’assemblée est conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
- Augmentation du capital social à concurrence d’un million neuf cent soixante-dix mille francs (1.970.000,- LUF),
pour le porter de son montant actuel de seize millions trois cent cinquante mille francs (16.350.000,- LUF) à dix-huit
millions trois cent vingt mille francs (18.320.000,- LUF), par la création et l’émission de cent quatre-vingt-dix-sept (197)
actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune.
<i>Souscription et libération des actions nouvellesi>
Modification afférente de l’article 3 des statuts.
II.- Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés ainsi que le nombre
d’actions qu’ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau, sera enregistrée avec le présent acte, ensemble avec les procurations paraphées ne varietur par les manda-
taires.
III.- Il résulte de la liste de présence que toutes les actions sont présentes ou représentées à l’assemblée. Dès lors,
l’assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur l’ordre du jour, dont les actionnaires ont pris
connaissance avant la présente assemblée.
IV.- Après délibération, l’assemblée prend, à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide d’augmenter le capital social à concurrence d’un million neuf cent soixante-dix mille
francs (1.970.000,- LUF), pour le porter de son montant actuel de seize millions trois cent cinquante mille francs
(16.350.000,- LUF) à dix-huit millions trois cent vingt mille francs (18.320.000,- LUF), par la création et l’émission de cent
quatre-vingt-dix-sept (197) actions nouvelles d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune, jouissant
des mêmes droits et avantages que les actions existantes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale, ayant pris acte du fait que l’actionnaire minoritaire a renoncé à son droit préférentiel de
souscription, décide d’admettre à la souscription des cent quatre-vingt-dix-sept (197) actions nouvelles, Monsieur Josep
Oliu Creus, économiste, demeurant à Alella (Barcelone).
<i>Intervention - Souscriptioni>
Est ensuite intervenu Monsieur Josep Oliu Creus, prénommé,
ici représenté par Monsieur Claude Faber, prénommé,
en vertu d’une procuration donnée en date du 15 janvier 1996, qui restera annexée au présent acte pour être enregis-
trée avec lui,
lequel a déclaré souscrire les cent quatre-vingt-dix-sept (197) actions nouvelles pour la valeur nominale de dix mille
francs (10.000,- LUF) chacune, lesquelles ont été intégralement libérées par le versement en espèces d’un montant d’un
million neuf cent soixante-dix mille francs (1.970.000,- LUF), ce dont la preuve a été apportée au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
12028
<i>Troisième résolutioni>
A la suite des résolutions qui précèdent, l’assemblée générale décide de modifier l’article 3, alinéa premier des statuts,
pour lui donner la teneur suivante:
«Le capital social est fixé à dix-huit millions trois cent vingt mille francs (18.320.000,- LUF), représenté par mille huit
cent trente-deux (1.832) actions d’une valeur nominale de dix mille francs (10.000,- LUF) chacune, entièrement
libérées.»
<i>Coûti>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison
de la présente augmentation de capital, sont évalués approximativement à 150.000,- francs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, Monsieur le Président lève la séance.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte, aucun autre actionnaire n’ayant
demandé à signer.
Signé: C. Faber, J. Ney, S. Colling, J.-P. Hencks.
Enregistré à Luxembourg, le 22 février 1996, vol. 89S, fol. 43, case 2. – Reçu 19.700 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
J.-P. Hencks.
(09367/216/74) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
JOLIU S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 46.191.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
J.-P. Hencks.
(09368/216/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
KALNE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 51.598.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d’Administration du 26 février 1996 que:
<i>Seule et unique résolutioni>
Le Conseil d’Administration prend acte de la démission (Annexe 1) de Monsieur Thierry Jaumin de ses fonctions
d’administrateur. Le Conseil d’Administration décide, à l’unanimité des voix, de coopter en son sein, et ce avec effet
immédiat, Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 8-14, rue Guillaume Schneider, en rempla-
cement de Monsieur Thierry Jaumin, démissionnaire.
Pour réquisition aux fins de modification au registre de commerce et des sociétés et de publication au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
KALNE S.A.
Signature
<i>L’agent domiciliatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09369/043/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
KERMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 40.657.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 32, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau …………………………………………………………………… LUF (612.210,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
Signature.
(09371/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12029
KERMA S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 35, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 40.657.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 32, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Report à nouveau …………………………………………………………………… LUF (831.392,-)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
Signature.
(09372/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
KALOA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 19.792.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
KALOA HOLDING S.A.
M. Mommaerts
J.P. Reiland
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09370/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
LUXSTREET S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.695.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 20 février 1996i>
L’Assemblée Générale Extraordinaire nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Sheridan Ralph Gill, administrateur de sociétés, demeurant à Le Friquet, Sark, Channel Islands, adminis-
trateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature;
- Madame Hazel Gill, administrateur de sociétés, demeurant à Le Friquet, Sark, Channel Islands;
- Monsieur Philipp Murray Stokes, administrateur de sociétés, demeurant à Rose Cottage, Sark, Channel Islands.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09376/657/17) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
MAXIME, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3380 Noertzange, 62, rue Principale.
R. C. Luxembourg B 29.798.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 86, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1996.
Signature.
(09378/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
MONDEGO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 30.289.
—
Les comptes annuels au 31 mars 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 32, case 5, ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
MONDEGO HOLDING S.A.
Signature
(09382/545/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12030
MONDEGO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue A. Neyen.
R. C. Luxembourg B 30.289.
—
<i>Extrait des résolutions prises lors de l’assemblée générale statutaire du 27 juillet 1995i>
Madame M.-F. Ries-Bonani et Messieurs A. De Bernardi et L- Bonani sont renommés administrateurs pour une
nouvelle période de trois ans. Madame R. Scheifer-Gillen est renommée commissaire aux comptes pour la même
période. Leur mandat viendra à échéance lors de l’assemblée générale statutaire de 1999.
Luxembourg, le 27 juillet 1995.
MONDEGO HOLDING S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 32, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09383/545/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
MBS-L, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 111, route d’Arlon.
R. C. Luxembourg B 29.984.
—
DISSOLUTION
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le dix-huit janvier.
Par-devant Maître Jacqueline Hansen-Peffer, notaire de résidence à Capellen.
Ont comparu:
1. - Monsieur Serge Willems, commerçant, demeurant à L-8473 Eischen, 34, rue de Hobscheid;
2. - Madame Romaine Mamer, sans état, épouse de Monsieur Serge Willems, demeurant à L-8473 Eischen, 34, rue de
Hobscheid.
Ces comparants sont les seuls associés de la Société à responsabilité limitée MBS-L, S.à r.l., avec siège social à L-8009
Strassen, 111, route d’Arlon, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 29.984,
constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 30 décembre 1988,
publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg, C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 109 du
24 avril 1989.
La société a un capital social d’un million deux cent cinquante mille francs (1.250.000,-), divisé en mille deux cent
cinquante (1.250) parts sociales de mille francs (1.000,- LUF) chacune.
D’un commun accord, les associés décident de dissoudre la prédite société avec effet rétroactif au 12 janvier 1996 et
déclarent que la liquidation a été faite aux droits des parties.
Les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à l’ancien siège
social.
Dont acte, fait et passé à Cap, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentaire par leurs nom,
prénom usuel, état et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. Willems, R. Mamer, J. Peffer.
Enregistré à Capellen, le 23 janvier 1996, vol. 406, fol. 57, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
Pour copie conforme, délivrée sur papier libre, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associa-
tions.
Cap, le 8 mars 1996.
J. Hansen-Peffer.
(09379/214/34) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
NATURATA, S.à r.l., Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Luxemburg.
H. R. Luxemburg B 31.794.
—
Im Jahre neunzehnhundertsechsundneunzig, am fünfzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul Bettingen, mit Amtssitz in Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Roland Majerus, technischer Ingenieur, wohnhaft in Helmsange;
2.- Herr Änder Schanck, technischer Ingenieur, wohnhaft in Hupperdingen;
3.- Frau Judita Freymuth, Hausfrau, wohnhaft in Luxemburg;
4.- Frau Anita Assel, Geschäftsfrau, wohnhaft in Luxemburg;
5.- Frau Marie-Pierre Querin, Hausfrau, wohnhaft in Rameldingen;
6.- Frau Johanna Merkhoffer, Sekretärin, wohnhaft in Luxemburg;
7.- BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG (BioG), mit Sitz in Luxemburg, hier vertreten durch Herrn
Änder Schanck, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als Präsident und Geschäftsführer, gemäss Satzung.
12031
Welche Komparenten erklären, in ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung NATURATA, S.à r.l., mit Sitz in Luxemburg, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den Notar
André-Jean-Joseph Schwachtgen, mit Amtssitz in Luxemburg, am 15. September 1989, veröffentlicht im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 63 vom 26. Februar 1990, eingetragen im Handelsregister beim Bezirks-
gericht Luxemburg, unter Sektion B und der Nummer 31.794,
sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden, zu welcher sie sich als ordentlich ein-
berufen betrachten, so dass die gegenwärtige Generalversammlung, die die Gesamtheit des Gesellschaftskapitals
darstellt, regelgerecht zusammentreten und somit gültig über folgende Tagesordnung beraten kann:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Annahme im Namen der Gesellschaft durch den Geschäftsführer der Gesellschaftsanteilsübertragung, welche
getätigt wurde unter Privatschrift am 13. Juli 1995.
2.- Neuaufteilung der Gesellschaftsanteile, Herausnehmen der Gesellschaftskapitalzeichnung aus der Satzung und
demgemäss Abänderung von Artikel fünf der Satzung wie folgt:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million vierhunderttausend (1.400.000,- LUF) luxembur-
gische Franken, aufgeteilt in vierzehnhundert (1.400) Anteile im Nennwert von je tausend (1.000,- LUF) Franken, alle
vollständig eingezahlt.
Die Gesellschaftsanteile bestehen nur in der Form von Namensanteilen.»
3.- Erweiterung des Gesellschaftszweckes und demgemäss Umänderung des Absatzes a) von Artikel zwei der Satzung
wie folgt:
«Art. 2. Absatz a. a) Der Handel mit lebensgemässen Gütern aus ökologisch angepasster, die Belange des Umwelt-
schutzes berücksichtigender Produktion unter anderem speziell auf das Kind ausgerichteter Produkte sowie Lebens-
mittel aus biologischem, insbesondere biologisch-dynamischem Anbau, wobei die Produkte der BioG (BIO-BAUERE-
GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG) bei marktgerechten Preisen Vorrang haben; sowie Dienstleistungen, die den
Handel mit den vorgenannten Gütern fördern.»
4.- Abänderung des achten Artikels der Satzung wie folgt:
«Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten, welche nicht Gesellschafter zu
sein brauchen, und jederzeit durch die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, welche sie ernennt, abberufen
werden können.
Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer, deren
Befugnisse und Gehälter.»
Gemäss der Tagesordnung haben die Gesellschafter einstimmig folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Gemäss Gesellschaftsanteilabtretung, getätigt unter Privatschrift am 13. Juli 1995, hat Herr Roland Majerus, vor-
genannt, fünfhundert (500) Anteile der Gesellschaft NATURATA, S.à r.l. an die BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT
LËTZEBUERG (BioG), vorgenannt, übertragen unter aller Gewähr Rechtens, zu dem zwischen den Parteien verein-
barten Preise.
Herr Roland Majerus, vorgenannt, in seiner Eigenschaft als alleiniger Geschäftsführer vorgenannter Gesellschaft
erklärt hiermit die vorgenannte Übertragung von Gesellschaftsanteilen im Namen der Gesellschaft anzunehmen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Zeichnung des Gesellschaftskapitals aus Artikel fünf der Satzung herauszunehmen.
Infolgedessen beschliessen die Gesellschafter, Artikel fünf der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf eine Million vierhunderttausend (1.400.000,- LUF) luxembur-
gische Franken, aufgeteilt in vierzehnhundert (1.400) Anteile im Nennwert von je tausend (1.000,- LUF) Franken, alle
vollständig eingezahlt.
Die Gesellschaftsanteile bestehen nur in der Form von Namensanteilen.»
Auf Grund der obengenannten getätigten Abtretung von Gesellschaftsanteilen, sowie aufgrund diverser anderer
Anteilsübertragungen geschehen unter Privatschrift, welche eine Neuaufteilung der Anteile zur Folge haben, ist somit
das Gesellschaftskapital heute wie folgt gezeichnet:
1) BIO-BAUERE-GENOSSENSCHAFT, vorgenannt, achthundert Anteile …………………………………………………………………
800
2) Herr Roland Majerus, vorgenannt, zweihundertfünf Anteile………………………………………………………………………………………
205
3) Frau Johanna Merkhoffer, vorgenannt, einhundert Anteile …………………………………………………………………………………………
100
4) Herr Änder Schanck, vorgenannt, fünfundneunzig Anteile …………………………………………………………………………………………
95
5) Frau Anita Assel, vorgenannt, fünfundsiebzig Anteile …………………………………………………………………………………………………
75
6) Frau Marie-Pierre Querin, vorgenannt, fünfundsiebzig Anteile …………………………………………………………………………………
75
7) Frau Judita Freymuth, vorgenannt, fünfzig Anteile………………………………………………………………………………………………………… 50
Total: vierzehnhundert Anteile ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.400
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, den Gesellschaftszweck zu erweitern und und demgemäss Absatz a) von Artikel zwei
der Satzung wie folgt umzuändern:
«Art. 2. Absatz a. a) Der Handel mit lebensgemässen Gütern aus ökologisch angepasster, die Belange des Umwelt-
schutzes berücksichtigender Produktion unter anderem speziell auf das Kind ausgerichteter Produkte sowie Lebens-
mittel aus biologischem, insbesondere biologisch-dynamischem Anbau, wobei die Produkte der BioG (BIO-BAUERE-
12032
GENOSSENSCHAFT LËTZEBUERG) bei marktgerechten Preisen Vorrang haben; sowie Dienstleistungen, die den
Handel mit den vorgenannten Gütern fördern.»
<i>Vierter und letzter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen, Artikel acht der Satzung wie folgt abzuändern:
«Art. 8. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten, welche nicht Gesellschafter zu
sein brauchen, und jederzeit durch die Gesellschaftsversammlung der Gesellschaft, welche sie ernennt, abberufen
werden können.
Die Generalversammlung der Gesellschafter bestimmt die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer, deren
Befügnisse und Gehälter.»
Die Kosten, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf dreissigtausend
Franken (30.000,- LUF) abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an die Erschienenen, haben dieselben mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: R. Majerus, A. Schanck, J. Freymuth, A. Assel, M.-P. Querin, J. Merkhoffer, P. Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 89S, fol. 50, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Für gleichlautende Ausfertigung, der Gesellschaft auf Begehr erteilt, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, erteilt.
Niederanven, den 11. März 1996.
P. Bettingen.
(09384/202/104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
NATURATA, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 31.794.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Niederanven, le 11 mars 1996.
P. Bettingen.
(09385/202/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
MC EUROPEAN CAPITAL (HOLDINGS) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d’Esch.
R. C. Luxembourg B 49.742.
—
La démission de Monsieur Fouad Said en tant qu’administrateur de catégorie C de MC EUROPEAN CAPITAL
(HOLDINGS) S.A. est acceptée avec effet le 17 juillet 1995.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
<i>Pour MC EUROPEAN CAPITAL (HOLDINGS) S.A.i>
BBL TRUST SERVICES LUXEMBOURG S.A.
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 27, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Medinger.
(09380/017/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
NORISCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 29, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(09389/576/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
NORISCO HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 10, avenue de la Faïencerie.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 29, case 10, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
<i>Pour le Conseil d’Administrationi>
Signature
(09390/576/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12033
NECKER S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 23, avenue de la Porte-Neuve.
R. C. Luxembourg B 40.865.
—
<i>Extraits des résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 15 janvier 1996i>
<i>Nomination de nouveaux administrateursi>
L’Assemblée Générale, constatant que Messieurs Jean Quintus, Gérard Coene et Jean Pierson avaient démissionné de
leurs fonctions d’Administrateur, a décidé de nommer en leur remplacement, Monsieur Jean Zeimet, Madame Christel
Henon et Madame Marcelle Clemens, pour la durée du mandat des Administrateurs démissionnaires restant à courir.
Leur mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 1997.
<i>Nomination d’un nouveau Commissaire aux Comptesi>
L’Assemblée Générale, constatant la démission de Monsieur Joseph Winandy de ses fonctions de Commissaire aux
comptes, a décidé de nommer en son remplacement, Madame Albertine Fischer, pour la durée du mandat du Commis-
saire aux comptes démissionnaire restant à courir. Son mandat viendra à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale
Ordinaire annuelle de 1997.
Fait à Luxembourg, le 15 janvier 1996.
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 20, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09387/720/21) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
NEW FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Esch-sur-Alzette, 47, rue de la Libération.
R. C. Luxembourg B 20.140.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 1996, vol. 416, fol. 68, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
DEBELUX AUDIT, S.à r.l.
Signature
(09388/722/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
OPEN DEAL, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Dippach.
R. C. Luxembourg B 39.609.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 86, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1996.
Signature.
(09391/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
ORIENTTEPPICH OASE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 52, rue d’Anvers.
R. C. Luxembourg B 43.468.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 72, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 1995.
Signature.
(09392/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
PEC EUROPE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Roodt-sur-Syre.
R. C. Luxembourg B 29.146.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1989, 1990 et 1991, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol.
86, case 2, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1996.
Signature.
(09394/603/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12034
PALOS S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 48.088.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 30, case 3, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
PALOS S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
(09393/526/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
PIVOINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.700.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 28 février 1996i>
L’assemblée générale extraordinaire nomme comme nouveaux administrateurs:
- Monsieur Sheridan Ralph Gill, administrateur de sociétés, demeurant à Le Friquet, Sark, Channel Islands, adminis-
trateur-délégué de la société, avec pouvoir d’engager la société sous sa seule signature.
- Madame Hazel Gill, administrateur de sociétés, demeurant à Le Friquet, Sark, Channel Islands.
- Monsieur Philipp Murray Stokes, administrateur de sociétés, demeurant à Le Friquet, Sark, Channel Islands.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09396/657/16) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
PIVOINE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 28, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 49.700.
—
<i>Extrait de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Luxembourg, le 28 février 1996i>
Le Conseil d’Administration décide de transférer le siège social de la société au 28, boulevard Joseph II, L-1840
Luxembourg.
Pour copie conforme
FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 33, case 7. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09397/657/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
P.O.S. MARKETING & CONSULT, GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, avenue de la Liberté.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am neunten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean Seckler, mit Amtswohnsitze in Junglinster.
Sind erschienen:
1.- Dame Angelika Mückl, geborene Nather, Kauffrau, wohnhaft in D-63546 Hammersbach, 20, Am Galgenberg,
hier vertreten durch Herrn Klaus Benscheidt, Rechtsanwalt, wohnhaft in D-Remscheid,
aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift, ausgestellt in Hammersbach, am 13. November 1995,
welche Vollmacht, nachdem sie von den Komparenten und dem unterzeichneten Notar ne varietur unterzeichnet
wurde, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden;
2.- Herr Roland Kuhlmann, Kaufmann, wohnhaft in D-Remscheid, Birgder Hammer, 28.
Die Komparenten ersuchten den amtierenden Notar, folgendes zu beurkunden:
- dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung P.O.S. MARKETING & CONSULT, GmbH, mit Sitz in L-3870 Schif-
flingen, 71, Cité Paerschen, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch den in Petingen residierenden
Notar Georges d’Huart, am 18. März 1994, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 351 vom 22. September 1994, mit
einem Gesellschaftskapital von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF), aufgeteilt in einhundert (100) Anteile von
jeweils fünftausend Franken (5.000,- LUF),
12035
- dass Dame Angelika Mückl einzige Gesellschafterin der Gesellschaft mit beschränkter Haftung P.O.S. MARKETING
& CONSULT, GmbH, wurde, gemäss Abtretung durch Herrn Hans Kessel, Kaufmann, wohnhaft in D-51465, Bergische
Gladbach, 19, Auf dem Horn, seiner einhundert (100) Anteile, vom 12. Mai 1995, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer
406 vom 25. August 1995,
- dass folgende Beschlüsse in ausserordentlicher Generalversammlung gefasst wurden:
<i>Erster Beschlussi>
Dame Angelika Mückl erklärt hiermit abzutreten und zu übertragem unter der gesetzlichen Gewähr Rechtens an
Herrn Roland Kuhlmann, hier anwesend und dies annehmend, einhundert (100) Gesellschaftsanteile der vorgenannten
Gesellschaft, und zwar zum Preise von fünfhunderttausend Franken (500.000,- LUF).
Der vorerwähnte Abtretungspreis wurde bereits vor gegenwärtiger Urkunde von dem Zessionar in bar bezahlt, was
die Zedentin ausdrücklich anerkennt und worüber sie Quittung und Titel bewilligt.
Der nunmehr alleinige Gesellschafter Herr Roland Kuhlmann, erklärt diese Übertragung als der Gesellschaft rechts-
gültig zugestellt, gemäss Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches, respektive des Artikels 190 des Gesetzes vom 10. August
1915, betreffend die Handelsgesellschaften.
<i>Zweiter Beschlussi>
Im Anschluss an die hiervor getätigte Zession wird Artikel 5 der Satzung abgeändert, und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt fünfhunderttausend (500.000,-) Franken, eingeteilt in einhundert Anteile
von je fünftausend (5.000,-) Franken, integral eingezahlt und gezeichnet durch Herrn Roland Kuhlmann, Kaufmann,
wohnhaft in D-Remscheid, Birgder Hammer, 28.»
<i>Dritter Beschlussi>
Der Sitz der Gesellschaft wird nach Luxemburg, 11, rue de la Liberté verlegt; Artikel 2 der Satzung wird dement-
sprechend abgeändert und erhält folgenden Wortlaut:
«Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg. Er kann durch Beschluss des Gesellschafters an jeden anderen Ort
des Grossherzogtums Luxemburg verlegt werden.»
<i>Vierter Beschlussi>
Herrn Hans Kessel wird Entlastung für die Ausübung des Mandates des Geschäftsführers gewährt.
Zum neuen Geschäftsführer wird Herr Roland Kuhlmann, Kaufmann, wohnhaft in D-Remscheid Birgder Hammer, 28,
ernannt, welcher durch seine alleinige Unterschrift die Gesellschaft verpflichten kann.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr
dreissigtausend Franken abgeschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, alle dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben alle mit dem Notar gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: K. Benscheidt, R. Kuhlmann, J. Seckler.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 février 1996, vol. 497, fol. 59, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur ff. i>(signé): R. Lentz.
Für gleichlautende Ausfertigung, erteilt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, den 11. März 1996.
J. Seckler.
(09398/231/64) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
P.O.S. MARKETING & CONSULT, GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
—
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 11 mars 1996.
J. Seckler
<i>Le notairei>
(09399/231/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
PECKELS JP & FILS, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Mersch.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1989, enregistrés à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 32, case 1, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
(09395/653/8) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12036
PURE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 43.303.
—
<i>Assemblée générale extraordinaire du 7 mars 1996i>
Il résulte des décisions de l’Assemblée générale extraordinaire du 7 mars 1996 au siège de la société que les organes
se composent comme suit:
<i>Conseil d’Administrationi>
- Monsieur Petr Dyminskii, Administrateur-Délégué,
- Monsieur Michael Rassimof, Administrateur,
- Monsieur Charles Ewert, Administrateur,
- Monsieur Jean-Pierre Schumacher, Administrateur.
<i>Commissaire aux comptesi>
SOCIETE FIDUCIAIRE DELTA S.A.
Luxembourg, le 7 mars 1996.
Pour extrait conforme
PURE S.A.
Signatures
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 29, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09401/588/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SANPAOLO BANK S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 18.498.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 20 octobre 1995, que le conseil a pris, entre
autres, la résolution suivante:
<i>Extrait de la première résolutioni>
Le conseil d’administration, dûment autorisé à cet effet par l’assemblée générale ordinaire du 13 octobre 1995, décide
d’appeler Monsieur Gian Piero Negri, administrateur, à la fonction de délégué à la gestion journalière de la société, en
remplacement de Monsieur Pasqualino Moscatelli, avec le titre d’administrateur-délégué.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 1996.
SANPAOLO BANK S.A.
Signature
<i>Le Directeur générali>
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09403/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
PROPCONS A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Senningerberg, 6H, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 53.539.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am achtundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitze in Düdelingen (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft PROPCONS
A.G., mit Sitz in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht
von und in Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 53.539, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den
amtierenden Notar, am 21. Dezember 1995, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jürgen Donicht, Diplombetriebswirt, wohnhaft in München
(Deutschland).
Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Claude Mack, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Sebastian Greinacher, Diplomkaufmann, wohnhaft in München
(Deutschland).
Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden
Notar zu Protokoll genommen werden.
A) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Aktieninhabern,
hervorgeht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;
diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, sowie die
Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur paraphiert,
bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
B) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber respektiv Aktien-
inhabervertreter, rechtmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.
12037
C) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg-Stadt nach Senningerberg und Abänderung von Artikel eins,
dritter Abschnitt der Satzung.
2.- Festlegung einer neuen Anschrift der Gesellschaft.
Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten, der General-
versammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz von Luxemburg-Stadt nach Senningerberg (Gemeinde von
Niederanven) zu verlegen und demgemäss Artikel eins, dritter Abschnitt der Satzung abzuändern, um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
«Art. 1. Dritter Abschnitt. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, die neue Anschrift der Gesellschaft nach L-2633 Senningerberg, 6H, route de
Trèves, c/o European Bank & Business Center, festzulegen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das
vorliegende Protokoll unterschrieben.
Gezeichnet: J. Donicht, S. Greinacher, C. Mack, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 1996, vol. 821, fol. 38, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Düdelingen, den 7. März 1996.
J. Elvinger.
(09400/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
REG GRUNDY PRODUCTIONS (LUXEMBOURG) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2B, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 33.853.
—
<i>Extrait du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire tenue au siège social le 17 novembre 1995i>
<i>à onze heures précisesi>
L’assemblée a ratifié la décision prise par le conseil d’administration le 5 mai 1995 à dix heures précises concernant
le remplacement de deux administrateurs.
L’assemblée a ratifié la décision prise par le conseil d’administration le 3 novembre 1995 concernant le remplacement
de deux administrateurs.
Les administrateurs, Madame Emanuela Spinetta, Monsieur David B. Begbie et Monsieur Ian R. Ousey, ainsi que le
commissaire aux comptes, R. John Usher, ont été réélus pour une nouvelle période statutaire de six ans. Les mandats
viendront à échéance à l’issue de l’assemblée générale annuellle de l’an 2001.
Pour extrait sincère et conforme
CORPORATE SERVICES INTERNATIONAL S.A.
<i>(Agent domiciliaire)i>
Signature
Signature
<i>Un administrateuri>
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 23 février 1996, vol. 476, fol. 83, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09402/000/22) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SMC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.985.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 27, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 1996.
<i>Pour ordrei>
SOCIETE DE REVISION
ET D’EXPERTISES S.C.
(09410/611/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12038
SMC HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 30.985.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 27, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 1996.
<i>Pour ordrei>
SOCIETE DE REVISION
ET D’EXPERTISES S.C.
(09411/611/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SAN MARINO GESTION S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 12, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 28.537.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 31 janvier 1996, que le conseil a pris, entre
autres, les résolutions suivantes:
<i>Huitième résolutioni>
Conformément à la loi, le conseil d’administration, pour l’exercice 1996, donne mandat de révision du fonds TITANO
FUND à la société ARTHUR ANDERSEN & CO, réviseur d’entreprises, Luxembourg, aux termes et conditions stipulés
par ceux-ci dans leur lettre de mission datée du 30 janvier 1996.
<i>Neuvième résolutioni>
Le conseil d’administration coopte Monsieur Doriano Demi en remplacement de Monsieur Giuseppe Passatore,
démissionnaire, et le nomme vice-président du conseil. Monsieur le président ainsi que l’ensemble du conseil souhaite la
bienvenue à Monsieur Doriano Demi et il profite de l’occasion qui lui est donnée pour remercier en son nom personnel
mais également au nom de tous les membres du conseil, Monsieur Giuseppe Passatore, pour sa précieuse collaboration
tout au long de son mandat.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 1996.
<i>Pour SAN MARINO GESTION S.A.i>
SANPAOLO BANK S.A.
Signature
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09404/043/25) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SOCIETE EUROPEENNE D’AQUACULTURE, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 23.879.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 86, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1996.
Signature.
(09416/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SOVAPAR, SOCIETE VAROISE DE PARTICIPATIONS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 21, rue Glesener.
R. C. Luxembourg B 43.823.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 32, case 4, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
AFFECTATION DU RESULTAT
- Bénéfice de l’exercice …………………………………………………………
ITL 160.786.180,-
- Affectation à la réserve légale …………………………………………
ITL (8.039.309,-)
- Report à nouveau ………………………………………………………………
ITL 152.746.871,-
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
Signature.
(09417/507/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12039
SEFINLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 45.778.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale statutaire du 26 juin 1995, que l’assemblée a pris,
entre autres, la résolution suivante:
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat du commissaire aux comptes expirant à la date de ce jour, l’assemblée décide de renouveler pour un terme
d’un an le mandat du commissaire aux comptes, à savoir Monsieur Jean Nicolas Bartholomey, comptable, demeurant à
Ernster, 15, rue de Rodenbourg. Le mandat ainsi conféré expirera à l’issue de l’assemblée générale statutaire de 1996.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SEFINLUX S.A.
R. Tonelli
F. Wouters
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 18, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09407/043/18) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SEFINLUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R. C. Luxembourg B 45.778.
—
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 26 février 1996, que:
<i>Première et unique résolutioni>
Le conseil d’administration prend acte de la démission (Annexe 1.) de Monsieur Thierry Jaumin de sa fonction d’admi-
nistrateur. Le conseil d’administration décide, à l’unanimité des voix, de coopter en son sein, et ce avec effet immédiat,
Monsieur Sergio Vandi, employé privé, demeurant à Luxembourg, 8-14, rue Guillaume Schneider, en remplacement de
Monsieur Thierry Jaumin, démissionnaire.
Réquisition aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 1996.
SEFINLUX S.A.
R. Tonelli
F. Wouters
<i>Présidenti>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 5 mars 1996, vol. 477, fol. 12, case 11. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09408/000/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
S.G.T., SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 20.477.
—
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d’administration qui a eu lieu à Luxembourg, le 20 décembre 1995i>
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration:
que Monsieur Alain Tytgadt a été coopté en tant qu’administrateur en remplacement de Monsieur Frappart, démis-
sionnaire.
<i>Pour la SOCIETE DE GESTION ET TRAVAUX S.A.i>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09409/250/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
TALOS HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 36.960.
—
Les comptes annuels au 30 septembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 32, case 5, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
TALOS HOLDING S.A.
Signature
(09419/545/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12040
SMC REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.001.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 27, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 1996.
<i>Pour ordrei>
SOCIETE DE REVISION
ET D’EXPERTISES S.C.
(09412/611/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SMC REAL ESTATE S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 40.001.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 27, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 1996.
<i>Pour ordrei>
SOCIETE DE REVISION
ET D’EXPERTISES S.C.
Signature
(09413/611/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SNOB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4660 Differdange, 7, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 36.285.
—
Le bilan au 31 décembre 1992, enregistré à Luxembourg, le 3 octobre 1994, vol. 459, fol. 11, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 1
er
juin 1994.
Signatures.
(09414/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SNOB, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4660 Differdange, 7, rue Michel Rodange.
R. C. Luxembourg B 36.285.
—
Le bilan au 31 décembre 1993, enregistré à Luxembourg, le 22 janvier 1996, vol. 475, fol. 72, case 11, a été déposé
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 février 1995.
Signatures.
(09415/000/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
TERRA CONSULT A.G., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: Senningerberg, 6H, route de Trèves.
H. R. Luxemburg B 52.657.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am achtundzwanzigsten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Joseph Elvinger, im Amtssitze in Düdelingen (Grossherzogtum Luxemburg).
Versammelten sich in ausserordentlicher Generalversammlung die Aktionäre der Aktiengesellschaft TERRA
CONSULT A.G., mit Sitz in L-1720 Luxemburg, 6, rue Heine, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim
Bezirksgericht von und in Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 52.657, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen
durch den amtierenden Notar, am 12. Oktober 1995, noch nicht veröffentlicht im Mémorial C.
Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Herrn Jürgen Donicht, Diplombetriebswirt, wohnhaft in München
(Deutschland).
Der Herr Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Herrn Claude Mack, Privatbeamter, wohnhaft in Luxemburg.
Die Versammlung bestimmt zum Stimmzähler Herrn Sebastian Greinacher, Diplomkaufmann, wohnhaft in München
(Deutschland).
Der Herr Vorsitzende erklärt die Sitzung für eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden
Notar zu Protokoll genommen werden.
A) Dass aus einer Anwesenheitsliste, unterzeichnet von den Vertretern der Gesellschaft und Aktieninhabern,
hervorgeht, dass sämtliche Aktieninhaber in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind;
12041
diese Liste, von den Mitgliedern des Büros und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, sowie die
Vollmachten der vertretenen Aktieninhaber, von den Komparenten und dem amtierenden Notar ne varietur paraphiert,
bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet, um mit derselben zur Einregistrierung zu gelangen.
B) Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit sämtlicher Aktieninhaber respektive Aktien-
inhabervertreter, rechtmässig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.
C) Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:
<i>Tagesordnung:i>
1.- Verlegung des Gesellschaftssitzes von Luxemburg-Stadt nach Senningerberg und Abänderung von Artikel eins,
dritter Abschnitt der Satzung.
2.- Festlegung einer neuen Anschrift der Gesellschaft.
Der Herr Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche den Verwaltungsrat dazu bewegten der General-
versammlung diese Tagesordnung zu unterbreiten.
Nach Diskussion nimmt die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgende Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, den Gesellschaftssitz von Luxemburg-Stadt nach Senningerberg (Gemeinde von
Niederanven) zu verlegen und demgemäss Artikel eins, dritter Abschnitt der Satzung abzuändern, um ihm folgenden
Wortlaut zu geben:
«Art. 1. Dritter Abschnitt. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Senningerberg.»
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschliesst, die neue Anschrift der Gesellschaft nach L-2633 Senningerberg, 6H, route de
Trèves, c/o European Bank & Business Center, festzulegen.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Worüber Protokoll, aufgenommen in Luxemburg, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vorlie-
gende Protokoll unterschrieben.
Gezeichnet: J. Donicht, S. Greinacher, C. Mack, J. Elvinger.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 5 mars 1996, vol. 821, fol. 38, case 10. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Ries.
Für gleichlautende Ausfertigung erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Düdelingen, den 7. März 1996.
J. Elvinger.
(09421/211/54) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
SPECTRUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 37, rue Notre-Dame.
R. C. Luxembourg B 12.279.
—
<i>Extrait des résolutions prises à l’assemblée générale statutaire du 6 juin 1994i>
– La démission de Mademoiselle Yolande Johanns, commissaire aux comptes, est acceptée et FIN-CONTROLE S.A.,
Luxembourg, est nommée en son remplacement jusqu’à l’assemblée générale statutaire de 1998.
Certifié sincère et conforme
SPECTRUM S.A.
Signature
Signature
<i>Administrateuri>
<i>Administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09418/526/15) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz. L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté.
H. R. Luxemburg B 29.509.
—
Im Jahre eintausendneunhundertsechsundneunzig, am vierzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Camille Mines, mit Amtswohnsitz in Redingen.
Tagte eine außerordentliche Generalversammlung der Aktiengesellschaft VP BANK (LUXEMBOURG) S.A., mit Sitz in
L-1931 Luxemburg, 23, avenue de la Liberté.
Genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister beim Bezirksgericht Luxemburg, Sektion B
Nr. 29.509, wurde gegründet als Finanzinstitut ohne Bankeigenschaft durch eine Urkunde vom 16. November 1988 des
unterzeichneten Notars, mit damaligem Amtswohnsitz in Clerf, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 47 vom 22. Februar
1989, Seite 2225.
Die Satzung wurde dahingehend geändert, daß die Gesellschaft den Zweck einer Vollbank erhielt, durch Urkunde des
amtierenden Notars vom 18. April 1989, veröffentlicht im Mémorial C Nr. 173 vom 22. Juni 1989, Seite 8251.
Erschienen ist:
Herr Anton Engler, geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, wohnhaft in Bereldange (Luxemburg),
handelnd im Namen:
12042
1) der VERWALTUNGS- UND PRIVAT-BANK AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in Vaduz, Fürstentum Liechten-
stein;
2) der FIB FINANZ- UND BETEILIGUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT, mit Sitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein,
aufgrund von zwei Vollmachten unter Privatschrift, welche dieser Urkunde beigebogen bleiben.
Der Komparent, welcher sämtliche 20.000 ausgegebenen Aktien vertritt, erklärt, daß er die Tagesordnung im voraus
gekannt hat und auf die gesetzlichen Fristen und Einberufungsschreiben verzichtet. Somit erfüllt er alle Bedingungen, um
eine rechtsgültige Generalversammlung abzuhalten und die nachfolgenden Satzungsänderungen zu beschließen.
Dies vorausgeschickt, ersucht Herr Engler den amtierenden Notar, folgende Änderungen der Gesellschaftssatzung
der VP BANK (LUXEMBOURG) S.A. zu beurkunden.
Nachstehende Artikel erhalten folgenden neuen Wortlaut:
Art. 4. Erster Absatz. Die Aktien sind Namensaktien.
Art. 6. Sechster Absatz. Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefaßt. Ausge-
nommen sind die Dringlichkeitsbeschlüsse gemäß dem vorgehenden Absatz, welche der Mitwirkung aller Verwaltungs-
ratsmitglieder bedürfen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
Art. 8 wird ersatzlos gestrichen. Die nachfolgenden Artikel erhalten eine um 1 niedrigere Nummer.
Art. 10 (alt). Erster Absatz. Die jährliche Generalversammlung findet am 4. Montag im Mai um 11.00 Uhr in
Luxemburg am Gesellschaftssitz oder an einem anderen in der Einberufung angegebenen Ort in der Stadt Luxemburg
statt.
Dritter Absatz. Eine außerordentliche Generalversammlung wird einberufen, wenn entsprechende Gründe
vorliegen oder wenn dies von einem oder mehreren Anteilseignern, die einzeln oder gemeinsam über 20 % des Gesell-
schaftskapitals verfügen, gefordert wird.
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde entstehenden Kosten werden auf 40.000,- Franken geschätzt.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Gesellschaftssitz, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten hat dieser mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unter-
zeichnet.
Gezeichnet: A. Engler, C. Mines.
Enregistré à Redange-sur-Attert, le 16 février 1996, vol. 395, fol. 16, case 8. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): Schaack.
Für gleichlautende Ausfertigung, auf stempelfreiem Papier erteilt, zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Redingen, den 27. Februar 1996.
C. Mines.
(09431/225/52) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
TBG INTERNATIONAL S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-1631 Luxemburg, 21, rue Glesener.
H. R. Luxemburg B 8.271.
—
Der Jahresabschluß zum 31. Dezember 1994, eingetragen in Luxemburg, den 11. März 1996, Vol. 477, Fol. 32, Case
4, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von und in Luxemburg, den 12. März 1996 hinterlegt.
ERGEBNISVERWENDUNG
- Gewinnvortrag …………………………………………………………………………
LUF 9.360,-
Zum Zweck der Veröffentlichung im Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 7. März 1995.
Unterschrift.
(09420/507/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
CANTRADE FUND MANAGEMENT COMPANY S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2011 Luxembourg, 3-5, place Winston Churchill.
R. C. Luxembourg B 37.878.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 38, case 11, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
<i>Extrait des résolutions prises par l’assemblée générale du 14 février 1996i>
Sont élus au conseil d’administration pour un terme d’un an:
* Dr. Thomas Schlieper, Präsident des Verwaltungsrates;
* Herr Olivier Baron van Lamsweerde, Mitglied;
* Herr Peter Scherkamp, Mitglied.
Est réélue commissaire aux comptes pour un terme d’un an:
PRICE WATERHOUSE, réviseur d’entreprises, Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UBS-INTRAG (SERVICES)
Société Anonyme
M. Hauser
G. Schintgen
(09465/027/20) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
12043
CENTRE FRANÇOIS BACLESSE,
(CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE),
Association sans but lucratif.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
Il résulte de l’assemblée générale extraordinaire des membres qui a eu lieu au siège social, le 16 octobre 1995, que:
– l’article 10 de l’association est modifié et a désormais la teneur suivante:
«Art. 10. L’administration de l’association est confiée à un conseil d’administration de 10 membres nommés par
l’assemblée générale. Chaque membre effectif a le droit de proposer un ou plusieurs noms.
Le conseil d’administration doit comprendre au moins un administrateur proposé par chaque membre effectif qui le
demande.
L’assemblée générale nomme également 10 membres suppléants du conseil d’administration selon la même
procédure.
Chaque membre suppléant remplacera dans ses fonctions l’administrateur qu’il supplée en cas d’empêchement de
celui-ci.
Chaque membre suppléant peut également assister à tous les conseils d’administration, y prendre la parole, mais
n’aura pas de droit de vote lorsque l’administrateur qu’il supplée est présent.»
– il est introduit un chapitre H intitulé «Révision des comptes annuels de l’association» comprenant un article 28
ayant la teneur suivante:
«Art. 28. Les opérations de l’association seront surveillées par un réviseur d’entreprise indépendant.
L’assemblée générale des membres désignera le réviseur indépendant et déterminera ses fonctions et la durée de
celles-ci.»
– sont nommés comme membres suppléants:
* Monsieur Emile Kmiotek, Hôpital de la Ville, Esch-sur-Alzette;
* Dr Jean Nosbaum, Fondation Norbert Metz, Eich;
* Monsieur Georges Bassing, Clinique St. Louis, Ettelbruck;
* Monsieur Lucien Sturm, Hôpital de la Ville, Dudelange;
* Dr Georges Sandt, Centre Hospitalier, Luxembourg;
* Dr Jean-Marie Bruch, Hôpital Princesse Marie-Astrid, Differdange;
* Dr Philippe Turk, Congrégation des Soeurs du Tiers Ordre Régulier de Notre-Dame du Mont Carmel à Luxem-
bourg S.A.;
* Soeur Victorine Cariers, Clinique Sainte Marie, Esch-sur-Alzette;
* Monsieur Marc Schlim, Clinique Sainte Elisabeth, Luxembourg;
* Monsieur Norbert Nick, Fondation François Elisabeth, Luxembourg.
– est nommée comme réviseur d’entreprise indépendant:
ASSOCIATION MOMENTANEE FIDUCIAIRE GENERALE / Marc Müller.
<i>Pour le CENTRE FRANÇOIS BACLESSEi>
<i>(CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE),i>
<i>Association sans but lucratifi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09432/250/46) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
CENTRE FRANÇOIS BACLESSE,
(CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE),
Association sans but lucratif.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
Suite à une erreur matérielle, il est nécessaire de remplacer dans la liste des administrateurs de l’association sans but
lucratif:
«Dr Ernest Rauchs, Clinique Sacré-Coeur, Luxembourg»
par
«Dr Ernest Rauchs, Fondation François Elisabeth, Luxembourg».
<i>Pour le CENTRE FRANÇOIS BACLESSEi>
<i>(CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE),i>
<i>Association sans but lucratifi>
Signature
<i>Un mandatairei>
Enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 20, case 9. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09433/250/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12044
CENTRE FRANÇOIS BACLESSE,
(CENTRE NATIONAL DE RADIOTHERAPIE),
Association sans but lucratif.
Siège social: Esch-sur-Alzette.
—
Le texte des statuts coordonné a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars
1996.
Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Association.
(09434/250/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
TREND FASHION, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Luxembourg, 23, rue des Capucins.
R. C. Luxembourg B 19.056.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 19 février 1996, vol. 476, fol. 68, case 9, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 8 mars 1996.
DEBELUX AUDIT, S.à r.l.
Signature
(09422/722/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
TRIOFALUX, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: Contern.
R. C. Luxembourg B 27.437.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, le 26 février 1996, vol. 476, fol. 86, case 2, ont
été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 février 1996.
Signature.
(09423/603/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
TY BORDARDOUE S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 26.484.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1993, enregistrés à Luxembourg, vol. 477, fol. 17, case 5, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
Signature.
(09424/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
VANTAGE INVESTISSEMENTS S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2343 Luxembourg, 17, rue des Pommiers.
R. C. Luxembourg B 32.555.
—
Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 1995, enregistrés à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 26, case
4, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
L’attestation a été donnée sans réserve.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
Signatures.
(09426/577/11) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
VANTAGE INVESTISSEMENTS S.A., Aktiengesellschaft.
Gesellschaftssitz: L-2343 Luxemburg, 17, rue des Pommiers.
H. R. Luxemburg B 32.555.
—
<i>Auszug aus der ordentlichen Generalversammlung,i>
<i>gehalten am 27. Februar 1996 von 11.30 bis 12.00 Uhri>
Die Gesellschafter fassen hiermit einstimmig die nachstehenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlußi>
Der vom Verwaltungsrat vorgelegte Lagebericht und der vom Kommissar geprüfte Jahresabschluß zum 31. Dezember
1995, umfassend die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang für das Geschäftsjahr 1995, werden
genehmigt.
12045
<i>Zweiter Beschlußi>
Dem Verwaltungsrat und dem Kommissar wird in getrennter Abstimmung für das Geschäftsjahr 1995 Entlastung
erteilt.
<i>Dritter Beschlußi>
Der im Jahresabschluß 1995 ausgewiesene Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.
<i>Vierter Beschlußi>
Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Artikels 100 des Gesetzes betreffend die Handelsgesellschaften vom
10. August 1915 wird die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen.
<i>Fünfter Beschlußi>
Die Demission der Verwaltungsratsmitglieder M
e
Carlos Zeyen, Herrn Horst Sonnentag und Herrn Carl Scharffe-
north und des Kommissars der Gesellschaft BDO BINDER (LUXEMBOURG), S.à r.l., wird mit ausdrücklichem Dank für
die der Gesellschaft erwiesenen Dienste zur Kenntnis genommen. Zu neuen Verwaltungsratsmitgliedern werden
ernannt:
– Herr Francis X. Morrissey, 767 Fifth Avenue, 28th Floor, 10153 New York City, USA;
– Dr. Ernst J. Walch, Zollstraße 9, 9490 Vaduz, Liechtenstein;
– Herr Klaus Krumnau, 17, rue des Pommiers, L-2343 Luxemburg.
Zum neuen Kommissar der Gesellschaft wird ernannt:
– EUROFIRM TRUST ESTABLISHMENT, Triesenberg, Liechtenstein.
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden mit der ordentlichen Generalversammlung
über das Geschäftsjahr 1996.
Für die Richtigkeit des Auszugs
G. P. Rockel
Enregistré à Luxembourg, le 7 mars 1996, vol. 477, fol. 26, case 4. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09427/577/40) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
VIENNA INTERNATIONAL, SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Siège social: Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R. C. Luxembourg B 42.603.
—
Le bilan au 31 octobre 1995, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 30, case 3, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
<i>Pour VIENNA INTERNATIONALi>
A. Schmit
<i>Administrateuri>
(09428/526/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
VIENNA INTERNATIONAL, SICAF, Société d’Investissement à Capital Fixe.
Gesellschaftssitz: Luxemburg, 11, rue Aldringen.
H. R. Luxemburg B 42.603.
—
<i>Auszug aus der Beschlußfassung der ordentlichen jährlichen Generalversammlung vom 20. Februar 1996i>
– Der Jahresgewinn zum 31. Oktober 1995 wird wie folgt verteilt:
. an gesetzliche Rücklage ………………………………………………
ATS
8.578,00
. Vortrag auf neue Rechnung ………………………………………
ATS
8.378.347,88
. Total…………………………………………………………………………………
ATS
8.386.925,88
– Die Kooptierung von Herrn Mag. Michael Giessrigl wird ratifiziert.
– Die Demission vom 16. November 1995 von Herrn Mag. Michael Giessrigl als Verwaltungsratsmitglied wird
angenommen und Herr Rudolf Nemetschke wird als Verwaltungsratsmitglied bis zur ordentlichen Generalversammlung
von 1997 an Stelle von Herrn Mag. Michael Giessrigl ernannt.
– Die Mandate der Herren Verwaltungsratsmitglieder, Mag. Constantin Veyder-Malberg, Rafik Fischer und André
Schmit werden für ein Jahr bis zur ordentlichen Generalversammlung von 1997 verlängert.
– Das Mandat des Wirtschaftsprüfers, KPMG AUDIT (früher KPMG PEAT MARWICK INTER-REVISION), wird für
ein Jahr, bis zur ordentlichen Generalversammlung von 1997 erneuert.
Für gleichlautende Abschrift
VIENNA INTERNATIONAL
KREDIETRUST
J. Vanden Bussche
J.-P. Gomez
<i>Premier Fondé de pouvoiri>
<i>Chef de Servicei>
Enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 30, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09429/526/27) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
12046
UNION DE FINANCEMENT ET DE PARTICIPATION DE LUXEMBOURG S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 32, rue Auguste Neyen.
R. C. Luxembourg B 23.110.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 11 mars 1996, vol. 477, fol. 32, case 5, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
UNION DE FINANCEMENT
ET DE PARTICIPATION
DE LUXEMBOURG S.A.
Signature
(09425/545/13) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
VIRA VOLGA HOLDING S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-Senningerberg, 5, rue Höhenhof.
R. C. Luxembourg B 48.572.
—
Les comptes annuels au 31 décembre 1994, enregistrés à Luxembourg, vol. 477, fol. 17, case 5, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
Signature.
(09430/693/10) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 1996.
CONNEX UNTERNEHMENSGRUPPE AG, Aktiengesellschaft.
—
Der Firmensitz der Gesellschaft CONNEX UNTERNEHMENSGRUPPE AG ist mit heutigem Datum fristlos
gekündigt.
Weiswampach, den 23. April 1996.
H. März.
Enregistré à Clervaux, le 23 avril 1996, vol. 204, fol. 47, case 6. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): F. Kleer.
(90661/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1996.
CONNEX UNTERNEHMENSGRUPPE AG, Aktiengesellschaft.
—
Das Mandat als Kommissar der Gesellschaft CONNEX UNTERNEHMENSGRUPPE AG ist mit heutigem Datum
fristlos gekündigt.
Weiswampach, den 23. April 1996.
H. März.
Enregistré à Clervaux, le 23 avril 1996, vol. 204, fol. 47, case 5. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): F. Kleer.
(90662/703/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 29 avril 1996.
SACHVERSTÄNDIGENBÜRO FÜR KRAFTFAHRZEUGTECHNIK /
EURO-TRUST SERVICE, Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
R. C. Diekirch B 1.543.
—
Le siège de la société SACHVERSTÄNDIGENBÜRO FÜR KRAFTFAHRZEUGTECHNIK/EURO-TRUST SERVICE,
GmbH, actuellement établi au 3, place Guillaume, L-9237 Diekirch, est dénoncé avec effet immédiat.
Diekirch, le 30 avril 1996.
FIDUCIAIRE GENERALE DU NORD S.A.
Signature
Enregistré à Diekirch, le 30 avril 1996, vol. 256, fol. 79, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): M. Siebenaler.
(90679/591/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Diekirch, le 30 avril 1996.
ASTRUM S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R. C. Luxembourg B 29.026.
—
Le bilan au 30 juin 1995, enregistré à Luxembourg, le 6 mars 1996, vol. 477, fol. 17, case 11, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 1996.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION
LUXEMBOURG S.A.
Signature
(09456/550/12) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
12047
I.E.M., S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1361 Luxembourg, 3, rue de l’Ordre de la Couronne de Chêne.
R. C. Luxembourg B 37.747.
—
Le bilan au 31 décembre 1995, enregistré à Capellen, le 12 mars 1996, vol. 130, fol. 78, case 9, a été déposé au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 1996.
Signature.
(09501/000/9) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
ILIAS S.A., Société Anonyme.
Registered office: Luxembourg.
R. C. Luxembourg B 45.050
—
DISSOLUTION
In the year one thousand nine hundred and ninety-six, on the twenty-third of February.
Before Us, Maître Frank Baden, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr Joost Has, manager, residing in L-5450 Stadtbredimus, 29, route du Vin,
acting in the name and on behalf of the company C.B.A. LIMITED, having its registered office in St. Peter
Port/Guernsey, P.O. Box 348, St. Andrews House, 3rd Floor,
by virtue of a proxy given in Guernsey, on the 16th of February, 1996, which proxy, initialled ne varietur by the person
appearing and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
Such appearer, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation ILIAS S.A., having its principal office in Luxembourg (R. C. Luxembourg B 45.050), has been
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on the 14th of September 1993, published in the Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, number 538 of the 9th of November 1993;
- that the capital of the corporation is fixed at thirty million Luxembourg francs (30,000,000.- LUF), represented by
three hundred (300) shares with a par value of one hundred thousand Luxembourg francs (100,000.- LUF);
- that the company C.B.A. LIMITED has become owner of the three hundred (300) shares and that it has decided to
dissolve the Company, as the Company has no more activity;
- that herewith the anticipated dissolution of the Company and the liquidation is pronounced with immediate effect;
- that the sole shareholder declares to take over all the assets of the Company and declares that all liabilities of the
Company against third parties have been fully paid off and that he is responsible for any eventual actually unknown liabil-
ities of the Company. He will also pay the fees of the present deed;
- that the liquidation of the Company is to be considered as achieved and the Company is thus held to be definitely
dissolved and liquidated;
- that discharge is granted to the directors and auditor for the execution of their mandate;
- that the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at the registered office
of the Company dissolved, in Luxembourg, 283, route d’Arlon.
Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; at the request of the appearing person and in case of divergences between the
English and the French texts, the English version will be prevailing.
The document having been read to the person appearing, known to the notary by his surname, name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an mil neuf cent quatre-vingt-seize, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Joost Has, manager, demeurant à L-5450 Stadtbredimus, 29, route du Vin,
agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société C.B.A. LIMITED, ayant son siège social à St. Peter
Port/Guernsey, P.O. Box 348, St. Andrews House, 3rd Floor,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Guernesey, le 16 février 1996, laquelle restera, après avoir été
paraphée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux présentes pour être soumise avec elles à la formalité
de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès qualités qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- La société anonyme ILIAS S.A., ayant son siège social à Luxembourg, inscrite au registre de commerce de
Luxembourg sous le numéro B 45.050, a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 14
septembre 1993, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 538 du 9 novembre 1993.
- Le capital social est fixé à trente millions de francs luxembourgeois (30.000.000,- LUF), représenté par trois cents
(300) actions d’une valeur nominale de cent mille francs luxembourgeois (100.000,- LUF) chacune.
12048
- Sa mandante est devenue propriétaire des trois cents (300) actions dont il s’agit et elle a décidé de dissoudre et de
liquider la société, celle-ci ayant cessé toute activité.
- Par la présente, elle prononce la dissolution anticipée de la société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.
- L’actionnaire unique déclare avoir réglé tout le passif de la société et avoir transféré tous les actifs à son profit.
L’actionnaire unique se trouve donc investi de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de
tout le passif social et de tous les engagements de la société, même inconnus à l’heure actuelle. Il réglera également les
frais des présentes.
- Partant, la liquidation de la Société est achevée et la Société est à considérer comme définitivement clôturée et
liquidée.
- Décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire de surveillance pour l’exécution de
leur mandat.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège social de la société
dissoute, à Luxembourg, 283, route d’Arlon.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur la demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue anglaise, suivi d’une version française; sur la demande du même comparant et en cas de divergences
entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fera foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. Has, F. Baden.
Enregistré à Luxembourg, le 1
er
mars 1996, vol. 89S, fol. 56, case 1. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
Pour expédition conforme, délivrée à la Société sur sa demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des
Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 1996.
F. Baden.
(09502/200/81) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
PLASTTECHNIK-VERTRIEBSGESELLSCHAFT (P.T.V.), Société à responsabilité limitée
Siège social: L-2443 Senningerberg, 75, rue de Romains.
R. C. Luxembourg B 12.592.
Constituée par-devant M
e
Frank Baden, notaire alors de résidence à Mersch, en date du 26 novembre 1974, acte publié
au Mémorial C, n
o
18 du 30 janvier 1975, modifiée par-devant le même notaire en date du 30 juin 1980, acte publié
au Mémorial C, n
o
201 du 15 septembre 1980, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 août 1989, acte
publié au Mémorial C, n
o
5 du 5 janvier 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 25 août 1989, acte
publiée au Mémoril C, n
o
30 du 24 janvier 1990, modifiée par-devant le même notaire en date du 10 mars 1993,
acte publié au Mémorial C, n
o
264 du 3 juin 1993, modifiée par-devant le même notaire en date du 22 décembre
1993, acte publié au Mémorial C, n
o
119 du 30 mars 1994.
—
Le bilan au 31 décembre 1994, enregistré à Luxembourg, le 8 mars 1996, vol. 477, fol. 30, case 1, a été déposé au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour PLASTTECHNIK-VERTRIEBSGESELLSCHAFT (P.T.V.), GmbHi>
KPMG Experts Comptables
Signature
(09528/537/19) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.
PLUSFIN S.A., Société Anonyme.
Siège social: Luxembourg, 18, rue de l’Eau.
R. C. Luxembourg B 46.350.
—
EXTRAIT
Conformément à l’article 6 des statuts, les administrateurs réunis le 7 mars 1996 au siège social ont nommé Dr. Diego
Lissi comme administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Un administrateuri>
Enregistré à Luxembourg, le 12 mars 1996, vol. 477, fol. 36, case 3. – Reçu 500 francs.
<i>Le Receveur i>(signé): J. Muller.
(09529/693/14) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 1996.